News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Dorothy Batts
1604 -
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Dorothy Batts
[1]
b. 19 Feb 1603/04
Theodor Daubney
c. 30 Apr 1606
2
Cornelius Dabney
[1.1]
b. 2 May 1631 d. 30 Apr 1694
Edith Moryson
b. 8 May 1631 d. Abt 1678
3
James Dabney
[1.1.1]
b. 24 May 1657 d. 11 Sep 1739
Ann Sherwood
4
Welthan Dabney
[1.1.1.1]
b. Bef 8 Jan 1698/99
James Ellett
5
Dabney Ellett
[1.1.1.1.1]
4
Cornelius Dabney
[1.1.1.2]
d. Bef 1745
Lucy Winston
b. Abt 1707 d. 1784
5
William Dabney
[1.1.1.2.1]
b. 14 Jul 1722 d. 21 May 1803
Philadelphia Gwathmey
b. 10 Dec 1722 d. 15 Mar 1812
6
Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.1]
b. 15 Aug 1749 d. 24 Feb 1834
Ann Hill
b. 11 Jul 1749 d. 14 May 1827
7
William Dabney
[1.1.1.2.1.1.1]
b. 22 Feb 1770 d. 18 Apr 1856
Hannah Temple Dabney
b. 4 Sep 1767 d. 5 Oct 1853
8
Diana Dabney
[1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 21 Jun 1788 d. 16 Sep 1862
Cornelius Dabney
b. 14 May 1774 d. 24 Jul 1856
9
William Winston Dabney
[1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 17 Aug 1807 d. 10 Dec 1877
Elizabeth Jennings Dabney
b. 16 Mar 1791 d. 17 Apr 1874
10
Elizabeth Louise Dabney
[1.1.1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 15 Sep 1828 d. 3 Feb 1904
8
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 26 Jun 1790 d. 2 Aug 1863
7
Humphrey Dabney
[1.1.1.2.1.1.2]
b. 2 Nov 1772 d. 6 Jun 1858
Katherine Collins
8
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 10 Dec 1797 d. 26 Nov 1879
Susan Hill Segar
b. 10 Apr 1765 d. 22 Sep 1846
9
John Collins Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. 21 Feb 1793 d. 16 Apr 1875
Florence Henry Miller
b. 1837/1865 d. 1854/1948
10
Margaret Henry Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.1.1]
+
S. Barksdale Penick
10
Miller Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.1.2]
10
Frederick Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.1.3]
9
Susan Segar Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.2]
b. 15 Mar 1795 d. 26 Jun 1878
9
Humphrey Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.3]
b. 4 Jan 1791 d. 25 Jun 1872
+
Roberta Blanks
9
Emma Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.4]
b. 11 Apr 1787 d. 17 Jun 1844
9
David Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.5]
b. 3 Feb 1789 d. 13 Jun 1865
9
Albert Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.6]
8
Katherine Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 21 Aug 1803 d. 4 Feb 1884
8
Sarah Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.3]
b. 15 Feb 1801 d. 24 Oct 1885
8
Mary Ann Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.4]
b. 4 May 1805 d. 14 Sep 1888
8
Susan Hill Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.5]
b. 17 Jul 1799 d. 21 Nov 1880
8
Saville Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.6]
7
Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.1.3]
b. 15 Jul 1774 d. 26 Sep 1862
7
Robert Dabney
[1.1.1.2.1.1.4]
b. 16 Mar 1768 d. 4 Jul 1841
7
Frances Dabney
[1.1.1.2.1.1.5]
b. 5 Jun 1780 d. 15 Jul 1867
John Segar
b. 7 Dec 1780 d. 13 Mar 1858
8
Susan Hill Segar
[1.1.1.2.1.1.5.1]
b. 10 Apr 1765 d. 22 Sep 1846
Albert Gallatin Dabney
b. 10 Dec 1797 d. 26 Nov 1879
9
John Collins Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.1]
b. 21 Feb 1793 d. 16 Apr 1875
Florence Henry Miller
b. 1837/1865 d. 1854/1948
10
Margaret Henry Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.1]
+
S. Barksdale Penick
10
Miller Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.2]
10
Frederick Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.3]
9
Susan Segar Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.2]
b. 15 Mar 1795 d. 26 Jun 1878
9
Humphrey Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.3]
b. 4 Jan 1791 d. 25 Jun 1872
+
Roberta Blanks
9
Emma Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.4]
b. 11 Apr 1787 d. 17 Jun 1844
9
David Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.5]
b. 3 Feb 1789 d. 13 Jun 1865
9
Albert Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.6]
8
Rebecca Ann Segar
[1.1.1.2.1.1.5.2]
b. 14 Apr 1788 d. 15 May 1879
8
Sarah Frances Segar
[1.1.1.2.1.1.5.3]
b. 17 Apr 1771 d. 19 Oct 1852
Richard Dabney
b. 25 Sep 1775 d. 19 Feb 1854
8
Catherine Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.4]
b. 10 Oct 1805 d. 19 Sep 1871
+
John Hilliard
8
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.5]
b. 10 Oct 1803 d. 16 Nov 1888
+
Elizabeth Smelt
6
Cornelius Dabney
[1.1.1.2.1.2]
b. 7 Jul 1744 d. 21 Oct 1825
Elizabeth Smith
b. 11 Jul 1744 d. 14 May 1831
7
Isaac Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.1]
b. 3 May 1768 d. 13 Aug 1842
Hannah Winston
b. 21 Oct 1767 d. 10 Apr 1846
8
Eliza Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.1]
b. 6 Jul 1793 d. 11 Sep 1874
+
Henry Hughs
8
Catherine Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.2]
b. 24 Sep 1805 d. 1 May 1879
+
Albert Meriwether
8
Dorothy Ann Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.3]
b. 3 Oct 1803 d. 6 Dec 1888
+
Thomas Meriwether
8
Hannah Gwathmey Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4]
b. 10 Feb 1791 d. 12 Mar 1877
Edwin Winston Dabney
b. 1821
9
Ann Eliza Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.1]
9
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.2]
9
Hannah Elizabeth Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.3]
9
Edwin Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.4]
9
Thomas Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.5]
9
Emma Juliet Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.6]
9
Cornelius Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.7]
9
John Bledsoe Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.8]
9
Robert Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.9]
9
George Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.10]
9
Virginia Louisa Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.11]
8
Martha Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.5]
b. 18 Aug 1795 d. 2 Oct 1876
+
Henry Hughes
b. 19 Sep 1795 d. 26 Oct 1884
8
Albert Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.6]
8
Urath Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.7]
8
Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.8]
7
William Spotswood Dabney
[1.1.1.2.1.2.2]
b. 25 Mar 1767 d. 2 Sep 1849
7
Cornelius Dabney
[1.1.1.2.1.2.3]
b. 13 May 1764 d. 29 Sep 1831
Mary Eggleston Catlett
b. 4 Jul 1763 d. 15 Feb 1823
8
Charles Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.1]
b. 21 Mar 1787 d. 17 May 1861
8
Ann Eliza Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.2]
b. 4 Jun 1791 d. 5 Sep 1865
+
Wiley Jones
8
Caroline Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.3]
b. 12 Jun 1789 d. 13 Jul 1862
8
Cornelius Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4]
b. 2 Mar 1785 d. 7 Aug 1844
Anne Harris
b. 6 Jul 1765 d. 17 Nov 1839
9
Celia Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4.1]
b. 25 Mar 1813 d. 29 Jul 1902
9
Ann Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4.2]
b. 16 Jan 1809 d. 25 Jun 1891
9
Polly Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4.3]
b. 22 Feb 1811 d. 30 May 1896
9
John Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4.4]
b. 11 Jun 1807 d. 7 Sep 1891
7
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4]
b. 17 Sep 1765 d. 18 Oct 1827
Ann Elizabeth Catlett
8
Cornelius Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1]
b. 24 Nov 1826
Susan Garnett
9
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.1]
9
James Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.2]
9
Cornelius Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.3]
9
Edwin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.4]
9
Henry Thomas Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.5]
9
Fannie Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.6]
9
Susan Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.7]
9
Eustacia Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.8]
+
Lou Hill
9
Annie Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.9]
8
Edwin Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2]
b. 1821
Hannah Gwathmey Dabney
b. 10 Feb 1791 d. 12 Mar 1877
9
Ann Eliza Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.1]
9
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.2]
9
Hannah Elizabeth Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.3]
9
Edwin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.4]
9
Thomas Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.5]
9
Emma Juliet Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.6]
9
Cornelius Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.7]
9
John Bledsoe Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.8]
9
Robert Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.9]
9
George Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.10]
9
Virginia Louisa Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.11]
8
Thomas Catlett Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.3]
b. 20 Sep 1823 d. 1886
8
Albert Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4]
Pamela Middleton
9
James Middleton Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4.1]
9
John Catlett Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4.2]
9
Albert Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4.3]
9
Harriet Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4.4]
8
John Temple Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.5]
8
Ann Maria Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.6]
8
Elizabeth Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.7]
+
Walter Lewis
8
Juliet Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.8]
+
Robert Meriwether
8
Walter Scales Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.9]
8
Joseph Whorton Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.10]
8
William Spotswood Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.11]
8
Virginia Louisa Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.12]
8
Robert Owen Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.13]
+
Elizabeth Eggleston
7
Elizabeth Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.5]
b. 18 May 1770 d. 12 Oct 1861
+
Methodist Clergyman Stuart
7
Martha Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.6]
b. 5 Jun 1772 d. 2 Jul 1840
+
Thomas Cooper
6
William Dabney
[1.1.1.2.1.3]
b. 24 Sep 1747 d. 13 Mar 1832
Sarah Gwathmey
b. 1766
7
Mordecai Booth Dabney
[1.1.1.2.1.3.1]
b. 22 Jun 1776 d. 10 Sep 1861
7
Martha Washington Dabney
[1.1.1.2.1.3.2]
b. 2 Feb 1768 d. 16 Jul 1842
7
Cornelius Dabney
[1.1.1.2.1.3.3]
b. 14 May 1774 d. 24 Jul 1856
Diana Dabney
b. 21 Jun 1788 d. 16 Sep 1862
8
William Winston Dabney
[1.1.1.2.1.3.3.1]
b. 17 Aug 1807 d. 10 Dec 1877
Elizabeth Jennings Dabney
b. 16 Mar 1791 d. 17 Apr 1874
9
Elizabeth Louise Dabney
[1.1.1.2.1.3.3.1.1]
b. 15 Sep 1828 d. 3 Feb 1904
7
William Dabney
[1.1.1.2.1.3.4]
b. 27 Apr 1772 d. 21 Aug 1853
7
Bushrod Dabney
[1.1.1.2.1.3.5]
b. 23 Mar 1770 d. 4 May 1847
7
Washington Dabney
[1.1.1.2.1.3.6]
b. 28 Jul 1778 d. 5 Sep 1864
6
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.4]
b. 18 Feb 1745 d. 7 Jun 1836
Diana Gwathmey
b. 1 Nov 1755 d. 14 Aug 1824
7
Owen Dabney
[1.1.1.2.1.4.1]
b. 11 Dec 1781 d. 16 May 1863
7
Lucy Dabney
[1.1.1.2.1.4.2]
b. 7 Sep 1771 d. 19 Mar 1855
+
John Merritt
7
Hannah Temple Dabney
[1.1.1.2.1.4.3]
b. 4 Sep 1767 d. 5 Oct 1853
William Dabney
b. 22 Feb 1770 d. 18 Apr 1856
8
Diana Dabney
[1.1.1.2.1.4.3.1]
b. 21 Jun 1788 d. 16 Sep 1862
Cornelius Dabney
b. 14 May 1774 d. 24 Jul 1856
9
William Winston Dabney
[1.1.1.2.1.4.3.1.1]
b. 17 Aug 1807 d. 10 Dec 1877
Elizabeth Jennings Dabney
b. 16 Mar 1791 d. 17 Apr 1874
10
Elizabeth Louise Dabney
[1.1.1.2.1.4.3.1.1.1]
b. 15 Sep 1828 d. 3 Feb 1904
8
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.4.3.2]
b. 26 Jun 1790 d. 2 Aug 1863
7
Anna Dabney
[1.1.1.2.1.4.4]
b. 14 Jun 1785 d. 15 Jul 1867
7
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.4.5]
b. 25 Sep 1775 d. 19 Feb 1854
Frances Dabney
b. 5 Jun 1780 d. 15 Jul 1867
8
Catherine Dabney
[1.1.1.2.1.4.5.1]
b. 10 Oct 1805 d. 19 Sep 1871
+
John Hilliard
8
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.4.5.2]
b. 10 Oct 1803 d. 16 Nov 1888
7
Temple Dabney
[1.1.1.2.1.4.6]
b. 13 Nov 1779 d. 2 Apr 1859
+
Hannah Temple Gwathmey
b. 29 Dec 1791 d. 21 Dec 1825
7
Joseph Dabney
[1.1.1.2.1.4.7]
b. 28 Oct 1777 d. 27 Mar 1856
7
Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.4.8]
b. 21 Jan 1783 d. 15 Jun 1868
7
Benjamin Dabney
[1.1.1.2.1.4.9]
b. 4 Aug 1773 d. 8 Feb 1851
Nancy Armistead
8
Thomas Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.1]
b. 4 Jan 1798
8
Philip Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.2]
b. 4 Mar 1800
8
Martha Burnell Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.3]
b. 15 Sep 1802
8
William Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.4]
b. 5 Jan 1805 d. Mar 1809
8
James Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.5]
b. 1 Nov 1806
7
Henry Dabney
[1.1.1.2.1.4.10]
b. 27 Nov 1769 d. 28 Dec 1841
+
Ann Jackson
6
Lucy Dabney
[1.1.1.2.1.5]
6
Owen Dabney
[1.1.1.2.1.6]
6
Gwathmey Dabney
[1.1.1.2.1.7]
+
Elizabeth Maddox
6
Lewis Dabney
[1.1.1.2.1.8]
6
Sarah Dabney
[1.1.1.2.1.9]
6
Philadelphia Dabney
[1.1.1.2.1.10]
3
John Dabney
[1.1.2]
b. Abt 1665 d. 1688
Sarah Ann Jennings
b. Abt 1670
4
Susanna Dabney
[1.1.2.1]
b. 1696
Francis Thornton Strother
b. 1700 d. 17 Apr 1752
5
William Strother
[1.1.2.1.1]
b. 30 Apr 1726 d. 5 Nov 1808
Sarah Bayly
b. Abt 1720
6
Sarah Dabney Strother
[1.1.2.1.1.1]
b. 14 Dec 1760 d. 13 Dec 1822
Richard Taylor
b. 3 Apr 1744 d. 19 Jan 1829
7
Zachary Taylor
[1.1.2.1.1.1.1]
b. 24 Nov 1784 d. 9 Jul 1850
Margaret Mackall Smith
b. 1787 d. 1852
8
Mary Elizabeth Taylor
[1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 20 Apr 1824 d. 25 Jul 1909
+
Philip Pendleton Dandridge
b. 2 Oct 1817 d. 28 Oct 1881
+
William Smith Bliss
b. 1815 d. 1853
4
Sarah Dabney
[1.1.2.2]
b. Abt 1698
3
Elizabeth Dabney
[1.1.3]
b. Abt 1655 d. 4 Apr 1688
3
George Dabney
[1.1.4]
b. 11 Sep 1653 d. 24 Oct 1729
Elizabeth Anderson
b. 7 Aug 1665 d. 8 Sep 1739
4
Sarah Dabney
[1.1.4.1]
b. 16 May 1695 d. 17 Apr 1767
William "Langloo" Winston
b. 12 Apr 1702 d. 1760
5
Mary Ann Winston
[1.1.4.1.1]
b. Abt 1735
John Walker
6
Benjamin Walker
[1.1.4.1.1.1]
6
John Walker
[1.1.4.1.1.2]
6
Frances Walker
[1.1.4.1.1.3]
6
Edmund Walker
[1.1.4.1.1.4]
5
Elizabeth Louise Winston
[1.1.4.1.2]
b. 17 Dec 1734 d. Abt 1772
Jr. Peter Fontaine, Jr
b. 15 Sep 1724 d. 1772
6
John Smith Fontaine
[1.1.4.1.2.1]
b. 6 Aug 1750 d. 14 Apr 1792
Martha "Patsy" Henry
b. Jun 1755 d. Oct 1818
7
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.4.1.2.1.1]
b. 30 Jan 1779 d. Jan 1818
+
Anne Carrington
b. 9 Nov 1787
7
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2]
b. 22 Feb 1775 d. 2 Oct 1852
Nancy Dabney Miller
b. 16 Aug 1775 d. 5 Jun 1862
8
Nancy Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.1]
b. 10 Dec 1802 d. 8 Sep 1856
John Thomas Brooks
d. 1872
9
John Fontaine Brooks
[1.1.4.1.2.1.2.1.1]
b. Cal 1844 d. 21 Jan 1918
10
Jr. John Fontaine Brooks
[1.1.4.1.2.1.2.1.1.1]
b. 19 Sep 1887
8
Elizabeth Louisa Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.2]
b. 17 Sep 1804 d. 1892
Edmund Dabney Winston
b. 17 Sep 1799 d. 21 Sep 1875
9
Nancy Miller Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.1]
b. 5 Mar 1825
+
Oliver H. Black
9
John Dabney Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.2]
b. 21 Feb 1822
9
William Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3]
b. 21 Jul 1828 d. 13 Aug 1878
Emma Eloise Furr
b. 1842 d. 9 Feb 1892
10
Edmund Tobias Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.1]
b. 22 Jul 1871 d. 26 Dec 1944
Florence Theresa Seale
b. 9 Feb 1876 d. 28 Jun 1959
11
Eloise Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.1.1]
b. 7 Mar 1899
Ozeph Chester Taylor
b. 1 Jul 1867
12
Edmund Warren Taylor
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.1.1.1]
[
=>
]
12
Dorothy Eloise Taylor
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.1.1.2]
[
=>
]
10
Galen Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.2]
b. 8 Feb 1873 d. 1928
+
Aurelia Odile Despommer
10
Masina Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.3]
b. 28 Aug 1875 d. 1928
+
Henry Henesler
9
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.4]
b. 8 Mar 1831 d. 1852
9
George Dabney Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.5]
b. 17 Sep 1833
+
Mrs. Iola Overton
9
Patrick Fontaine Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.6]
b. 5 Mar 1845 d. 1 Apr 1906
8
John Dabney Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.3]
b. 26 Mar 1799 d. 17 Feb 1822
8
Sally Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.4]
b. 28 Jan 1801 d. 27 Jul 1804
8
Charles D. Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.5]
b. 7 Nov 1806 d. 23 Apr 1807
8
Edward Benjamin Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6]
b. 5 Aug 1814 d. 19 Jan 1884
Mary Ann "Nancy" Swisher
b. 7 Jan 1821 d. 13 Jul 1855
9
Edward Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.1]
b. 4 Aug 1849
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2]
b. Abt 1845 d. 16 Mar 1888
Mary "Molly" Elizabeth Meade
b. Abt 1850 d. 29 Jun 1889
10
Mary Bogard "Bertie" Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1]
b. 8 Dec 1869
Henry Dick Lester
b. 17 Apr 1842
11
Houston Fontaine Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.1]
Georgia Gordon
12
Gayle Elliott Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.1.1]
[
=>
]
12
Alan Maury Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.1.2]
[
=>
]
12
Clayton Fontaine Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.1.3]
11
Henry Dick Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2]
Sarah Stewart Thornton
12
Jr. Henry Dick Lester, Jr
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2.1]
[
=>
]
12
James Owen Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2.2]
12
Judith Ann Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2.3]
12
Mary Kathleen Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2.4]
[
=>
]
11
Maury Todd Fontaine Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.3]
b. Abt 1910
11
Ann "Annie" Fontaine Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.4]
b. 5 Jul 1898
10
William Meade Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.2]
b. Mar 1871
11
John Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.2.1]
10
Annie Meade Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3]
b. Abt 1872
Joseph Gibson Ford
b. 18 Dec 1874 d. 13 Oct 1927
11
Minnie K Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.1]
b. 1906
+
Taylor
11
Alva Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.2]
b. 1908
+
Traylor
11
Joseph Gibson Ford, Jr.
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.3]
b. 1903
Helen Ford
b. Abt 1908
12
Helen A Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.3.1]
12
Betty J Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.3.2]
11
William F Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.4]
b. 1904
10
Louisa Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.4]
b. Feb 1880
10
Edward Meade Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.5]
9
Jacques Mirabeau Bonaparte Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3]
b. 11 Oct 1841 d. 1 Oct 1921
Llemuella Smith Brickell
b. 7 May 1843 d. 7 Jan 1922
10
James Francis Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.1]
b. 25 Jul 1875
Teen Ratliff
11
Jeanie Katherine Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.1.1]
+
Edward Maddox Stubblefield
d. 4 Jun 1962
11
James Francis Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.1.2]
11
Mary Elizabeth Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.1.3]
10
Annie Gale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.2]
b. 26 Feb 1877 d. 28 Jul 1907
+
A. L. Chapman
10
Llemuella Moore Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3]
b. 11 Jul 1879
Alexander Smith
11
Jeanie Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.1]
b. 20 Oct 1897 d. 26 Jul 1907
11
Elizabeth Brickell Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2]
b. 2 Dec 1899
Charles M. Henderson
12
Charles Henderson
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2.1]
b. 1 Jan
12
Mary Jane Henderson
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2.2]
12
L'Moore Patricia Henderson
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2.3]
12
Barbara Ann Henderson
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2.4]
11
Alexander Moore Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.3]
11
Robert Grey Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.4]
Beatrice Jones
12
Alice Montelle Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.4.1]
[
=>
]
12
Ross Alex Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.4.2]
Inez
12
Frances Louise Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.4.3]
11
Lamar Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.5]
Carolyn Lipscom
12
Carolyn Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.5.1]
[
=>
]
12
Sara Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.5.2]
11
Evander Frierson Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.6]
Alice Hall
12
Evander Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.6.1]
12
Phyllis Elenis
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.6.2]
11
Troy Cheairs Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.7]
12
Mary Lee Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.7.1]
11
L'Moore Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.8]
Dale Alford
12
Dale Alford
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.8.1]
12
Anne Maury Alford
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.8.2]
12
L'Moore Fontaine Alford
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.8.3]
10
Henry Boursuoine Brickell Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4]
b. 1 Apr 1868
Idonda Hate
b. 1 Jul 1873 d. 13 Jun 1898
11
Mary Ella Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1]
b. 10 Feb 1892
Guy H. Price
12
Jeanella Frances Price
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1.1]
12
George Hartwell Price
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1.2]
12
Mary Fontaine Price
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1.3]
[
=>
]
12
Charles Henry Guy Price
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1.4]
11
Jr. Henry Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.2]
b. 16 Sep 1894
Frances Elizabeth Swenn
b. 14 Nov 1893
12
Henry Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.2.1]
b. 29 Sep 1921 d. Jan 1922
12
Charles Temple Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.2.2]
12
Mary Elizabeth Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.2.3]
11
Edward Armstrong Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.3]
b. 8 Dec 1895
10
Edward Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.5]
b. 22 Feb 1871
Rebecca Cheatham Barksdale
11
William Barksdale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.5.1]
Helen Mosal
12
Jr. William Barksdale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.5.1.1]
12
Judith Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.5.1.2]
10
Mary Agnes Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.6]
b. 23 Apr 1874
John S. Mays
11
John Fontaine Mays
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.6.1]
b. 19 Sep 1900
Anne Duvall
12
John Terriberry Mays
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.6.1.1]
12
David Duvall Mays
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.6.1.2]
10
Jeanie Wilson Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.7]
b. 25 Aug 1869
10
Jr. Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8]
b. 26 Mar 1882 d. 1 Aug 1934
Kathryn Mary Martin
11
Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.1]
+
Patricia
11
Kathryn Martin Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.2]
Frank Gotch
12
Fontaine Gotch
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.2.1]
12
Faith Gotch
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.2.2]
12
Frank Robert Gotch
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.2.3]
Mrs. Susan Catherine Britton
b. 1829 d. 28 May 1908
9
John Eaton Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4]
b. 12 Dec 1860 d. 20 Aug 1908
Adelle Armenta Stokes
b. 22 Dec 1844 d. 14 Feb 1923
10
John Eaton Fontaine, Jr.
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1]
b. 23 Jul 1889 d. 29 Aug 1962
Sydney Hosford Latimer
11
III John Eaton Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.1]
Eleanor Anne Haldeman
12
Anne Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.1.1]
12
Martha Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.1.2]
12
IV John Eaton Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.1.3]
[
=>
]
11
Douglass Latimer Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.2]
Bertha Van Landingham
12
Jr. Douglass Latimer Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.2.1]
[
=>
]
12
Rebecca VanLandingham Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.2.2]
[
=>
]
12
Patrick Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.2.3]
+
Alice Louise Jamison
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.5]
b. 15 Dec 1869 d. 10 Jan 1959
+
Ernestine Doll
9
Susan Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.6]
b. Cal 1865
+
F. R. Sawyer
8
Mary Boursiquot Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.7]
b. 13 Jun 1808 d. 27 May 1891
Jesse Perkins
b. 29 Mar 1798 d. 27 Nov 1872
9
Arthur Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1]
b. 29 Nov 1844 d. 4 Jul 1909
Annie Laurie Shotwell
b. 15 Jan 1851 d. 18 Jul 1911
10
Ellen Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.1]
b. 8 May 1875
10
Annie Shotwell Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.2]
b. 1882
Arch M. Crump
11
Anne Perkins Crump
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.2.1]
b. 31 Jul 1916 d. 24 Dec 1962
Leighton Smylie Miller
12
George Crump Miller
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.2.1.1]
[
=>
]
10
Laura Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.3]
b. 29 Dec 1871
10
Jessie C. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.4]
b. 1888
+
McDonald
9
Virginia Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.2]
b. 12 Jan 1831 d. 5 Jun 1905
Frisby Augustin Freeland
d. 1857
10
Mary Fontaine Freeland
[1.1.4.1.2.1.2.7.2.1]
b. 27 Oct 1853 d. 1912
10
Thomas Freeland
[1.1.4.1.2.1.2.7.2.2]
b. 6 Nov 1856 d. 1910
+
Jennie Wilkerson
+
Andrew Dewees Banks
b. 6 Jan 1833 d. 21 Jul 1881
9
Jessie Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.3]
b. 19 Feb 1848 d. 14 Dec 1902
James Brownlow Yellowley
b. 17 Oct 1848 d. 6 Jun 1914
10
Edward Clements Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.1]
b. 12 Aug 1873
+
Callie Hays
10
Maury Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2]
Joanna Willcoxen
11
Julia Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.1]
James Majors
12
Joanna Fontaine Majors
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.1.1]
12
James Franklin Majors
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.1.2]
11
Jessie Fontaine Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.2]
Will Wilkerson
12
Wllliam Archer Wilkerson
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.2.1]
12
Robert Fontaine Wilkerson
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.2.2]
12
Maury Archer Wilkerson
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.2.3]
10
Jesse Perkins Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.3]
b. 23 Oct 1882
Maggie Bell McCall
11
Jr. Jesse Perkins Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.3.1]
11
Edward Clements Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.3.2]
10
James Brownlow Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.4]
b. 12 Sep 1879
+
Margaret
10
Mary Fontaine Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.5]
10
Douglas Crittenden Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.6]
9
Mary Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.4]
b. 29 Dec 1832 d. 3 Aug 1892
Abner Green Gale
10
Jessie Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.1]
b. 1859
+
Marcy Johnson
10
Thomas Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2]
b. 23 Feb 1857 d. 24 Sep 1934
Anne Sue Thornton
11
Freeland Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.1]
b. 15 Jul 1888 d. 28 Mar 1945
Ethel Richardson
12
Mary Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.1.1]
[
=>
]
12
Jean Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.1.2]
[
=>
]
11
Gertrude Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.2]
b. 21 Jun 1890 d. 14 Dec 1969
Charles Edward McDonnell
12
William Thornton McDonnell
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.2.1]
12
Charles Edward McDonnell
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.2.2]
[
=>
]
11
Ada Thornton Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.3]
b. 24 Apr 1887 d. 30 Jul 1887
11
William Thornton Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.4]
b. 24 Apr 1892 d. 27 Dec 1894
11
Douglas Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.5]
b. 24 Jul 1894 d. 24 Nov 1916
11
Sidney Moore Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.6]
b. 24 Mar 1896 d. 1896
11
Mary Perkins Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.7]
+
William Graham Cline
10
Jennie Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.3]
10
Ida Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.4]
9
Nancy Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.5]
b. 1835 d. 1835
9
James Lawrence Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6]
b. 3 Aug 1841 d. 8 Sep 1914
Mathilda Jane Sillers
b. 1856 d. Aug 1888
10
Jr. James Lawrence Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.1]
b. 1882
Alice Smith
11
James Edward Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.1.1]
Felice
12
Douglas Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.1.1.1]
12
Steven Ernest Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.1.1.2]
[
=>
]
10
Arthur Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.2]
b. 1880 d. 1882
10
Mary Belle Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3]
b. 9 Apr 1884 d. 1 May 1969
Wallace Bruce Colbert
b. 18 Mar 1877 d. 19 Jan 1936
11
Dorothea Spottswood Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.1]
11
Ella Jeanne Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.2]
11
Anita Perkins Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.3]
12
R. J. Whitley
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.3.1]
11
James Perkins Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.4]
11
Mary Belle Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.5]
10
Anna Mathilda Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.4]
+
Oscar Pate
10
Edgar Allen Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.5]
b. Dec 1896 d. CHILD
10
Ione Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.6]
b. Jan 1891 d. Abt 1910
Florence F. Mayfield
b. Jun 1856
10
Jr. James Lawrence Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.7]
b. 1882
Alice Smith
11
James Edward Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.7.1]
Felice
12
Douglas Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.7.1.1]
12
Steven Ernest Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.7.1.2]
[
=>
]
10
Edgar Allen Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.8]
b. Dec 1896 d. CHILD
10
Ione Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.9]
b. Jan 1891 d. Abt 1910
8
Martha Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.8]
b. 9 Mar 1798 d. 20 Dec 1881
William H. Perkins
b. 2 Aug 1800 d. 31 Jan 1871
9
Cowan Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.1]
b. 1834
9
John Dabney Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2]
b. 14 Mar 1831 d. 1 Feb 1917
Julia Franklin Brown
b. 28 Aug 1843 d. 11 Sep 1928
10
Elbert West Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1]
b. 1 Oct 1867 d. 16 Oct 1938
Jessie Elizabeth Muir
b. 3 Jul 1872 d. 27 Jan 1955
11
Erwin Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.1]
Gladys Myrtle Brown
12
Evelyn Elizabeth Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.1.1]
[
=>
]
11
Waldo Muir Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.2]
Jeanette "Nettie" Julia Jones
12
Barbara Lee Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.2.1]
[
=>
]
11
Marjorie A. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.3]
b. Apr 1897 d. 13 Nov 1928
Clair Barnhart Fish
b. 23 Aug 1898 d. 25 Sep 1970
12
Marion C. Fish
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.3.1]
[
=>
]
12
Jean Adrene Fish
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.3.2]
10
Martha "Mattie" Warren Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2]
b. 27 Sep 1861 d. 19 Sep 1944
Alfred Edwin Smith
b. 25 Dec 1857 d. 20 Aug 1939
11
Edwin Fordt Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.1]
Lila Elizabeth Oliver
12
Barbara Mae Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.1.1]
[
=>
]
12
Lyle Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.1.2]
11
Alma Louise Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.2]
b. 11 Oct 1893 d. 9 Apr 1937
Harry Bishop Taylor
b. 15 Apr 1887 d. 1 Dec 1966
12
Garth Bishop Taylor
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.2.1]
12
Robert F Taylor
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.2.2]
11
Elbert Perkins Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.3]
b. 20 Sep 1885 d. 18 Oct 1972
Bertha Maude Taylor
12
Donald Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.3.1]
b. Abt 1908
12
Virgil Wesley Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.3.2]
12
Warren Taylor Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.3.3]
[
=>
]
11
Ira Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.4]
b. 2 Oct 1887 d. 23 Dec 1963
+
Bertha Fisher McKean
b. 26 Sep 1893 d. 30 Jan 1960
10
John William Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.3]
b. 18 Jul 1860 d. Feb 1870
9
Edward Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3]
b. 13 Sep 1833 d. 4 Apr 1905
Jennie F. Garrett
b. 4 Oct 1838 d. 14 Aug 1874
10
W. Clyde Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.1]
b. 28 Nov 1867 d. 11 Apr 1869
10
Thomas Ira Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.2]
b. 3 Apr 1870 d. 14 May 1876
10
Jr. Edward Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.3]
b. 12 Feb 1873 d. 21 Sep 1873
10
Lillard Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.4]
b. Abt 1860 d. Aft 1892
10
Edna May Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.5]
b. Abt 1865 d. Aft 1880
10
Fontelle L Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.6]
b. Abt 1863 d. Aft 1880
10
Jennie Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.7]
b. 20 Jul 1874 d. 20 Jul 1874
Sarah Catherine "Kate" E McNeiley
b. Sep 1842 d. 24 Sep 1931
10
Annie Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.8]
b. 4 Aug 1877 d. 11 Jun 1964
+
McMichael
9
Patrick Henry "Park" Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4]
b. 22 Jan 1829 d. 14 Apr 1910
Mary Jane Guthrie
b. Between 1836 and 1837 d. 1 Mar 1865
10
Fannie Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.1]
b. 12 Oct 1867 d. 20 Feb 1908
10
William Flood Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.2]
b. 1872 d. 1930
10
Charles Edgar Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.3]
b. Abt 1858
10
Lula Eliza Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.4]
b. Abt 1860
George D. Pruit
11
Adie Jouett Pruit
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.4.1]
10
Burton Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.5]
10
Henry Olean Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.6]
10
Robert Lee Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.7]
10
II William Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.8]
Martha Ann Flood
b. 7 Sep 1840 d. 25 Apr 1914
10
Fannie Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.9]
b. 12 Oct 1867 d. 20 Feb 1908
10
Minneola Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.10]
b. Abt 1869
+
George Bloom
10
William Flood Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.11]
b. 1872 d. 1930
10
Charles Edgar Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.12]
b. Abt 1858
10
Burton Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.13]
10
Henry Olean Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.14]
10
II William Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.15]
9
Louisa Ann Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.5]
b. 18 Jun 1825 d. 25 Aug 1852
Benjamin Franklin Crawley
b. 16 Sep 1822 d. 1900
10
Martha Henry Crawley
[1.1.4.1.2.1.2.8.5.1]
b. 23 Mar 1847 d. 18 Oct 1920
+
Nathaniel Cyrus Dryden
b. 23 Jan 1873 d. 21 Sep 1915
+
Nathaniel C Dryden
b. Dec 1844
10
Henry Wayne Crawley
[1.1.4.1.2.1.2.8.5.2]
b. Apr 1852
Mary
11
Rosalie Crawley
[1.1.4.1.2.1.2.8.5.2.1]
10
Lena E Crawley
[1.1.4.1.2.1.2.8.5.3]
b. Jul 1862
9
Rosalie Spottswood Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.6]
b. 11 Mar 1839 d. 17 Jan 1909
+
John H. Bradley
9
Mary Lightfoot Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.7]
b. 5 Sep 1836 d. 18 Apr 1904
John McNaught Home
b. 1830 d. 1865
10
Lewis Olean Home
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.1]
b. 1856
Eliza Jane Moore
b. 1859
11
Frances Ralston Home
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.1.1]
b. 21 Jun 1888
+
Guy R. Stowell
b. 31 May 1888
11
Mary Catherine Home
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.1.2]
+
Lewis Reed
David Irvine Stephenson, M.D.
b. 14 Aug 1829 d. 1901
10
Rosalie I. Stephenson
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.2]
b. 25 Oct 1872 d. 3 Mar 1936
Frank Thomas Ransom
b. 25 Jun 1873 d. 9 Oct 1950
11
Mary Margaret "Marg" Ransom
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.2.1]
9
William Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.8]
b. 6 Oct 1841 d. 10 Aug 1861
9
Charles Archelaus Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9]
b. 28 Apr 1827 d. 18 May 1904
Eusebia M. Strange
b. 16 Sep 1825 d. 16 Dec 1915
10
James M. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.1]
b. Aug 1857
Mary (Molly) F
b. Dec 1864
11
Jerimy Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.1.1]
b. Jun 1894
11
William C Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.1.2]
b. Oct 1889
11
Mary Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.1.3]
b. Aug 1891
10
Mary Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.2]
b. 1850
10
William Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.3]
b. 1851 d. Bef 17 Jul 1860
10
Annie Louise Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.4]
b. 1855
Benjamin Allen
11
Clarence Allen
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.4.1]
10
Archelaus Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.5]
b. Jan 1860
10
Sallie Mitchell Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6]
b. 15 May 1861 d. Nov 1938
Talbot McNeiley
b. Abt 1860 d. Dec 1941
11
Susan Deette McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.1]
b. 1902 d. 1965
11
Rosalie Cordelia McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.2]
Kenneth R. Miner
12
Mildred Alene Minor
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.2.1]
11
Neville Sperry McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.3]
Joseph Martin Nord
12
Mac D. Nord
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.3.1]
12
Edwin J. Nord
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.3.2]
11
Winifred McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.4]
b. 23 Dec 1889 d. 10 May 1964
+
Glen Edwin Stover
11
Charles Thomas McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.5]
b. 14 Oct 1888 d. 25 Jul 1965
+
Frances Creason
11
Naomi Catherine McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.6]
b. Mar 1882 d. 1965
11
Norman McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.7]
b. Abt 1881
10
Henry S. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.7]
b. 20 Aug 1857 d. 10 Nov 1939
F. H.
11
Charles N. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.7.1]
b. 17 Jan 1882 d. 30 Aug 1882
+
John Overton Redd
b. 1788 d. 1858
8
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9]
b. 28 Dec 1817 d. 20 Aug 1871
Sarah Ann "Sally" Dandridge
b. 1823 d. Aft 1880
9
Charles Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.1]
b. 1846
9
John Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2]
b. 14 Aug 1841 d. 3 Sep 1925
Sarah Amanda "Dallie" Duncan
b. Jul 1849 d. Nov 1940
10
John Brooks "Little Jack" Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1]
b. 14 Oct 1871 d. 13 Aug 1967
Catherine English Crawford
11
Charles English Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1.1]
Grace May Fleming
12
Charles English Fontaine, Jr.
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1.1.1]
12
Margaret Crawford Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1.1.2]
11
Jack Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1.2]
10
Charles De La Bouley Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.2]
b. 26 Oct 1873 d. 20 Oct 1916
10
Andrew Duncan Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.3]
b. 21 Oct 1875 d. 5 May 1954
10
Maury Blackwell Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.4]
b. Jun 1879 d. 1946
9
Mary Chaillon Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.3]
b. 1852 d. 1933
9
Bettie Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.4]
b. 1854
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.5]
b. 1855 d. 1896
9
Sarah M "Sally" Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.6]
b. 1857 d. 1943
9
Francis Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.7]
b. 14 Feb 1843 d. 8 Aug 1844
9
Frances Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.8]
b. 14 Mar 1845 d. 29 Oct 1845
9
Ann Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.9]
b. 27 Feb 1848 d. 19 May 1849
9
Benjamin Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.10]
b. Abt 1849 d. 15 Jun 1931
9
Edward Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.11]
b. 26 Oct 1858 d. 9 Apr 1859
9
Martha "Patty" S Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.12]
b. 1862
7
William Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3]
b. 25 Nov 1786 d. 1816
Martha Hale Dandridge
b. 23 Sep 1795 d. 7 Apr 1875
8
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1]
b. 18 May 1813 d. 3 Nov 1845
Sarah Miller Cole
b. 14 Feb 1815 d. 2 Mar 1892
9
Samuel Cole Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1]
b. 1 May 1835 d. 3 Jun 1891
Mary Morton Anderson
b. 16 Apr 1852 d. 9 Jan 1904
10
Robert Anderson Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.1]
b. 7 Mar 1879 d. 1955
Genevieve Kearfott
11
Nancy Herr Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.1.1]
b. 13 Aug 1916 d. 30 Jun 1947
10
William Hale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.2]
b. 7 Mar 1882 d. 1883/1972
10
Jr. Samuel Cole Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.3]
b. 1883 d. 1884/1973
10
Justina Cole Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.4]
b. 1887 d. 1969
+
Arthur B. Richardson
b. 1882 d. 1903/1973
9
Watson Hale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.2]
9
Nathaniel Cole Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.3]
9
Katherine Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.4]
Overton Redd Wootton
b. 1837
10
Eva Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.1]
10
Nora Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.2]
10
Lucy Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.3]
10
Sallie Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.4]
10
Maude Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.5]
10
Nathaniel Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.6]
10
William Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.7]
10
John Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.8]
10
Hale Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.9]
9
Unity Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.5]
+
Edward Estes
8
Anne Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.2]
b. 1810/1838 d. 1807/1918
8
William Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3]
b. 7 Nov 1810 d. 1882
Sarah Shelton Aylett
b. 24 Jun 1811 d. 5 Mar 1875
9
Sarah Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.1]
b. 18 Jan 1848
Henry Sampson
b. 10 Mar 1847 d. 18 Sep 1915
10
Cornelia Dandridge Sampson
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1]
b. 1 Apr 1874 d. 13 Sep 1903
Malcolm Graham
b. Feb 1865
11
Sarah Aylett Graham
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.1]
Frank W. Simpson
12
Jr. Frank W. Simpson
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.1.1]
12
Geary Graham Simpson
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.1.2]
[
=>
]
12
William A. Simpson
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.1.3]
+
Powell
11
Malcolm Montrose Graham
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.2]
b. 16 Sep 1898
9
William Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2]
b. 27 Nov 1834 d. 2 Nov 1917
Mary Adelaide Burrows
b. 4 Jan 1838 d. 28 Mar 1887
10
Elizabeth Adelaide Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.1]
b. 6 Jan 1873 d. 19 Nov 1916
10
John Lansing Burrows Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.2]
b. 18 Jun 1868 d. 11 May 1913
+
Elizabeth Rose Waggener
b. 12 Apr 1870 d. 9 Oct 1925
10
William Winston Spottswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.3]
b. 16 Mar 1870 d. 19 Aug 1939
Florence West Evans
b. Mar 1877 d. 21 Jan 1928
11
Evan-Burrows Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.3.1]
Cornelius Vanderbilt Whitney
12
Neil “Sonny” Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.3.1.1]
[
=>
]
+
Sterling Lawrence Adair
b. 18 Dec 1894 d. 14 Jan 1921
Harold “Stubby” Herman Kruger
b. 23 Sep 1898 d. 7 Oct 1965
12
Robert "Bobby" Kruger
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.3.1.2]
+
Jack Lynch
+
Mabel Kathleen Lawrence
b. Abt 1890
10
William Spottswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.4]
b. 27 Feb 1862 d. 28 Jul 1863
10
Mary Aylett Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.5]
b. 13 May 1866 d. 8 Aug 1933
10
Marion Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.6]
b. 10 Jan 1880 d. 10 Jan 1880
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3]
b. 1841 d. 1915
Annie Elizabeth Redd
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.1]
10
James Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.2]
b. 1888
10
John Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.3]
b. 1887
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.1]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.1.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.1.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.1.3]
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.2]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.3]
b. 3 Dec 1897
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.4]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.4.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.4.2]
11
John Winston Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.5]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.5.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.6]
11
William Fontaine Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.7]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.8]
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.5]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.6]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.7]
b. 1879
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.8]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.9]
b. 1877
9
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.4]
b. 1838 d. 1856
9
Philip Aylett Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.5]
b. 1845 d. 1862
9
Marian Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.6]
b. 19 May 1840 d. 1913
+
John Hairston Redd
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
9
Alexander Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.7]
b. Abt 1836 d. CHILD
9
Elizabeth Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.8]
b. 28 Jun 1833
+
Elizabeth Henry Aylett
b. Nov 1798 d. 14 Nov 1818
8
Sarah Ann Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4]
b. 5 Nov 1815 d. 9 Feb 1909
Edmund Burwell Redd
b. 4 Jun 1808 d. 10 Aug 1850
9
James Smith Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.1]
b. Abt 1841
Sarah Hairston
10
Annie Spotswood Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.1.1]
+
John G. Hulsbush
10
Pocahontas Cabel Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.1.2]
+
Norman Thomas Mallonee
9
Celeste Tunstall Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.2]
b. Abt 1843
Samuel Pickney Caldwell
10
Alice Brandon Caldwell
[1.1.4.1.2.1.3.4.2.1]
9
Annie Elizabeth Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.3]
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
Patrick Henry Fontaine
b. 1841 d. 1915
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.1]
10
James Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.2]
b. 1888
10
John Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.3]
b. 1887
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.1]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.1.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.1.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.1.3]
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.2]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.3]
b. 3 Dec 1897
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.4]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.4.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.4.2]
11
John Winston Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.5]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.5.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.6]
11
William Fontaine Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.7]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.8]
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.5]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.6]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.7]
b. 1879
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.8]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.9]
b. 1877
9
William Spotswood Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4]
b. 1 Mar 1839 d. 1 Nov 1909
Mary Taylor Wootton
b. 27 Aug 1844 d. 26 Apr 1918
10
Ella Spotswood Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1]
b. 5 Oct 1872 d. 25 Mar 1932
Richard Wordsworth Fischer
11
Grace Brown Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.1]
Frank Beauregard Jenkins
b. Abt 1906 d. Abt 1950
12
Grace Jenkins
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.1.1]
11
Spotswood Redd Gill Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.2]
b. 5 Apr 1896 d. Abt Jun 1923
11
Jr. Richard Wordsworth Fischer, Jr
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.3]
b. 7 Sep 1897 d. 24 Mar 1937
11
Caroline Dorothea Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.4]
IV Jesse Marden
b. 18 Jan 1906 d. 4 Jul 1962
12
Ann Marden
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.4.1]
11
John Gill Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.5]
b. 3 Feb 1901 d. 2 Jan 1950
+
Grace Elizabeth Shelfer
b. 2 Feb 1908 d. 8 Apr 1961
11
Mary Elizabeth Redd Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.6]
+
James Everett Sanner
b. 15 Jul 1896 d. Oct 1968
11
Ann Franklin Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.7]
b. 8 Sep 1905 d. Abt 1909
11
Martha Redd Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.8]
+
Frank Lewis
11
Lucinda Reamey Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.9]
b. 1 Jan 1907 d. 4 Nov 1960
+
Carl Hubbard
+
Ralph Ray Jack Williams
11
Louis Christian Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.10]
11
Matthew Redd Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.11]
b. Abt 1911 d. Bef 1920
10
Lucinda Dabney Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.2]
b. 1 Sep 1866 d. 9 Nov 1912
10
II Edmund Burwell Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.3]
b. 23 Feb 1868 d. CHILD
10
Martha Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.4]
b. 19 Sep 1870 d. 9 Nov 1933
+
Overton Reamey
d. Abt 1898
+
Jack B. Walker
b. 1 Jun 1859
10
Sarah Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.5]
b. 5 Oct 1872 d. 20 Jul 1873
9
John Hairston Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.5]
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
+
Marian Dandridge Fontaine
b. 19 May 1840 d. 1913
9
Mary Dandridge Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.6]
b. 8 Jan 1837 d. 10 Sep 1888
John Wayt
b. Abt 1831
10
Martha "Mattie" Frances Wayt
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1]
b. Jun 1874 d. Feb 1926
William Augustus Osborne
b. 15 Dec 1869 d. Jul 1942
11
Frances West Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.1]
Hiram Oscar Kerns, Jr
b. 24 May 1893 d. 5 Oct 1964
12
Elizabeth Osborne Kerns
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.1.1]
12
Hiram Oscar Kerns, III
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.1.2]
[
=>
]
12
Edward Johnson Kerns
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.1.3]
[
=>
]
11
William Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.2]
b. Abt 1908
11
Marion Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.3]
b. Abt 1908
11
Dorothy Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.4]
b. Abt 1910
11
Elizabeth Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.5]
b. Abt 1904
11
Mary Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.6]
b. Abt 1898
11
Kate Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.7]
b. Abt 1901
9
Edmund Madison Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.7]
b. 18 Dec 1844 d. 2 Oct 1928
+
Anna Richardson
b. Abt 1859 d. Abt 1929
9
Martha Catherine Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.8]
b. 3 Apr 1833 d. 15 Sep 1913
+
John Francis Wootton
b. Abt 1827 d. Abt 1888
9
Ella E. Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.9]
b. Abt 1849 d. Abt 1919
+
Francis Watlington
b. Abt 1847 d. Abt 1917
7
Martha Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.4]
b. 4 Jul 1781 d. 12 Sep 1845
II Nathaniel West Dandridge
b. 14 Jan 1771 d. 26 Jul 1847
8
III Nathaniel West Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.1]
b. 1824
Harriett A. Wylie
b. Abt 1828 d. 1815/1910
9
William B. Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.1.1]
b. Abt 1853
9
Mary Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.1.2]
b. Abt 1849
8
William Fontaine Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2]
b. 1804
Susan C. Stith
b. Abt 1809 d. 1830/1898
9
Catherine Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.1]
b. Abt 1826
9
John W. Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.2]
b. Abt 1829
9
Mona H. Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.3]
b. Abt 1835
9
Morrison Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.4]
b. Abt 1838
9
Spotswood Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.5]
b. Abt 1841
8
Charles Fontaine Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.3]
b. 1806 d. 1866
Tabitha Ann McGee
b. 1794/1829 d. 1815/1910
9
McGee Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.3.1]
d. 7 Apr 1861
8
Henry Bolling Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4]
b. 1823 d. Aft 1885
Caroline Wylie
9
Mary Jane Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.1]
b. Abt 1829
9
Zelia Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.2]
b. Abt 1832
+
E. H. Lewis
9
Matilda Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.3]
b. Abt 1834
9
Elizabeth Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.4]
b. Abt 1836
+
William P. Ome
9
Martha Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.5]
b. Abt 1838
9
Bolling Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.6]
b. Abt 1839
Adeline Kenon Wilbourn
b. 1818/1843 d. 1865/1931
9
Lightfoot Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.7]
b. 17 Apr 1874 d. 13 Dec 1928
Henry Woodson Baker
b. 26 Jan 1859 d. 24 Dec 1929
10
Katie Jenkins Baker
[1.1.4.1.2.1.4.4.7.1]
Marvin N. Fogleman
11
Mary Kate Fogleman
[1.1.4.1.2.1.4.4.7.1.1]
Thomas Dove Copeland
12
Connie Sue Copeland
[1.1.4.1.2.1.4.4.7.1.1.1]
[
=>
]
12
Sharon Diane Copeland
[1.1.4.1.2.1.4.4.7.1.1.2]
[
=>
]
9
Nannie Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.8]
b. 1844/1872 d. 1849/1954
9
Jr. Henry Bolling Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.9]
b. 1844/1872 d. 1850/1951
8
Rosalie Spotswood Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.5]
b. 1825 d. 1898
+
William Daugherty Bradford
b. 1785/1820 d. 1811/1900
8
Martha Lightfoot Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.6]
b. 1821 d. 3 Jun 1850
Richard Bolton
b. 1785/1820 d. 1811/1900
9
William Bolton
[1.1.4.1.2.1.4.6.1]
8
Eliza Ann Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.7]
b. 1800 d. 1855
+
William Herford
b. 1765/1797 d. 1822/1884
7
John James Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5]
b. 1788 d. 3 Jan 1852
Mary Carr Redd
b. 5 Dec 1794 d. 26 Sep 1837
8
Mary Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5.1]
b. Abt 1815
James Edward Waller
9
John Fontaine Waller
[1.1.4.1.2.1.5.1.1]
b. 1842 d. 1909
Martha Malone
10
Mary Alice Waller
[1.1.4.1.2.1.5.1.1.1]
b. 1872 d. 1954
+
David Alexander Shepard
b. 1879 d. 1959
8
Madison Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5.2]
b. 1824 d. 1891
Elizabeth Gillespie
b. 1836
9
Martha Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5.2.1]
b. Sep 1873
+
Robert Willis Flournoy
b. 22 Sep 1867
9
Elizabeth Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5.2.2]
+
Walter C. Harris
7
Edward Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.6]
b. 12 Feb 1776 d. 12 Feb 1792
7
Dorothea Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.7]
b. 1791 d. 1793
6
Edmund Fontaine
[1.1.4.1.2.2]
b. 1754 d. 1759
6
Sarah Fontaine
[1.1.4.1.2.3]
b. 1755 d. 1776
Charles Rose
b. Abt 1751
7
Alexander Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.3.1]
b. 1780 d. 1831
Sarah Rose Fontaine
b. 21 Sep 1796 d. 1863
8
Lawrence Berry Rose
[1.1.4.1.2.3.1.1]
b. 1821 d. 1877
Eliza Welford
9
Jr. Lawrence Berry Rose
[1.1.4.1.2.3.1.1.1]
9
Susan Welford Rose
[1.1.4.1.2.3.1.1.2]
8
Edmund Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2]
b. 1817 d. 1893
Betty Maury
9
Alexander Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2.1]
9
John Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2.2]
9
Robert Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2.3]
9
Sarah Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2.4]
8
Charles Alexander Rose
[1.1.4.1.2.3.1.3]
b. 1823 d. 1875
+
M. Rutherford
Logie Childs
9
Rutherford Rose
[1.1.4.1.2.3.1.3.1]
9
Hugh Rose
[1.1.4.1.2.3.1.3.2]
9
Charles Rose
[1.1.4.1.2.3.1.3.3]
8
Louisa Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.3.1.4]
b. 1819 d. 1891
John Potts
9
Rose Potts
[1.1.4.1.2.3.1.4.1]
9
Douglas Potts
[1.1.4.1.2.3.1.4.2]
9
Morris Templin Potts
[1.1.4.1.2.3.1.4.3]
9
Elizabeth Hawley Potts
[1.1.4.1.2.3.1.4.4]
7
Peter Rose
[1.1.4.1.2.3.2]
7
Sarah Elizabeth Rose
[1.1.4.1.2.3.3]
7
John Rose
[1.1.4.1.2.3.4]
6
Mary Ann Fontaine
[1.1.4.1.2.4]
b. Abt 1759 d. 5 Apr 1799
Bowles Armistead
b. 1752 d. Bef 21 Jun 1785
7
Peter Fontaine Armistead
[1.1.4.1.2.4.1]
b. 1778 d. 1866
Martha Fontaine Winston
b. 7 Jul 1784 d. 3 Aug 1870
8
Peter Fontaine Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.1]
8
Patrick Henry Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.2]
+
Clanton
8
Isaac Coles Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.3]
8
Eliza Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.4]
8
Virginia Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.5]
+
Lanier
8
George Washington Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.6]
8
Mary Anne Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.7]
8
Martha Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.8]
8
William Bowles Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.9]
7
Elizabeth Armistead
[1.1.4.1.2.4.2]
b. 1780
Ludwell Lee
b. 1761 d. 1836
8
Eliza A. Lee
[1.1.4.1.2.4.2.1]
b. 1807
Jr. Wilson Cary Selden
9
Eleanor Love Selden
[1.1.4.1.2.4.2.1.1]
+
John Augustine Washington
b. 3 May 1821 d. 13 Sep 1861
8
Lightfoot Lee
[1.1.4.1.2.4.2.2]
8
Mary Lee
[1.1.4.1.2.4.2.3]
+
W. Selden
8
Lee
[1.1.4.1.2.4.2.4]
+
Knapp
7
Mary Bowles Armistead
[1.1.4.1.2.4.3]
b. 1783 d. 2 Mar 1864
Charles Alexander
8
Ellen Alexander
[1.1.4.1.2.4.3.1]
8
C. Armistead Alexander
[1.1.4.1.2.4.3.2]
Wilson Cary Selden
8
Jr. Wilson Cary Selden
[1.1.4.1.2.4.3.3]
Eliza A. Lee
b. 1807
9
Eleanor Love Selden
[1.1.4.1.2.4.3.3.1]
+
John Augustine Washington
b. 3 May 1821 d. 13 Sep 1861
7
Armistead
[1.1.4.1.2.4.4]
Terrill
8
Armistead Bowles Terrill
[1.1.4.1.2.4.4.1]
7
William Bowles Armistead
[1.1.4.1.2.4.5]
John Lewis
d. 1825
7
Frances Lewis
[1.1.4.1.2.4.6]
Keeling Terrell
8
John Terrell
[1.1.4.1.2.4.6.1]
7
Howell Lewis
[1.1.4.1.2.4.7]
7
Mary Ann Lewis
[1.1.4.1.2.4.8]
Charles Alexander
8
Armistead Alexander
[1.1.4.1.2.4.8.1]
8
Ellen Alexander
[1.1.4.1.2.4.8.2]
+
Selden
8
Mary Alexander
[1.1.4.1.2.4.8.3]
+
E. Lippit
8
Fontaine Alexander
[1.1.4.1.2.4.8.4]
+
L. Washington
6
James Fontaine
[1.1.4.1.2.5]
b. Abt 1761 d. 29 Oct 1790
6
Judith Fontaine
[1.1.4.1.2.6]
b. Abt 1763
6
Susanna Fontaine
[1.1.4.1.2.7]
b. Abt 1765
6
William Fontaine
[1.1.4.1.2.8]
b. 22 Jan 1751 d. 6 Oct 1810
Anne Morris
b. 14 Apr 1766 d. 21 Jul 1852
7
Sarah Rose Fontaine
[1.1.4.1.2.8.1]
b. 21 Sep 1796 d. 1863
Alexander Fontaine Rose
b. 1780 d. 1831
8
Lawrence Berry Rose
[1.1.4.1.2.8.1.1]
b. 1821 d. 1877
Eliza Welford
9
Jr. Lawrence Berry Rose
[1.1.4.1.2.8.1.1.1]
9
Susan Welford Rose
[1.1.4.1.2.8.1.1.2]
8
Edmund Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2]
b. 1817 d. 1893
Betty Maury
9
Alexander Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2.1]
9
John Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2.2]
9
Robert Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2.3]
9
Sarah Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2.4]
8
Charles Alexander Rose
[1.1.4.1.2.8.1.3]
b. 1823 d. 1875
+
M. Rutherford
Logie Childs
9
Rutherford Rose
[1.1.4.1.2.8.1.3.1]
9
Hugh Rose
[1.1.4.1.2.8.1.3.2]
9
Charles Rose
[1.1.4.1.2.8.1.3.3]
8
Louisa Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.8.1.4]
b. 1819 d. 1891
John Potts
9
Rose Potts
[1.1.4.1.2.8.1.4.1]
9
Douglas Potts
[1.1.4.1.2.8.1.4.2]
9
Morris Templin Potts
[1.1.4.1.2.8.1.4.3]
9
Elizabeth Hawley Potts
[1.1.4.1.2.8.1.4.4]
7
Peter Forreau Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2]
b. Abt 1793 d. 1815/1820
8
Charles Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.1]
8
Louisa Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.2]
8
John Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.3]
8
Alexander Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.4]
8
William Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.5]
7
Edmund Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3]
b. 29 Jan 1801 d. 26 Jun 1869
Maria Louisa Shackleford
b. 4 Feb 1807 d. 30 May 1876
8
Elizabeth "Betsey" Ann Betty Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.1]
b. Abt 1827 d. 1 May 1876
Thomas H. DeWitt
9
Mary Brown DeWitt
[1.1.4.1.2.8.3.1.1]
b. 9 Oct 1860
William H. Adams
b. Abt 1860
10
Helen Adams
[1.1.4.1.2.8.3.1.1.1]
b. May 1890
10
Anthony Crece Adams
[1.1.4.1.2.8.3.1.1.2]
b. Feb 1892
10
Fontaine DeWitt Adams
[1.1.4.1.2.8.3.1.1.3]
b. 25 Oct 1893 d. 30 Dec 1951
9
Edmund Fontaine DeWitt
[1.1.4.1.2.8.3.1.2]
b. Abt 1856
9
Louisa Fontaine DeWitt
[1.1.4.1.2.8.3.1.3]
d. CHILD
9
Nora Braxton DeWitt
[1.1.4.1.2.8.3.1.4]
d. CHILD
8
John Boursiquot Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.2]
b. 1 Apr 1840 d. 1 Oct 1864
Elizabeth Winston Price
9
Ellen Stuart Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.2.1]
Albert Sidney Morton
10
Stuart Fontaine Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.1]
10
Ellen Price Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.2]
10
D'Arcy Paul Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.3]
10
Jr. Albert Sidney Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.4]
10
Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.5]
d. INFANT
8
Mary Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.3]
b. 1835 d. 1910
Thomas L. Broun
b. 26 Dec 1823
9
Louisa Fontaine Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.1]
Malcolm Jackson
10
Thomas Broun Jackson
[1.1.4.1.2.8.3.3.1.1]
10
Anna Arbuthnot Jackson
[1.1.4.1.2.8.3.3.1.2]
9
Edmund Fontaine Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.2]
Sue Payton Kent
10
Jr. Edmund Fontaine Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.2.1]
10
Virginia Peyton Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.2.2]
9
Ann Conway Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.3]
Philip Sidney Powers
10
Thomas Broun Powers
[1.1.4.1.2.8.3.3.3.1]
10
Louisa Fontaine Powers
[1.1.4.1.2.8.3.3.3.2]
10
Ann Conway Powers
[1.1.4.1.2.8.3.3.3.3]
8
Edmund Fontaine Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.4]
b. 1837 d. 1 Jul 1861
8
Lucy Dabney Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.5]
b. 29 May 1844 d. 12 Mar 1917
Chiswell D. Dabney
b. 25 Jul 1844 d. 28 Apr 1923
9
John Charles Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.1]
b. Abt 1874 d. 1899
9
Jr. Chiswell Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.2]
b. Jul 1876 d. 1908
9
Louisa Fontaine Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.3]
b. Aug 1879
9
Lucy Fontaine Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.4]
b. Oct 1881
9
Elizabeth Towles Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.5]
b. Feb 1887 d. 1948
9
Edmund Fontaine Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.6]
b. Feb 1883 d. 1926
9
Louise Shackelford Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.7]
b. Aug 1879 d. 1950
8
William Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.6]
b. 6 Jun 1828 d. 5 Aug 1842
8
Sarah Louisa Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.7]
b. 8 Nov 1831 d. CHILD
8
Jane Catherine Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.8]
b. 31 Mar 1833 d. 20 Oct 1909
Richard Hardway Meade
9
Edmonia Fontaine Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.1]
d. CHILD
9
Lila Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.2]
+
Benjamin B. Valentine
9
Jr. Richard Hardway Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.3]
Eleanor Prior Adkins
10
III Richard Hardway Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.3.1]
9
Louise Fontaine Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.4]
+
Clarence Cadot
9
Kate Fontaine Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.5]
9
Marianne Skelton Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.6]
8
Richard Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.9]
b. 5 Aug 1842 d. 15 Oct 1914
8
Rosalie Shackelford Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.10]
b. 12 Mar 1851 d. 5 Jan 1933
8
Rose Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.11]
b. 7 Mar 1848 d. 23 May 1848
7
Louise Elizabeth Fontaine
[1.1.4.1.2.8.4]
b. Abt 1791 d. 10 Nov 1806
7
Jr. William Fontaine
[1.1.4.1.2.8.5]
b. Abt 1797 d. 22 Jun 1824
7
Charles Fontaine
[1.1.4.1.2.8.6]
b. 25 May 1806 d. Jan 1827
7
Alexander Rose Fontaine
[1.1.4.1.2.8.7]
b. 1808 d. 1870
7
John Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.8]
b. 1803 d. 1827
7
James Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9]
b. 1799 d. 20 Jan 1875
Juliet C. Morris
b. Abt 1827 d. 1876
8
William Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.1]
b. 1 Dec 1835
8
Charles Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.2]
b. Abt 1851
8
Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.3]
b. 1852 d. 1881
8
Joseph Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.4]
b. 1854 d. 1915
8
Sally Rose Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.5]
b. Abt 1855
8
John Dabney Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.6]
b. Abt 1850 d. CHILD
8
Susan Watson Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.7]
b. 16 May 1849
Carter Nelson Berkeley Minor
b. 6 Oct 1842
9
James Fontaine Minor
[1.1.4.1.2.8.9.7.1]
b. 24 Jul 1876
+
Lilian Forbes Lyman
b. Abt 1885
9
Berkeley Minor
[1.1.4.1.2.8.9.7.2]
b. 8 May 1879
9
Charles Landon Carter Minor
[1.1.4.1.2.8.9.7.3]
b. Abt 1881 d. Abt 1881
8
James Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.8]
d. CHILD
8
Peter Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.9]
Lydia Laidley
9
James Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.9.1]
9
Betsy Ann Quarrier Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.9.2]
d. CHILD
9
Keith Niles Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.9.3]
8
Nancy Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.10]
d. CHILD
5
Edmund Winston
[1.1.4.1.3]
b. Abt 1745 d. 1818
Alice Winston
b. 20 Mar 1753 d. 1784
6
Jr. Edmund Winston
[1.1.4.1.3.1]
b. 1778 d. 1864
+
Carolyne Wyatt
6
Elizabeth Winston
[1.1.4.1.3.2]
b. 1783 d. 1856
+
Bennett W. Moseley
d. 1811
6
George Dabney Winston
[1.1.4.1.3.3]
b. 2 Aug 1771 d. 15 Jul 1831
Dorothea Spotswood Henry
b. 2 Aug 1778 d. 17 Jun 1854
7
James Winston
[1.1.4.1.3.3.1]
b. 1815 d. 1852
7
Edmund Dabney Winston
[1.1.4.1.3.3.2]
b. 17 Sep 1799 d. 21 Sep 1875
Elizabeth Louisa Fontaine
b. 17 Sep 1804 d. 1892
8
Nancy Miller Winston
[1.1.4.1.3.3.2.1]
b. 5 Mar 1825
+
Oliver H. Black
8
John Dabney Winston
[1.1.4.1.3.3.2.2]
b. 21 Feb 1822
8
William Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3]
b. 21 Jul 1828 d. 13 Aug 1878
Emma Eloise Furr
b. 1842 d. 9 Feb 1892
9
Edmund Tobias Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3.1]
b. 22 Jul 1871 d. 26 Dec 1944
Florence Theresa Seale
b. 9 Feb 1876 d. 28 Jun 1959
10
Eloise Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1]
b. 7 Mar 1899
Ozeph Chester Taylor
b. 1 Jul 1867
11
Edmund Warren Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.1]
Benna Dean
12
Edmund Warren Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.1.1]
12
Benna Jeanne Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.1.2]
12
Dorothy Frances Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.1.3]
11
Dorothy Eloise Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2]
Jr. William Leroy Evans
12
William Leroy Evans
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2.1]
12
John Scott Evans
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2.2]
12
James Randall Evans
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2.3]
12
Cynthia Ann Evans
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2.4]
9
Galen Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3.2]
b. 8 Feb 1873 d. 1928
+
Aurelia Odile Despommer
9
Masina Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3.3]
b. 28 Aug 1875 d. 1928
+
Henry Henesler
8
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.4.1.3.3.2.4]
b. 8 Mar 1831 d. 1852
8
George Dabney Winston
[1.1.4.1.3.3.2.5]
b. 17 Sep 1833
+
Mrs. Iola Overton
8
Patrick Fontaine Winston
[1.1.4.1.3.3.2.6]
b. 5 Mar 1845 d. 1 Apr 1906
7
William Winston
[1.1.4.1.3.3.3]
b. 1809
7
Edward Henry Winston
[1.1.4.1.3.3.4]
b. 1811
Susan Moorehead Reynolds
8
Prior Winston
[1.1.4.1.3.3.4.1]
b. 1821/1860 d. 1830/1937
7
Sallie Butler Winston
[1.1.4.1.3.3.5]
b. 1807
+
Charles Dandridge
b. 1786/1818 d. 1812/1898
7
Fayette Henry Winston
[1.1.4.1.3.3.6]
b. 1813
Martha Dix
b. 1796/1827 d. 1821/1909
8
Lucy Winston
[1.1.4.1.3.3.6.1]
b. 1821/1860 d. 1839/1940
+
Hoffman
b. 1813/1858 d. 1839/1935
8
Elvira Winston
[1.1.4.1.3.3.6.2]
b. 1821/1860 d. 1839/1940
+
J. C. Granberry
b. 1813/1858 d. 1839/1935
7
Patrick Henry Winston
[1.1.4.1.3.3.7]
b. 28 Jan 1802
7
George Winston
[1.1.4.1.3.3.8]
b. 1804
7
Elvira Virginia Winston
[1.1.4.1.3.3.9]
d. 17 Jun 1854
James W. Crenshaw
b. 1786/1818 d. 1818/1898
8
Elvira Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.1]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
James C. Marvin
b. 1810/1851 d. 1836/1929
8
Sallie Winston Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.2]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
John Miller
b. 1810/1851 d. 1836/1929
8
Dorothea Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.3]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
David F. Smyer
b. 1810/1851 d. 1836/1929
8
Patrick Henry Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.4]
b. 1818/1853 d. 1839/1931
+
Lula Mack
b. 1818/1859 d. 1839/1939
8
Virginia Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.5]
b. 3 Dec 1838
+
James W. Harper
b. 1810/1851 d. 1836/1929
6
Alice Winston
[1.1.4.1.3.4]
b. 1784
Frederic Cabell
b. 1775 d. 5 Mar 1841
7
Edmund Cabell
[1.1.4.1.3.4.1]
b. 12 Jul 1808
7
Lewis Carrington Cabell
[1.1.4.1.3.4.2]
b. 12 Jun 1814 d. 1896
7
Sarah Lynne Cabell
[1.1.4.1.3.4.3]
b. 27 Aug 1804 d. 16 Jul 1820
7
Mary Mildred Cabell
[1.1.4.1.3.4.4]
b. 15 Jan 1802 d. 3 Mar 1880
John Horsley
8
Edmond Winston Horsley
[1.1.4.1.3.4.4.1]
Lucy Wilhelmina Gwatkin
9
Edmonia Winston Horsley
[1.1.4.1.3.4.4.1.1]
+
P. L. Saunders
7
Alice Winston Cabell
[1.1.4.1.3.4.5]
b. Apr 1806 d. INFANT
7
Virginia Pauline Cabell
[1.1.4.1.3.4.6]
b. 15 Jul 1812 d. 23 May 1894
John Ware Mosby
b. 30 Jun 1804 d. 28 Dec 1875
8
Frederick Cabell Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.1]
b. 7 Jun 1840 d. 22 Nov 1841
8
Mary Winston Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.2]
b. 19 Feb 1843 d. 1 Jan 1847
8
Clifford C. Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.3]
b. 2 Jun 1834 d. 5 Sep 1834
8
Alice Jane Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.4]
b. 8 Jul 1836
John Churchill Garner
9
John Floyd Churchill Garner
[1.1.4.1.3.4.6.4.1]
Anne
10
Winston Churchill Garner
[1.1.4.1.3.4.6.4.1.1]
8
Carrington Winston Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.5]
b. 30 Sep 1849
+
Cora Cannon Clark
8
Ella Floy Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.6]
b. 29 Aug 1846
7
Frederic Montimer Cabell
[1.1.4.1.3.4.7]
b. 15 Jan 1802 d. 1873
7
Clifford Cabell
[1.1.4.1.3.4.8]
b. 17 Aug 1810 d. 18 Sep 1871
6
Mary Winston
[1.1.4.1.3.5]
+
John Jones
Dorothea Spotswood Dandridge
b. 25 Sep 1755 d. 14 Feb 1831
6
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.4.1.3.6]
b. 1775/1798 d. 1780/1882
4
Jr. George Dabney
[1.1.4.2]
b. 2 Jan 1700 d. 18 Nov 1768
Ann Anderson
b. 14 Sep 1691 d. 17 May 1767
5
James Dabney
[1.1.4.2.1]
b. 6 Jan 1735/36 d. 13 Nov 1803
Judith Anderson
6
William S. Dabney
[1.1.4.2.1.1]
b. 1771 d. 1813
Sarah Watson
b. Abt 1775
7
Jr. William S. Dabney
[1.1.4.2.1.1.1]
b. Abt 1822 d. 1865
Susan FitzHugh Gordon
b. Abt 1822
8
William Cecil Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1]
b. 4 Jul 1869 d. 20 Aug 1894
Jane Bell Minor
b. 22 Sep 1847 d. 1914
9
Cecil Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.1]
b. 1884 d. 1913
+
Frances Cole
9
William Minor Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.2]
b. 21 Aug 1873
9
James Cabell Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.3]
b. 8 Oct 1875
Mary Beverley Whittle
10
Mary Beverley Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.3.1]
10
William Minor Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.3.2]
10
Elizabeth Calvert Page Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.3.3]
9
Susan FitzHugh Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.4]
St. George Tucker Grinnan
b. 6 Apr 1870
10
William C. Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.1]
10
David Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.2]
10
Jane Bell Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.3]
10
St. George Tucker Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.4]
10
Georgia Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.5]
9
Marian Gordon Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.5]
9
Jane Bell Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.6]
+
E. Ruffln Jones
5
III George Dabney
[1.1.4.2.2]
Grace Smith
b. 1736
6
IV George Dabney
[1.1.4.2.2.1]
b. Abt 1760
+
Ann Nelson
6
Ann Dabney
[1.1.4.2.2.2]
b. 10 Feb 1759 d. 18 Jun 1831
+
Samuel Anderson
b. 25 Jun 1757 d. 4 Apr 1826
4
William Dabney
[1.1.4.3]
b. 1707 d. Aug 1773
Susannah Ann Barrett
b. 1714 d. 1753
5
George Francis Dabney
[1.1.4.3.1]
b. 17 Aug 1742 d. 1824
Elizabeth Randolph Price
b. 1740 d. 1819
6
John Dabney
[1.1.4.3.1.1]
b. 1770 d. 4 May 1816
Susannah Dabney Morris
b. 25 Dec 1773 d. 28 Feb 1850
7
John Blair Dabney
[1.1.4.3.1.1.1]
b. 15 Nov 1794 d. 23 Apr 1868
Elizabeth Lewis Towles
b. 25 Dec 1801 d. 22 Mar 1883
8
Maria Louisa Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.1]
b. 15 Jun 1825 d. 5 Aug 1902
William Cabell Carrington
b. 27 Aug 1821 d. 29 Dec 1851
9
Williamine "Willa" Cabell Carrington
[1.1.4.3.1.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1852 d. 16 Feb 1934
Robert Alexander Lancaster
b. 1829 d. 1902
10
Henry Carrington Lancaster
[1.1.4.3.1.1.1.1.1.1]
b. 12 Nov 1882
9
Louisa Edmonia Carrington
[1.1.4.3.1.1.1.1.2]
b. 1846 d. Abt 1847
9
Elizabeth Lewis Carrington
[1.1.4.3.1.1.1.1.3]
b. 14 Oct 1849
8
Belle Lewis Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.2]
b. 1829 d. 1887
8
William Oliver Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.3]
b. 1832 d. 1850
8
Susan Morris Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.4]
b. 4 Aug 1827 d. 27 Mar 1918
8
John Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.5]
b. 1822 d. 25 Nov 1887
8
Elizabeth Lewis Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.6]
b. May 1830 d. 1904
8
Catherine Morris Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.7]
b. 16 Dec 1837 d. 1881
8
Caroline Agatha Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.8]
b. 1842 d. 1865
8
Chiswell D. Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9]
b. 25 Jul 1844 d. 28 Apr 1923
Lucy Dabney Fontaine
b. 29 May 1844 d. 12 Mar 1917
9
John Charles Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.1]
b. Abt 1874 d. 1899
9
Jr. Chiswell Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.2]
b. Jul 1876 d. 1908
9
Louisa Fontaine Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.3]
b. Aug 1879
9
Lucy Fontaine Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.4]
b. Oct 1881
9
Elizabeth Towles Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.5]
b. Feb 1887 d. 1948
9
Edmund Fontaine Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.6]
b. Feb 1883 d. 1926
9
Louise Shackelford Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.7]
b. Aug 1879 d. 1950
Nell H
b. Abt 1884
9
Edmund Fontaine Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.8]
b. Feb 1883 d. 1926
8
Charles Edward Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.10]
d. 1887
6
Anne Dabney
[1.1.4.3.1.2]
b. 1762 d. 1830
6
Catherine Dabney
[1.1.4.3.1.3]
b. 1768
6
Chiswell Dabney
[1.1.4.3.1.4]
b. 24 Jun 1791 d. 30 Mar 1865
Nancy Wiatt
b. 2 Feb 1796 d. 1 Aug 1834
7
Sarah Elizabeth Dabney
[1.1.4.3.1.4.1]
b. 14 Apr 1821 d. 26 Feb 1884
John Scarsbrook Langhorne
b. 1 Jun 1818 d. 29 Aug 1886
8
Chiswell Dabney "Chillie" Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1]
b. 4 Nov 1843 d. 14 Feb 1919
Nancy Witcher "Namie" Keene
b. 30 Aug 1848 d. 7 Oct 1903
9
Elizabeth "Lizzie" Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.1]
b. 1867 d. 9 Apr 1914
9
Elisha Keene Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.2]
b. Feb 1868 d. 28 Dec 1916
9
Irene Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.3]
b. 5 Jan 1874 d. 21 Apr 1956
9
Harry S. Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.4]
b. Oct 1874 d. Nov 1907
9
Nancy Witcher Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.5]
b. 19 May 1879 d. 18 Apr 1964
William Waldorf Astor
b. 19 May 1879 d. 30 Sep 1952
10
William Waldorf Astor, Jr.
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.1]
b. 13 Aug 1907 d. 7 Mar 1966
10
Nancy Phyllis Louise "Wisie" Astor
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.2]
10
Francis David Langhorne Astor
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.3]
10
Michael Langhorne Astor
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.4]
10
John Jacob "Jakie" Astor
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.5]
Robert Gould Shaw, II
b. 16 Jun 1872 d. 29 Mar 1930
10
Robert Gould Shaw, III
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.6]
b. 18 Aug 1898 d. 10 Jul 1970
9
Nora Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.6]
b. 14 Sep 1887 d. 16 Jul 1955
Paul Phipps
b. 3 Mar 1883 d. 1953
10
Joyce Irene Phipps
[1.1.4.3.1.4.1.1.6.1]
9
Phillis Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.7]
b. 3 Nov 1881 d. 20 Jan 1937
9
William Henry Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.8]
b. 4 Nov 1882 d. 9 Jun 1938
8
John S Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.2]
b. 1868
8
Anne Frances Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.3]
b. 10 Apr 1842 d. 3 Jun 1907
8
Elizabeth Dabney Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.4]
b. 1845 d. 1918
8
Nannie S Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.5]
b. Abt 1842
8
Henry S Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.6]
b. Abt 1848
7
John Dabney
[1.1.4.3.1.4.2]
b. 1819 d. 2 Jul 1832
7
Lucy B Dabney
[1.1.4.3.1.4.3]
b. 1828
7
Catherine Maria Dabney
[1.1.4.3.1.4.4]
b. 1832 d. 1886
7
Ann C Dabney
[1.1.4.3.1.4.5]
d. 7 Dec 1839
7
George William Dabney
[1.1.4.3.1.4.6]
Martha Ann Norvell
b. 1797 d. 1 Oct 1815
7
George William Dabney
[1.1.4.3.1.4.7]
b. 1815
7
Sarah Elizabeth Dabney
[1.1.4.3.1.4.8]
b. 1775 d. 1808
7
Elizabeth Dabney
[1.1.4.3.1.4.9]
b. 1803 d. 26 Feb 1884
5
Samuel Dabney
[1.1.4.3.2]
b. 16 Apr 1752
Jane Meriwether
6
Charles Dabney
[1.1.4.3.2.1]
b. 1 Jul 1781 d. Sep 1833
Elizabeth Randolph Price
7
Robert Lewis Dabney
[1.1.4.3.2.1.1]
b. 5 Mar 1820 d. 3 Jan 1898
Margareta Lavinia Morrison
b. 1824 d. 1909
8
Charles William Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.1]
b. 19 Jun 1855
Mary Chilton Brent
b. 12 Apr 1861
9
Mary Moore Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.1.1]
b. 30 Aug 1886
+
Alexander Thomson
9
Katherine Brent Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.1.2]
b. 14 Feb 1893
+
Jr. John William Ingle
9
Marguerite Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.1.3]
8
Samuel Brown Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.2]
b. 1860
+
Annie Euginia Prescott
8
Lewis Meriwether Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.3]
b. 1865 d. 1923
+
Stella Hutcheson
7
Anne Elizabeth Dabney
[1.1.4.3.2.1.2]
b. 23 Sep 1814 d. 1839/1908
+
George Woodson Payne
b. 29 Dec 1810 d. Jan 1870
7
Charles William Dabney
[1.1.4.3.2.1.3]
7
George Francis Dabney
[1.1.4.3.2.1.4]
6
Francis Dabney
[1.1.4.3.2.2]
b. 1 Jul 1781
5
Charles Dabney
[1.1.4.3.3]
b. Abt 1749
5
Mary Dabney
[1.1.4.3.4]
b. 1740 d. Oct 1835
+
Edmund Massie
b. Abt 1747
5
William Dabney
[1.1.4.3.5]
b. 3 Dec 1745
4
Judith Dabney
[1.1.4.4]
b. 17 May 1693 d. 16 Mar 1774
4
Susannah Dabney
[1.1.4.5]
b. 21 Mar 1691
4
Mary Dabney
[1.1.4.6]
b. 20 Mar 1696 d. 2 Sep 1763
Stephen Pettus
b. 1685
5
Dabney Pettus
[1.1.4.6.1]
4
Elizabeth Dabney
[1.1.4.7]
c. 11 Nov 1698 d. Bef 1729
Matthew Anderson
b. 21 Apr 1703 d. 22 May 1786
5
George Anderson
[1.1.4.7.1]
b. Abt 1725 d. 1808
Frances Woodson
b. 1730
6
George Dabney Anderson
[1.1.4.7.1.1]
b. Abt 1750 d. 1811
Susannah Mimms
b. 1736 d. 25 Feb 1824
7
Judith Anderson
[1.1.4.7.1.1.1]
b. Abt 1773 d. 18 Jun 1862
Richard Beckwith Payne
b. 9 Aug 1776 d. 8 Sep 1858
8
Elizabeth Beckwith Payne
[1.1.4.7.1.1.1.1]
b. 20 Aug 1815 d. 12 Oct 1815
8
Robert Burton Payne
[1.1.4.7.1.1.1.2]
b. 16 Aug 1795 d. 11 Mar 1875
+
Frances Gardner Anderson
b. 23 Nov 1810 d. 7 Aug 1881
+
Susannah ANDERSON
8
George Anderson Payne
[1.1.4.7.1.1.1.3]
b. 28 Mar 1797 d. 18 May 1839
8
Norella Burton Payne
[1.1.4.7.1.1.1.4]
b. 25 Dec 1801 d. 9 Feb 1889
Jesse Reese Hughes
d. 6 Jan 1880
9
Robert Burton Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.4.1]
b. 3 Nov 1820 d. 4 Dec 1900
Sarah Elizabeth Cleveland
b. 13 Jun 1824 d. 24 Aug 1864
10
Margaret Lelia Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1]
b. 12 Dec 1850 d. 18 Dec 1940
III Isaac Otey Perkins, Jr.
b. 20 Dec 1846 d. 18 Jan 1913
11
Edwin Judson Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.1]
b. Abt 1880
+
Henrietta Tapscott Snead
b. Abt 1880
11
Nathaniel James Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.2]
b. 31 May 1877 d. 20 Apr 1962
Ethel Vernon Beard
b. 25 Sep 1879 d. 19 Jan 1934
12
Ethel Goodwin Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.2.1]
[
=>
]
11
Lelia Cary Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.3]
11
Louise Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.4]
11
IV Isaac Otey Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.5]
11
Braxton Lee Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.6]
11
Jeter Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.7]
11
William Beckwith Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.8]
12
Jr. William Beckwith Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.8.1]
[
=>
]
11
Robert Cleveland Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.9]
8
William Jordan Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5]
b. 23 Sep 1806 d. 24 Feb 1890
Sarah Elizabeth Herring
b. 1804 d. 1885
9
Sarah Judson Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.1]
b. 20 Sep 1847 d. 30 Jun 1890
John Hillery Morris
b. 9 Sep 1840 d. 25 Jan 1922
10
Alvin Ruffin Morris
[1.1.4.7.1.1.1.5.1.1]
b. 22 Aug 1876 d. 9 Oct 1967
Mertie Brent Gillespie
11
Alberta Morris
[1.1.4.7.1.1.1.5.1.1.1]
Raymond R. Quesenberry
b. 15 Jul 1911
12
Betty Jo Quesenberry
[1.1.4.7.1.1.1.5.1.1.1.1]
+
Theodore Currin
9
Alberta Jordan Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.2]
b. 15 Aug 1832 d. 6 Jun 1868
Walter Samuel Johnson
b. Abt 1812
10
Johnson
[1.1.4.7.1.1.1.5.2.1]
b. Yes, date unknown
9
Luther Rice Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.3]
b. 8 Nov 1834 d. 7 Sep 1885
Malvina Virginia Bowles
b. Abt 1839
10
Beckwith Benjamin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.3.1]
b. Yes, date unknown
9
Nancy B. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.4]
b. 15 Jul 1837 d. 14 Jun 1914
+
John Daniel Winn
9
Tucker W. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5]
b. 13 Feb 1840 d. 11 Nov 1921
Sarah F. Stines
b. 1842
10
William B. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5.1]
b. 1868
10
Rosa B. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5.2]
b. 1870
10
Alfred Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5.3]
b. 1871
10
Georgie T. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5.4]
b. 1878
9
Fleming H. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.6]
b. 1850 d. 27 Jun 1865
9
Mariah Agnes Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.7]
b. 10 Aug 1853 d. 24 Nov 1930
+
John Saunders
9
Hattie Evilene Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.8]
b. 26 May 1856 d. 19 May 1927
+
George Clements
b. 30 Jun 1855 d. 8 Oct 1936
9
George Anderson Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.9]
b. 20 Aug 1842 d. 20 Jan 1890
Mary M. Johns
b. Abt 1856
10
Magnus Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.9.1]
b. Between 15 Jun 1879 and 15 Jun 1880
10
Bernie Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.9.2]
b. Abt 1873
9
Thomas Gilman Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.10]
b. 19 Apr 1845 d. 27 Jan 1926
+
Mollie B Payne
b. Abt 1878
Eliza M Payne
b. Mar 1846 d. Abt 1905
10
Nannie Beckwith Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.10.1]
b. 26 Oct 1870 d. 24 Jun 1957
10
Oteria Virginia Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.10.2]
b. 14 Aug 1868 d. 10 Feb 1952
10
Oliver V Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.10.3]
b. Abt 1868
8
Mary Brockenbrough Payne
[1.1.4.7.1.1.1.6]
b. 15 Jul 1809 d. 3 Sep 1883
George Loving Seay
b. 15 Jul 1809 d. 3 Sep 1883
9
Norella Burton Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.1]
b. 19 Jan 1837 d. 2 Apr 1882
Benjamin Anderson SOWELL
b. 29 Feb 1832 d. 13 Jul 1912
10
Mary Paulina SOWELL
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1]
b. 12 Aug 1869 d. 25 Mar 1952
Russell Winston JENNINGS
b. 22 Feb 1870 d. 9 May 1941
11
Norella Burton JENNINGS
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1.1]
James Newton WOOD
b. Abt 1892 d. 19 Dec 1930
12
Mary Norella WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1.1.1]
12
WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1.1.2]
12
James WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1.1.3]
9
Joseph Morton Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.2]
9
Robert Hasley Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3]
Lucy Oliver Cleveland
10
Chester Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.1]
10
Randolf Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.2]
10
Welford Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.3]
+
Clair Soule
10
Lorena Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.4]
10
Norella Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.5]
10
Sally Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.6]
9
Mary B. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.4]
9
Emily Judson Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.5]
9
Georgie A. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.6]
9
Judith Elizabeth Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.7]
9
Phillip G. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.8]
9
Sidney Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.9]
9
Richard B. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.10]
9
George P. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.11]
8
Susan Mims Payne
[1.1.4.7.1.1.1.7]
b. 3 Feb 1812 d. 1886
Jeremiah Cleveland
b. 1786 d. Apr 1866
9
Mary Susan Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.1]
b. 23 Jan 1843 d. 22 Jul 1920
Williams Pitt JENNINGS
b. 2 Nov 1835 d. 27 Jul 1928
10
Russell Winston JENNINGS
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1]
b. 22 Feb 1870 d. 9 May 1941
Mary Paulina SOWELL
b. 12 Aug 1869 d. 25 Mar 1952
11
Norella Burton JENNINGS
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1.1]
James Newton WOOD
b. Abt 1892 d. 19 Dec 1930
12
Mary Norella WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1.1.1]
12
WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1.1.2]
12
James WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1.1.3]
9
John Poindexter Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.2]
b. 20 Aug 1846 d. 30 Jun 1924
9
James Fleming Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.3]
b. 1850 d. 7 Oct 1865
9
Judith Payne Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.4]
b. Mar 1854 d. 29 Sep 1923
9
George Beckwith Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.5]
b. 26 Jan 1842 d. 16 Feb 1932
9
Virginia Morton Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.6]
b. Sep 1845 d. 1916
8
Fleming S Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8]
b. 5 Aug 1799 d. 13 Jan 1857
Isabella Winn
b. 1805 d. 15 Jul 1882
9
James Franklin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1]
b. Nov 1837 d. Dec 1904
Angelina Ontario Keoka Chiles
b. 29 Apr 1849 d. 13 Mar 1933
10
Alice Clark Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1]
b. 20 Feb 1872 d. 20 Dec 1963
John E. Talley
b. 1876
11
Louise P Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.1]
b. Abt 1904
+
Smith
11
Maude A Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.2]
b. Abt 1909
11
Erma Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.3]
b. Abt 1911
+
Lacy Morris
11
Alice Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.4]
b. Abt 1902
+
Harold King
11
Cecil V Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.5]
+
Leo Isbell
11
Frank W Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.6]
b. Abt 1906
Betty
12
Marian Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.6.1]
12
Betsy Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.6.2]
10
Georgia Magnolia Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.2]
b. 30 Mar 1869 d. 2 Dec 1935
+
Harry Masoncupp
10
Walter Daniel Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3]
b. 10 May 1875 d. 22 Jul 1970
Flora Lee Martin
11
Carroll Thomas Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.1]
Frances Tomlin
12
Jr. Carroll Thomas Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.1.1]
[
=>
]
12
Michael Scott Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.1.2]
11
Virginia Cameron Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.2]
John Marshall Ballard
12
David Lee Ballard
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.2.1]
[
=>
]
11
Elizabeth Rebecca Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.3]
Samuel Goodson
12
Sharon Goodson
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.3.1]
[
=>
]
+
Emerson Lewis
11
Wilbur Martin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.4]
b. 1912 d. 29 Feb 1932
11
Robert Lee Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.5]
b. 23 Sep 1914 d. 6 Mar 1932
11
Stuart Daniel Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.6]
+
Audrey Macirdo
+
Edna Luckard
11
James Franklin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7]
Elizabeth Rush
12
Dale Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.1]
12
Shawna Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.2]
12
Dawn Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.3]
12
Gwendolyn Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.4]
12
Jr. James Franklin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.5]
+
Linda
10
Laura Belle Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4]
b. 19 Aug 1877 d. 1946
William G. Hughes
b. 1866
11
Mattie Payne Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.1]
+
Jr. Louis Saksen
b. 1866
11
Doris E. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.2]
+
Earl Carsell
11
Aubrey Scott Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.3]
11
Roy Linwood Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.4]
11
Charlie F. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.5]
11
William E. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.6]
11
James D. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.7]
11
Alfred G. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.8]
11
Jessie B. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.9]
11
Ruth Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.10]
+
William Marion
9
Richard Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.2]
b. Abt 1825 d. Between 1881 and 1900
9
Judith B Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.3]
b. Abt 1829
9
Eliza M Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.4]
b. Mar 1846 d. Abt 1905
Thomas Gilman Payne
b. 19 Apr 1845 d. 27 Jan 1926
10
Nannie Beckwith Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.4.1]
b. 26 Oct 1870 d. 24 Jun 1957
10
Oteria Virginia Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.4.2]
b. 14 Aug 1868 d. 10 Feb 1952
10
Oliver V Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.4.3]
b. Abt 1868
9
Flavius Josephus Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.5]
b. 7 Jul 1833 d. 20 Jan 1919
9
Barrett G Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.6]
b. 22 Mar 1827 d. 30 Apr 1904
8
Margaret Sydenham Payne
[1.1.4.7.1.1.1.9]
b. 23 Feb 1804 d. 19 May 1890
Susanna Swann
b. 1643 d. Feb 1724
3
Dorothy Dabney
[1.1.5]
b. Abt 1678 d. 1720
William Anderson
b. Abt 1665 d. 7 Apr 1717
4
Anna Anderson
[1.1.5.1]
b. 1719 d. 1769
James Trice
4
John Trice
[1.1.5.2]
b. 1720
3
Cornelius Dabney
[1.1.6]
b. 7 Apr 1688 d. 17 Feb 1765
Sarah Jennings
b. 3 Apr 1702 d. 1790
4
John Dabney
[1.1.6.1]
b. 17 Oct 1725 d. 1821
Anne Harris
b. 31 Mar 1724 d. Aft 1770
5
Sarah Ann Dabney
[1.1.6.1.1]
b. 2 Oct 1740 d. 10 Jan 1822
Thomas Waller
b. 29 Jul 1732 d. 10 Feb 1788
6
Mary Waller
[1.1.6.1.1.1]
b. 26 Feb 1761 d. 1850
6
Anna Waller
[1.1.6.1.1.2]
b. 11 Nov 1762 d. 5 Aug 1834
Joel Harris
b. 25 Apr 1761 d. 1826
7
Ira Harris
[1.1.6.1.1.2.1]
b. Abt 1785 d. 1863
Sarah Lewis
8
Charles Warner Harris
[1.1.6.1.1.2.1.1]
b. 15 Feb 1822 d. 23 Apr 1860
Angeline Mildred Brown
b. 9 Oct 1832
9
Mary Howell Harris
[1.1.6.1.1.2.1.1.1]
b. 15 Sep 1854 d. 12 Jan 1857
9
Charles Lee Harris
[1.1.6.1.1.2.1.1.2]
b. 24 Jul 1857
8
Waller Harris
[1.1.6.1.1.2.1.2]
+
Mary Frances Brown
8
Mary Ann Harris
[1.1.6.1.1.2.1.3]
Burlington Dabney Brown
b. 17 May 1820 d. 26 Apr 1886
9
Hugh Hescott Brown
[1.1.6.1.1.2.1.3.1]
b. 7 Apr 1846
+
Mary Ann Metier
9
Ira Lewis Brown
[1.1.6.1.1.2.1.3.2]
b. 2 Mar 1848
9
Linn Roy Brown
[1.1.6.1.1.2.1.3.3]
b. 5 Nov 1849 d. 22 Mar 1850
9
Frank Brown
[1.1.6.1.1.2.1.3.4]
+
Bettie French
9
Harry Brown
[1.1.6.1.1.2.1.3.5]
+
Virginia Ann Bishop
9
Ralph Brown
[1.1.6.1.1.2.1.3.6]
9
Hattie Brown
[1.1.6.1.1.2.1.3.7]
+
Samuel Hatcher
9
Nettie Brown
[1.1.6.1.1.2.1.3.8]
+
E .A. Lofton
8
Benjamin Harris
[1.1.6.1.1.2.1.4]
8
Lewis Harris
[1.1.6.1.1.2.1.5]
6
Agnes Waller
[1.1.6.1.1.3]
b. 17 Nov 1764 d. 7 Nov 1817
+
Sharp Smith
b. 1747/1767 d. 1792/1853
6
Sarah Waller
[1.1.6.1.1.4]
b. 24 Jan 1767 d. 22 Mar 1829
+
Joseph Spicer
b. 1750/1770 d. 1795/1856
6
Carr Waller
[1.1.6.1.1.5]
b. 12 Mar 1769 d. 7 May 1843
+
Elizabeth Martin
b. 1765/1785 d. 1800/1869
+
Susannah Edwards
b. 1765/1785 d. 1800/1869
6
Dabney Waller
[1.1.6.1.1.6]
b. 20 Feb 1772 d. 6 Jun 1849
Elizabeth Minor
b. 26 Sep 1768 d. 7 Jan 1832
7
Thomas Carr Waller
[1.1.6.1.1.6.1]
b. 29 Jul 1799
6
Pomfrett Waller
[1.1.6.1.1.7]
b. 8 May 1774 d. 29 Apr 1814
+
Sallie Woolfolk
b. 1770/1789 d. 1805/1873
6
Dorothy Waller
[1.1.6.1.1.8]
b. 31 Mar 1777 d. 2 Dec 1838
+
E. T. Rowzie
b. 1760/1780 d. 1805/1866
6
John Waller
[1.1.6.1.1.9]
b. 10 Feb 1780 d. 10 Sep 1824
6
Elizabeth Waller
[1.1.6.1.1.10]
b. 2 Mar 1783 d. 7 Jun 1872
5
Mary Dabney
[1.1.6.1.2]
b. 14 Sep 1742 d. 31 Oct 1818
Thomas Carr Minor
b. 5 Aug 1740 d. 16 Feb 1816
6
Elizabeth Minor
[1.1.6.1.2.1]
b. 26 Sep 1768 d. 7 Jan 1832
Dabney Waller
b. 20 Feb 1772 d. 6 Jun 1849
7
Thomas Carr Waller
[1.1.6.1.2.1.1]
b. 29 Jul 1799
5
William Dabney
[1.1.6.1.3]
b. 2 Jun 1750 d. 5 May 1836
+
Jane Quarles
b. 1742/1773 d. 1776/1855
5
John Dabney
[1.1.6.1.4]
b. 3 May 1749 d. 11 Mar 1831
Margueretta Smith
b. 1742/1762 d. 1777/1846
6
George Dabney
[1.1.6.1.4.1]
7
Benjamin Dabney
[1.1.6.1.4.1.1]
b. 15 Sep 1757 d. 25 May 1806
Sarah Smith
b. 27 Feb 1775 d. 21 Dec 1851
8
Martha Burwell Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.1]
b. 15 Sep 1802 d. 1883
Lewis Webb Chamberlayne
b. 1798 d. 1854
9
Lucy Parke Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.1]
b. 1842 d. 1927
George William Bagby
b. 1828 d. 1883
10
Virginia Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.1]
III Henry Taylor
11
IV Henry Taylor
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.1.1]
Isabel de Leon Williams
12
Alice Marshall Taylor
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.1.1.1]
12
V Henry Taylor
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.1.1.2]
10
Lewis Webb Chamberlayne Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.2]
d. CHILD
10
John Hampden Chamberlayne Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.3]
10
Martha Burwell Dabney Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.4]
10
Woodville Latham Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.5]
d. INFANT
10
Parke Chamberlayne Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.6]
10
Jr. George William Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.7]
10
Robert Coleman Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.8]
10
Ellen Matthews Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.9]
10
Philip Haxall Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.10]
d. 1926
Mary Clarkson Allen
11
II Philip Haxall Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.10.1]
11
Virginia Allen Bagby
[1.1.6.1.4.1.1.1.1.10.2]
9
II Edward Pye Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.2]
b. 21 Jan 1821 d. 1877
9
Hartwell Macon Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3]
b. 1836 d. 1905
Elmina McDearmon
b. 1842 d. 1894
10
William Nelson Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.1]
10
Thomas Gallaudet Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.2]
d. 1894
10
John Stewart Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.3]
d. CHILD
10
Edward Pye Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.4]
Emma Frances Furbush
11
Ada Lee Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.4.1]
11
Jr. Edward Pye Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.4.2]
11
Charles Hartwell Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.4.3]
11
Frances Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.4.4]
11
Ellen Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.4.5]
11
A. Bentley Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.4.6]
10
Sarah Dabney Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5]
Thomas Walter Davis
11
Hartwell Chamberlayne Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.1]
b. Mar 1900
Vera Mae Holden
12
Virginia Louise Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.1.1]
12
Jr. Hartwell Chamberlayne Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.1.2]
12
Mary Ann Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.1.3]
11
Virginia Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.2]
11
Harrison Bolen Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.3]
11
Rebecca Cook Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.4]
+
Howard Cleo Burris
11
Dorothy McDearmon Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.5]
11
Parke Chamberlayne Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.6]
11
Edward Dabney Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.7]
11
Jr. Thomas Walter Davis
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.5.8]
10
Lewis Webb Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.6]
d. 1906
11
Mary Frances Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.3.6.1]
9
John Hampden Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4]
b. 2 Jun 1838 d. 18 Feb 1882
Mary Walker Gibson
d. 1905
10
Jr. John Hampden Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.1]
b. 30 Jan 1878 d. 3 Oct 1925
+
Alice Doyle
10
Lucy Atkinson Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.2]
b. 9 Jul 1875
Jr. Richard Clarke Scott
11
Churchill Gibson Scott
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.2.1]
b. 1 Feb 1905
11
John Hampden Chamberlayne Scott
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.2.2]
b. 1903 d. 1904
Clarence Maynard
11
Lucy Chamberlayne Maynard
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.2.3]
d. INFANT
10
Martha Dabney Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.3]
b. 3 Jul 1874
+
Ph.D. Walter Scott McNeil
Edward Pleasants Valentine
b. 6 Apr 1864 d. 24 Mar 1908
11
Martha Chamberlayne Valentine
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.3.1]
b. 1895
John Hill Cronley
12
Jr. John Hill Cronley
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.3.1.1]
11
Ann Pleasants Valentine
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.3.2]
b. 1898
Oscar Edward Cesare
12
Oscar Edward Valentine Cesare
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.3.2.1]
+
John Bartram Kelley
10
Ph.D. Lewis Parke Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.4]
b. 3 Jun 1879 d. 1917
Elizabeth Claiborne Mann
11
Mary Gibson Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.4.1]
11
Elizabeth Claiborne Mann Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.4.2]
10
Ph.D. Churchill Gibson Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.5]
b. 23 Dec 1876
Elizabeth Bolling
11
Edward Pye Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.5.1]
11
III John Hampden Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.5.2]
10
Bessie Gibson Chamberlayne
[1.1.6.1.4.1.1.1.4.6]
b. 8 Aug 1880
8
Philip Augustine Lee Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.2]
b. 4 Mar 1800 d. 1878
8
Thomas Gregory Smith Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.3]
b. 4 Jan 1798 d. 28 Feb 1885
+
Mary Adelaide Tyler
Martha Burwell Armistead
8
George Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4]
b. 25 Mar 1779 d. 31 Dec 1827
Susanna Littlepage Quarles
b. 12 Mar 1778 d. 18 Apr 1827
9
George Henry Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.1]
b. 8 Apr 1798 d. 27 May 1842
+
Martha Tebbs
9
James Lyons Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.2]
b. 25 Jul 1808 d. Bef 1887
+
Elizabeth Washington Dade
9
Ann West Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.3]
b. 2 Sep 1793 d. 1869
+
Benjamin Dabney
+
John Lumpkin
9
Emily Anderson Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.4]
b. 22 Nov 1794
+
Gabriel Gray
9
Elizabeth Camp Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.5]
b. 27 Sep 1796 d. 1866
9
Susanna Quarles Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.6]
b. 27 Sep 1796 d. 1798
9
Susanna Dandridge Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.7]
b. 26 Nov 1799 d. 1800
9
Mary Eleanor Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.8]
b. 7 Feb 1801
+
Benjamin Pendleton Hoomes
9
Benjamin Franklin Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.9]
b. 12 Oct 1802 d. Bef 1887
+
Nelson
9
Agnes Dandridge Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.10]
b. 29 Jun 1804 d. 13 Jun 1880
+
Boughton
+
George Augustus Spiller
9
Frances Anderson Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.11]
b. 31 Jan 1806 d. Bef 1887
+
John Taliaferro
+
Custis Carter
9
boy Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.12]
b. 23 Apr 1807 d. 23 Apr 1807
9
John Fushee Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.13]
b. 10 Dec 1810 d. 1811
9
Thomas Smith Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.14]
b. 7 Apr 1812
+
Rebecca Dylees
9
Harriet Richardson Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.15]
b. 12 Sep 1815 d. 1817
9
Maria Hoomes Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.4.16]
b. 2 Dec 1817 d. Bef 1887
+
William F. Turner
8
Benjamin Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.5]
b. 1784
8
Anne Dabney
[1.1.6.1.4.1.1.6]
b. 1786
+
Thomas Smith
7
James Dabney
[1.1.6.1.4.1.2]
7
Thomas Dabney
[1.1.6.1.4.1.3]
7
George Dabney
[1.1.6.1.4.1.4]
6
James Dabney
[1.1.6.1.4.2]
6
Nancy Dabney
[1.1.6.1.4.3]
6
John Dabney
[1.1.6.1.4.4]
5
Anna Dabney
[1.1.6.1.5]
b. Abt 1751 d. Aft 1784
+
Henry Terrill
b. 1730
5
Elizabeth Jennings Dabney
[1.1.6.1.6]
b. 18 Jun 1751 d. 21 Jul 1826
Bernard Brown
b. 28 Jan 1749/50 d. 26 Feb 1800
6
Reuben Dabney Brown
[1.1.6.1.6.1]
b. 16 Jan 1777 d. 5 Jul 1849
Lucy Thompson Brown
b. 17 Jan 1784
7
Susanna T. Brown
[1.1.6.1.6.1.1]
b. 29 Mar 1809 d. 3 Feb 1855
H. Nimrod Brown
b. 5 Apr 1797 d. 11 Aug 1835
8
Reuben Brown
[1.1.6.1.6.1.1.1]
b. Abt 1825
7
George Thompson Brown
[1.1.6.1.6.1.2]
b. 29 Dec 1807 d. 7 Jun 1883
Amanda Brown
b. 16 Jan 1809 d. 5 Mar 1882
8
Sarah P. Brown
[1.1.6.1.6.1.2.1]
b. Abt 1846
+
Benjamin Adams
b. Abt 1844
8
Reuben Dabney Brown
[1.1.6.1.6.1.2.2]
b. 20 Jun 1848
Margaret Matilda Crenshaw
9
Mary Elizabeth Brown
[1.1.6.1.6.1.2.2.1]
8
William Brown
[1.1.6.1.6.1.2.3]
b. Abt 1834
8
Lucy Brown
[1.1.6.1.6.1.2.4]
b. Abt 1844
+
Adams
8
Llewellyn Brown
[1.1.6.1.6.1.2.5]
b. Abt 1830
8
Benjamin Brown
[1.1.6.1.6.1.2.6]
b. Abt 1840
8
Amanda C. Brown
[1.1.6.1.6.1.2.7]
b. Apr 1822 d. 16 Sep 1839
8
Susan Brown
[1.1.6.1.6.1.2.8]
b. Abt 1842
+
John Chenault
8
George Brown
[1.1.6.1.6.1.2.9]
b. Abt 1832
8
Clifton Brown
[1.1.6.1.6.1.2.10]
b. Abt 1837
8
Charles Brown
[1.1.6.1.6.1.2.11]
b. Abt 1850
7
Brightberry Brown
[1.1.6.1.6.1.3]
b. Abt 1811
7
Llewellyn Brown
[1.1.6.1.6.1.4]
b. Abt 1815
7
Francina Rhodes Brown
[1.1.6.1.6.1.5]
b. 1819 d. 1894
6
Bernard M. Brown
[1.1.6.1.6.2]
b. 15 Mar 1781 d. 1825
Miriam Cave Maupin
b. 19 Dec 1783
7
Thompson Brown
[1.1.6.1.6.2.1]
b. 6 Oct 1803
+
Sarah Brown
7
Sarah J. Brown
[1.1.6.1.6.2.2]
b. 11 Apr 1805
Clifton Brown
b. 6 Aug 1799
8
Tazwell Brown
[1.1.6.1.6.2.2.1]
+
Isabella Brown
8
Virginia A. Brown
[1.1.6.1.6.2.2.2]
8
T. H. B. Brown
[1.1.6.1.6.2.2.3]
Elizabeth Ellen Carpenter
9
Lulu Brown
[1.1.6.1.6.2.2.3.1]
b. 8 Jul 1870 d. 18 Jan 1943
Augustus Renick McNeill
b. 26 Nov 1859 d. 19 Jun 1932
10
Augustus Cleland McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.1.1]
b. 11 Jul 1887 d. 26 Aug 1938
Nannie Bell Gilkessen
11
John Gilkeson McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.1.1.1]
b. 28 Apr 1918 d. 12 Mar 1966
11
Robert Spottswood McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.1.1.2]
11
Thomas Bernard McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.1.1.3]
+
Betty Miley Pilgrim
10
Daniel Brown McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.1.2]
b. 4 Mar 1889 d. 14 Mar 1943
+
Lulu Darrow
9
Verdie Leigh Brown
[1.1.6.1.6.2.2.3.2]
b. 13 Feb 1861 d. 24 Nov 1920
Edward Williams McNeill
b. 15 Jun 1857 d. 16 Feb 1927
10
Chauncey S. McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.2.1]
b. 1886
+
Carolyn Lee
10
Llewellyn Brown McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.2.2]
b. Cal 1881
Elizabeth Heiskell
11
Jean McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.2.2.1]
10
Roland Karl McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.2.3]
b. 5 Jun 1889 d. 23 Jan 1934
+
Marie Inskeep
10
Verdie Genevieve McNeill
[1.1.6.1.6.2.2.3.2.4]
+
Harry Cronin
9
DeWitt Brown
[1.1.6.1.6.2.2.3.3]
9
Bernard Brown
[1.1.6.1.6.2.2.3.4]
9
Sallie Brown
[1.1.6.1.6.2.2.3.5]
9
Edward Brown
[1.1.6.1.6.2.2.3.6]
8
William A. Brown
[1.1.6.1.6.2.2.4]
8
Susan Brown
[1.1.6.1.6.2.2.5]
7
Pyrenia D. Brown
[1.1.6.1.6.2.3]
b. 31 Dec 1806
+
Tilman J. Maupin
7
Elizabeth Dabney Brown
[1.1.6.1.6.2.4]
b. 8 Aug 1822
+
Clifton Brown
b. 6 Aug 1799
7
Sidna R. Brown
[1.1.6.1.6.2.5]
b. 8 Jan 1812
7
Bernard L. Brown
[1.1.6.1.6.2.6]
b. 9 Aug 1816 d. 10 Feb 1868
Mary Elizabeth Dailey
b. Abt 1817 d. 18 May 1907
8
Lucy Blanche Brown
[1.1.6.1.6.2.6.1]
b. 10 Aug 1853 d. 2 Feb 1935
+
McCrum
8
Oscar Lee Brown
[1.1.6.1.6.2.6.2]
b. 31 Aug 1851 d. 4 May 1888
8
Alice Goodman Brown
[1.1.6.1.6.2.6.3]
b. 15 Feb 1862 d. 28 Jan 1890
8
Florence A Brown
[1.1.6.1.6.2.6.4]
b. 29 Nov 1845 d. 9 Dec 1928
8
Adeliza Frances Brown
[1.1.6.1.6.2.6.5]
b. 14 Jan 1844 d. 4 Jan 1934
8
Laura Sedna Brown
[1.1.6.1.6.2.6.6]
b. 17 Sep 1847 d. 31 May 1860
8
Charles Bernard Brown
[1.1.6.1.6.2.6.7]
b. 12 Nov 1857
8
Roberta Lee Brown
[1.1.6.1.6.2.6.8]
b. 23 Nov 1865 d. 12 Apr 1931
8
Clarence Hugh Dailey Brown
[1.1.6.1.6.2.6.9]
b. 11 Dec 1859 d. 4 Sep 1884
7
Smith W. Brown
[1.1.6.1.6.2.7]
b. 19 Apr 1814
Martha M. Brown
b. 4 May 1813 d. 15 Apr 1850
8
Mary Emnier Brown
[1.1.6.1.6.2.7.1]
b. 31 May 1847
8
Elizabeth Lewis Brown
[1.1.6.1.6.2.7.2]
b. 19 Oct 1845 d. 9 Feb 1848
8
Allen Henry Brown
[1.1.6.1.6.2.7.3]
b. 29 Apr 1841 d. 12 May 1864
8
Lucie Mariam Brown
[1.1.6.1.6.2.7.4]
b. 15 Apr 1854
8
John Jarman Brown
[1.1.6.1.6.2.7.5]
b. 17 Feb 1849 d. Feb 1903
+
Marie E. Mallory
b. 6 Jun 1826 d. 8 Jun 1886
7
James D. Brown
[1.1.6.1.6.2.8]
b. 11 Feb 1826
+
Kate Ford
7
Allen W. Brown
[1.1.6.1.6.2.9]
b. 21 Nov 1809
+
Mary Koogler
7
Francis Brown
[1.1.6.1.6.2.10]
+
Adams
6
Ira Benajah Brown
[1.1.6.1.6.3]
b. 5 Jun 1794 d. 26 Feb 1842
Frances Jarman Mullins
b. 1 Dec 1798 d. 23 May 1835
7
Burlington Dabney Brown
[1.1.6.1.6.3.1]
b. 17 May 1820 d. 26 Apr 1886
Mary Ann Harris
8
Hugh Hescott Brown
[1.1.6.1.6.3.1.1]
b. 7 Apr 1846
+
Mary Ann Metier
8
Ira Lewis Brown
[1.1.6.1.6.3.1.2]
b. 2 Mar 1848
8
Linn Roy Brown
[1.1.6.1.6.3.1.3]
b. 5 Nov 1849 d. 22 Mar 1850
8
Frank Brown
[1.1.6.1.6.3.1.4]
+
Bettie French
8
Harry Brown
[1.1.6.1.6.3.1.5]
+
Virginia Ann Bishop
8
Ralph Brown
[1.1.6.1.6.3.1.6]
8
Hattie Brown
[1.1.6.1.6.3.1.7]
+
Samuel Hatcher
8
Nettie Brown
[1.1.6.1.6.3.1.8]
+
E .A. Lofton
7
Virginia Frances Brown
[1.1.6.1.6.3.2]
b. 17 Dec 1822 d. 1883
William Kavanaugh Hocker
b. 1820 d. 1897
8
Lucy B. Hocker
[1.1.6.1.6.3.2.1]
Powhatan Patteson Truehart
b. 6 Nov 1851
9
Virginia Truehart
[1.1.6.1.6.3.2.1.1]
b. 1879
+
Edward Kilbourne
8
Fannie Hocker
[1.1.6.1.6.3.2.2]
8
Nannie Hocker
[1.1.6.1.6.3.2.3]
7
James Landon Brown
[1.1.6.1.6.3.3]
b. 22 Jun 1824 d. 7 Jun 1852
7
Sarah Ann Brown
[1.1.6.1.6.3.4]
b. 1 Mar 1826 d. 1 May 1846
7
Samantha Susan Brown
[1.1.6.1.6.3.5]
b. 21 Mar 1828 d. 30 Mar 1896
+
James Nathan Gentry
7
Jacintha Catherine Brown
[1.1.6.1.6.3.6]
b. 10 Aug 1830 d. 10 Jun 1880
+
William Kavanaugh Oldham
7
Angeline Mildred Brown
[1.1.6.1.6.3.7]
b. 9 Oct 1832
+
John Harris Miller
Charles Warner Harris
b. 15 Feb 1822 d. 23 Apr 1860
8
Mary Howell Harris
[1.1.6.1.6.3.7.1]
b. 15 Sep 1854 d. 12 Jan 1857
8
Charles Lee Harris
[1.1.6.1.6.3.7.2]
b. 24 Jul 1857
7
Brown
[1.1.6.1.6.3.8]
b. 28 Feb 1835
7
Mary Elizabeth Brown
[1.1.6.1.6.3.9]
b. 17 Jan 1818 d. 1 Aug 1854
Roberts
8
Brown Roberts
[1.1.6.1.6.3.9.1]
8
Frank Roberts
[1.1.6.1.6.3.9.2]
8
Fannie Roberts
[1.1.6.1.6.3.9.3]
8
William Roberts
[1.1.6.1.6.3.9.4]
8
John Roberts
[1.1.6.1.6.3.9.5]
+
Mary Caruthers
6
Lucy Brown
[1.1.6.1.6.4]
b. 7 Nov 1778 d. 16 Feb 1852
+
Nathaniel Thompson
d. 1874
6
Sarah Brown
[1.1.6.1.6.5]
b. 6 Jun 1792 d. 2 May 1852
Beverly A. Brown
7
Virginia Brown
[1.1.6.1.6.5.1]
7
Emaline Brown
[1.1.6.1.6.5.2]
+
Alexander Mosely
7
Lucy Frances Brown
[1.1.6.1.6.5.3]
+
John Hawthorne
+
John Holbrooke
7
Sarah Brown
[1.1.6.1.6.5.4]
+
Vernon Cobbs
7
Edwin Brown
[1.1.6.1.6.5.5]
+
Bettie Thompson
6
Charles M. Brown
[1.1.6.1.6.6]
b. 3 May 1783 d. 1879
Mary Brown
b. 1783 d. 1879
7
Ezra M. Brown
[1.1.6.1.6.6.1]
+
Sally Tilman
7
Bettie Brown
[1.1.6.1.6.6.2]
+
William H. Jones
7
Elvira Brown
[1.1.6.1.6.6.3]
+
Ayers
7
Bezaleel Ira Brown
[1.1.6.1.6.6.4]
Mary Ann Garth
8
Brown
[1.1.6.1.6.6.4.1]
+
Oscar Early
7
Charles Thomas Brown
[1.1.6.1.6.6.5]
7
Algernon Brown
[1.1.6.1.6.6.6]
7
Oswin Brown
[1.1.6.1.6.6.7]
6
Asa Brightberry Brown
[1.1.6.1.6.7]
b. 5 Jun 1794 d. 30 Jan 1839
Marie Brown
7
Thomas Ally Brown
[1.1.6.1.6.7.1]
7
Martha Brown
[1.1.6.1.6.7.2]
7
Bernard Brown
[1.1.6.1.6.7.3]
+
Susan Brown
7
Bettie Brown
[1.1.6.1.6.7.4]
+
Samuel Woodson
6
Benjamin Hescott Brown
[1.1.6.1.6.8]
b. 12 Mar 1790 d. 5 Dec 1875
Judith Fretwell
b. 8 Mar 1782 d. 13 Feb 1870
7
William Bernard Brown
[1.1.6.1.6.8.1]
Belle Clayton
8
Jennie Brown
[1.1.6.1.6.8.1.1]
8
Amanda Brown
[1.1.6.1.6.8.1.2]
+
McMahon
8
James Brown
[1.1.6.1.6.8.1.3]
7
Thomas Brown
[1.1.6.1.6.8.2]
7
Charles Wesley Brown
[1.1.6.1.6.8.3]
Venia Spurgeon
8
Mollie Brown
[1.1.6.1.6.8.3.1]
8
Benjamin Brown
[1.1.6.1.6.8.3.2]
7
Iurenia Brown
[1.1.6.1.6.8.4]
+
Sampson Wright
7
Virginia Brown
[1.1.6.1.6.8.5]
+
Alexander Blake
7
Betsy Brown
[1.1.6.1.6.8.6]
+
Richardson
7
Francina Brown
[1.1.6.1.6.8.7]
+
Mark Long
7
Velunia Ann Brown
[1.1.6.1.6.8.8]
+
John Ingraham
7
Elvenie Brown
[1.1.6.1.6.8.9]
+
Griggs
6
Bezaleel G. Brown
[1.1.6.1.6.9]
b. 22 Sep 1787 d. 20 Apr 1825
Elizabeth E. Michie
7
William Dabney Brown
[1.1.6.1.6.9.1]
7
Martha Brown
[1.1.6.1.6.9.2]
C. H. Parrott
8
Lizzie Parrott
[1.1.6.1.6.9.2.1]
8
W. H. Parrott
[1.1.6.1.6.9.2.2]
8
C. C. Parrott
[1.1.6.1.6.9.2.3]
8
Soonie Parrott
[1.1.6.1.6.9.2.4]
7
Cynthia Brown
[1.1.6.1.6.9.3]
+
William Harris Brown
7
Addison Brown
[1.1.6.1.6.9.4]
7
John Augustus Brown
[1.1.6.1.6.9.5]
+
Columbia Brown
7
Angeline Brown
[1.1.6.1.6.9.6]
+
George Kemper
6
Robert Thompson Brown
[1.1.6.1.6.10]
b. 16 Jan 1777 d. 30 Mar 1851
Elizabeth Crenshaw
b. Abt 1779 d. 1852
7
Anna Dabney Brown
[1.1.6.1.6.10.1]
b. 5 Jul 1799 d. 21 Apr 1880
+
John Wesley Harris
b. 5 Apr 1795 d. 2 Apr 1870
7
Frances Brown
[1.1.6.1.6.10.2]
b. Abt 1818
+
William Parker
b. Abt 1815
7
James Madison Brown
[1.1.6.1.6.10.3]
b. Abt 1815
Mary E.
b. Abt 1826
8
Lucy Brown
[1.1.6.1.6.10.3.1]
b. Abt 1847
7
Sarah Jane Brown
[1.1.6.1.6.10.4]
b. Abt 1806
+
George Rogers
b. Abt 1806
7
Elizabeth Brown
[1.1.6.1.6.10.5]
b. Abt 1808 d. 1877
+
Arthur Hambrick
7
Nancy T. Brown
[1.1.6.1.6.10.6]
+
Charles H. Ledsinger
7
Lucy Brown
[1.1.6.1.6.10.7]
+
Ira Ledbetter
7
Mary Brown
[1.1.6.1.6.10.8]
+
William P. Browning
7
Bernard Brown
[1.1.6.1.6.10.9]
Elizabeth Franklin
8
Brightberry T. Brown
[1.1.6.1.6.10.9.1]
b. Aug 1834
+
Martha Hoskins
6
Thomas Harris Brown
[1.1.6.1.6.11]
b. 16 Apr 1785
+
Lucy Goodman
Mildred Brown
b. 7 Nov 1788
7
Robin Brown
[1.1.6.1.6.11.1]
+
Crenshaw
7
Lavinia Brown
[1.1.6.1.6.11.2]
+
John Holbrook
7
Emaline Brown
[1.1.6.1.6.11.3]
+
William G. Fretwell
7
Eliza Dabney Brown
[1.1.6.1.6.11.4]
+
Lewis Campbell
7
Susan Brown
[1.1.6.1.6.11.5]
+
Benjamin Childress
7
Parthenia Brown
[1.1.6.1.6.11.6]
+
William Haydon
7
Lucy Ann Brown
[1.1.6.1.6.11.7]
+
Richard Noel
6
Francina Brown
[1.1.6.1.6.12]
b. 24 May 1775 d. 3 May 1846
John Rodes
b. 2 Jun 1766 d. 1839
7
William Rodes
[1.1.6.1.6.12.1]
b. 1765/1801 d. 1806/1880
+
Elizabeth Clarissa Yancey
b. 1775/1803 d. 1806/1885
+
Clarissa Yancey
7
Jacintha Tazewell Rodes
[1.1.6.1.6.12.2]
b. 20 Aug 1809
John Massie Smith
8
John Massie Smith
[1.1.6.1.6.12.2.1]
8
Frances Rodes Smith
[1.1.6.1.6.12.2.2]
8
Charles Thompson Smith
[1.1.6.1.6.12.2.3]
8
Bettie Massie Smith
[1.1.6.1.6.12.2.4]
8
William Henry Smith
[1.1.6.1.6.12.2.5]
8
Robert Hardin Smith
[1.1.6.1.6.12.2.6]
James M. Harris
8
James Clifton Harris
[1.1.6.1.6.12.2.7]
8
Lizzie Woods Harris
[1.1.6.1.6.12.2.8]
8
Mary Alice Harris
[1.1.6.1.6.12.2.9]
7
Sydney Rodes
[1.1.6.1.6.12.3]
Powhatan Jones
8
Judith Francena Rodes
[1.1.6.1.6.12.3.1]
7
Ryland Rodes
[1.1.6.1.6.12.4]
+
Virginia Woods
7
Sarah Rodes
[1.1.6.1.6.12.5]
+
Samuel Woods
7
John Rodes
[1.1.6.1.6.12.6]
+
Ann
7
Frances Rodes
[1.1.6.1.6.12.7]
+
Garland Brown
7
Virginia Rodes
[1.1.6.1.6.12.8]
+
Wilson C. Smith
7
Tyree Rodes
[1.1.6.1.6.12.9]
7
Lucy Rodes
[1.1.6.1.6.12.10]
+
Newlands
5
Susan Dabney
[1.1.6.1.7]
b. 1756 d. 1784/1850
+
Thomas Harris
b. 3 Apr 1755 d. 12 Sep 1842
5
Lucy Dabney
[1.1.6.1.8]
b. Abt 1757 d. 1747/1849
+
Thomas McReynolds
5
Rebecca Dabney
[1.1.6.1.9]
b. Abt 1759 d. 1773/1849
+
Thomas Warner
b. 1732/1764 d. 1773/1844
5
Cornelius Dabney
[1.1.6.1.10]
b. Abt 1761 d. 1747/1846
+
Jane Harris
+
Frances Harris
5
Nancy Dabney
[1.1.6.1.11]
b. Abt 1763 d. 1773/1849
+
John Hunter
b. 1732/1764 d. 1773/1844
4
Sarah Dabney
[1.1.6.2]
b. 16 Nov 1724 d. 5 Mar 1815
Benjamin Brown
b. Abt 1718 d. 9 Nov 1762
5
Barzillai Brown
[1.1.6.2.1]
b. 1747 d. 4 Jan 1829
+
Mary Thompson
5
Benajah Brown
[1.1.6.2.2]
b. 1748 d. 1814
Mary Jarman
6
Beverley Brown
[1.1.6.2.2.1]
6
Miletus Brown
[1.1.6.2.2.2]
7
Beverly A. Brown
[1.1.6.2.2.2.1]
Sarah Brown
b. 6 Jun 1792 d. 2 May 1852
8
Virginia Brown
[1.1.6.2.2.2.1.1]
8
Emaline Brown
[1.1.6.2.2.2.1.2]
+
Alexander Mosely
8
Lucy Frances Brown
[1.1.6.2.2.2.1.3]
+
John Hawthorne
+
John Holbrooke
8
Sarah Brown
[1.1.6.2.2.2.1.4]
+
Vernon Cobbs
8
Edwin Brown
[1.1.6.2.2.2.1.5]
+
Bettie Thompson
6
Garland Brown
[1.1.6.2.2.3]
Patsey Bransford
7
Jack Brown
[1.1.6.2.2.3.1]
7
Martha Brown
[1.1.6.2.2.3.2]
7
Sallie Brown
[1.1.6.2.2.3.3]
+
James Jarman
7
Katie Brown
[1.1.6.2.2.3.4]
7
Patsey Brown
[1.1.6.2.2.3.5]
5
Brightberry Brown
[1.1.6.2.3]
b. 13 Feb 1762 d. 26 Jan 1846
Susan Thompson
b. 21 Jan 1766
6
Horace Brown
[1.1.6.2.3.1]
b. 14 Apr 1807
Lucy E. Parrott
b. 6 May 1814
7
H. Nimrod Brown
[1.1.6.2.3.1.1]
b. Abt 1834
Sue Almond
8
Sudie B. Brown
[1.1.6.2.3.1.1.1]
Nathaniel B. Early
9
Richard Nimrod Early
[1.1.6.2.3.1.1.1.1]
+
Anna Lohr
9
Lucille Early
[1.1.6.2.3.1.1.1.2]
+
Albert N. Fray
9
Mary Ann Early
[1.1.6.2.3.1.1.1.3]
+
Bledsoe B. Parrott
9
Nathaniel B. Early
[1.1.6.2.3.1.1.1.4]
7
William H. Brown
[1.1.6.2.3.1.2]
b. 8 Apr 1840
Mollie Banks
b. 2 Dec 1858 d. 29 Nov 1941
8
Horace Brown
[1.1.6.2.3.1.2.1]
b. 1903
8
James W. Brown
[1.1.6.2.3.1.2.2]
b. 1 Mar 1893
8
Edward Nimrod Brown
[1.1.6.2.3.1.2.3]
b. 1898
8
Lula Brown
[1.1.6.2.3.1.2.4]
+
Charles Garth
8
Henry Brown
[1.1.6.2.3.1.2.5]
7
George Brown
[1.1.6.2.3.1.3]
7
Brown
[1.1.6.2.3.1.4]
7
Mary Susan Brown
[1.1.6.2.3.1.5]
+
Edgar Emmett Brown
7
Charles Brown
[1.1.6.2.3.1.6]
+
Virginia Cobb
7
Edward Brown
[1.1.6.2.3.1.7]
6
Edmund Brown
[1.1.6.2.3.2]
b. 7 Apr 1792
Theodosia Michie
7
Marshall Brown
[1.1.6.2.3.2.1]
6
Mildred Brown
[1.1.6.2.3.3]
b. 7 Nov 1788
Thomas Harris Brown
b. 16 Apr 1785
7
Robin Brown
[1.1.6.2.3.3.1]
+
Crenshaw
7
Lavinia Brown
[1.1.6.2.3.3.2]
+
John Holbrook
7
Emaline Brown
[1.1.6.2.3.3.3]
+
William G. Fretwell
7
Eliza Dabney Brown
[1.1.6.2.3.3.4]
+
Lewis Campbell
7
Susan Brown
[1.1.6.2.3.3.5]
+
Benjamin Childress
7
Parthenia Brown
[1.1.6.2.3.3.6]
+
William Haydon
7
Lucy Ann Brown
[1.1.6.2.3.3.7]
+
Richard Noel
6
Suca Brown
[1.1.6.2.3.4]
b. 17 Sep 1803 d. 14 Aug 1805
6
H. Nimrod Brown
[1.1.6.2.3.5]
b. 5 Apr 1797 d. 11 Aug 1835
Susanna T. Brown
b. 29 Mar 1809 d. 3 Feb 1855
7
Reuben Brown
[1.1.6.2.3.5.1]
b. Abt 1825
6
Jr. Brightberry Brown
[1.1.6.2.3.6]
b. 17 Nov 1794
Harriet Rollins
7
Isabella Brown
[1.1.6.2.3.6.1]
+
Tazwell Brown
7
Jacqueline Brown
[1.1.6.2.3.6.2]
6
Clifton Brown
[1.1.6.2.3.7]
b. 6 Aug 1799
+
Elizabeth Dabney Brown
b. 8 Aug 1822
Sarah J. Brown
b. 11 Apr 1805
7
Tazwell Brown
[1.1.6.2.3.7.1]
+
Isabella Brown
7
Virginia A. Brown
[1.1.6.2.3.7.2]
7
T. H. B. Brown
[1.1.6.2.3.7.3]
Elizabeth Ellen Carpenter
8
Lulu Brown
[1.1.6.2.3.7.3.1]
b. 8 Jul 1870 d. 18 Jan 1943
Augustus Renick McNeill
b. 26 Nov 1859 d. 19 Jun 1932
9
Augustus Cleland McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.1.1]
b. 11 Jul 1887 d. 26 Aug 1938
Nannie Bell Gilkessen
10
John Gilkeson McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.1.1.1]
b. 28 Apr 1918 d. 12 Mar 1966
10
Robert Spottswood McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.1.1.2]
10
Thomas Bernard McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.1.1.3]
+
Betty Miley Pilgrim
9
Daniel Brown McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.1.2]
b. 4 Mar 1889 d. 14 Mar 1943
+
Lulu Darrow
8
Verdie Leigh Brown
[1.1.6.2.3.7.3.2]
b. 13 Feb 1861 d. 24 Nov 1920
Edward Williams McNeill
b. 15 Jun 1857 d. 16 Feb 1927
9
Chauncey S. McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.2.1]
b. 1886
+
Carolyn Lee
9
Llewellyn Brown McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.2.2]
b. Cal 1881
Elizabeth Heiskell
10
Jean McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.2.2.1]
9
Roland Karl McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.2.3]
b. 5 Jun 1889 d. 23 Jan 1934
+
Marie Inskeep
9
Verdie Genevieve McNeill
[1.1.6.2.3.7.3.2.4]
+
Harry Cronin
8
DeWitt Brown
[1.1.6.2.3.7.3.3]
8
Bernard Brown
[1.1.6.2.3.7.3.4]
8
Sallie Brown
[1.1.6.2.3.7.3.5]
8
Edward Brown
[1.1.6.2.3.7.3.6]
7
William A. Brown
[1.1.6.2.3.7.4]
7
Susan Brown
[1.1.6.2.3.7.5]
+
Nettie Farrar
6
William Brown
[1.1.6.2.3.8]
b. 1 Aug 1790
Susan Fretwell
7
Strother Brown
[1.1.6.2.3.8.1]
8
Orville Brown
[1.1.6.2.3.8.1.1]
6
Amanda Brown
[1.1.6.2.3.9]
b. 16 Jan 1809 d. 5 Mar 1882
George Thompson Brown
b. 29 Dec 1807 d. 7 Jun 1883
7
Sarah P. Brown
[1.1.6.2.3.9.1]
b. Abt 1846
+
Benjamin Adams
b. Abt 1844
7
Reuben Dabney Brown
[1.1.6.2.3.9.2]
b. 20 Jun 1848
Margaret Matilda Crenshaw
8
Mary Elizabeth Brown
[1.1.6.2.3.9.2.1]
7
William Brown
[1.1.6.2.3.9.3]
b. Abt 1834
7
Lucy Brown
[1.1.6.2.3.9.4]
b. Abt 1844
+
Adams
7
Llewellyn Brown
[1.1.6.2.3.9.5]
b. Abt 1830
7
Benjamin Brown
[1.1.6.2.3.9.6]
b. Abt 1840
7
Amanda C. Brown
[1.1.6.2.3.9.7]
b. Apr 1822 d. 16 Sep 1839
7
Susan Brown
[1.1.6.2.3.9.8]
b. Abt 1842
+
John Chenault
7
George Brown
[1.1.6.2.3.9.9]
b. Abt 1832
7
Clifton Brown
[1.1.6.2.3.9.10]
b. Abt 1837
7
Charles Brown
[1.1.6.2.3.9.11]
b. Abt 1850
5
Bernis Brown
[1.1.6.2.4]
b. 15 Aug 1752 d. 30 Oct 1814
Henrietta Rodes
b. 26 May 1761 d. 1 Jun 1846
6
Sarah Brown
[1.1.6.2.4.1]
b. 17 Jan 1783 d. 1825
Thomas Jones
b. 1777 d. 1863
7
Henrietta Brown Jones
[1.1.6.2.4.1.1]
b. 8 Jan 1810 d. 16 Dec 1891
John McNeill
b. 26 Feb 1793 d. 3 Jun 1876
8
Sarah Nancy McNeill
[1.1.6.2.4.1.1.1]
b. 14 Feb 1833 d. 1 Feb 1884
Edmund Alexander Ramsey
b. 1 Feb 1822 d. 19 Mar 1899
9
John M. Ramsey
[1.1.6.2.4.1.1.1.1]
b. 1851 d. Apr 1891
Harriet Gertrude Wright
10
John E. Ramsey
[1.1.6.2.4.1.1.1.1.1]
b. Apr 1887
+
Avis Wise
10
Harry T. Ramsey
[1.1.6.2.4.1.1.1.1.2]
b. 29 May 1890
+
Jessie Doyle
9
Cora E. Ramsey
[1.1.6.2.4.1.1.1.2]
b. 1857
+
John Halbert
9
Edmond Thomas Ramsey
[1.1.6.2.4.1.1.1.3]
b. 15 Apr 1864 d. 5 May 1938
+
May McNeilly Breast
b. 1 Apr 1871 d. 23 Jan 1965
9
Mary Ella Ramsey
[1.1.6.2.4.1.1.1.4]
b. 1853 d. 1894
William Gourley
b. 1847 d. 1914
10
Lillie M. Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1]
b. 6 Jul 1880 d. 14 Sep 1916
Charles Grider Bruce
b. 12 Jun 1879 d. 1933
11
Ella Lucille Bruce
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1.1]
b. 19 Feb 1903 d. 22 Mar 1930
11
James Robert Bruce
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1.2]
Mary Ruth Elizabeth Carroll
12
Bonnie Rose Bruce
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1.2.1]
b. 18 Jun 1929 d. 17 Jul 1929
12
Ruth Ann Bruce
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1.2.2]
12
Jr. James Robert Bruce
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1.2.3]
[
=>
]
12
Rebecca Carroll Bruce
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1.2.4]
[
=>
]
12
John Edward Bruce
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1.2.5]
[
=>
]
12
Lillian Elizabeth Bruce
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.1.2.6]
[
=>
]
10
John A. Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.2]
b. 1874 d. 1912
10
Samuel Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.3]
b. 1887
10
Rebecca Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.4]
b. 18 Sep 1882 d. 29 Nov 1963
David D. Walker
b. 30 Nov 1878 d. 19 Feb 1946
11
Jr. David D. Walker
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.4.1]
Christine Coggin
12
Larry Walker
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.4.1.1]
[
=>
]
12
Steve Walker
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.4.1.2]
[
=>
]
12
John Walker
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.4.1.3]
12
Dan Walker
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.4.1.4]
10
Merle Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.5]
b. 8 May 1890
10
Sara Elizabeth Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.6]
b. 1894
Wesley James Hailey
11
Charles Hailey
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.6.1]
+
Betty
11
Jr. Wesley James Hailey
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.6.2]
Polly Sue Bracey
12
III Wesley James Hailey
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.6.2.1]
10
Jr. William Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.7]
+
Jim
10
Arthur Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.8]
+
Alfa Whitsett
10
Henry Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.9]
Hazel Lipe
11
Raymond W. Gourley
[1.1.6.2.4.1.1.1.4.9.1]
b. 5 Feb 1902 d. 5 May 1966
9
Marietta Ramsey
[1.1.6.2.4.1.1.1.5]
b. 1854
+
Denney
8
Joseph B. McNeill
[1.1.6.2.4.1.1.2]
b. 1835 d. 24 Aug 1920
Jane M. Keys
9
Sarah E. McNeill
[1.1.6.2.4.1.1.2.1]
b. Abt 1858
9
John Cage McNeill
[1.1.6.2.4.1.1.2.2]
b. Abt 1857
+
Emma J. Staggs
+
Sarah Catherine McNeely
b. 1846
8
Elizabeth A. McNeill
[1.1.6.2.4.1.1.3]
b. 1841
+
Benjamin H. Hargrave
6
Henrietta Brown
[1.1.6.2.4.2]
b. 6 Mar 1787
+
John Ruff
6
Anna Brown
[1.1.6.2.4.3]
b. 25 Apr 1789 d. 6 May 1817
John Dickerson
7
Henrietta Rodes Dickerson
[1.1.6.2.4.3.1]
Henry Tazewell Austin
8
Felix Houston Austin
[1.1.6.2.4.3.1.1]
6
Bernis Brown
[1.1.6.2.4.4]
b. 5 May 1791
6
Tyree Rodes Brown
[1.1.6.2.4.5]
b. 13 Jun 1793 d. 26 Dec 1836
Sarah Nicholas
d. 28 Dec 1836
7
Julian Henrietta Rodes Brown
[1.1.6.2.4.5.1]
b. 7 Apr 1818
+
Charles Carthrae
7
Sidna Elizabeth Brown
[1.1.6.2.4.5.2]
b. 18 May 1821
+
Addison Carthrae
7
Madison Nicholas Brown
[1.1.6.2.4.5.3]
b. 21 Mar 1815 d. 17 Dec 1880
Mary Sewell Hopkins
d. 6 Jun 1896
8
Tyree Brown
[1.1.6.2.4.5.3.1]
b. 31 Jan 1860 d. 23 Sep 1893
Sallie Rust
9
Roger Q. Brown
[1.1.6.2.4.5.3.1.1]
9
Rust B. Brown
[1.1.6.2.4.5.3.1.2]
9
Richard Tyree Brown
[1.1.6.2.4.5.3.1.3]
8
Thomas Jefferson Brown
[1.1.6.2.4.5.3.2]
Clemmie Rust
9
Kate Strother Brown
[1.1.6.2.4.5.3.2.1]
9
Pocahontas Rust Brown
[1.1.6.2.4.5.3.2.2]
8
Mary Virginia Brown
[1.1.6.2.4.5.3.3]
+
Morris Osburn
8
Julian Catherine Brown
[1.1.6.2.4.5.3.4]
+
Alfred T. Irvine
d. 8 Mar 1875
8
Frances Elizabeth Brown
[1.1.6.2.4.5.3.5]
d. 19 Jun 1861
6
Benjamin Thompson Brown
[1.1.6.2.4.6]
b. 6 Jan 1796 d. 15 Jun 1867
Lucy Ann Richards
7
Lucian Brown
[1.1.6.2.4.6.1]
b. 29 Mar 1850 d. 17 May 1930
Frances Michie
b. 18 Jul 1856 d. 11 Jul 1928
8
Mary Nelson Brown
[1.1.6.2.4.6.1.1]
b. 20 Feb 1883
8
Frances Ann Brown
[1.1.6.2.4.6.1.2]
b. 12 Feb 1886
8
Elizabeth Louise Brown
[1.1.6.2.4.6.1.3]
b. 14 Dec 1888
8
John Richards Brown
[1.1.6.2.4.6.1.4]
b. 12 Jun 1891
Lorena C. Miller
9
Mary Joan Brown
[1.1.6.2.4.6.1.4.1]
+
James Ross Oyler
8
Lucian Howard Brown
[1.1.6.2.4.6.1.5]
b. 19 Sep 1894
Gladys Layman
9
Robert Randolph Brown
[1.1.6.2.4.6.1.5.1]
Gloria M. Luerdrick
10
Randolph Michie Brown
[1.1.6.2.4.6.1.5.1.1]
10
Kevin David Brown
[1.1.6.2.4.6.1.5.1.2]
10
Douglas Christopher Brown
[1.1.6.2.4.6.1.5.1.3]
10
Gregory Shaffer Brown
[1.1.6.2.4.6.1.5.1.4]
10
Paul Martin Brown
[1.1.6.2.4.6.1.5.1.5]
7
Elizabeth Brown
[1.1.6.2.4.6.2]
7
John R. Brown
[1.1.6.2.4.6.3]
+
Candice Hall
7
Lucy Ann Brown
[1.1.6.2.4.6.4]
7
Jefferson Randolph Brown
[1.1.6.2.4.6.5]
+
Florence Carter
7
James R. Brown
[1.1.6.2.4.6.6]
+
Lillie Smith
7
Bernis B. Brown
[1.1.6.2.4.6.7]
+
Elizabeth Imbodin
6
Elizabeth Brown
[1.1.6.2.4.7]
b. 23 Jul 1798
+
Charles Carthrae
6
John R. Brown
[1.1.6.2.4.8]
b. 7 Jan 1801
6
Mary A. Brown
[1.1.6.2.4.9]
b. 30 Oct 1780 d. 11 Dec 1795
6
Brown
[1.1.6.2.4.10]
b. 1 Dec 1781
6
Nancy Brown
[1.1.6.2.4.11]
b. 26 Dec 1784
5
Bezaleel Brown
[1.1.6.2.5]
b. 29 Jul 1754 d. 4 Jan 1829
Mary Thompson
6
Lucy Thompson Brown
[1.1.6.2.5.1]
b. 17 Jan 1784
Reuben Dabney Brown
b. 16 Jan 1777 d. 5 Jul 1849
7
Susanna T. Brown
[1.1.6.2.5.1.1]
b. 29 Mar 1809 d. 3 Feb 1855
H. Nimrod Brown
b. 5 Apr 1797 d. 11 Aug 1835
8
Reuben Brown
[1.1.6.2.5.1.1.1]
b. Abt 1825
7
George Thompson Brown
[1.1.6.2.5.1.2]
b. 29 Dec 1807 d. 7 Jun 1883
Amanda Brown
b. 16 Jan 1809 d. 5 Mar 1882
8
Sarah P. Brown
[1.1.6.2.5.1.2.1]
b. Abt 1846
+
Benjamin Adams
b. Abt 1844
8
Reuben Dabney Brown
[1.1.6.2.5.1.2.2]
b. 20 Jun 1848
Margaret Matilda Crenshaw
9
Mary Elizabeth Brown
[1.1.6.2.5.1.2.2.1]
8
William Brown
[1.1.6.2.5.1.2.3]
b. Abt 1834
8
Lucy Brown
[1.1.6.2.5.1.2.4]
b. Abt 1844
+
Adams
8
Llewellyn Brown
[1.1.6.2.5.1.2.5]
b. Abt 1830
8
Benjamin Brown
[1.1.6.2.5.1.2.6]
b. Abt 1840
8
Amanda C. Brown
[1.1.6.2.5.1.2.7]
b. Apr 1822 d. 16 Sep 1839
8
Susan Brown
[1.1.6.2.5.1.2.8]
b. Abt 1842
+
John Chenault
8
George Brown
[1.1.6.2.5.1.2.9]
b. Abt 1832
8
Clifton Brown
[1.1.6.2.5.1.2.10]
b. Abt 1837
8
Charles Brown
[1.1.6.2.5.1.2.11]
b. Abt 1850
7
Brightberry Brown
[1.1.6.2.5.1.3]
b. Abt 1811
7
Llewellyn Brown
[1.1.6.2.5.1.4]
b. Abt 1815
7
Francina Rhodes Brown
[1.1.6.2.5.1.5]
b. 1819 d. 1894
6
Mary Brown
[1.1.6.2.5.2]
b. 1783 d. 1879
Charles M. Brown
b. 3 May 1783 d. 1879
7
Ezra M. Brown
[1.1.6.2.5.2.1]
+
Sally Tilman
7
Bettie Brown
[1.1.6.2.5.2.2]
+
William H. Jones
7
Elvira Brown
[1.1.6.2.5.2.3]
+
Ayers
7
Bezaleel Ira Brown
[1.1.6.2.5.2.4]
Mary Ann Garth
8
Brown
[1.1.6.2.5.2.4.1]
+
Oscar Early
7
Charles Thomas Brown
[1.1.6.2.5.2.5]
7
Algernon Brown
[1.1.6.2.5.2.6]
7
Oswin Brown
[1.1.6.2.5.2.7]
6
William T. Brown
[1.1.6.2.5.3]
d. 1877
Mary Ann Jarman
7
J. W. Brown
[1.1.6.2.5.3.1]
7
Bezaleel Brown
[1.1.6.2.5.3.2]
7
Lucy Brown
[1.1.6.2.5.3.3]
7
Sarah Brown
[1.1.6.2.5.3.4]
+
John R. Early
7
Mary S. Brown
[1.1.6.2.5.3.5]
+
William E. Bibb
6
Bezaleel Brown
[1.1.6.2.5.4]
d. 1878
Elizabeth Price
7
George Brown
[1.1.6.2.5.4.1]
Harriett Golding
8
Mary Brown
[1.1.6.2.5.4.1.1]
8
Lucien L. Brown
[1.1.6.2.5.4.1.2]
8
Virgil Brown
[1.1.6.2.5.4.1.3]
8
Wilmes Brown
[1.1.6.2.5.4.1.4]
8
Sallie Belle Brown
[1.1.6.2.5.4.1.5]
+
Faunt Kemper
7
Mary Frances Brown
[1.1.6.2.5.4.2]
+
Waller Harris
7
Oscar Brown
[1.1.6.2.5.4.3]
7
Columbia Brown
[1.1.6.2.5.4.4]
+
John Augustus Brown
7
Erastus R. Brown
[1.1.6.2.5.4.5]
+
Harper
7
Francis Brown
[1.1.6.2.5.4.6]
7
W. W. Brown
[1.1.6.2.5.4.7]
+
Sprinkle
7
Mattie A. Brown
[1.1.6.2.5.4.8]
7
Lucy T. Brown
[1.1.6.2.5.4.9]
J. D. Garth
8
Lizzie Garth
[1.1.6.2.5.4.9.1]
8
Allie Garth
[1.1.6.2.5.4.9.2]
8
Sarah Garth
[1.1.6.2.5.4.9.3]
Buck Autrim
9
Price Autrim
[1.1.6.2.5.4.9.3.1]
+
Constable
9
Columbia Autrim
[1.1.6.2.5.4.9.3.2]
+
Gus Brown
8
Mattie A. Garth
[1.1.6.2.5.4.9.4]
J. J. Laferty
9
Edward Laferty
[1.1.6.2.5.4.9.4.1]
+
Taylor
9
William Laferty
[1.1.6.2.5.4.9.4.2]
+
Owens
9
George Laferty
[1.1.6.2.5.4.9.4.3]
+
Lay
9
Walter Laferty
[1.1.6.2.5.4.9.4.4]
+
Tally
9
Annie Laferty
[1.1.6.2.5.4.9.4.5]
+
Cates
8
Charles Garth
[1.1.6.2.5.4.9.5]
Ham Michie
8
Fannie Michie
[1.1.6.2.5.4.9.6]
7
Cornelia Brown
[1.1.6.2.5.4.10]
+
J. W. Poynts
7
Aldretus P. Brown
[1.1.6.2.5.4.11]
+
Emily Scott
6
Elizabeth Brown
[1.1.6.2.5.5]
Jesse Garth
7
Polly Garth
[1.1.6.2.5.5.1]
7
Bezaleel Garth
[1.1.6.2.5.5.2]
7
Brightberry Garth
[1.1.6.2.5.5.3]
Graves
8
Martha Garth
[1.1.6.2.5.5.3.1]
Calvin Garnett
9
Henry Garnett
[1.1.6.2.5.5.3.1.1]
9
Virgil Garnett
[1.1.6.2.5.5.3.1.2]
9
Robert Garnett
[1.1.6.2.5.5.3.1.3]
8
Virginia Garth
[1.1.6.2.5.5.3.2]
7
William Garth
[1.1.6.2.5.5.4]
7
Sarah Garth
[1.1.6.2.5.5.5]
7
Thomas Garth
[1.1.6.2.5.5.6]
6
Sarah Brown
[1.1.6.2.5.6]
Charles Parrott
7
Lucy E. Parrott
[1.1.6.2.5.6.1]
b. 6 May 1814
Horace Brown
b. 14 Apr 1807
8
H. Nimrod Brown
[1.1.6.2.5.6.1.1]
b. Abt 1834
Sue Almond
9
Sudie B. Brown
[1.1.6.2.5.6.1.1.1]
Nathaniel B. Early
10
Richard Nimrod Early
[1.1.6.2.5.6.1.1.1.1]
+
Anna Lohr
10
Lucille Early
[1.1.6.2.5.6.1.1.1.2]
+
Albert N. Fray
10
Mary Ann Early
[1.1.6.2.5.6.1.1.1.3]
+
Bledsoe B. Parrott
10
Nathaniel B. Early
[1.1.6.2.5.6.1.1.1.4]
8
William H. Brown
[1.1.6.2.5.6.1.2]
b. 8 Apr 1840
Mollie Banks
b. 2 Dec 1858 d. 29 Nov 1941
9
Horace Brown
[1.1.6.2.5.6.1.2.1]
b. 1903
9
James W. Brown
[1.1.6.2.5.6.1.2.2]
b. 1 Mar 1893
9
Edward Nimrod Brown
[1.1.6.2.5.6.1.2.3]
b. 1898
9
Lula Brown
[1.1.6.2.5.6.1.2.4]
+
Charles Garth
9
Henry Brown
[1.1.6.2.5.6.1.2.5]
8
George Brown
[1.1.6.2.5.6.1.3]
8
Brown
[1.1.6.2.5.6.1.4]
8
Mary Susan Brown
[1.1.6.2.5.6.1.5]
+
Edgar Emmett Brown
8
Charles Brown
[1.1.6.2.5.6.1.6]
+
Virginia Cobb
8
Edward Brown
[1.1.6.2.5.6.1.7]
7
Sarah Parrott
[1.1.6.2.5.6.2]
7
William T. Parrott
[1.1.6.2.5.6.3]
7
Columbia M. Parrott
[1.1.6.2.5.6.4]
7
B. B. Parrott
[1.1.6.2.5.6.5]
7
N. B. Parrott
[1.1.6.2.5.6.6]
7
C. H. Parrott
[1.1.6.2.5.6.7]
Martha Brown
8
Lizzie Parrott
[1.1.6.2.5.6.7.1]
8
W. H. Parrott
[1.1.6.2.5.6.7.2]
8
C. C. Parrott
[1.1.6.2.5.6.7.3]
8
Soonie Parrott
[1.1.6.2.5.6.7.4]
5
Lucretia Brown
[1.1.6.2.6]
b. 1746
Robert Harris
b. 8 Mar 1740/41 d. 1796
6
Tyree Rodes Harris
[1.1.6.2.6.1]
b. 15 Mar 1765 d. 1841
6
Elijah Harris
[1.1.6.2.6.2]
6
Bazleel B. Bernice Harris
[1.1.6.2.6.3]
6
Lucretia Harris
[1.1.6.2.6.4]
6
Mourning Harris
[1.1.6.2.6.5]
6
Nancy Harris
[1.1.6.2.6.6]
+
Jr. Ratliff Boon
b. 1755 d. 1815
6
Lucy Harris
[1.1.6.2.6.7]
6
Patsy Harris
[1.1.6.2.6.8]
6
Sarah Harris
[1.1.6.2.6.9]
5
Bernard Brown
[1.1.6.2.7]
b. 28 Jan 1749/50 d. 26 Feb 1800
Elizabeth Jennings Dabney
b. 18 Jun 1751 d. 21 Jul 1826
6
Reuben Dabney Brown
[1.1.6.2.7.1]
b. 16 Jan 1777 d. 5 Jul 1849
Lucy Thompson Brown
b. 17 Jan 1784
7
Susanna T. Brown
[1.1.6.2.7.1.1]
b. 29 Mar 1809 d. 3 Feb 1855
H. Nimrod Brown
b. 5 Apr 1797 d. 11 Aug 1835
8
Reuben Brown
[1.1.6.2.7.1.1.1]
b. Abt 1825
7
George Thompson Brown
[1.1.6.2.7.1.2]
b. 29 Dec 1807 d. 7 Jun 1883
Amanda Brown
b. 16 Jan 1809 d. 5 Mar 1882
8
Sarah P. Brown
[1.1.6.2.7.1.2.1]
b. Abt 1846
+
Benjamin Adams
b. Abt 1844
8
Reuben Dabney Brown
[1.1.6.2.7.1.2.2]
b. 20 Jun 1848
Margaret Matilda Crenshaw
9
Mary Elizabeth Brown
[1.1.6.2.7.1.2.2.1]
8
William Brown
[1.1.6.2.7.1.2.3]
b. Abt 1834
8
Lucy Brown
[1.1.6.2.7.1.2.4]
b. Abt 1844
+
Adams
8
Llewellyn Brown
[1.1.6.2.7.1.2.5]
b. Abt 1830
8
Benjamin Brown
[1.1.6.2.7.1.2.6]
b. Abt 1840
8
Amanda C. Brown
[1.1.6.2.7.1.2.7]
b. Apr 1822 d. 16 Sep 1839
8
Susan Brown
[1.1.6.2.7.1.2.8]
b. Abt 1842
+
John Chenault
8
George Brown
[1.1.6.2.7.1.2.9]
b. Abt 1832
8
Clifton Brown
[1.1.6.2.7.1.2.10]
b. Abt 1837
8
Charles Brown
[1.1.6.2.7.1.2.11]
b. Abt 1850
7
Brightberry Brown
[1.1.6.2.7.1.3]
b. Abt 1811
7
Llewellyn Brown
[1.1.6.2.7.1.4]
b. Abt 1815
7
Francina Rhodes Brown
[1.1.6.2.7.1.5]
b. 1819 d. 1894
6
Bernard M. Brown
[1.1.6.2.7.2]
b. 15 Mar 1781 d. 1825
Miriam Cave Maupin
b. 19 Dec 1783
7
Thompson Brown
[1.1.6.2.7.2.1]
b. 6 Oct 1803
+
Sarah Brown
7
Sarah J. Brown
[1.1.6.2.7.2.2]
b. 11 Apr 1805
Clifton Brown
b. 6 Aug 1799
8
Tazwell Brown
[1.1.6.2.7.2.2.1]
+
Isabella Brown
8
Virginia A. Brown
[1.1.6.2.7.2.2.2]
8
T. H. B. Brown
[1.1.6.2.7.2.2.3]
Elizabeth Ellen Carpenter
9
Lulu Brown
[1.1.6.2.7.2.2.3.1]
b. 8 Jul 1870 d. 18 Jan 1943
Augustus Renick McNeill
b. 26 Nov 1859 d. 19 Jun 1932
10
Augustus Cleland McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.1.1]
b. 11 Jul 1887 d. 26 Aug 1938
Nannie Bell Gilkessen
11
John Gilkeson McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.1.1.1]
b. 28 Apr 1918 d. 12 Mar 1966
11
Robert Spottswood McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.1.1.2]
11
Thomas Bernard McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.1.1.3]
+
Betty Miley Pilgrim
10
Daniel Brown McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.1.2]
b. 4 Mar 1889 d. 14 Mar 1943
+
Lulu Darrow
9
Verdie Leigh Brown
[1.1.6.2.7.2.2.3.2]
b. 13 Feb 1861 d. 24 Nov 1920
Edward Williams McNeill
b. 15 Jun 1857 d. 16 Feb 1927
10
Chauncey S. McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.2.1]
b. 1886
+
Carolyn Lee
10
Llewellyn Brown McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.2.2]
b. Cal 1881
Elizabeth Heiskell
11
Jean McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.2.2.1]
10
Roland Karl McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.2.3]
b. 5 Jun 1889 d. 23 Jan 1934
+
Marie Inskeep
10
Verdie Genevieve McNeill
[1.1.6.2.7.2.2.3.2.4]
+
Harry Cronin
9
DeWitt Brown
[1.1.6.2.7.2.2.3.3]
9
Bernard Brown
[1.1.6.2.7.2.2.3.4]
9
Sallie Brown
[1.1.6.2.7.2.2.3.5]
9
Edward Brown
[1.1.6.2.7.2.2.3.6]
8
William A. Brown
[1.1.6.2.7.2.2.4]
8
Susan Brown
[1.1.6.2.7.2.2.5]
7
Pyrenia D. Brown
[1.1.6.2.7.2.3]
b. 31 Dec 1806
+
Tilman J. Maupin
7
Elizabeth Dabney Brown
[1.1.6.2.7.2.4]
b. 8 Aug 1822
+
Clifton Brown
b. 6 Aug 1799
7
Sidna R. Brown
[1.1.6.2.7.2.5]
b. 8 Jan 1812
7
Bernard L. Brown
[1.1.6.2.7.2.6]
b. 9 Aug 1816 d. 10 Feb 1868
Mary Elizabeth Dailey
b. Abt 1817 d. 18 May 1907
8
Lucy Blanche Brown
[1.1.6.2.7.2.6.1]
b. 10 Aug 1853 d. 2 Feb 1935
+
McCrum
8
Oscar Lee Brown
[1.1.6.2.7.2.6.2]
b. 31 Aug 1851 d. 4 May 1888
8
Alice Goodman Brown
[1.1.6.2.7.2.6.3]
b. 15 Feb 1862 d. 28 Jan 1890
8
Florence A Brown
[1.1.6.2.7.2.6.4]
b. 29 Nov 1845 d. 9 Dec 1928
8
Adeliza Frances Brown
[1.1.6.2.7.2.6.5]
b. 14 Jan 1844 d. 4 Jan 1934
8
Laura Sedna Brown
[1.1.6.2.7.2.6.6]
b. 17 Sep 1847 d. 31 May 1860
8
Charles Bernard Brown
[1.1.6.2.7.2.6.7]
b. 12 Nov 1857
8
Roberta Lee Brown
[1.1.6.2.7.2.6.8]
b. 23 Nov 1865 d. 12 Apr 1931
8
Clarence Hugh Dailey Brown
[1.1.6.2.7.2.6.9]
b. 11 Dec 1859 d. 4 Sep 1884
7
Smith W. Brown
[1.1.6.2.7.2.7]
b. 19 Apr 1814
Martha M. Brown
b. 4 May 1813 d. 15 Apr 1850
8
Mary Emnier Brown
[1.1.6.2.7.2.7.1]
b. 31 May 1847
8
Elizabeth Lewis Brown
[1.1.6.2.7.2.7.2]
b. 19 Oct 1845 d. 9 Feb 1848
8
Allen Henry Brown
[1.1.6.2.7.2.7.3]
b. 29 Apr 1841 d. 12 May 1864
8
Lucie Mariam Brown
[1.1.6.2.7.2.7.4]
b. 15 Apr 1854
8
John Jarman Brown
[1.1.6.2.7.2.7.5]
b. 17 Feb 1849 d. Feb 1903
+
Marie E. Mallory
b. 6 Jun 1826 d. 8 Jun 1886
7
James D. Brown
[1.1.6.2.7.2.8]
b. 11 Feb 1826
+
Kate Ford
7
Allen W. Brown
[1.1.6.2.7.2.9]
b. 21 Nov 1809
+
Mary Koogler
7
Francis Brown
[1.1.6.2.7.2.10]
+
Adams
6
Ira Benajah Brown
[1.1.6.2.7.3]
b. 5 Jun 1794 d. 26 Feb 1842
Frances Jarman Mullins
b. 1 Dec 1798 d. 23 May 1835
7
Burlington Dabney Brown
[1.1.6.2.7.3.1]
b. 17 May 1820 d. 26 Apr 1886
Mary Ann Harris
8
Hugh Hescott Brown
[1.1.6.2.7.3.1.1]
b. 7 Apr 1846
+
Mary Ann Metier
8
Ira Lewis Brown
[1.1.6.2.7.3.1.2]
b. 2 Mar 1848
8
Linn Roy Brown
[1.1.6.2.7.3.1.3]
b. 5 Nov 1849 d. 22 Mar 1850
8
Frank Brown
[1.1.6.2.7.3.1.4]
+
Bettie French
8
Harry Brown
[1.1.6.2.7.3.1.5]
+
Virginia Ann Bishop
8
Ralph Brown
[1.1.6.2.7.3.1.6]
8
Hattie Brown
[1.1.6.2.7.3.1.7]
+
Samuel Hatcher
8
Nettie Brown
[1.1.6.2.7.3.1.8]
+
E .A. Lofton
7
Virginia Frances Brown
[1.1.6.2.7.3.2]
b. 17 Dec 1822 d. 1883
William Kavanaugh Hocker
b. 1820 d. 1897
8
Lucy B. Hocker
[1.1.6.2.7.3.2.1]
Powhatan Patteson Truehart
b. 6 Nov 1851
9
Virginia Truehart
[1.1.6.2.7.3.2.1.1]
b. 1879
+
Edward Kilbourne
8
Fannie Hocker
[1.1.6.2.7.3.2.2]
8
Nannie Hocker
[1.1.6.2.7.3.2.3]
7
James Landon Brown
[1.1.6.2.7.3.3]
b. 22 Jun 1824 d. 7 Jun 1852
7
Sarah Ann Brown
[1.1.6.2.7.3.4]
b. 1 Mar 1826 d. 1 May 1846
7
Samantha Susan Brown
[1.1.6.2.7.3.5]
b. 21 Mar 1828 d. 30 Mar 1896
+
James Nathan Gentry
7
Jacintha Catherine Brown
[1.1.6.2.7.3.6]
b. 10 Aug 1830 d. 10 Jun 1880
+
William Kavanaugh Oldham
7
Angeline Mildred Brown
[1.1.6.2.7.3.7]
b. 9 Oct 1832
+
John Harris Miller
Charles Warner Harris
b. 15 Feb 1822 d. 23 Apr 1860
8
Mary Howell Harris
[1.1.6.2.7.3.7.1]
b. 15 Sep 1854 d. 12 Jan 1857
8
Charles Lee Harris
[1.1.6.2.7.3.7.2]
b. 24 Jul 1857
7
Brown
[1.1.6.2.7.3.8]
b. 28 Feb 1835
7
Mary Elizabeth Brown
[1.1.6.2.7.3.9]
b. 17 Jan 1818 d. 1 Aug 1854
Roberts
8
Brown Roberts
[1.1.6.2.7.3.9.1]
8
Frank Roberts
[1.1.6.2.7.3.9.2]
8
Fannie Roberts
[1.1.6.2.7.3.9.3]
8
William Roberts
[1.1.6.2.7.3.9.4]
8
John Roberts
[1.1.6.2.7.3.9.5]
+
Mary Caruthers
6
Lucy Brown
[1.1.6.2.7.4]
b. 7 Nov 1778 d. 16 Feb 1852
+
Nathaniel Thompson
d. 1874
6
Sarah Brown
[1.1.6.2.7.5]
b. 6 Jun 1792 d. 2 May 1852
Beverly A. Brown
7
Virginia Brown
[1.1.6.2.7.5.1]
7
Emaline Brown
[1.1.6.2.7.5.2]
+
Alexander Mosely
7
Lucy Frances Brown
[1.1.6.2.7.5.3]
+
John Hawthorne
+
John Holbrooke
7
Sarah Brown
[1.1.6.2.7.5.4]
+
Vernon Cobbs
7
Edwin Brown
[1.1.6.2.7.5.5]
+
Bettie Thompson
6
Charles M. Brown
[1.1.6.2.7.6]
b. 3 May 1783 d. 1879
Mary Brown
b. 1783 d. 1879
7
Ezra M. Brown
[1.1.6.2.7.6.1]
+
Sally Tilman
7
Bettie Brown
[1.1.6.2.7.6.2]
+
William H. Jones
7
Elvira Brown
[1.1.6.2.7.6.3]
+
Ayers
7
Bezaleel Ira Brown
[1.1.6.2.7.6.4]
Mary Ann Garth
8
Brown
[1.1.6.2.7.6.4.1]
+
Oscar Early
7
Charles Thomas Brown
[1.1.6.2.7.6.5]
7
Algernon Brown
[1.1.6.2.7.6.6]
7
Oswin Brown
[1.1.6.2.7.6.7]
6
Asa Brightberry Brown
[1.1.6.2.7.7]
b. 5 Jun 1794 d. 30 Jan 1839
Marie Brown
7
Thomas Ally Brown
[1.1.6.2.7.7.1]
7
Martha Brown
[1.1.6.2.7.7.2]
7
Bernard Brown
[1.1.6.2.7.7.3]
+
Susan Brown
7
Bettie Brown
[1.1.6.2.7.7.4]
+
Samuel Woodson
6
Benjamin Hescott Brown
[1.1.6.2.7.8]
b. 12 Mar 1790 d. 5 Dec 1875
Judith Fretwell
b. 8 Mar 1782 d. 13 Feb 1870
7
William Bernard Brown
[1.1.6.2.7.8.1]
Belle Clayton
8
Jennie Brown
[1.1.6.2.7.8.1.1]
8
Amanda Brown
[1.1.6.2.7.8.1.2]
+
McMahon
8
James Brown
[1.1.6.2.7.8.1.3]
7
Thomas Brown
[1.1.6.2.7.8.2]
7
Charles Wesley Brown
[1.1.6.2.7.8.3]
Venia Spurgeon
8
Mollie Brown
[1.1.6.2.7.8.3.1]
8
Benjamin Brown
[1.1.6.2.7.8.3.2]
7
Iurenia Brown
[1.1.6.2.7.8.4]
+
Sampson Wright
7
Virginia Brown
[1.1.6.2.7.8.5]
+
Alexander Blake
7
Betsy Brown
[1.1.6.2.7.8.6]
+
Richardson
7
Francina Brown
[1.1.6.2.7.8.7]
+
Mark Long
7
Velunia Ann Brown
[1.1.6.2.7.8.8]
+
John Ingraham
7
Elvenie Brown
[1.1.6.2.7.8.9]
+
Griggs
6
Bezaleel G. Brown
[1.1.6.2.7.9]
b. 22 Sep 1787 d. 20 Apr 1825
Elizabeth E. Michie
7
William Dabney Brown
[1.1.6.2.7.9.1]
7
Martha Brown
[1.1.6.2.7.9.2]
C. H. Parrott
8
Lizzie Parrott
[1.1.6.2.7.9.2.1]
8
W. H. Parrott
[1.1.6.2.7.9.2.2]
8
C. C. Parrott
[1.1.6.2.7.9.2.3]
8
Soonie Parrott
[1.1.6.2.7.9.2.4]
7
Cynthia Brown
[1.1.6.2.7.9.3]
+
William Harris Brown
7
Addison Brown
[1.1.6.2.7.9.4]
7
John Augustus Brown
[1.1.6.2.7.9.5]
+
Columbia Brown
7
Angeline Brown
[1.1.6.2.7.9.6]
+
George Kemper
6
Robert Thompson Brown
[1.1.6.2.7.10]
b. 16 Jan 1777 d. 30 Mar 1851
Elizabeth Crenshaw
b. Abt 1779 d. 1852
7
Anna Dabney Brown
[1.1.6.2.7.10.1]
b. 5 Jul 1799 d. 21 Apr 1880
+
John Wesley Harris
b. 5 Apr 1795 d. 2 Apr 1870
7
Frances Brown
[1.1.6.2.7.10.2]
b. Abt 1818
+
William Parker
b. Abt 1815
7
James Madison Brown
[1.1.6.2.7.10.3]
b. Abt 1815
Mary E.
b. Abt 1826
8
Lucy Brown
[1.1.6.2.7.10.3.1]
b. Abt 1847
7
Sarah Jane Brown
[1.1.6.2.7.10.4]
b. Abt 1806
+
George Rogers
b. Abt 1806
7
Elizabeth Brown
[1.1.6.2.7.10.5]
b. Abt 1808 d. 1877
+
Arthur Hambrick
7
Nancy T. Brown
[1.1.6.2.7.10.6]
+
Charles H. Ledsinger
7
Lucy Brown
[1.1.6.2.7.10.7]
+
Ira Ledbetter
7
Mary Brown
[1.1.6.2.7.10.8]
+
William P. Browning
7
Bernard Brown
[1.1.6.2.7.10.9]
Elizabeth Franklin
8
Brightberry T. Brown
[1.1.6.2.7.10.9.1]
b. Aug 1834
+
Martha Hoskins
6
Thomas Harris Brown
[1.1.6.2.7.11]
b. 16 Apr 1785
+
Lucy Goodman
Mildred Brown
b. 7 Nov 1788
7
Robin Brown
[1.1.6.2.7.11.1]
+
Crenshaw
7
Lavinia Brown
[1.1.6.2.7.11.2]
+
John Holbrook
7
Emaline Brown
[1.1.6.2.7.11.3]
+
William G. Fretwell
7
Eliza Dabney Brown
[1.1.6.2.7.11.4]
+
Lewis Campbell
7
Susan Brown
[1.1.6.2.7.11.5]
+
Benjamin Childress
7
Parthenia Brown
[1.1.6.2.7.11.6]
+
William Haydon
7
Lucy Ann Brown
[1.1.6.2.7.11.7]
+
Richard Noel
6
Francina Brown
[1.1.6.2.7.12]
b. 24 May 1775 d. 3 May 1846
John Rodes
b. 2 Jun 1766 d. 1839
7
William Rodes
[1.1.6.2.7.12.1]
b. 1765/1801 d. 1806/1880
+
Elizabeth Clarissa Yancey
b. 1775/1803 d. 1806/1885
+
Clarissa Yancey
7
Jacintha Tazewell Rodes
[1.1.6.2.7.12.2]
b. 20 Aug 1809
John Massie Smith
8
John Massie Smith
[1.1.6.2.7.12.2.1]
8
Frances Rodes Smith
[1.1.6.2.7.12.2.2]
8
Charles Thompson Smith
[1.1.6.2.7.12.2.3]
8
Bettie Massie Smith
[1.1.6.2.7.12.2.4]
8
William Henry Smith
[1.1.6.2.7.12.2.5]
8
Robert Hardin Smith
[1.1.6.2.7.12.2.6]
James M. Harris
8
James Clifton Harris
[1.1.6.2.7.12.2.7]
8
Lizzie Woods Harris
[1.1.6.2.7.12.2.8]
8
Mary Alice Harris
[1.1.6.2.7.12.2.9]
7
Sydney Rodes
[1.1.6.2.7.12.3]
Powhatan Jones
8
Judith Francena Rodes
[1.1.6.2.7.12.3.1]
7
Ryland Rodes
[1.1.6.2.7.12.4]
+
Virginia Woods
7
Sarah Rodes
[1.1.6.2.7.12.5]
+
Samuel Woods
7
John Rodes
[1.1.6.2.7.12.6]
+
Ann
7
Frances Rodes
[1.1.6.2.7.12.7]
+
Garland Brown
7
Virginia Rodes
[1.1.6.2.7.12.8]
+
Wilson C. Smith
7
Tyree Rodes
[1.1.6.2.7.12.9]
7
Lucy Rodes
[1.1.6.2.7.12.10]
+
Newlands
5
Dabney Brown
[1.1.6.2.8]
b. 18 Jun 1751 d. 22 Jun 1773
+
Thompson
4
Mary Elizabeth Dabney
[1.1.6.3]
b. 13 Jun 1726 d. 1760
Christopher Harris
b. 17 Feb 1724/25 d. 3 Feb 1794
5
Dabney Harris
[1.1.6.3.1]
b. 15 Dec 1745 d. 1746/1835
5
Sarah Harris
[1.1.6.3.2]
b. 11 Jun 1747 d. 5 Jul 1796
James Martin
b. 1 May 1730 d. 5 Mar 1799
6
Christopher Martin
[1.1.6.3.2.1]
b. 28 Jul 1760
Ann Turner
7
Sinai Martin
[1.1.6.3.2.1.1]
b. Abt 1815 d. 29 Nov 1869
5
Robert Harris
[1.1.6.3.3]
b. 24 Aug 1749 d. 18 Nov 1833
Nancy Grubbs
b. 24 Nov 1749 d. 30 Apr 1835
6
Catherine Harris
[1.1.6.3.3.1]
b. Abt 1787
+
James Stone
6
Mary Harris
[1.1.6.3.3.2]
b. Abt 1781
+
William Woods
6
Tyree Harris
[1.1.6.3.3.3]
b. Abt 1782
Sally Garland
7
Robert Harris
[1.1.6.3.3.3.1]
b. 22 Feb 1818
Frances Copher
8
Tyree Harris
[1.1.6.3.3.3.1.1]
8
Susan Harris
[1.1.6.3.3.3.1.2]
+
Hill
7
Thomas Berry Harris
[1.1.6.3.3.3.2]
b. 1815 d. 1892
Mary Frances Harris
b. 10 Nov 1827 d. 28 Feb 1906
8
Martha Overton Harris
[1.1.6.3.3.3.2.1]
8
Sallie Tyree Harris
[1.1.6.3.3.3.2.2]
+
A. M. Wathall
8
Susan Harris
[1.1.6.3.3.3.2.3]
8
William Christopher Harris
[1.1.6.3.3.3.2.4]
8
Mary Elizabeth Harris
[1.1.6.3.3.3.2.5]
+
J. A. Vansant
8
Overton Thomas Harris
[1.1.6.3.3.3.2.6]
8
Tyree Crawford Harris
[1.1.6.3.3.3.2.7]
8
Isabel Harris
[1.1.6.3.3.3.2.8]
7
Malinda Harris
[1.1.6.3.3.3.3]
+
Samuel Jameson
7
Caleb Rice Harris
[1.1.6.3.3.3.4]
Minerva
8
John Stone Harris
[1.1.6.3.3.3.4.1]
7
Paulina Harris
[1.1.6.3.3.3.5]
+
Joseph Frakes
7
William Hayden Harris
[1.1.6.3.3.3.6]
Amelia Ellington
8
Joseph Harris
[1.1.6.3.3.3.6.1]
7
Susan Harris
[1.1.6.3.3.3.7]
+
John Jameson
7
Overton Harris
[1.1.6.3.3.3.8]
+
Mary Ellington
7
Benjamin F. Harris
[1.1.6.3.3.3.9]
Lucy Hensley
8
Mary Susan Harris
[1.1.6.3.3.3.9.1]
+
Vivion
8
Alnett Harris
[1.1.6.3.3.3.9.2]
+
Vivion
8
William T. Harris
[1.1.6.3.3.3.9.3]
8
Benjamin W. Harris
[1.1.6.3.3.3.9.4]
8
Samuel H. Harris
[1.1.6.3.3.3.9.5]
7
Sallie Ann Harris
[1.1.6.3.3.3.10]
+
Archibald Dinwiddie
7
Mary Catherine Harris
[1.1.6.3.3.3.11]
d. 1904
+
George Burroughs
7
James Berry Harris
[1.1.6.3.3.3.12]
Lucy Cockerel
8
William Thomas Harris
[1.1.6.3.3.3.12.1]
8
Effie Harris
[1.1.6.3.3.3.12.2]
+
Howard Sutherland
8
John T. Harris
[1.1.6.3.3.3.12.3]
8
James W. Harris
[1.1.6.3.3.3.12.4]
8
Martha Virginia Harris
[1.1.6.3.3.3.12.5]
+
Henderson Hancock
8
Katherine Harris
[1.1.6.3.3.3.12.6]
+
Howard Sutherland
7
Tyree Crawford Harris
[1.1.6.3.3.3.13]
d. 1854
Lavinia Hughes
8
William L. Harris
[1.1.6.3.3.3.13.1]
8
Mary Cameron Harris
[1.1.6.3.3.3.13.2]
+
Vorries
8
Harris
[1.1.6.3.3.3.13.3]
+
William McCracken
6
Higgason Harris
[1.1.6.3.3.4]
b. 3 Apr 1774 d. Aft 1839
Nancy Garland
b. Abt 1780 d. Bef 1840
7
Lucy Ann Harris
[1.1.6.3.3.4.1]
b. 7 Jul 1809 d. 2 Oct 1877
John Martin Ogan
b. 30 Jan 1812 d. 17 Jun 1893
8
Sierra Nevada Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.1]
b. 3 Aug 1853 d. 24 Jun 1938
Christopher Columbus Smith
b. 5 Sep 1841 d. 14 Aug 1910
9
Hazel Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.1]
b. Abt 1886
9
Euphemia Ann Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.2]
Albert Wallis Mathews
b. 29 Oct 1882 d. 3 Jan 1956
10
Myrtle E. Mathews
[1.1.6.3.3.4.1.1.2.1]
Earl Vernon
11
Earlene Vernon
[1.1.6.3.3.4.1.1.2.1.1]
11
Robert Vernon
[1.1.6.3.3.4.1.1.2.1.2]
10
Jr. Albert Wallis Mathews
[1.1.6.3.3.4.1.1.2.2]
Amy Helene Clark
11
Glenn Wallace Mathews
[1.1.6.3.3.4.1.1.2.2.1]
11
Myrtle Arlene Mathews
[1.1.6.3.3.4.1.1.2.2.2]
9
Mamie Josephine Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.3]
b. Abt 1874
William W. Anderson
10
Rebecca Nevada Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.1]
b. 5 May 1897
Carl W. Haag
b. 2 Feb 1888 d. 20 Jul 1940
11
Jean Lee Haag
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.1.1]
11
Joyce Ann Haag
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.1.2]
11
Phil W. Haag
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.1.3]
10
Warren Alvord Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.2]
Edna Mae
11
John Nathan Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.2.1]
11
Mamie Mae Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.2.2]
11
Alice Nevada Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.2.3]
+
Elsie Faulkner Elam
10
Alice Phillis Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.3]
Kenneth Paul Meriam
11
Kenneth Terry Meriam
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.3.1]
11
Jeffery Paul Meriam
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.3.2]
10
Bessie Alberta Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.4]
+
Chester Elliot
10
Esther Margaret Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.5]
J. Garrison
11
Margaret Garrison
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.5.1]
10
Zilla May Anderson
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.6]
Frank Haag
11
Dennis Haag
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.6.1]
11
Donald Haag
[1.1.6.3.3.4.1.1.3.6.2]
9
Margaret Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.4]
b. Abt 1882
+
Byron Nesbit
9
Orlando Jarvis Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.5]
b. 27 May 1880 d. 16 Aug 1965
+
Clara Stewart
9
Charles Taylor Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6]
b. 23 Feb 1875 d. 2 Oct 1969
Sarah Maud Blanch
b. 8 Mar 1873 d. 5 Sep 1952
10
Evelyn Muriel Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.1]
b. 5 Sep 1900 d. 6 May 1972
Walter Irving Long
11
Jr. Walter Irving Long
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.1.1]
11
Ardeene LaVerne Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.1.2]
11
Evelyn Lorraine Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.1.3]
11
Easton Lodge Long
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.1.4]
10
Charlotte Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.2]
b. 19 Feb 1919 d. 28 Feb 1919
10
Charles Christopher Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.3]
b. 14 Jun 1906
+
Velma Spraker
Millie McLarrin
11
Charles David Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.3.1]
10
Elbert Leroy Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.4]
b. 22 Nov 1903 d. Jun 1955
10
Florence Agnes Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.5]
b. 21 Aug 1901 d. 19 Jan 1922
Roy Shedd
11
Lucille Shedd
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.5.1]
10
Hazel Maud Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.6]
b. 19 Oct 1913 d. SeeNotes
Merlin French
11
Susie French
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.6.1]
11
Nancy French
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.6.2]
11
Frankie French
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.6.3]
11
Cindy French
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.6.4]
10
Mervyn Ogan Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.7]
b. 7 Dec 1910 d. 29 May 1943
10
Edmond Lodge Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.8]
Helen Scanlon
11
Jr. Edmond Lodge Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.8.1]
10
Roberta Mabel Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.9]
Ray Bence
11
John Bence
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.9.1]
11
Diane Bence
[1.1.6.3.3.4.1.1.6.9.2]
9
Robert Calvin Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.7]
b. Abt 1891 d. 26 Dec 1962
+
Goldie
9
Lila Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.8]
b. Abt 1889
9
Lola Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.9]
b. Abt 1871 d. Abt 1892
William Sleightam
10
William Sleightam
[1.1.6.3.3.4.1.1.9.1]
9
Maude Nevada Smith
[1.1.6.3.3.4.1.1.10]
b. 5 Nov 1894 d. Abt 1948
+
Norm Nelson
Arnold Melvin Gifford
b. 2 Oct 1892
10
Fern Jane Gifford
[1.1.6.3.3.4.1.1.10.1]
b. 5 Nov 1918 d. 3 Oct 1924
10
June Doris Gifford
[1.1.6.3.3.4.1.1.10.2]
Edwin Bruce Gould
11
James Carter Gould
[1.1.6.3.3.4.1.1.10.2.1]
10
Loren Clifton Gifford
[1.1.6.3.3.4.1.1.10.3]
Jean Evelyn Blackburn
11
Alan Leslie Gifford
[1.1.6.3.3.4.1.1.10.3.1]
11
Lorna Jean Gifford
[1.1.6.3.3.4.1.1.10.3.2]
8
James Robert Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.2]
b. 1851 d. 12 Mar 1939
Effie B. Hansborough
d. Bef 1900
9
Oscar Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.2.1]
b. 30 Sep 1873 d. 14 Aug 1896
9
John Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.2.2]
b. Nov 1875
9
Olive Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.2.3]
b. May 1885
9
Bertha Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.2.4]
b. Oct 1881
9
Julia Adelia Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.2.5]
b. 2 Aug 1879 d. 11 Jul 1954
Frank Harvey Carlisle
10
Percy Carlisle
[1.1.6.3.3.4.1.2.5.1]
b. 1902
10
Frank H. Carlisle
[1.1.6.3.3.4.1.2.5.2]
10
Collier C. Carlisle
[1.1.6.3.3.4.1.2.5.3]
+
Mattson
+
Catherine Brown
d. 16 Aug 1920
8
Elizabeth J. Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.3]
b. 1848 d. 22 Apr 1895
William Alexander Smith
b. 26 Mar 1844 d. 1929
9
Roy Smith
[1.1.6.3.3.4.1.3.1]
9
Lucinda Smith
[1.1.6.3.3.4.1.3.2]
bur. 1891
8
William Higgason Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4]
b. Jan 1847 d. 25 Mar 1901
Lydia Hannah Hamilton
b. 29 May 1854 d. 10 Oct 1935
9
William Lester Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.1]
b. 13 Apr 1876 d. 31 Oct 1960
Addie Vivian Caldwell
b. 14 Jun 1881 d. 5 Jan 1970
10
Maxwell Eugene Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.1.1]
Dorothy Amen
d. 25 Jul 1936
11
Ph.D. Eugene Amen Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.1.1.1]
Beatrice Marie Whitmore
11
Thomas Merrit Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.1.1.2]
11
Kathleen Marie Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.1.1.3]
11
Richard Maxwell Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.1.1.4]
9
Lucy Adeline Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.2]
b. Aug 1888
Hall
10
Harry R. Hall
[1.1.6.3.3.4.1.4.2.1]
b. 7 Sep 1905
9
Leland Stanford Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.3]
b. Jan 1890 d. 19 May 1930
+
D.
9
James Marvin Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.4]
Marie Hulda Briggs
10
Marvin Eugene Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.4.1]
9
Helena Mabel Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.5]
b. Abt 1874
+
James J. Phillips
9
Isiah Lyle Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.6]
b. 13 Nov 1878 d. 5 Jul 1947
Edna Grider
b. Abt 1892 d. 17 Jul 1917
10
John Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.6.1]
b. Abt 1917 d. 1 Jul 1920
9
Robert Martin Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.7]
b. 9 Nov 1885 d. 2 Jan 1968
+
E. M.
9
Harry Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.8]
b. 22 Sep 1882 d. 31 Aug 1931
Gilberta Mae Ottman
b. 1891
10
Harry Kenneth Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.8.1]
Mary Ermin Martin
11
Sally Irene Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.4.8.1.1]
8
Euphemia Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.5]
b. 1845
John Smith Boyd Shuart
9
Helen E. Shuart
[1.1.6.3.3.4.1.5.1]
b. 1862 d. 21 Feb 1931
Henry Switzgebel
10
Louise Switzgebel
[1.1.6.3.3.4.1.5.1.1]
10
Alice Switzgebel
[1.1.6.3.3.4.1.5.1.2]
8
Thomas Dudley Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.6]
b. 1843
Hattie E.
b. Abt 1853
9
Irving Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.6.1]
b. Abt 1869
9
Nettie E. Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.6.2]
b. Abt 1870
9
Arthur D. Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.6.3]
b. Dec 1873 d. 30 Aug 1959
+
Pearl
b. Jul 1876
+
Mae G.
d. 24 Feb 1949
8
Zella Frances Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.7]
b. 10 Jun 1841 d. 4 Jul 1917
Henry J. Verser
b. Abt 1833
9
Alonzo C. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.1]
b. Jan 1873 d. 22 Dec 1915
Carrie M.
10
Viola C. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.1.1]
10
Myrtle L. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.1.2]
b. Mar 1897
9
Lula F. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.2]
b. Feb 1877
9
James H. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.3]
b. Jul 1872
+
Mabel E. le Gette
9
Charles B. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.4]
b. 1866 d. 30 Apr 1933
+
Ida M. Keney
9
Albert Dudley Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.5]
b. 14 Jan 1865 d. 27 Dec 1929
Emma F.
b. Jan 1870
10
Alvin Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.5.1]
11
Alvin Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.5.1.1]
10
Ruby F. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.5.2]
10
Pearl Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.5.3]
b. 1894
10
Clara L. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.5.4]
b. 1898
10
Ray P. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.5.5]
b. 1900
9
John H. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.6]
b. Abt 1863
+
Sophie Walter
d. 3 Sep 1943
9
Clara A. Verser
[1.1.6.3.3.4.1.7.7]
b. 1859
+
O. F. Hansborough
+
Googins
8
Parthena Catherine Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.8]
b. 23 Oct 1838 d. 18 Oct 1875
Dudley Wells
b. 24 Sep 1829 d. 29 May 1907
9
Leona Ogan Wells
[1.1.6.3.3.4.1.8.1]
b. 26 Dec 1867 d. 1948
+
Henry F. Weston
9
Mary Jane% Wells
[1.1.6.3.3.4.1.8.2]
b. 8 Aug 1858
+
Byron James Stone
+
Charles Frank
9
Martha Ann Wells
[1.1.6.3.3.4.1.8.3]
b. 8 Aug 1858 d. 14 Jul 1947
Nelson Lee Stockton
b. 23 Aug 1853 d. 15 Jul 1923
10
Amy Lee Stockton
[1.1.6.3.3.4.1.8.3.1]
10
Alfred James Stockton
[1.1.6.3.3.4.1.8.3.2]
b. 27 Jan 1882 d. 16 Apr 1953
Ethel Enid Carter
b. 18 Feb 1890 d. 26 Jul 1955
11
Jack Carter Stockton
[1.1.6.3.3.4.1.8.3.2.1]
b. 26 Mar 1919 d. 18 Jan 1965
+
Carrie Kinward
+
Agnes Isabel Quirke
10
Edna Parthena Stockton
[1.1.6.3.3.4.1.8.3.3]
+
Carney
+
Truman James Hull
10
Marjorie May Stockton
[1.1.6.3.3.4.1.8.3.4]
b. 10 Mar 1892 d. 17 Nov 1969
Percy Ray Mathews
11
William Stockton Mathews
[1.1.6.3.3.4.1.8.3.4.1]
11
Bettie Lee Mathews
[1.1.6.3.3.4.1.8.3.4.2]
8
Mary Ann Ogan
[1.1.6.3.3.4.1.9]
b. 19 Mar 1837 d. 14 Mar 1917
+
Wesley Parson Campbell
7
Nancy Harris
[1.1.6.3.3.4.2]
b. 27 May 1812
7
Teresa Harris
[1.1.6.3.3.4.3]
b. 22 Apr 1815 d. 1915
+
Milton Jones
b. 1812 d. 1905
7
Rebecca Harris
[1.1.6.3.3.4.4]
b. 27 Jul 1820
7
Cathrine Harris
[1.1.6.3.3.4.5]
b. 12 Apr 1822
7
Elizabeth Berry Harris
[1.1.6.3.3.4.6]
b. 16 May 1817 d. 17 Dec 1906
James Simeral Ogan
b. 12 May 1815 d. 4 Feb 1900
8
John Higgason Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.1]
b. 23 Sep 1844 d. 1 Nov 1930
Mary M. Doty
b. 14 Jun 1848 d. 7 Apr 1918
9
Eveline Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.1.1]
b. 4 Jan 1875 d. Abt 1950
+
Grant Stutsman
d. 1943
Logan Hern
b. Abt 1865
10
John Wesley Higgenson Hern
[1.1.6.3.3.4.6.1.1.1]
b. 10 Feb 1895 d. 16 Jan 1944
11
Lawrence Hern
[1.1.6.3.3.4.6.1.1.1.1]
9
Ida May Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.1.2]
b. 19 Jul 1869 d. Bef 1880
9
Louetta Theresa Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.1.3]
b. 23 Feb 1885 d. 13 Sep 1927
J. W. Jackson
10
Ivan W. Jackson
[1.1.6.3.3.4.6.1.3.1]
b. 18 Nov 1907 d. 4 Nov 1931
+
Delos Giles
d. Abt 1950
9
Mary Ellen Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.1.4]
b. 11 Jun 1868 d. 1950
George S. Metcalf
10
George Metcalf
[1.1.6.3.3.4.6.1.4.1]
+
Taylor
8
Juliana Rachel Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.2]
b. 23 Nov 1846 d. 29 May 1912
J. Rice Hern
b. Abt 1828 d. 27 Jul 1921
9
Jay J. Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.1]
b. 21 Mar 1862 d. 12 Sep 1929
Etta E. Wraton
b. Oct 1871
10
Russell Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.1.1]
10
Carl Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.1.2]
10
Bertha M. Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.1.3]
b. Oct 1893
10
Leslie W. Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.1.4]
b. Oct 1891
10
Lenore Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.1.5]
9
Patrick M. Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.2]
b. Abt 1881
+
Anna F.
9
Carl Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.3]
b. Abt 1878
9
Elizabeth Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.4]
b. Abt 1875
+
Joel Hern
9
Jerome Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.5]
b. Abt 1870
9
Ernest Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.6]
b. Abt 1867
9
Logan Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.7]
b. Abt 1865
Eveline Ogan
b. 4 Jan 1875 d. Abt 1950
10
John Wesley Higgenson Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.7.1]
b. 10 Feb 1895 d. 16 Jan 1944
11
Lawrence Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.7.1.1]
9
George Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.8]
b. 25 Aug 1887 d. 6 Feb 1966
9
Harris Herbert Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.9]
b. 29 Nov 1883 d. 5 Oct 1971
Genevieve Bleitzman Banta
b. Abt 1887 d. Abt 1930
10
Barbara Ellen Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.9.1]
b. 16 Apr 1919 d. 30 Jan 1950
10
Emma Elizabeth Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.9.2]
+
Wayne Maxwell
10
Harriet Bernice Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.9.3]
b. 1909
William Vance
11
Shirley May Vance
[1.1.6.3.3.4.6.2.9.3.1]
10
Helen Frances Hern
[1.1.6.3.3.4.6.2.9.4]
William S. Reid
d. Dec 1970
11
Patricia Lynn Reid
[1.1.6.3.3.4.6.2.9.4.1]
+
Earl Lumar Mathiot
8
Theresa Jane Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.3]
b. 31 Aug 1838 d. 14 Nov 1918
Thomas Jefferson Maxey
b. 8 Oct 1828 d. 28 Aug 1903
9
Mary E. Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.1]
b. 4 Feb 1859 d. 26 Mar 1860
9
Alice Jane Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.2]
b. 20 Feb 1861 d. 31 Jan 1949
+
George Washington Topham
b. 13 May 1865 d. 6 Mar 1932
9
Mildred Florence Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.3]
b. 26 Oct 1867 d. 4 Jun 1938
Claude T. Trimble
10
Tevis Maxey Trimble
[1.1.6.3.3.4.6.3.3.1]
Bernice Gruver
b. 18 Oct 1902
11
Danna Lee Trimble
[1.1.6.3.3.4.6.3.3.1.1]
b. 28 Nov 1923 d. 18 Feb 1963
9
Clayborn Thomas Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.4]
b. 24 May 1864 d. 17 May 1944
Anna Isabelle Bose
b. 31 Aug 1866 d. 31 Mar 1948
10
Elizabeth Theresa Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.4.1]
b. 27 Oct 1904
+
Eugene Louis Demarco
10
Margaret Anne Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.4.2]
Vincent Alexander Swenson
b. 12 Feb 1913 d. 22 Mar 1970
11
Janet Lynn Swenson
[1.1.6.3.3.4.6.3.4.2.1]
11
Laura Louise Swenson
[1.1.6.3.3.4.6.3.4.2.2]
10
Frank Louis Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.4.3]
Georgia Lee Waddington
11
Frances Lee Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.4.3.1]
11
Beth Ann Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.4.3.2]
9
Joshua Frank Maxey
[1.1.6.3.3.4.6.3.5]
b. Abt 1860
8
Mary Eleanor Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.4]
b. 23 Sep 1842 d. 16 Sep 1933
Nicholas Rollins Harris
b. 1835 d. 1902
9
Nicholas Rolland Harris
[1.1.6.3.3.4.6.4.1]
b. 10 Mar 1874 d. 1938
+
Edna Shafer
9
James Dudley Harris
[1.1.6.3.3.4.6.4.2]
b. 28 Dec 1869 d. 10 Feb 1946
Susan Abbie Walker
b. 15 Mar 1883 d. 25 Jul 1956
10
Eleanor Harris
[1.1.6.3.3.4.6.4.2.1]
Ronald Stuart Bond
b. 15 Jul 1911 d. 10 Dec 1959
11
Linda Ann Bond
[1.1.6.3.3.4.6.4.2.1.1]
+
Clyde C. Disher
9
Marshall C. Harris
[1.1.6.3.3.4.6.4.3]
b. 6 Mar 1868 d. 10 Dec 1957
Susan Surface
10
Russell S. Harris
[1.1.6.3.3.4.6.4.3.1]
b. 12 Feb 1896 d. 7 Apr 1970
Marjorie Williams
11
Rolland W. Harris
[1.1.6.3.3.4.6.4.3.1.1]
11
Warren Harris
[1.1.6.3.3.4.6.4.3.1.2]
9
Cyrus Harris
[1.1.6.3.3.4.6.4.4]
b. 15 May 1892 d. 17 May 1922
+
Annie Murphy
8
Millie Ann Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.5]
b. 24 Feb 1840 d. 5 Dec 1923
8
Sarah Catherine Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.6]
b. 19 Oct 1854 d. 27 Jul 1937
John Milton Smith
b. 1838 d. 1890
9
Marshall W. Smith
[1.1.6.3.3.4.6.6.1]
b. 1888 d. 1889
9
Maude Smith
[1.1.6.3.3.4.6.6.2]
b. 24 Feb 1877 d. 3 Oct 1965
William H. Diehl
d. Jan 1945
10
Dorothy Diehl
[1.1.6.3.3.4.6.6.2.1]
b. Abt 1797
9
Nelson F. Smith
[1.1.6.3.3.4.6.6.3]
b. 20 Apr 1884 d. 4 Mar 1965
Grace E. Hales
10
Smith
[1.1.6.3.3.4.6.6.3.1]
Chesley M. Pinkham
11
Milton H. Pinkham
[1.1.6.3.3.4.6.6.3.1.1]
11
Nelson B. Pinkham
[1.1.6.3.3.4.6.6.3.1.2]
11
Donald Pinkham
[1.1.6.3.3.4.6.6.3.1.3]
9
Roy M. Smith
[1.1.6.3.3.4.6.6.4]
b. Apr 1882 d. 1960
9
Sadie Smith
[1.1.6.3.3.4.6.6.5]
d. Aft 1965
Ed Bronk
d. Bef 1965
10
Kenneth Bronk
[1.1.6.3.3.4.6.6.5.1]
Joseph Christopher Martin
b. 6 Nov 1853 d. 26 Dec 1922
9
Guelda Lane Martin
[1.1.6.3.3.4.6.6.6]
b. 30 Jun 1896 d. 25 May 1967
Joseph Weiland Schweizer
b. 29 Nov 1891 d. 16 May 1961
10
John Joseph Schweizer
[1.1.6.3.3.4.6.6.6.1]
Marga Marie Gregory
11
Marla Sue Schweizer
[1.1.6.3.3.4.6.6.6.1.1]
10
Marie Dorothy Schweizer
[1.1.6.3.3.4.6.6.6.2]
Angelo Peter Granaroli
11
David Martin Granaroli
[1.1.6.3.3.4.6.6.6.2.1]
11
Carolyn Giovanni Granaroli
[1.1.6.3.3.4.6.6.6.2.2]
8
Harrison William Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.7]
b. 12 Apr 1860 d. Bef 1869
8
James Washington Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8]
b. 13 Feb 1857 d. 4 Jan 1933
Ada Ann Spooner
b. 26 Feb 1851 d. 14 Feb 1931
9
Ralph Milo Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.1]
b. 28 May 1889 d. 24 Aug 1970
+
Edna Mae Hansen
b. 9 Sep 1880 d. 16 Jan 1954
+
Mary Frances Fern-Fisk Moss Ashmore
b. 6 May 1913 d. 21 Oct 1970
9
Elizabeth Cornelia Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.2]
b. 20 Jul 1880 d. 7 Mar 1970
Harbron Williams Morris
b. 10 Feb 1885 d. 1949
10
Marion Elizabeth Morris
[1.1.6.3.3.4.6.8.2.1]
Curtis Gerald Linkey
b. 23 Jul 1908
11
Lila Morris Linkey
[1.1.6.3.3.4.6.8.2.1.1]
George Andrew Mangis
11
Martha Elizabeth Mangis
[1.1.6.3.3.4.6.8.2.1.2]
10
Frances Harbron Morris
[1.1.6.3.3.4.6.8.2.2]
Edgar William Morris, Jr
11
James Gregory Morris
[1.1.6.3.3.4.6.8.2.2.1]
11
Barbara Jane Morris
[1.1.6.3.3.4.6.8.2.2.2]
9
Milton Ellsworth Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.3]
b. 27 Oct 1884 d. 13 Jan 1898
9
Perry Warren Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.4]
b. 13 Feb 1883 d. 20 Oct 1949
9
Rolland James Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.5]
b. 14 Nov 1886 d. 3 Sep 1966
Myrtle Ella Treloar
b. 20 Mar 1889 d. 4 Aug 1967
10
Reginald Treloar Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.5.1]
Donna May Buker
11
Chester Vance Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.5.1.1]
11
Laura Lee Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.5.1.2]
11
Susan Elizabeth Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.5.1.3]
9
Charles Simeral Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.8.6]
b. Oct 1879 d. 5 Oct 1956
+
Maude Anna Tregoning
b. 25 Jan 1881 d. 1 May 1953
+
Frances Cora Autchins
8
Ogan
[1.1.6.3.3.4.6.9]
d. INFANT
7
Mary Harris
[1.1.6.3.3.4.7]
b. 3 Dec 1801
+
James Miller
7
Thomas Harris
[1.1.6.3.3.4.8]
b. 20 Dec 1802
7
Tyree Harris
[1.1.6.3.3.4.9]
b. 1803 d. 16 May 1846
+
Nancy Harris Jones
b. 1803 d. Aft 1860
7
Sarah Harris
[1.1.6.3.3.4.10]
b. 23 Sep 1804 d. 17 Nov 1893
David Rice
b. 4 Sep 1800 d. 28 Mar 1886
8
Higgason Harris Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1]
b. 6 Jun 1831 d. 16 Sep 1923
+
Martha Hagan
b. Jul 1835
Sarah E. Sappington
b. Abt 1855 d. 2 Jan 1882
9
Sarah E. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.1]
b. 17 Jul 1876
Jess Olds
10
William Harris Olds
[1.1.6.3.3.4.10.1.1.1]
b. 1908 d. 1911
10
Clarence Rice Olds
[1.1.6.3.3.4.10.1.1.2]
+
Dolly Dent
10
Lorraine Olds
[1.1.6.3.3.4.10.1.1.3]
+
Waldo Wade
b. 1894
+
lon F. McQuitty
9
Tyre Harris Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.2]
Myrtle M. Bullard
b. Abt 1885
10
Martha Elizabeth Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1]
b. 21 Nov 1907
Clifford O. Carr
11
Lorene C. Carr
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1.1]
Wesley Lavrar
12
Larry Lavrar
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1.1.1]
12
Kenneth Lavrar
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1.1.2]
12
Cherie Lorene Lavrar
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1.1.3]
11
Lillian Beatrice Carr
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1.2]
Jack Stewart
12
Steven Stewart
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1.2.1]
12
Russell Stewart
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1.2.2]
12
Michael Stewart
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.1.2.3]
+
Kenneth Holmes
10
Elmore Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.2]
b. 3 Jun 1911 d. Sep 1964
Lucille Derring
11
Michael Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.2.1]
10
Hollis Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.3]
Helen
d. 10 Oct 1969
11
Robert Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.2.3.1]
9
Parmer Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.3]
b. 7 Mar 1880 d. 21 Jun 1914
Elizabeth Frances Telljohn
10
Kenneth Palmer Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.1]
Racine Brown
11
Carolyn Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.1.1]
Nelson Edwin Elder
12
Nelson Kenneth Elder
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.1.1.1]
+
Roslaind Kane
10
Mildred Irene Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.2]
b. 16 Sep 1911
10
Virgil E. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.3]
b. 23 Aug 1908
+
Mable R. Rice
+
Maureen Sapp
10
Una Lampkin Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.4]
b. 18 Jan 1906
Clare Luther Thomas
11
Loa Kay Thomas
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.4.1]
Jerry Bennett
12
Jerilee Bennett
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.4.1.1]
12
Dane Bennett
[1.1.6.3.3.4.10.1.3.4.1.2]
9
Joseph Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.4]
b. Feb 1880
9
Mary S. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.5]
b. Abt 1875 d. 27 Aug 1936
Mary Sapshire Cropper
b. 27 Nov 1837 d. 11 Jun 1874
9
Lelia B. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.6]
b. 20 Jul 1870 d. 20 Dec 1957
Benjamin B. Manford
b. 24 Jan 1857 d. 3 Dec 1935
10
William Berkeley Manford
[1.1.6.3.3.4.10.1.6.1]
10
Van Camp Manford
[1.1.6.3.3.4.10.1.6.2]
b. 17 Apr 1890 d. 28 Jan 1960
Beulah
b. Cal 1897
11
Jack Manford
[1.1.6.3.3.4.10.1.6.2.1]
11
Harold Manford
[1.1.6.3.3.4.10.1.6.2.2]
+
Hattie
10
Olepha Manford
[1.1.6.3.3.4.10.1.6.3]
b. Cal 1894
9
William F. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.7]
b. 15 Aug 1871 d. 11 Sep 1954
Bessie H. Olds
b. 20 Aug 1883
10
Estelle Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1]
b. Abt 1903
William Buescher
11
Maribeth Buescher
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.1]
Fredrick E. Jackson
b. 1934 d. 5 Sep 1970
12
Karla Renee Jackson
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.1.1]
12
Marla Kay Jackson
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.1.2]
11
Carolyn Beth Buescher
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.2]
Denver E. Willis
12
William Russell Willis
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.2.1]
11
James Wesley Buescher
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.3]
Virginia Ruth Hule
12
Daryl Keith Buescher
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.3.1]
11
Una Mae Buescher
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.4]
Bobby W. Carruth
12
Linda Marie Carruth
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.4.1]
Lahmon Pace
12
Heather Leigh Pace
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.4.2]
12
Hollis Lorraine Pace
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.4.3]
11
Sarah Estelle Buescher
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.5]
James H. Brown
12
Clark Douglas Brown
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.5.1]
12
Matthew Brown
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.5.2]
11
Rose Marie Buescher
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.6]
James E. Corgan
12
William S. Corgan
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.6.1]
12
Wesley K. Corgan
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.6.2]
12
Lynne Marie Corgan
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.6.3]
12
Carol Lee Corgan
[1.1.6.3.3.4.10.1.7.1.6.4]
9
Mary S. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.8]
b. Est 1874/1875
9
John Richard Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9]
b. 17 Dec 1859
Henizella Easley
b. 16 Oct 1867 d. Aft 1934
10
Gertrude Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.1]
Walter Overstreet
b. 11 Jan 1887 d. 22 Feb 1958
11
Raymond Overstreet
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.1.1]
Bertha Rau
12
Wallace Edmund Overstreet
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.1.1.1]
b. 20 Feb 1932 d. 6 Jul 1959
12
Larry Lee Overstreet
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.1.1.2]
12
Sue Carol Overstreet
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.1.1.3]
10
Charles Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.2]
b. 13 Oct 1889 d. Jun 1964
Rose Mueller
11
Dorthy Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.2.1]
10
Myrtle Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.3]
b. 5 Jul 1891
Ray Jones
11
Catherine Jones
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.3.1]
Charles Knaebel
12
Jeannie Knaebel
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.3.1.1]
12
Richard Knaebel
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.3.1.2]
11
Norton P. Jones
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.3.2]
Eleanor Kroll
12
Evon Jones
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.3.2.1]
12
Kay Jones
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.3.2.2]
12
Karen Jones
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.3.2.3]
10
Osa B. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.4]
b. 31 Mar 1894 d. Mar 1967
Boyd Edwards
11
Gordon Edwards
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.4.1]
Oma Scott
12
Joyce Edwards
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.4.1.1]
12
Jennie Edwards
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.4.1.2]
11
James Edwards
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.4.2]
10
Arthur Bryan Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.5]
Anna Rose Caspari
b. 1889
11
Arthur Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.5.1]
11
Ruth Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.5.2]
+
Stalliman
11
Lorraine Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.5.3]
+
Dierpin
10
Margaret W. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.6]
b. 13 Feb 1898
Orsen King
b. Abt 1880
11
Margie King
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.6.1]
Carl Buettner
12
John Gregory Buettner
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.6.1.1]
12
Sandra Louise Buettner
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.6.1.2]
10
Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.9.7]
b. 15 Aug 1902 d. 1902
+
Collie Robinson
9
David G. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10]
b. 8 Oct 1857 d. 19 Mar 1943
Mary Lizzie Davis
b. Abt 1869
10
Harold F. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1]
b. Abt 1912
Muriel Jakes
11
Joseph Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.1]
Lida Arnsmeyer
12
Boyd Taylor Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.1.1]
12
Vincent Shawn Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.1.2]
11
Barbara Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.2]
Henry Sapp
12
Darrell Milton Sapp
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.2.1]
12
James Bradford Sapp
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.2.2]
12
Brenda Louise Sapp
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.2.3]
11
Wayne Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.3]
Donna Lee Koechner
12
Michael Wayne Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.3.1]
12
Jeffrey Travis Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.3.2]
12
Georgetta Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.1.3.3]
10
Garland L. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.2]
10
Lloyd Franklin Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.3]
10
Vesta Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.10.4]
9
Franklin D. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.11]
b. 23 Sep 1862 d. 27 Mar 1936
Mae Howell
10
Harris Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.11.1]
10
Ailene Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.11.2]
9
Penelope Winslow Rice
[1.1.6.3.3.4.10.1.12]
b. Abt 1866
8
Sarah E. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.2]
b. 14 Aug 1846 d. 20 Aug 1954
Edward Camplin Burnett
b. 13 Oct 1838 d. 10 Jan 1894
9
Cornelius F. Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.1]
b. 27 Dec 1874 d. 17 Mar 1880
9
Minnie E. Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.2]
b. Abt 1871 d. 1909
9
Lora Lee Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.3]
b. 23 Oct 1877 d. 28 Jan 1893
9
John Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.4]
b. Aug 1883
May Barnett
10
Lora Bess Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.4.1]
10
Mildred Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.4.2]
10
Leon Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.4.3]
9
Carrie Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.5]
b. 22 Jun 1880 d. 6 Dec 1963
Odis Zumwalt
b. 19 Jan 1880 d. Nov 1963
10
Cletus Zumwalt
[1.1.6.3.3.4.10.2.5.1]
10
Fredia Zumwalt
[1.1.6.3.3.4.10.2.5.2]
9
Sallie Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.6]
+
Jack Martyn
b. 6 Dec 1891
9
Edward Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.7]
Ara Nichols
10
Ray Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.7.1]
10
E. P. Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.7.2]
10
Spencer Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.7.3]
10
Wallace Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.7.4]
10
Harry Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.7.5]
10
Ruth Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.7.6]
10
Gladys Fay Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.7.7]
9
Frank Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.8]
9
Mamie Burnett
[1.1.6.3.3.4.10.2.9]
b. Mar 1895
8
John J. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3]
b. 17 Mar 1836 d. 11 Jul 1910
Isabelle J. Nichols
b. 2 Jan 1840 d. 20 Jul 1879
9
Oren Crane Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.1]
b. 26 Oct 1872 d. 18 Jan 1896
9
Cora Lee Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.2]
b. 12 Oct 1870 d. 10 Jul 1894
9
Luther H. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.3]
b. 8 Sep 1866 d. 6 Apr 1938
+
Fannie M. Quarles
b. 8 Sep 1857 d. 20 Feb 1938
9
Celsus D. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4]
b. 7 Jul 1868 d. 8 Jul 1958
Laura G. Green
b. 21 Jul 1870 d. 18 Nov 1926
10
Herbert F. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.1]
b. 9 Jun 1900 d. 18 Apr 1958
Mona Elaine Klingner
11
Joseph Weldon Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.1.1]
11
Dorothy Elaine Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.1.2]
+
Dan Rich
10
Howard B. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.2]
Alma Estes
b. 23 Jun 1910
11
Larry Gene Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.2.1]
Vanda Gibson
12
Samantha Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.2.1.1]
12
Sarah Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.2.1.2]
11
Carol Jane Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.2.2]
+
Robert Rappold
11
Sally Lou Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.2.3]
George Garnache
12
Rebecca Nichole Garnache
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.2.3.1]
12
Christopher Aaron Garnache
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.2.3.2]
10
Susan I. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.3]
b. 17 Mar 1908
Paul Rose
11
Sylvia Rose
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.3.1]
John Davies
12
Jerry Davies
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.3.1.1]
12
Jack Davies
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.3.1.2]
12
Julie Davies
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.3.1.3]
11
Jerry Paul Rose
[1.1.6.3.3.4.10.3.4.3.2]
+
Kenneth Polson
9
Rice
[1.1.6.3.3.4.10.3.5]
b. Aft 1865 d. INFANT
+
Sallie A. Douglass
b. Abt 1846 d. 15 Sep 1888
8
David Barton Rice
[1.1.6.3.3.4.10.4]
b. 7 Mar 1849 d. 2 May 1929
Nancy B. Slater
b. Aug 1857 d. 12 Apr 1926
9
Charles Perry Rice
[1.1.6.3.3.4.10.4.1]
b. 19 Jul 1882 d. 17 Mar 1885
9
Mary M. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.4.2]
b. May 1888
Burdette Martin
10
Joella Martin
[1.1.6.3.3.4.10.4.2.1]
9
Kate Rice
[1.1.6.3.3.4.10.4.3]
b. Sep 1884
+
Floyd Forsee
9
Lottie Rice
[1.1.6.3.3.4.10.4.4]
b. May 1886
+
Wallace Rice
8
Henry Rice
[1.1.6.3.3.4.10.5]
b. Abt 1831 d. Bef 1882
8
Mosias Rice
[1.1.6.3.3.4.10.6]
b. 14 Dec 1838
8
Julina Rice
[1.1.6.3.3.4.10.7]
b. 17 Aug 1833 d. 4 Apr 1924
Tyree N. Jones
b. 3 May 1832 d. 29 Jan 1882
9
Mosias D. Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.1]
b. Abt 1859
9
John Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.2]
b. Est 1860/1870
9
Mary J. Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.3]
b. Abt 1861
9
Savilla Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.4]
b. Abt 1873
9
Leander Perry Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.5]
b. 6 Aug 1857 d. 7 Jul 1947
Alice Northway Coonce
b. 29 Jul 1858 d. 13 Feb 1889
10
Ocra E. Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.5.1]
b. 27 Sep 1888 d. 7 Apr 1891
10
Charles Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.5.2]
10
Iva Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.5.3]
Mary Belle Wallace
b. 14 Apr 1858 d. 19 Dec 1945
10
Ray Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.5.4]
9
Sarah E. Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.6]
b. 2 Nov 1853 d. 23 Dec 1921
Richard Crenshaw
b. 21 May 1853
10
Elmer Crenshaw
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.1]
Maude Morris
11
Joe Perry Crenshaw
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.1.1]
b. 28 Apr 1903
Karleen Brooks
12
Donna Lee Crenshaw
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.1.1.1]
[
=>
]
12
James Dean Crenshaw
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.1.1.2]
[
=>
]
12
David Brooks Crenshaw
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.1.1.3]
[
=>
]
10
Nellie Maude Crenshaw
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.2]
Lawerance Richard Sapp
11
Opal Sapp
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.2.1]
+
James Kenneth Dickinson
11
Kenneth Sapp
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.2.2]
11
Martin Sapp
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.2.3]
11
Adrain Sapp
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.2.4]
10
Mary Crenshaw
[1.1.6.3.3.4.10.7.6.3]
+
Forbes
9
Doll Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.7]
Bev Hart
10
Nellie Hart
[1.1.6.3.3.4.10.7.7.1]
+
Raymond Mountjoy
10
Virginia Hart
[1.1.6.3.3.4.10.7.7.2]
+
John Luckley
9
Isabelle Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.8]
9
Lidy Jones
[1.1.6.3.3.4.10.7.9]
8
Martha A. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.8]
b. 20 Mar 1843 d. 26 Dec 1878
William P. Boqua
b. 14 Jan 1833 d. 27 Nov 1891
9
Sarah Boqua
[1.1.6.3.3.4.10.8.1]
b. Abt 1878
9
Laura Boqua
[1.1.6.3.3.4.10.8.2]
b. Abt 1871
9
Dora Boqua
[1.1.6.3.3.4.10.8.3]
b. Abt 1873
Lee Vandiver
10
William Vandever
[1.1.6.3.3.4.10.8.3.1]
b. Bef 1893
+
Mary Delmore
b. 1873 d. 4 Jul 1936
10
Jose Vandiver
[1.1.6.3.3.4.10.8.3.2]
10
Boqua Vandiver
[1.1.6.3.3.4.10.8.3.3]
10
Dorthy Vandiver
[1.1.6.3.3.4.10.8.3.4]
10
Clyde Vandiver
[1.1.6.3.3.4.10.8.3.5]
10
Rollie Vandiver
[1.1.6.3.3.4.10.8.3.6]
10
Archie Vandiver
[1.1.6.3.3.4.10.8.3.7]
9
Rosa Boqua
[1.1.6.3.3.4.10.8.4]
b. Abt 1877
Claude Christian
10
Lorraine Christian
[1.1.6.3.3.4.10.8.4.1]
10
Carl Christian
[1.1.6.3.3.4.10.8.4.2]
8
Amanda Rice
[1.1.6.3.3.4.10.9]
b. 29 Jan 1830 d. 24 Jul 1868
Caleb Armitage
b. Abt 1823 d. Bef 11 Sep 1871
9
Sarah Francis Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.1]
b. 21 Jun 1850 d. 16 Jun 1933
James M. Delmore
b. 1844/1845
10
Thomas E. Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.1]
b. Jul 1870
+
Ellen
b. Aft 1850
10
William David Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.2]
b. Feb 1872 d. 6 Apr 1949
+
Grace May DeFord
b. Bef 1890
10
Mary Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.3]
b. 1873 d. 4 Jul 1936
+
William Vandever
b. Bef 1893
10
James Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.4]
b. 1875
+
Gussie
b. Aft 1855
10
Manda Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.5]
b. 1877
10
Henry Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.6]
b. 1879
10
Elizabeth Lucille Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.7]
b. 1888
+
John R. Williams
b. Aft 1850
10
Ann Clare Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.8]
b. 11 Sep 1889 d. 5 Sep 1970
+
Halleck
b. Aft 1850
+
F. F. Tryon
b. Aft 1850
10
Victor Delmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.1.9]
b. 1891 d. 1945
9
Julia K. Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.2]
b. 1859 d. 1942
Philip J. Gilmore
b. 1854 d. 1941
10
Nora Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.1]
b. Abt 1879
+
Ben Skinner
Allen
11
Mary Allen
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.1.1]
+
Knibb
11
Alma Allen
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.1.2]
Chappman
11
Philip Chappman
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.1.3]
11
Rosella Chappman
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.1.4]
11
Geneva Chappman
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.1.5]
10
John E. Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.2]
b. 21 Nov 1884 d. 15 Sep 1913
+
Stella
10
Fritz Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.3]
b. 14 Sep 1900 d. 15 Oct 1901
10
Louis Ancil Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.4]
b. 24 Jun 1896 d. 13 Feb 1962
10
Keith Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.5]
b. 10 Mar 1900 d. 7 Feb 1971
Mena Proctor
b. 8 Feb 1903
11
Kenneth Keith Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.5.1]
Doris Marie Green
12
Cheryl Lynn Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.5.1.1]
11
Karl Richard Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.5.2]
Betty Hampton
12
Richard Kevin Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.5.2.1]
12
Darla Kay Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.5.2.2]
10
Ann Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.6]
+
Charles Sutton
10
Roy Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.7]
Josephine Dennis
11
Goldie Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.7.1]
11
Woodrow Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.7.2]
10
Nettie Gilmore
[1.1.6.3.3.4.10.9.2.8]
9
Nettie Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.3]
b. Abt 1862
+
Minor Ballenger
b. Abt 1853
9
Higgason Harrison Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.4]
b. 20 Oct 1855 d. 23 Feb 1941
9
John Fletcher Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.5]
b. 7 Jun 1853 d. 16 Jun 1929
+
Mary J. Jamison
b. Bef 1868
9
William D. Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.6]
b. 1848 d. 26 Dec 1863
9
G. Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.7]
b. Abt 1863
9
Andrew Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.8]
b. Abt 1866
9
Everett Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.9]
b. Abt 1866
9
Eva Armitage
[1.1.6.3.3.4.10.9.10]
8
Thomas B. Rice
[1.1.6.3.3.4.10.10]
b. 21 Jun 1841
7
Garland Harris
[1.1.6.3.3.4.11]
b. 14 Apr 1807
7
Jr. Higgason Harris
[1.1.6.3.3.4.12]
6
Nancy Harris
[1.1.6.3.3.5]
b. Abt 1785
+
William Stone
6
Lucy Harris
[1.1.6.3.3.6]
b. 1770 d. Bef 1839
6
Elizabeth Harris
[1.1.6.3.3.7]
b. 7 May 1782 d. 1838
5
Tyree Harris
[1.1.6.3.4]
b. 24 Jun 1751 d. 1752/1841
5
Elizabeth Harris
[1.1.6.3.5]
b. 9 May 1752 d. 1753/1846
5
Mourning Harris
[1.1.6.3.6]
b. 4 Jun 1754 d. 1755/1848
+
Foster Jones
d. 1814
5
Christopher Harris
[1.1.6.3.7]
b. 21 Jul 1755 d. 27 Jul 1841
Elizabeth Grubbs
6
Tyree Harris Harris
[1.1.6.3.7.1]
b. 21 Feb 1778
6
Nancy Harris
[1.1.6.3.7.2]
b. 2 Feb 1782
+
Josiah Thorpe
6
Mourning Harris
[1.1.6.3.7.3]
b. 31 Oct 1783 d. 4 Jul 1865
+
Zacariah Thorpe
6
Robert Harris
[1.1.6.3.7.4]
b. 6 Mar 1787
Mary Taylor
b. 24 Sep 1778 d. 18 Apr 1858
7
Shelton Harris
[1.1.6.3.7.4.1]
b. 20 Sep 1820 d. 9 May 1896
+
Caroline Duncan
Martha Thorpe
8
Mary Emma Harris
[1.1.6.3.7.4.1.1]
8
Robert Harris
[1.1.6.3.7.4.1.2]
+
Theresa Anderson
7
Fannie Harris
[1.1.6.3.7.4.2]
+
Thomas Coyle
7
Elizabeth Harris
[1.1.6.3.7.4.3]
+
Joseph Pearson
7
James Harris
[1.1.6.3.7.4.4]
Mary Searcy
8
Caroline Harris
[1.1.6.3.7.4.4.1]
+
Jeremiah Broadduss
8
Fannie Harris
[1.1.6.3.7.4.4.2]
8
Mattie Harris
[1.1.6.3.7.4.4.3]
8
Joseph Harris
[1.1.6.3.7.4.4.4]
+
Callie Gaines
8
Robert Harris
[1.1.6.3.7.4.4.5]
+
Leslie Hurley
7
Mary Harris
[1.1.6.3.7.4.5]
+
Bolin
7
Hensley Harris
[1.1.6.3.7.4.6]
Emma Benton
8
Minnie Harris
[1.1.6.3.7.4.6.1]
8
Hattie Harris
[1.1.6.3.7.4.6.2]
8
Amanda Harris
[1.1.6.3.7.4.6.3]
6
Thomas Harris
[1.1.6.3.7.5]
b. 18 Jan 1780 d. 1806
+
Mary Annie Booten
5
Mary Harris
[1.1.6.3.8]
b. 10 Jun 1757 d. 1758/1851
+
George Jones
4
Jr. Cornelius Dabney
[1.1.6.4]
b. 12 Mar 1726/27
4
Elizabeth Dabney
[1.1.6.5]
b. 9 Jan 1729
Daniel Maupin
b. 25 Mar 1722 d. 11 Oct 1803
5
Cornelius Maupin
[1.1.6.5.1]
b. 3 Feb 1758 d. 9 Dec 1840
Ann Bratton
6
Tilman J. Maupin
[1.1.6.5.1.1]
+
Pyrenia D. Brown
b. 31 Dec 1806
5
Daniel Maupin
[1.1.6.5.2]
b. 6 Dec 1760 d. 29 Aug 1832
Virginia Elizabeth Gentry
b. 27 Dec 1761 d. 10 Jun 1804
6
Susannah Maupin
[1.1.6.5.2.1]
b. Abt 1790 d. 2 Feb 1858
David Gentry
b. 1787
7
Elizabeth Gentry
[1.1.6.5.2.1.1]
b. 1805 d. 1851
7
Marcus Gentry
[1.1.6.5.2.1.2]
7
Benjamin Gentry
[1.1.6.5.2.1.3]
7
Jane Gentry
[1.1.6.5.2.1.4]
+
William Stevenson
7
Nancy Gentry
[1.1.6.5.2.1.5]
+
William Means
7
Sidney Gentry
[1.1.6.5.2.1.6]
+
Margaret Robinson
4
Francis Dabney
[1.1.6.6]
John Maupin
b. 1725 d. 1806
5
Cornelius Maupin
[1.1.6.6.1]
b. 8 Jan 1760 d. 10 Apr 1846
+
Mourning Harris
b. 3 May 1760 d. 20 Nov 1837
3
Mary Dabney
[1.1.7]
b. 22 Jan 1679/80 d. 7 Sep 1748
Jr. Thomas Carr, Jr
b. 1678 d. 29 May 1737
4
John Carr
[1.1.7.1]
b. 25 Jun 1706 d. 17 Jun 1778
Barbara Ann Overton
b. 20 Apr 1720 d. 24 Dec 1794
5
James Carr
[1.1.7.1.1]
b. 20 Aug 1740 d. 6 Sep 1741
5
Elizabeth Carr
[1.1.7.1.2]
b. 28 Dec 1747
5
Garland Carr
[1.1.7.1.3]
b. 10 Jul 1754 d. 16 Oct 1838
Mary Phillips Winston
b. Abt 1763
6
James Overton Carr
[1.1.7.1.3.1]
b. 6 Oct 1793
6
Elizabeth Carr
[1.1.7.1.3.2]
b. 21 Aug 1791
6
Barbara Ann Carr
[1.1.7.1.3.3]
b. 14 Feb 1789 d. Abt 1859
Jonathan Boucher Carr
b. 1775 d. 1859
7
Dabney Terrill Carr
[1.1.7.1.3.3.1]
b. 1819
Eliza English
8
Mary Carr
[1.1.7.1.3.3.1.1]
8
Nelly Carr
[1.1.7.1.3.3.1.2]
7
Chloe Lee Carr
[1.1.7.1.3.3.2]
b. 1813
7
James Ferrill Carr
[1.1.7.1.3.3.3]
b. 1828
7
Garland Overton Carr
[1.1.7.1.3.3.4]
b. 1817 d. Abt 1846
8
James Overton Carr
[1.1.7.1.3.3.4.1]
b. Abt 1837 d. 1852
Mary Allen
9
Jane Margaret Carr
[1.1.7.1.3.3.4.1.1]
b. 1832
9
Hetty Carr
[1.1.7.1.3.3.4.1.2]
b. 1825
9
Richard Henry Carr
[1.1.7.1.3.3.4.1.3]
b. 1823
9
Virginia Carr
[1.1.7.1.3.3.4.1.4]
b. Abt 1819
9
Ann Carr
[1.1.7.1.3.3.4.1.5]
9
Elizabeth Carr
[1.1.7.1.3.3.4.1.6]
8
Elizabeth Carr
[1.1.7.1.3.3.4.2]
+
John Paxton
7
Ellen Boucher Carr
[1.1.7.1.3.3.5]
b. 1821 d. Abt 1890
Benjamin Todd
d. 1862
8
Mollie Todd
[1.1.7.1.3.3.5.1]
+
William O. Todd
8
Laura Todd
[1.1.7.1.3.3.5.2]
8
Birdie Winston Todd
[1.1.7.1.3.3.5.3]
8
Price Todd
[1.1.7.1.3.3.5.4]
8
Overton Todd
[1.1.7.1.3.3.5.5]
7
Frank Carr
[1.1.7.1.3.3.6]
b. 1823
Ella Chandler
d. 1894
8
Nannie Carr
[1.1.7.1.3.3.6.1]
+
Leon Ridgeway
8
Frank Carr
[1.1.7.1.3.3.6.2]
7
Elizabeth Maria Carr
[1.1.7.1.3.3.7]
b. 1825
James Douglass
8
Maria Lee Douglass
[1.1.7.1.3.3.7.1]
Adams
9
Helen Douglass Adams
[1.1.7.1.3.3.7.1.1]
8
Benjamin Douglass
[1.1.7.1.3.3.7.2]
9
Gordon Douglass
[1.1.7.1.3.3.7.2.1]
7
William Kimbrough Carr
[1.1.7.1.3.3.8]
b. 1811
7
Mary Ann Carr
[1.1.7.1.3.3.9]
b. 1815 d. 4 Sep 1875
Hugh Walker Minor
b. 31 Jul 1807 d. 12 Dec 1858
8
Martha Lee Minor
[1.1.7.1.3.3.9.1]
b. Abt 1836
Jr. Thomas Walker Gilmer
b. 25 Jul 1834
9
III Thomas Walker Gilmer
[1.1.7.1.3.3.9.1.1]
b. 7 Sep 1869
8
George R. Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2]
b. Mar 1839
Sallie
b. 1839
9
Mary W. Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2.1]
b. Cal 1870
Roberts Coles
b. 29 Jun 1862 d. 17 Jan 1935
10
Jr. Roberts Coles
[1.1.7.1.3.3.9.2.1.1]
Doris Rafferty
11
III Roberts Coles
[1.1.7.1.3.3.9.2.1.1.1]
10
George Minor Coles
[1.1.7.1.3.3.9.2.1.2]
+
Jane Stuart Stringfellow
9
Sallie Cook Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2.2]
b. Nov 1868
9
Peter L. Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2.3]
b. Dec 1881
9
Elysa Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2.4]
b. Aug 1874
9
Jr. George R. Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2.5]
b. Oct 1876
9
Frank C. Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2.6]
b. Apr 1880
9
Lawrence Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2.7]
b. Cal 1867
9
Anne L. Minor
[1.1.7.1.3.3.9.2.8]
b. Aug 1865
6
Mary Winston Carr
[1.1.7.1.3.4]
b. 28 Apr 1796 d. 12 Feb 1852
Achilles Broadhead
b. Abt 1789 d. 4 Oct 1853
7
Elizabeth Maria Broadhead
[1.1.7.1.3.4.1]
b. 25 Aug 1829 d. 2 Jul 1892
+
H. B. Logan
7
James Overton Broadhead
[1.1.7.1.3.4.2]
b. 29 May 1819
Mary Snowdon Dorsey
8
Charles S. Broadhead
[1.1.7.1.3.4.2.1]
8
Nannie Dorsey Broadhead
[1.1.7.1.3.4.2.2]
8
Mary W. Broadhead
[1.1.7.1.3.4.2.3]
+
William Horton
7
Garland Carr Broadhead
[1.1.7.1.3.4.3]
b. 30 Oct 1827
+
Victoria Regina Royall
b. 1841
Marion Wallace Wright
b. 9 Apr 1843 d. 24 Nov 1883
8
Jr. Garland Carr Broadhead
[1.1.7.1.3.4.3.1]
b. 4 Jan 1873
8
Marion Gertrude Broadhead
[1.1.7.1.3.4.3.2]
b. 21 May 1877
+
S. Frank Conly
8
Harry Howard Broadhead
[1.1.7.1.3.4.3.3]
b. 29 Oct 1879
8
Mary West Broadhead
[1.1.7.1.3.4.3.4]
b. 28 Apr 1866
William E. Whitsitt
9
Garland Broadhead Whitsitt
[1.1.7.1.3.4.3.4.1]
Mary C.
b. Cal 1897
10
Jr. Garland Broadhead Whitsitt
[1.1.7.1.3.4.3.4.1.1]
10
Constance M. Whitsitt
[1.1.7.1.3.4.3.4.1.2]
10
Frank C. Whitsitt
[1.1.7.1.3.4.3.4.1.3]
7
Mary Ann Broadhead
[1.1.7.1.3.4.4]
b. 28 Jul 1821 d. 3 Jul 1890
John H. Newby
d. 1888
8
William Garland Newby
[1.1.7.1.3.4.4.1]
+
Etta Price
8
John Broadhead Newby
[1.1.7.1.3.4.4.2]
Libby North
9
Florence Newby
[1.1.7.1.3.4.4.2.1]
9
Mary Newby
[1.1.7.1.3.4.4.2.2]
7
William Ferrill Broadhead
[1.1.7.1.3.4.5]
b. 23 Nov 1836
Rosalie Weber
8
Overton Broadhead
[1.1.7.1.3.4.5.1]
8
Rosalie Broadhead
[1.1.7.1.3.4.5.2]
8
Archibald Broadhead
[1.1.7.1.3.4.5.3]
8
James Broadhead
[1.1.7.1.3.4.5.4]
8
William Broadhead
[1.1.7.1.3.4.5.5]
6
Daniel Ferrell Carr
[1.1.7.1.3.5]
b. 10 Dec 1786 d. 6 Jun 1847
Virginia Emily Terrell
b. 14 May 1781 d. 24 Sep 1842
7
William Garland Carr
[1.1.7.1.3.5.1]
b. Cal 1810 d. Abt 1894
Charlotte M. Duke
b. Cal 1819
8
Emily I. Carr
[1.1.7.1.3.5.1.1]
b. 16 Jul 1854 d. 7 Sep 1935
+
Harrison
8
Lucy L. Carr
[1.1.7.1.3.5.1.2]
b. Cal 1845 d. Feb 1895
Henry L. Stuart
9
Eleanor C. Stuart
[1.1.7.1.3.5.1.2.1]
b. 1 Sep 1876 d. 6 Jan 1907
Jr. Watt H. Daniel
10
Sara Daniel
[1.1.7.1.3.5.1.2.1.1]
9
Mary DeNeale Stuart
[1.1.7.1.3.5.1.2.2]
b. 3 Nov 1877 d. 4 May 1966
8
Nannie P. Carr
[1.1.7.1.3.5.1.3]
b. 1839
Francis S. Bronough
9
William Bronough
[1.1.7.1.3.5.1.3.1]
b. 1864
8
James Garland Carr
[1.1.7.1.3.5.1.4]
b. 1843
8
Charlotte Carr
[1.1.7.1.3.5.1.5]
b. 1846
J. Cochran
9
Charlotte Cochran
[1.1.7.1.3.5.1.5.1]
+
Cochran
8
Martha Winston Carr
[1.1.7.1.3.5.1.6]
b. Cal 1855 d. 1893
Jonathan Carter
b. 22 Mar 1852 d. 24 Jun 1887
9
John Ferrell Carter
[1.1.7.1.3.5.1.6.1]
b. 11 Nov 1887 d. 15 Oct 1938
Mary Lucile Deavours
10
Robertine Ellison Carter
[1.1.7.1.3.5.1.6.1.1]
10
Katherine Winston Carter
[1.1.7.1.3.5.1.6.1.2]
10
Lucile Deavours Carter
[1.1.7.1.3.5.1.6.1.3]
8
Jr. William Garland Carr
[1.1.7.1.3.5.1.7]
b. 1861 d. 11 Jun 1887
8
Ferrell D. Carr
[1.1.7.1.3.5.1.8]
b. Cal 1849
8
Elizabeth Carr
[1.1.7.1.3.5.1.9]
b. Cal 1858
7
Martha Winston Carr
[1.1.7.1.3.5.2]
b. 20 May 1813
George Washington Clive
b. 12 Mar 1809 d. 12 Apr 1883
8
Mary Waters Clive
[1.1.7.1.3.5.2.1]
b. Cal 1837
John Pryor Allison
b. 1832
9
Patricia Winston Allison
[1.1.7.1.3.5.2.1.1]
b. Cal 1867
Thomas Nelson Phillips
b. 2 Dec 1850 d. 13 Mar 1921
10
Thomas Milton Phillips
[1.1.7.1.3.5.2.1.1.1]
+
Vera Ragan
10
Nelson Allison Phillips
[1.1.7.1.3.5.2.1.1.2]
b. 4 Nov 1905 d. 4 Nov 1905
9
William Allison
[1.1.7.1.3.5.2.1.2]
b. Cal 1860
9
George Allison
[1.1.7.1.3.5.2.1.3]
b. Cal 1865
9
L. P. Allison
[1.1.7.1.3.5.2.1.4]
8
Catherine Davis Clive
[1.1.7.1.3.5.2.2]
b. 27 Jun 1857 d. 25 Nov 1927
George Murray
b. 5 Oct 1851 d. 15 Nov 1903
9
Mary Carr Murray
[1.1.7.1.3.5.2.2.1]
b. 14 Sep 1892 d. 3 Dec 1939
9
Katie Carey Murray
[1.1.7.1.3.5.2.2.2]
b. 14 Sep 1892 d. 14 Sep 1892
9
George Lindley Murray
[1.1.7.1.3.5.2.2.3]
b. Abt 1893
9
Earl Randolph Murray
[1.1.7.1.3.5.2.2.4]
9
Helen Clive Murray
[1.1.7.1.3.5.2.2.5]
d. 3 Dec 1939
8
Emily Terrell Clive
[1.1.7.1.3.5.2.3]
b. 17 Jun 1847 d. 23 Mar 1931
Elbert Wiley Kirkpatrick
b. 12 Oct 1844 d. 24 Mar 1924
9
Kirkpatrick
[1.1.7.1.3.5.2.3.1]
b. 17 Jun 1875 d. 3 Jul 1875
9
Ray H. Kirkpatrick
[1.1.7.1.3.5.2.3.2]
b. 16 Sep 1876 d. 16 Dec 1964
Ella Bell
b. 1878 d. Dec 1939
10
Lloyd Kirkpatrick
[1.1.7.1.3.5.2.3.2.1]
b. 1904
+
Thelma
10
Kathleen Kirkpatrick
[1.1.7.1.3.5.2.3.2.2]
b. Cal 1906
+
Paul Schaeffer
9
Alice Kirkpatrick
[1.1.7.1.3.5.2.3.3]
b. 13 Aug 1878 d. 17 Mar 1969
Charles Waide
b. 7 Oct 1868 d. 29 Oct 1939
10
Martha Waide
[1.1.7.1.3.5.2.3.3.1]
Jay Y. Crum
b. 18 Nov 1910
11
Thomas Crum
[1.1.7.1.3.5.2.3.3.1.1]
11
Jr. Jay Crum
[1.1.7.1.3.5.2.3.3.1.2]
+
Walter H. Schubert
10
Elbert Waide
[1.1.7.1.3.5.2.3.3.2]
+
Freda Virginia Barham
9
Sara Kirkpatrick
[1.1.7.1.3.5.2.3.4]
b. Jul 1880 d. 1929
9
Jack Kirkpatrick
[1.1.7.1.3.5.2.3.5]
b. 10 Jul 1882 d. 16 Jan 1883
9
LeRoy Kirkpatrick
[1.1.7.1.3.5.2.3.6]
+
Katherine Allen
8
Isabelle F. Clive
[1.1.7.1.3.5.2.4]
b. 13 May 1848 d. 10 Feb 1874
8
George Washington Clive, Jr
[1.1.7.1.3.5.2.5]
8
William Clive
[1.1.7.1.3.5.2.6]
8
Clara Ida V. Clive
[1.1.7.1.3.5.2.7]
7
Eleanor Clarissa Carr
[1.1.7.1.3.5.3]
+
Thomas Woodson
b. 1798
7
Dorothy Dabney Carr
[1.1.7.1.3.5.4]
6
Francis Carr
[1.1.7.1.3.6]
b. 4 Feb 1784 d. Abt 1843
Virginia Terrell
b. 1798 d. 1860
7
Peter Carr
[1.1.7.1.3.6.1]
d. 1859
+
Lydia Laura Lewis
d. 1864
Maria Morris
7
Francis Edward Garland Carr
[1.1.7.1.3.6.2]
b. Abt 1825 d. 1893
Sally Watson Carr
b. 12 Sep 1826 d. 1850
8
George Watson Carr
[1.1.7.1.3.6.2.1]
b. Abt 1845
5
John Carr
[1.1.7.1.4]
b. 11 Aug 1750 d. 5 Apr 1753
5
Samuel Carr
[1.1.7.1.5]
b. 6 Jan 1745/46 d. 16 May 1777
5
James Carr
[1.1.7.1.6]
b. 15 Nov 1741 d. 10 Oct 1747
5
Dabney Carr
[1.1.7.1.7]
b. 26 Oct 1743 d. 16 May 1773
Martha Jefferson
b. 29 May 1746 d. 3 Sep 1811
6
Peter Carr
[1.1.7.1.7.1]
b. 2 Jan 1770 d. 1815
+
Elizabeth Overton Carr
b. 27 Apr 1773 d. 1837
Hester Stevenson
b. 1767 d. 1834
7
Jane Margaret Carr
[1.1.7.1.7.1.1]
b. 15 Mar 1809 d. 22 Jan 1903
Wilson Jefferson Cary
b. 1806 d. 1877
8
Sarah Nicholas Cary
[1.1.7.1.7.1.1.1]
b. 1832
James Howard McHenry
9
Juliana H. McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.1]
d. 1901
9
Wilson Cary McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.2]
Edith Dove
10
Howard McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.2.1]
+
Frances Garrison
10
Edith Dove McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.2.2]
9
John McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.3]
Priscilla Pinkney Stewart
10
John McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.3.1]
10
James McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.3.2]
+
Margaret Hambleton Ober
10
Julia Howard McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.3.3]
Jr. Robert Lee Randolph
b. 1895
11
Robert Lee Randolph
[1.1.7.1.7.1.1.1.3.3.1]
11
Priscilla Stewart Randolph
[1.1.7.1.7.1.1.1.3.3.2]
10
Priscilla Pinkney McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.3.4]
Duncan Forbes Thayer
11
Priscilla Stewart Thayer
[1.1.7.1.7.1.1.1.3.4.1]
11
Cornelia Van Rensselaer Thayer
[1.1.7.1.7.1.1.1.3.4.2]
9
Ellen McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.4]
R. Brent Keyser
10
Ellen Keyser
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.1]
James Bruce
11
Ellen Bruce
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.1.1]
11
Louise Este Bruce
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.1.2]
10
Juliana Brent Keyser
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.2]
Gaylord Lee Clark
11
Juliana Gaylord Clark
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.2.1]
11
Letitia Lee Clark
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.2.2]
11
Mathilde Keyser Clark
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.2.3]
11
Gaylord Lee Clark
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.2.4]
11
Sally Cary Clark
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.2.5]
10
W. McHenry Keyser
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.3]
Margaret Hambleton Ober
11
Robert Brent Keyser
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.3.1]
11
W. McHenry Keyser
[1.1.7.1.7.1.1.1.4.3.2]
9
Sophia McHenry
[1.1.7.1.7.1.1.1.5]
Charles Morton Stewart
10
Charles Morton Stewart
[1.1.7.1.7.1.1.1.5.1]
Lillie Emerson Van Leuven
11
Charles Morton Stewart
[1.1.7.1.7.1.1.1.5.1.1]
10
Margaret Stewart
[1.1.7.1.7.1.1.1.5.2]
10
Sophia McHenry Stewart
[1.1.7.1.7.1.1.1.5.3]
George Martin Gillet
11
George Martin Gillet
[1.1.7.1.7.1.1.1.5.3.1]
11
James McHenry Gillet
[1.1.7.1.7.1.1.1.5.3.2]
8
Virginia Cary
[1.1.7.1.7.1.1.2]
b. 1833 d. Abt 1833
8
Wilson Miles Cary
[1.1.7.1.7.1.1.3]
b. Abt 1830
8
John Brune Cary
[1.1.7.1.7.1.1.4]
b. 1840 d. 1917
Frances Eugenia Daniel
9
Hetty Cary
[1.1.7.1.7.1.1.4.1]
Fairfax Harrison
b. 13 Mar 1869
10
Ursula Harrison
[1.1.7.1.7.1.1.4.1.1]
b. 14 Dec 1898
10
Constance Cary Harrison
[1.1.7.1.7.1.1.4.1.2]
b. 30 Mar 1895
10
Sally Cary Fairfax Harrison
[1.1.7.1.7.1.1.4.1.3]
10
Richard Harrison
[1.1.7.1.7.1.1.4.1.4]
7
Dabney S. Carr
[1.1.7.1.7.1.2]
b. 1802 d. 1854
7
Ellen Boucher Carr
[1.1.7.1.7.1.3]
b. 1806 d. 1876
6
Lucy Maria Carr
[1.1.7.1.7.2]
b. 7 Mar 1768 d. 1803
Richard M. Terrell
b. 1765 d. 3 Oct 1802
7
Virginia Terrell
[1.1.7.1.7.2.1]
b. 1798 d. 1860
Francis Carr
b. 4 Feb 1784 d. Abt 1843
8
Peter Carr
[1.1.7.1.7.2.1.1]
d. 1859
+
Lydia Laura Lewis
d. 1864
7
Ann Overton Terrell
[1.1.7.1.7.2.2]
b. 1797
7
Mary Jane Terrell
[1.1.7.1.7.2.3]
b. 1803 d. 1879
John Andrew Gardiner Davis
b. 1802 d. 1840
8
John Staige Davis
[1.1.7.1.7.2.3.1]
b. 1824 d. 1885
+
Lucy Landon Blackford
Caroline Kean Hill
b. 1833 d. 1912
9
John Staige Davis
[1.1.7.1.7.2.3.1.1]
b. 24 Jun 1866
Volumnia Hundley Staples
b. 1 Apr 1868
10
Adeline Staples Davis
[1.1.7.1.7.2.3.1.1.1]
b. 25 Oct 1894
Lawrence L. Phillips
11
Harriet B. Phillips
[1.1.7.1.7.2.3.1.1.1.1]
10
Jr. John Staige Davis
[1.1.7.1.7.2.3.1.1.2]
b. 15 Sep 1900
10
Eugenia Davis
[1.1.7.1.7.2.3.1.1.3]
b. 17 Aug 1896
Jr. John Woods Harris
11
Eugenia Davis Harris
[1.1.7.1.7.2.3.1.1.3.1]
7
Dabney Carr Terrell
[1.1.7.1.7.2.4]
b. 1801 d. 1827
7
Martha Jefferson Terrell
[1.1.7.1.7.2.5]
b. 17 Jul 1793
7
Lucy Terrell
[1.1.7.1.7.2.6]
b. 1795
6
Samuel Carr
[1.1.7.1.7.3]
b. 9 Oct 1771 d. 25 Jul 1855
Maria Dabney
b. Abt 1801
7
George Watson Carr
[1.1.7.1.7.3.1]
b. 1823
Pinnie Laws
8
Sally Carr
[1.1.7.1.7.3.1.1]
Emma Gilmer Watts
8
William Watts Carr
[1.1.7.1.7.3.1.2]
8
Betty Carr
[1.1.7.1.7.3.1.3]
+
Donald McDonald
7
Sally Watson Carr
[1.1.7.1.7.3.2]
b. 12 Sep 1826 d. 1850
Francis Edward Garland Carr
b. Abt 1825 d. 1893
8
George Watson Carr
[1.1.7.1.7.3.2.1]
b. Abt 1845
7
Maria Jefferson Carr
[1.1.7.1.7.3.3]
b. 1826
7
Sarah Carr
[1.1.7.1.7.3.4]
b. 1828 d. 1848
7
Lawrence Carr
[1.1.7.1.7.3.5]
Eleanor Barbara Carr
b. Abt 1779 d. 1815
7
James Lawrence Carr
[1.1.7.1.7.3.6]
b. 1811 d. 1875
7
Martha Carr
[1.1.7.1.7.3.7]
b. 1808 d. 1816
7
Dabney Overton Carr
[1.1.7.1.7.3.8]
b. 1806 d. 1841
7
John Addison Carr
[1.1.7.1.7.3.9]
b. 1801 d. 1839
6
Mary Carr
[1.1.7.1.7.4]
b. 7 Mar 1768
Daniel Sladding
b. 1760/1765 d. 1800/1810
7
Arthur Slaton
[1.1.7.1.7.4.1]
b. 1797
6
Jr. Dabney Carr
[1.1.7.1.7.5]
b. 27 Apr 1773 d. 8 Jan 1837
Elizabeth Overton Carr
b. 27 Apr 1773 d. 1837
7
Nancy Addison Carr
[1.1.7.1.7.5.1]
b. Abt 1812
7
Dabney Jefferson Carr
[1.1.7.1.7.5.2]
b. 1817 d. 1826
7
Nancy Addison Carr
[1.1.7.1.7.5.3]
b. Abt 1801
7
Jane Cary Carr
[1.1.7.1.7.5.4]
b. 3 Dec 1807 d. 21 Jul 1859
Peyton Randolph Harrison
b. 19 Nov 1800 d. 10 Sep 1887
8
Virginia Randolph Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.1]
b. 31 Mar 1834 d. 9 Aug 1895
William James Hoge
b. 14 Aug 1825 d. 5 Jul 1864
9
Payton Harrison Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1]
b. 6 Jan 1858 d. 12 Oct 1940
Mary Stuart
b. 3 Feb 1862
10
Jr. Payton Harrison Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.1]
b. 26 Jan 1889
Blanche Weissinger Smith
b. 14 Sep 1891
11
Payton Harrison Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.1.1]
11
Nell Hunt Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.1.2]
10
William Lacy Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.2]
b. 25 Nov 1885
Emily Tyron Mengel
b. 12 Mar 1892
11
Emily Tryon Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.2.1]
11
Mary Holladay Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.2.2]
11
William Lacy Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.2.3]
10
Virginia Randolph Bolling Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.3]
b. 8 Jun 1884 d. 5 May 1937
+
Emidio San Germano
b. 13 Jun 1882 d. 13 Jun 1960
10
Mary Stuart Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.4]
b. 21 Feb 1887
+
George Harrison Houston
b. 4 Jan 1883 d. 9 Jul 1949
10
Elizabeth Addison Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.5]
b. 17 Jan 1891
+
Edmund Taylor Meriwether
b. 25 Jun 1881 d. 7 Jul 1961
10
Evelyn Cary Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.1.6]
b. 17 Aug 1897
+
George Jackson Mead
b. 27 Dec 1891
9
Mary Swift Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.2]
b. 15 Oct 1855 d. 20 Apr 1934
DeLacey Wardlaw
b. 5 Nov 1856 d. 20 Jan 1934
10
Virginia Randolph Wardlaw
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.1]
b. 1 Aug 1881
James William Adamson
b. Bef 1877
11
George Delacey Adamson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.1.1]
b. 16 May 1914 d. 9 Sep 1915
11
Elizabeth Randolph Adamson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.1.2]
11
Mary Virginia Adamson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.1.3]
11
Jessie Buxton Adamson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.1.4]
10
Blanche Lewis Wardlaw
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.2]
b. 6 Aug 1883
+
Frank Reeves Webb
10
Carolyn Cunningham Wardlaw
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.3]
b. 19 Jul 1891
John Jay Naugle
11
John Jay Naugle
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.3.1]
10
Mary Louise Wardlaw
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4]
William McKeen Thompson
11
Randolph Murray Thompson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.1]
11
Addishon Hoge Thompson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.2]
11
Donald Wardlaw Thompson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.3]
11
Jr. William McKeon Thompson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.4]
11
Delacey Alexander Thompson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.5]
William MacKeen Thomson
b. 26 Jun 1882 d. 9 Aug 1970
11
Donald Wardlaw Thomson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.6]
11
DeLacey Alexander Thomson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.7]
11
William Mackeen Thomson, Jr.
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.8]
+
Helen M. Richardson
+
Rosalee M Malphurs
11
Addison Hoge Thomson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.9]
11
Randolph Murray Thomson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.10]
Mary H Turner
12
Laura Bennett Thomson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.10.1]
[
=>
]
11
David Mackeen Thomson
[1.1.7.1.7.5.4.1.2.4.11]
+
Valaria Jane Anderson
9
Dabney Carr Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.3]
b. 24 Feb 1860 d. 11 Aug 1861
9
William Hoge
[1.1.7.1.7.5.4.1.4]
b. 1 Mar 1864 d. 13 Aug 1868
8
Dabney Carr Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.2]
b. 12 Sep 1830 d. 16 Feb 1862
Sallie Pendleton Buchanan
b. 1835 d. 1916
9
Jane Carr Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.2.1]
b. 1856 d. 1864
9
Dabney Carr Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.2.2]
b. 15 Oct 1858
Ellen Robinson Riley
b. 13 May 1876
10
William Riley Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.2.2.1]
b. 25 Nov 1900
10
Dabney Carr Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.2.2.2]
9
Ann Spottiswoode Dandridge Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.2.3]
b. 1860 d. 1898
8
Peyton Randolph Harrison, Jr
[1.1.7.1.7.5.4.3]
b. 17 Jun 1832 d. 21 Jul 1861
Sarah Forrest Hunter
b. 7 Jul 1833 d. 11 Jan 1926
9
Peyton Randolph Harrison, III
[1.1.7.1.7.5.4.3.1]
b. 21 Jul 1859 d. 25 Aug 1941
Nannie Spotswood Boyd
b. 22 Nov 1873 d. 26 May 1937
10
Holmes Boyd Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.1]
b. 22 Oct 1899 d. 22 May 1911
10
Peyton Randolph Harrison, IV
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.2]
b. 2 Sep 1905 d. 16 Feb 1938
10
Anne "Nana" Spottswood Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.3]
+
Bennett Taylor
Lilian Irene Gorham
b. Nov 1873 d. 1890
10
Lillian Gorham Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.4]
b. Aug 1890 d. 20 Nov 1969
Forrest Agustus Brown
b. 28 Jul 1888 d. May 1965
11
Peyton Randolph Brown
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.4.1]
+
Barbara C
11
Forrest Washington Brown
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.4.2]
11
Sarah F Brown
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.4.3]
11
David Hunter Brown
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.4.4]
b. 20 Dec 1923 d. 4 Mar 1958
11
Lillian J Brown
[1.1.7.1.7.5.4.3.1.4.5]
9
Jane Cary Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.3.2]
b. 1856 d. 1928
9
Edmund Pendleton Hunter Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.3.3]
b. 27 Dec 1857 d. 25 Aug 1941
Carolina Henderson Webster
b. 14 Aug 1860 d. 7 Jul 1933
10
Edmund Pendleton Hunter Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.3.3.1]
+
Miriam Louise Washabaugh
10
Sarah Hunter Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.3.3.2]
b. 3 Mar 1893 d. 11 Sep 1967
+
Charles Downing Pinkerton
10
Carolyn Webster Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.3.3.3]
b. 19 Apr 1897
8
Mary Clifton Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.4]
b. 21 Apr 1839 d. 14 Mar 1862
8
Nancy Addison "Nannie" Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.5]
b. 8 Aug 1841 d. 23 Feb 1862
8
Henry Tucker Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.6]
b. 12 Jun 1844 d. 4 Mar 1914
8
Randolph Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.7]
b. 16 Jan 1829 d. 22 Sep 1863
8
William Wirt Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.8]
b. 16 Feb 1837 d. 19 Jan 1880
8
Elizabeth Carr Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.9]
b. 3 Mar 1826 d. 27 Apr 1847
8
Williana Irving Harrison
[1.1.7.1.7.5.4.10]
b. 27 Feb 1847
6
Martha Carr
[1.1.7.1.7.6]
b. Abt 1775
6
Jane Barbara Carr
[1.1.7.1.7.7]
b. 1766 d. 1840
Jr. Wilson Miles Cary
b. 1760 d. 1793
7
Wilson Jefferson Cary
[1.1.7.1.7.7.1]
b. 1784 d. 1823
Virginia Randolph
b. 30 Jan 1786 d. 2 May 1852
8
Archibald Cary
[1.1.7.1.7.7.1.1]
b. 1815 d. 1854
Mominia Fairfax
b. 1820 d. 1875
9
Constance Fairfax Cary
[1.1.7.1.7.7.1.1.1]
b. 1843 d. 1920
Burton Norvell Harrison
b. 14 Jul 1838 d. 29 Mar 1904
10
Fairfax Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.1.1.1]
b. 13 Mar 1869
Hetty Cary
11
Ursula Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.1.1.1.1]
b. 14 Dec 1898
11
Constance Cary Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.1.1.1.2]
b. 30 Mar 1895
11
Sally Cary Fairfax Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.1.1.1.3]
11
Richard Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.1.1.1.4]
10
Archibald Cary Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.1.1.2]
10
Francis Burton Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.1.1.3]
8
Martha Jefferson Cary
[1.1.7.1.7.7.1.2]
b. 1820 d. 1873
Jr. Gouverneur Morris
b. 9 Feb 1813 d. 20 Aug 1888
9
III Gouverneur Morris
[1.1.7.1.7.7.1.2.1]
b. 27 Dec 1844 d. 16 Feb 1897
Henrietta Baldwin
b. 1850
10
Henrietta Fairfax Morris
[1.1.7.1.7.7.1.2.1.1]
b. 22 Aug 1874
10
IV Gouverneur Morris
[1.1.7.1.7.7.1.2.1.2]
b. 7 Feb 1876
10
Powhattan Randolph Morris
[1.1.7.1.7.7.1.2.1.3]
b. 17 Mar 1878
+
Louisa Addison Hughes
b. Mar 1875
8
Mary Randolph Cary
[1.1.7.1.7.7.1.3]
b. 1811 d. 1887
Orlando Fairfax
b. 1806 d. 1882
9
Ethelbert Fairfax
[1.1.7.1.7.7.1.3.1]
b. 1845 d. 1865
9
Monimia Fairfax
[1.1.7.1.7.7.1.3.2]
b. 27 Dec 1837
+
George Davis
b. 1 Mar 1820 d. 23 Feb 1896
9
Randolph Fairfax
[1.1.7.1.7.7.1.3.3]
b. 1842 d. 1862
9
Mary Edith Fairfax
[1.1.7.1.7.7.1.3.4]
+
John Jaquelin Ambler Moncure
9
Virginia Fairfax
[1.1.7.1.7.7.1.3.5]
d. 1832
9
Edith Fairfax
[1.1.7.1.7.7.1.3.6]
d. 1839
9
Orlando Cary Fairfax
[1.1.7.1.7.7.1.3.7]
d. 1836
9
Jane Cary Fairfax
[1.1.7.1.7.7.1.3.8]
8
Anne Mantia Cary
[1.1.7.1.7.7.1.4]
b. 1813 d. 1822
8
Ellen Randolph Cary
[1.1.7.1.7.7.1.5]
b. 1817 d. 1901
8
Sally Newsum Cary
[1.1.7.1.7.7.1.6]
b. 1822 d. Abt 1823
8
Louisa Hartwell Cary
[1.1.7.1.7.7.1.7]
b. 1823 d. Abt 1823
8
Wilson Jefferson Cary
[1.1.7.1.7.7.1.8]
b. 1806 d. 1877
Jane Margaret Carr
b. 15 Mar 1809 d. 22 Jan 1903
9
Sarah Nicholas Cary
[1.1.7.1.7.7.1.8.1]
b. 1832
James Howard McHenry
10
Juliana H. McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.1]
d. 1901
10
Wilson Cary McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.2]
Edith Dove
11
Howard McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.2.1]
+
Frances Garrison
11
Edith Dove McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.2.2]
10
John McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3]
Priscilla Pinkney Stewart
11
John McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3.1]
11
James McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3.2]
+
Margaret Hambleton Ober
11
Julia Howard McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3.3]
Jr. Robert Lee Randolph
b. 1895
12
Robert Lee Randolph
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3.3.1]
12
Priscilla Stewart Randolph
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3.3.2]
11
Priscilla Pinkney McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3.4]
Duncan Forbes Thayer
12
Priscilla Stewart Thayer
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3.4.1]
12
Cornelia Van Rensselaer Thayer
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.3.4.2]
10
Ellen McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4]
R. Brent Keyser
11
Ellen Keyser
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.1]
James Bruce
12
Ellen Bruce
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.1.1]
12
Louise Este Bruce
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.1.2]
11
Juliana Brent Keyser
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.2]
Gaylord Lee Clark
12
Juliana Gaylord Clark
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.2.1]
12
Letitia Lee Clark
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.2.2]
12
Mathilde Keyser Clark
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.2.3]
12
Gaylord Lee Clark
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.2.4]
12
Sally Cary Clark
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.2.5]
11
W. McHenry Keyser
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.3]
Margaret Hambleton Ober
12
Robert Brent Keyser
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.3.1]
12
W. McHenry Keyser
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.4.3.2]
10
Sophia McHenry
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.5]
Charles Morton Stewart
11
Charles Morton Stewart
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.5.1]
Lillie Emerson Van Leuven
12
Charles Morton Stewart
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.5.1.1]
11
Margaret Stewart
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.5.2]
11
Sophia McHenry Stewart
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.5.3]
George Martin Gillet
12
George Martin Gillet
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.5.3.1]
12
James McHenry Gillet
[1.1.7.1.7.7.1.8.1.5.3.2]
9
Virginia Cary
[1.1.7.1.7.7.1.8.2]
b. 1833 d. Abt 1833
9
Wilson Miles Cary
[1.1.7.1.7.7.1.8.3]
b. Abt 1830
9
John Brune Cary
[1.1.7.1.7.7.1.8.4]
b. 1840 d. 1917
Frances Eugenia Daniel
10
Hetty Cary
[1.1.7.1.7.7.1.8.4.1]
Fairfax Harrison
b. 13 Mar 1869
11
Ursula Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.8.4.1.1]
b. 14 Dec 1898
11
Constance Cary Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.8.4.1.2]
b. 30 Mar 1895
11
Sally Cary Fairfax Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.8.4.1.3]
11
Richard Harrison
[1.1.7.1.7.7.1.8.4.1.4]
8
Jane Blair Cary
[1.1.7.1.7.7.1.9]
b. 1808 d. 1888
Edward Dunlap Smith
9
Archibald Cary Smith
[1.1.7.1.7.7.1.9.1]
b. 1853 d. 1911
7
Sarah Cary
[1.1.7.1.7.7.2]
b. 1788
7
Miles Cary
[1.1.7.1.7.7.3]
b. 1789 d. 1827
Elizabeth Scarsbrooke Wilson Curle
8
Lucius Falkland Cary
[1.1.7.1.7.7.3.1]
b. 1815 d. 1845
Lucy Anne Henley
9
Wilson Miles Cary
[1.1.7.1.7.7.3.1.1]
b. 1843 d. 1919
Anne Eliza Sublett
b. 1846 d. 1875
10
Hunsdon Cary
[1.1.7.1.7.7.3.1.1.1]
b. 4 Apr 1872
+
Mary Miller
10
Emily Sampson Cary
[1.1.7.1.7.7.3.1.1.2]
Jr. Thomas Marshall
11
Fairfax Cary Marshall
[1.1.7.1.7.7.3.1.1.2.1]
Lilias Blair McPhail
10
II Lucius Falkland Cary
[1.1.7.1.7.7.3.1.1.3]
b. 1879
+
Alma Miller Cecil
10
Lilias Blair Cary
[1.1.7.1.7.7.3.1.1.4]
b. 11 Sep 1883 d. Nov 1972
Thomas King Currie
11
Jr. Thomas King Currie
[1.1.7.1.7.7.3.1.1.4.1]
9
Harriette Cary
[1.1.7.1.7.7.3.1.2]
b. 22 Mar 1838
+
William Christian
8
Henry Cary
[1.1.7.1.7.7.3.2]
9
Jr. Henry Cary
[1.1.7.1.7.7.3.2.1]
7
Martha Carr Cary
[1.1.7.1.7.7.4]
b. Abt 1791
5
Overton Carr
[1.1.7.1.8]
b. 17 Jul 1752
Mary Ann Addison
b. Abt 1753
6
Jonathan Boucher Carr
[1.1.7.1.8.1]
b. 1775 d. 1859
Barbara Ann Carr
b. 14 Feb 1789 d. Abt 1859
7
Dabney Terrill Carr
[1.1.7.1.8.1.1]
b. 1819
Eliza English
8
Mary Carr
[1.1.7.1.8.1.1.1]
8
Nelly Carr
[1.1.7.1.8.1.1.2]
7
Chloe Lee Carr
[1.1.7.1.8.1.2]
b. 1813
7
James Ferrill Carr
[1.1.7.1.8.1.3]
b. 1828
7
Garland Overton Carr
[1.1.7.1.8.1.4]
b. 1817 d. Abt 1846
8
James Overton Carr
[1.1.7.1.8.1.4.1]
b. Abt 1837 d. 1852
Mary Allen
9
Jane Margaret Carr
[1.1.7.1.8.1.4.1.1]
b. 1832
9
Hetty Carr
[1.1.7.1.8.1.4.1.2]
b. 1825
9
Richard Henry Carr
[1.1.7.1.8.1.4.1.3]
b. 1823
9
Virginia Carr
[1.1.7.1.8.1.4.1.4]
b. Abt 1819
9
Ann Carr
[1.1.7.1.8.1.4.1.5]
9
Elizabeth Carr
[1.1.7.1.8.1.4.1.6]
8
Elizabeth Carr
[1.1.7.1.8.1.4.2]
+
John Paxton
7
Ellen Boucher Carr
[1.1.7.1.8.1.5]
b. 1821 d. Abt 1890
Benjamin Todd
d. 1862
8
Mollie Todd
[1.1.7.1.8.1.5.1]
+
William O. Todd
8
Laura Todd
[1.1.7.1.8.1.5.2]
8
Birdie Winston Todd
[1.1.7.1.8.1.5.3]
8
Price Todd
[1.1.7.1.8.1.5.4]
8
Overton Todd
[1.1.7.1.8.1.5.5]
7
Frank Carr
[1.1.7.1.8.1.6]
b. 1823
Ella Chandler
d. 1894
8
Nannie Carr
[1.1.7.1.8.1.6.1]
+
Leon Ridgeway
8
Frank Carr
[1.1.7.1.8.1.6.2]
7
Elizabeth Maria Carr
[1.1.7.1.8.1.7]
b. 1825
James Douglass
8
Maria Lee Douglass
[1.1.7.1.8.1.7.1]
Adams
9
Helen Douglass Adams
[1.1.7.1.8.1.7.1.1]
8
Benjamin Douglass
[1.1.7.1.8.1.7.2]
9
Gordon Douglass
[1.1.7.1.8.1.7.2.1]
7
William Kimbrough Carr
[1.1.7.1.8.1.8]
b. 1811
7
Mary Ann Carr
[1.1.7.1.8.1.9]
b. 1815 d. 4 Sep 1875
Hugh Walker Minor
b. 31 Jul 1807 d. 12 Dec 1858
8
Martha Lee Minor
[1.1.7.1.8.1.9.1]
b. Abt 1836
Jr. Thomas Walker Gilmer
b. 25 Jul 1834
9
III Thomas Walker Gilmer
[1.1.7.1.8.1.9.1.1]
b. 7 Sep 1869
8
George R. Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2]
b. Mar 1839
Sallie
b. 1839
9
Mary W. Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2.1]
b. Cal 1870
Roberts Coles
b. 29 Jun 1862 d. 17 Jan 1935
10
Jr. Roberts Coles
[1.1.7.1.8.1.9.2.1.1]
Doris Rafferty
11
III Roberts Coles
[1.1.7.1.8.1.9.2.1.1.1]
10
George Minor Coles
[1.1.7.1.8.1.9.2.1.2]
+
Jane Stuart Stringfellow
9
Sallie Cook Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2.2]
b. Nov 1868
9
Peter L. Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2.3]
b. Dec 1881
9
Elysa Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2.4]
b. Aug 1874
9
Jr. George R. Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2.5]
b. Oct 1876
9
Frank C. Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2.6]
b. Apr 1880
9
Lawrence Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2.7]
b. Cal 1867
9
Anne L. Minor
[1.1.7.1.8.1.9.2.8]
b. Aug 1865
6
Jr. Overton Carr
[1.1.7.1.8.2]
b. Abt 1769
+
Baker
6
Mary Ann Carr
[1.1.7.1.8.3]
b. Abt 1770
6
Nellie Carr
[1.1.7.1.8.4]
b. Abt 1771
6
Eleanor Barbara Carr
[1.1.7.1.8.5]
b. Abt 1779 d. 1815
Samuel Carr
b. 9 Oct 1771 d. 25 Jul 1855
7
James Lawrence Carr
[1.1.7.1.8.5.1]
b. 1811 d. 1875
7
Martha Carr
[1.1.7.1.8.5.2]
b. 1808 d. 1816
7
Dabney Overton Carr
[1.1.7.1.8.5.3]
b. 1806 d. 1841
7
John Addison Carr
[1.1.7.1.8.5.4]
b. 1801 d. 1839
6
Elizabeth Overton Carr
[1.1.7.1.8.6]
b. 27 Apr 1773 d. 1837
+
Peter Carr
b. 2 Jan 1770 d. 1815
Jr. Dabney Carr
b. 27 Apr 1773 d. 8 Jan 1837
7
Nancy Addison Carr
[1.1.7.1.8.6.1]
b. Abt 1812
7
Dabney Jefferson Carr
[1.1.7.1.8.6.2]
b. 1817 d. 1826
7
Nancy Addison Carr
[1.1.7.1.8.6.3]
b. Abt 1801
7
Jane Cary Carr
[1.1.7.1.8.6.4]
b. 3 Dec 1807 d. 21 Jul 1859
Peyton Randolph Harrison
b. 19 Nov 1800 d. 10 Sep 1887
8
Virginia Randolph Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.1]
b. 31 Mar 1834 d. 9 Aug 1895
William James Hoge
b. 14 Aug 1825 d. 5 Jul 1864
9
Payton Harrison Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1]
b. 6 Jan 1858 d. 12 Oct 1940
Mary Stuart
b. 3 Feb 1862
10
Jr. Payton Harrison Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.1]
b. 26 Jan 1889
Blanche Weissinger Smith
b. 14 Sep 1891
11
Payton Harrison Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.1.1]
11
Nell Hunt Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.1.2]
10
William Lacy Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.2]
b. 25 Nov 1885
Emily Tyron Mengel
b. 12 Mar 1892
11
Emily Tryon Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.2.1]
11
Mary Holladay Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.2.2]
11
William Lacy Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.2.3]
10
Virginia Randolph Bolling Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.3]
b. 8 Jun 1884 d. 5 May 1937
+
Emidio San Germano
b. 13 Jun 1882 d. 13 Jun 1960
10
Mary Stuart Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.4]
b. 21 Feb 1887
+
George Harrison Houston
b. 4 Jan 1883 d. 9 Jul 1949
10
Elizabeth Addison Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.5]
b. 17 Jan 1891
+
Edmund Taylor Meriwether
b. 25 Jun 1881 d. 7 Jul 1961
10
Evelyn Cary Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.1.6]
b. 17 Aug 1897
+
George Jackson Mead
b. 27 Dec 1891
9
Mary Swift Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.2]
b. 15 Oct 1855 d. 20 Apr 1934
DeLacey Wardlaw
b. 5 Nov 1856 d. 20 Jan 1934
10
Virginia Randolph Wardlaw
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.1]
b. 1 Aug 1881
James William Adamson
b. Bef 1877
11
George Delacey Adamson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.1.1]
b. 16 May 1914 d. 9 Sep 1915
11
Elizabeth Randolph Adamson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.1.2]
11
Mary Virginia Adamson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.1.3]
11
Jessie Buxton Adamson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.1.4]
10
Blanche Lewis Wardlaw
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.2]
b. 6 Aug 1883
+
Frank Reeves Webb
10
Carolyn Cunningham Wardlaw
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.3]
b. 19 Jul 1891
John Jay Naugle
11
John Jay Naugle
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.3.1]
10
Mary Louise Wardlaw
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4]
William McKeen Thompson
11
Randolph Murray Thompson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.1]
11
Addishon Hoge Thompson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.2]
11
Donald Wardlaw Thompson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.3]
11
Jr. William McKeon Thompson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.4]
11
Delacey Alexander Thompson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.5]
William MacKeen Thomson
b. 26 Jun 1882 d. 9 Aug 1970
11
Donald Wardlaw Thomson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.6]
11
DeLacey Alexander Thomson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.7]
11
William Mackeen Thomson, Jr.
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.8]
+
Helen M. Richardson
+
Rosalee M Malphurs
11
Addison Hoge Thomson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.9]
11
Randolph Murray Thomson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.10]
Mary H Turner
12
Laura Bennett Thomson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.10.1]
[
=>
]
11
David Mackeen Thomson
[1.1.7.1.8.6.4.1.2.4.11]
+
Valaria Jane Anderson
9
Dabney Carr Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.3]
b. 24 Feb 1860 d. 11 Aug 1861
9
William Hoge
[1.1.7.1.8.6.4.1.4]
b. 1 Mar 1864 d. 13 Aug 1868
8
Dabney Carr Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.2]
b. 12 Sep 1830 d. 16 Feb 1862
Sallie Pendleton Buchanan
b. 1835 d. 1916
9
Jane Carr Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.2.1]
b. 1856 d. 1864
9
Dabney Carr Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.2.2]
b. 15 Oct 1858
Ellen Robinson Riley
b. 13 May 1876
10
William Riley Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.2.2.1]
b. 25 Nov 1900
10
Dabney Carr Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.2.2.2]
9
Ann Spottiswoode Dandridge Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.2.3]
b. 1860 d. 1898
8
Peyton Randolph Harrison, Jr
[1.1.7.1.8.6.4.3]
b. 17 Jun 1832 d. 21 Jul 1861
Sarah Forrest Hunter
b. 7 Jul 1833 d. 11 Jan 1926
9
Peyton Randolph Harrison, III
[1.1.7.1.8.6.4.3.1]
b. 21 Jul 1859 d. 25 Aug 1941
Nannie Spotswood Boyd
b. 22 Nov 1873 d. 26 May 1937
10
Holmes Boyd Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.1]
b. 22 Oct 1899 d. 22 May 1911
10
Peyton Randolph Harrison, IV
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.2]
b. 2 Sep 1905 d. 16 Feb 1938
10
Anne "Nana" Spottswood Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.3]
+
Bennett Taylor
Lilian Irene Gorham
b. Nov 1873 d. 1890
10
Lillian Gorham Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.4]
b. Aug 1890 d. 20 Nov 1969
Forrest Agustus Brown
b. 28 Jul 1888 d. May 1965
11
Peyton Randolph Brown
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.4.1]
+
Barbara C
11
Forrest Washington Brown
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.4.2]
11
Sarah F Brown
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.4.3]
11
David Hunter Brown
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.4.4]
b. 20 Dec 1923 d. 4 Mar 1958
11
Lillian J Brown
[1.1.7.1.8.6.4.3.1.4.5]
9
Jane Cary Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.3.2]
b. 1856 d. 1928
9
Edmund Pendleton Hunter Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.3.3]
b. 27 Dec 1857 d. 25 Aug 1941
Carolina Henderson Webster
b. 14 Aug 1860 d. 7 Jul 1933
10
Edmund Pendleton Hunter Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.3.3.1]
+
Miriam Louise Washabaugh
10
Sarah Hunter Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.3.3.2]
b. 3 Mar 1893 d. 11 Sep 1967
+
Charles Downing Pinkerton
10
Carolyn Webster Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.3.3.3]
b. 19 Apr 1897
8
Mary Clifton Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.4]
b. 21 Apr 1839 d. 14 Mar 1862
8
Nancy Addison "Nannie" Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.5]
b. 8 Aug 1841 d. 23 Feb 1862
8
Henry Tucker Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.6]
b. 12 Jun 1844 d. 4 Mar 1914
8
Randolph Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.7]
b. 16 Jan 1829 d. 22 Sep 1863
8
William Wirt Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.8]
b. 16 Feb 1837 d. 19 Jan 1880
8
Elizabeth Carr Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.9]
b. 3 Mar 1826 d. 27 Apr 1847
8
Williana Irving Harrison
[1.1.7.1.8.6.4.10]
b. 27 Feb 1847
5
Sarah Elizabeth Carr
[1.1.7.1.9]
b. 25 Sep 1758 d. 12 May 1759
5
John Carr
[1.1.7.1.10]
b. 1738 d. 3 Nov 1747
5
Mary Carr
[1.1.7.1.11]
b. 14 Sep 1756 d. 7 Jul 1797
James Minor
b. 18 Feb 1745 d. 9 Jun 1791
6
Ann Minor
[1.1.7.1.11.1]
b. 10 Aug 1784 d. 2 Mar 1806
+
David Yancey
b. 20 Jun 1777 d. Dec 1807
6
Sarah Minor
[1.1.7.1.11.2]
b. 4 Nov 1776 d. 22 Apr 1808
+
William Wardlaw
6
Dabney Minor
[1.1.7.1.11.3]
b. 7 Dec 1774 d. 12 Oct 1824
Eliza Johnson
7
William Wardlaw Minor
[1.1.7.1.11.3.1]
b. 22 Aug 1812 d. 16 May 1887
Mary Waters Terrell
b. 6 Dec 1814 d. 2 Jan 1894
8
Jane Bell Minor
[1.1.7.1.11.3.1.1]
b. 22 Sep 1847 d. 1914
William Cecil Dabney
b. 4 Jul 1869 d. 20 Aug 1894
9
Cecil Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.1]
b. 1884 d. 1913
+
Frances Cole
9
William Minor Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.2]
b. 21 Aug 1873
9
James Cabell Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.3]
b. 8 Oct 1875
Mary Beverley Whittle
10
Mary Beverley Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.3.1]
10
William Minor Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.3.2]
10
Elizabeth Calvert Page Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.3.3]
9
Susan FitzHugh Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.4]
St. George Tucker Grinnan
b. 6 Apr 1870
10
William C. Grinnan
[1.1.7.1.11.3.1.1.4.1]
10
David Grinnan
[1.1.7.1.11.3.1.1.4.2]
10
Jane Bell Grinnan
[1.1.7.1.11.3.1.1.4.3]
10
St. George Tucker Grinnan
[1.1.7.1.11.3.1.1.4.4]
10
Georgia Grinnan
[1.1.7.1.11.3.1.1.4.5]
9
Marian Gordon Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.5]
9
Jane Bell Dabney
[1.1.7.1.11.3.1.1.6]
+
E. Ruffln Jones
7
Catharine Henrietta Minor
[1.1.7.1.11.3.2]
b. 22 Sep 1808 d. 15 Nov 1877
+
Elkhanna Winchester Reinhart
b. 1 Sep 1779 d. 17 May 1841
7
Matilda Wirt Minor
[1.1.7.1.11.3.3]
b. 1 Nov 1815
+
Hudson Martin
7
Sarah Eliza Minor
[1.1.7.1.11.3.4]
b. 21 Sep 1810 d. 4 Oct 1854
7
Mary Minor
[1.1.7.1.11.3.5]
b. 26 Feb 1806 d. 1846
+
Albert Gallatin Quarles
+
M. J. Terrill
6
John Minor
[1.1.7.1.11.4]
b. 2 Apr 1791 d. 4 Apr 1849
+
Jane Bell
b. 26 Sep 1796 d. 28 Jan 1835
6
Mary Minor
[1.1.7.1.11.5]
b. 1 Sep 1780 d. 20 Aug 1805
+
Richard Henry Allen
b. 1774 d. 7 Sep 1805
6
Elizabeth Minor
[1.1.7.1.11.6]
b. 11 Oct 1778 d. 22 Mar 1807
Alexander Garret
7
Mary Anne Garrett
[1.1.7.1.11.6.1]
d. Bef 1825
+
Valentine Wood Southall
b. 1789/1790 d. 22 Aug 1861
6
Barbara Overton Minor
[1.1.7.1.11.7]
b. 25 Nov 1786 d. 27 Jun 1790
6
Jr. James Minor
[1.1.7.1.11.8]
b. 22 Nov 1788 d. 29 Aug 1841
+
Christianna Tompkins
b. 24 Oct 1785 d. 3 Aug 1833
Mary Garland
b. Abt 1708 d. 10 Mar 1736
5
Thomas Carr
[1.1.7.1.12]
b. 25 Nov 1735 d. 1807
Lucy Barksdale
b. Abt 1739
6
Mary Carr
[1.1.7.1.12.1]
b. Abt 1760
6
Jr. Thomas Carr
[1.1.7.1.12.2]
b. Abt 1760
6
Dabney Carr
[1.1.7.1.12.3]
+
Lucy Digges
6
John Manoah Carr
[1.1.7.1.12.4]
6
Nathaniel Carr
[1.1.7.1.12.5]
6
Elizabeth Carr
[1.1.7.1.12.6]
6
Samuel Carr
[1.1.7.1.12.7]
4
Anne Carr
[1.1.7.2]
b. Abt 1690
Samuel Overton
b. 14 Aug 1685 d. 22 Apr 1760
5
Polly Overton
[1.1.7.2.1]
b. 29 Jan 1731/32 d. 17 Feb 1815
William Winston
b. 1737 d. 1799
6
Mary Phillips Winston
[1.1.7.2.1.1]
b. Abt 1763
Garland Carr
b. 10 Jul 1754 d. 16 Oct 1838
7
James Overton Carr
[1.1.7.2.1.1.1]
b. 6 Oct 1793
7
Elizabeth Carr
[1.1.7.2.1.1.2]
b. 21 Aug 1791
7
Barbara Ann Carr
[1.1.7.2.1.1.3]
b. 14 Feb 1789 d. Abt 1859
Jonathan Boucher Carr
b. 1775 d. 1859
8
Dabney Terrill Carr
[1.1.7.2.1.1.3.1]
b. 1819
Eliza English
9
Mary Carr
[1.1.7.2.1.1.3.1.1]
9
Nelly Carr
[1.1.7.2.1.1.3.1.2]
8
Chloe Lee Carr
[1.1.7.2.1.1.3.2]
b. 1813
8
James Ferrill Carr
[1.1.7.2.1.1.3.3]
b. 1828
8
Garland Overton Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4]
b. 1817 d. Abt 1846
9
James Overton Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4.1]
b. Abt 1837 d. 1852
Mary Allen
10
Jane Margaret Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4.1.1]
b. 1832
10
Hetty Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4.1.2]
b. 1825
10
Richard Henry Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4.1.3]
b. 1823
10
Virginia Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4.1.4]
b. Abt 1819
10
Ann Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4.1.5]
10
Elizabeth Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4.1.6]
9
Elizabeth Carr
[1.1.7.2.1.1.3.4.2]
+
John Paxton
8
Ellen Boucher Carr
[1.1.7.2.1.1.3.5]
b. 1821 d. Abt 1890
Benjamin Todd
d. 1862
9
Mollie Todd
[1.1.7.2.1.1.3.5.1]
+
William O. Todd
9
Laura Todd
[1.1.7.2.1.1.3.5.2]
9
Birdie Winston Todd
[1.1.7.2.1.1.3.5.3]
9
Price Todd
[1.1.7.2.1.1.3.5.4]
9
Overton Todd
[1.1.7.2.1.1.3.5.5]
8
Frank Carr
[1.1.7.2.1.1.3.6]
b. 1823
Ella Chandler
d. 1894
9
Nannie Carr
[1.1.7.2.1.1.3.6.1]
+
Leon Ridgeway
9
Frank Carr
[1.1.7.2.1.1.3.6.2]
8
Elizabeth Maria Carr
[1.1.7.2.1.1.3.7]
b. 1825
James Douglass
9
Maria Lee Douglass
[1.1.7.2.1.1.3.7.1]
Adams
10
Helen Douglass Adams
[1.1.7.2.1.1.3.7.1.1]
9
Benjamin Douglass
[1.1.7.2.1.1.3.7.2]
10
Gordon Douglass
[1.1.7.2.1.1.3.7.2.1]
8
William Kimbrough Carr
[1.1.7.2.1.1.3.8]
b. 1811
8
Mary Ann Carr
[1.1.7.2.1.1.3.9]
b. 1815 d. 4 Sep 1875
Hugh Walker Minor
b. 31 Jul 1807 d. 12 Dec 1858
9
Martha Lee Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.1]
b. Abt 1836
Jr. Thomas Walker Gilmer
b. 25 Jul 1834
10
III Thomas Walker Gilmer
[1.1.7.2.1.1.3.9.1.1]
b. 7 Sep 1869
9
George R. Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2]
b. Mar 1839
Sallie
b. 1839
10
Mary W. Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.1]
b. Cal 1870
Roberts Coles
b. 29 Jun 1862 d. 17 Jan 1935
11
Jr. Roberts Coles
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.1.1]
Doris Rafferty
12
III Roberts Coles
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.1.1.1]
11
George Minor Coles
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.1.2]
+
Jane Stuart Stringfellow
10
Sallie Cook Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.2]
b. Nov 1868
10
Peter L. Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.3]
b. Dec 1881
10
Elysa Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.4]
b. Aug 1874
10
Jr. George R. Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.5]
b. Oct 1876
10
Frank C. Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.6]
b. Apr 1880
10
Lawrence Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.7]
b. Cal 1867
10
Anne L. Minor
[1.1.7.2.1.1.3.9.2.8]
b. Aug 1865
7
Mary Winston Carr
[1.1.7.2.1.1.4]
b. 28 Apr 1796 d. 12 Feb 1852
Achilles Broadhead
b. Abt 1789 d. 4 Oct 1853
8
Elizabeth Maria Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.1]
b. 25 Aug 1829 d. 2 Jul 1892
+
H. B. Logan
8
James Overton Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.2]
b. 29 May 1819
Mary Snowdon Dorsey
9
Charles S. Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.2.1]
9
Nannie Dorsey Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.2.2]
9
Mary W. Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.2.3]
+
William Horton
8
Garland Carr Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.3]
b. 30 Oct 1827
+
Victoria Regina Royall
b. 1841
Marion Wallace Wright
b. 9 Apr 1843 d. 24 Nov 1883
9
Jr. Garland Carr Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.3.1]
b. 4 Jan 1873
9
Marion Gertrude Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.3.2]
b. 21 May 1877
+
S. Frank Conly
9
Harry Howard Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.3.3]
b. 29 Oct 1879
9
Mary West Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.3.4]
b. 28 Apr 1866
William E. Whitsitt
10
Garland Broadhead Whitsitt
[1.1.7.2.1.1.4.3.4.1]
Mary C.
b. Cal 1897
11
Jr. Garland Broadhead Whitsitt
[1.1.7.2.1.1.4.3.4.1.1]
11
Constance M. Whitsitt
[1.1.7.2.1.1.4.3.4.1.2]
11
Frank C. Whitsitt
[1.1.7.2.1.1.4.3.4.1.3]
8
Mary Ann Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.4]
b. 28 Jul 1821 d. 3 Jul 1890
John H. Newby
d. 1888
9
William Garland Newby
[1.1.7.2.1.1.4.4.1]
+
Etta Price
9
John Broadhead Newby
[1.1.7.2.1.1.4.4.2]
Libby North
10
Florence Newby
[1.1.7.2.1.1.4.4.2.1]
10
Mary Newby
[1.1.7.2.1.1.4.4.2.2]
8
William Ferrill Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.5]
b. 23 Nov 1836
Rosalie Weber
9
Overton Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.5.1]
9
Rosalie Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.5.2]
9
Archibald Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.5.3]
9
James Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.5.4]
9
William Broadhead
[1.1.7.2.1.1.4.5.5]
7
Daniel Ferrell Carr
[1.1.7.2.1.1.5]
b. 10 Dec 1786 d. 6 Jun 1847
Virginia Emily Terrell
b. 14 May 1781 d. 24 Sep 1842
8
William Garland Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1]
b. Cal 1810 d. Abt 1894
Charlotte M. Duke
b. Cal 1819
9
Emily I. Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.1]
b. 16 Jul 1854 d. 7 Sep 1935
+
Harrison
9
Lucy L. Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.2]
b. Cal 1845 d. Feb 1895
Henry L. Stuart
10
Eleanor C. Stuart
[1.1.7.2.1.1.5.1.2.1]
b. 1 Sep 1876 d. 6 Jan 1907
Jr. Watt H. Daniel
11
Sara Daniel
[1.1.7.2.1.1.5.1.2.1.1]
10
Mary DeNeale Stuart
[1.1.7.2.1.1.5.1.2.2]
b. 3 Nov 1877 d. 4 May 1966
9
Nannie P. Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.3]
b. 1839
Francis S. Bronough
10
William Bronough
[1.1.7.2.1.1.5.1.3.1]
b. 1864
9
James Garland Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.4]
b. 1843
9
Charlotte Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.5]
b. 1846
J. Cochran
10
Charlotte Cochran
[1.1.7.2.1.1.5.1.5.1]
+
Cochran
9
Martha Winston Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.6]
b. Cal 1855 d. 1893
Jonathan Carter
b. 22 Mar 1852 d. 24 Jun 1887
10
John Ferrell Carter
[1.1.7.2.1.1.5.1.6.1]
b. 11 Nov 1887 d. 15 Oct 1938
Mary Lucile Deavours
11
Robertine Ellison Carter
[1.1.7.2.1.1.5.1.6.1.1]
11
Katherine Winston Carter
[1.1.7.2.1.1.5.1.6.1.2]
11
Lucile Deavours Carter
[1.1.7.2.1.1.5.1.6.1.3]
9
Jr. William Garland Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.7]
b. 1861 d. 11 Jun 1887
9
Ferrell D. Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.8]
b. Cal 1849
9
Elizabeth Carr
[1.1.7.2.1.1.5.1.9]
b. Cal 1858
8
Martha Winston Carr
[1.1.7.2.1.1.5.2]
b. 20 May 1813
George Washington Clive
b. 12 Mar 1809 d. 12 Apr 1883
9
Mary Waters Clive
[1.1.7.2.1.1.5.2.1]
b. Cal 1837
John Pryor Allison
b. 1832
10
Patricia Winston Allison
[1.1.7.2.1.1.5.2.1.1]
b. Cal 1867
Thomas Nelson Phillips
b. 2 Dec 1850 d. 13 Mar 1921
11
Thomas Milton Phillips
[1.1.7.2.1.1.5.2.1.1.1]
+
Vera Ragan
11
Nelson Allison Phillips
[1.1.7.2.1.1.5.2.1.1.2]
b. 4 Nov 1905 d. 4 Nov 1905
10
William Allison
[1.1.7.2.1.1.5.2.1.2]
b. Cal 1860
10
George Allison
[1.1.7.2.1.1.5.2.1.3]
b. Cal 1865
10
L. P. Allison
[1.1.7.2.1.1.5.2.1.4]
9
Catherine Davis Clive
[1.1.7.2.1.1.5.2.2]
b. 27 Jun 1857 d. 25 Nov 1927
George Murray
b. 5 Oct 1851 d. 15 Nov 1903
10
Mary Carr Murray
[1.1.7.2.1.1.5.2.2.1]
b. 14 Sep 1892 d. 3 Dec 1939
10
Katie Carey Murray
[1.1.7.2.1.1.5.2.2.2]
b. 14 Sep 1892 d. 14 Sep 1892
10
George Lindley Murray
[1.1.7.2.1.1.5.2.2.3]
b. Abt 1893
10
Earl Randolph Murray
[1.1.7.2.1.1.5.2.2.4]
10
Helen Clive Murray
[1.1.7.2.1.1.5.2.2.5]
d. 3 Dec 1939
9
Emily Terrell Clive
[1.1.7.2.1.1.5.2.3]
b. 17 Jun 1847 d. 23 Mar 1931
Elbert Wiley Kirkpatrick
b. 12 Oct 1844 d. 24 Mar 1924
10
Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.1]
b. 17 Jun 1875 d. 3 Jul 1875
10
Ray H. Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.2]
b. 16 Sep 1876 d. 16 Dec 1964
Ella Bell
b. 1878 d. Dec 1939
11
Lloyd Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.2.1]
b. 1904
+
Thelma
11
Kathleen Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.2.2]
b. Cal 1906
+
Paul Schaeffer
10
Alice Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.3]
b. 13 Aug 1878 d. 17 Mar 1969
Charles Waide
b. 7 Oct 1868 d. 29 Oct 1939
11
Martha Waide
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.3.1]
Jay Y. Crum
b. 18 Nov 1910
12
Thomas Crum
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.3.1.1]
12
Jr. Jay Crum
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.3.1.2]
+
Walter H. Schubert
11
Elbert Waide
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.3.2]
+
Freda Virginia Barham
10
Sara Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.4]
b. Jul 1880 d. 1929
10
Jack Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.5]
b. 10 Jul 1882 d. 16 Jan 1883
10
LeRoy Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.1.5.2.3.6]
+
Katherine Allen
9
Isabelle F. Clive
[1.1.7.2.1.1.5.2.4]
b. 13 May 1848 d. 10 Feb 1874
9
George Washington Clive, Jr
[1.1.7.2.1.1.5.2.5]
9
William Clive
[1.1.7.2.1.1.5.2.6]
9
Clara Ida V. Clive
[1.1.7.2.1.1.5.2.7]
8
Eleanor Clarissa Carr
[1.1.7.2.1.1.5.3]
+
Thomas Woodson
b. 1798
8
Dorothy Dabney Carr
[1.1.7.2.1.1.5.4]
7
Francis Carr
[1.1.7.2.1.1.6]
b. 4 Feb 1784 d. Abt 1843
Virginia Terrell
b. 1798 d. 1860
8
Peter Carr
[1.1.7.2.1.1.6.1]
d. 1859
+
Lydia Laura Lewis
d. 1864
Maria Morris
8
Francis Edward Garland Carr
[1.1.7.2.1.1.6.2]
b. Abt 1825 d. 1893
Sally Watson Carr
b. 12 Sep 1826 d. 1850
9
George Watson Carr
[1.1.7.2.1.1.6.2.1]
b. Abt 1845
6
Martha Winston
[1.1.7.2.1.2]
b. Abt 1770
William Garland Terrell
b. 25 May 1766 d. 1811
7
Richmond Terrell
[1.1.7.2.1.2.1]
b. 1775
Sarah Meriwether Overton
b. 11 Aug 1794
8
Mary Waters Terrell
[1.1.7.2.1.2.1.1]
b. 6 Dec 1814 d. 2 Jan 1894
William Wardlaw Minor
b. 22 Aug 1812 d. 16 May 1887
9
Jane Bell Minor
[1.1.7.2.1.2.1.1.1]
b. 22 Sep 1847 d. 1914
William Cecil Dabney
b. 4 Jul 1869 d. 20 Aug 1894
10
Cecil Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.1]
b. 1884 d. 1913
+
Frances Cole
10
William Minor Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.2]
b. 21 Aug 1873
10
James Cabell Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.3]
b. 8 Oct 1875
Mary Beverley Whittle
11
Mary Beverley Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.3.1]
11
William Minor Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.3.2]
11
Elizabeth Calvert Page Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.3.3]
10
Susan FitzHugh Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.4]
St. George Tucker Grinnan
b. 6 Apr 1870
11
William C. Grinnan
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.4.1]
11
David Grinnan
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.4.2]
11
Jane Bell Grinnan
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.4.3]
11
St. George Tucker Grinnan
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.4.4]
11
Georgia Grinnan
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.4.5]
10
Marian Gordon Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.5]
10
Jane Bell Dabney
[1.1.7.2.1.2.1.1.1.6]
+
E. Ruffln Jones
7
Virginia Emily Terrell
[1.1.7.2.1.2.2]
b. 14 May 1781 d. 24 Sep 1842
Daniel Ferrell Carr
b. 10 Dec 1786 d. 6 Jun 1847
8
William Garland Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1]
b. Cal 1810 d. Abt 1894
Charlotte M. Duke
b. Cal 1819
9
Emily I. Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.1]
b. 16 Jul 1854 d. 7 Sep 1935
+
Harrison
9
Lucy L. Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.2]
b. Cal 1845 d. Feb 1895
Henry L. Stuart
10
Eleanor C. Stuart
[1.1.7.2.1.2.2.1.2.1]
b. 1 Sep 1876 d. 6 Jan 1907
Jr. Watt H. Daniel
11
Sara Daniel
[1.1.7.2.1.2.2.1.2.1.1]
10
Mary DeNeale Stuart
[1.1.7.2.1.2.2.1.2.2]
b. 3 Nov 1877 d. 4 May 1966
9
Nannie P. Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.3]
b. 1839
Francis S. Bronough
10
William Bronough
[1.1.7.2.1.2.2.1.3.1]
b. 1864
9
James Garland Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.4]
b. 1843
9
Charlotte Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.5]
b. 1846
J. Cochran
10
Charlotte Cochran
[1.1.7.2.1.2.2.1.5.1]
+
Cochran
9
Martha Winston Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.6]
b. Cal 1855 d. 1893
Jonathan Carter
b. 22 Mar 1852 d. 24 Jun 1887
10
John Ferrell Carter
[1.1.7.2.1.2.2.1.6.1]
b. 11 Nov 1887 d. 15 Oct 1938
Mary Lucile Deavours
11
Robertine Ellison Carter
[1.1.7.2.1.2.2.1.6.1.1]
11
Katherine Winston Carter
[1.1.7.2.1.2.2.1.6.1.2]
11
Lucile Deavours Carter
[1.1.7.2.1.2.2.1.6.1.3]
9
Jr. William Garland Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.7]
b. 1861 d. 11 Jun 1887
9
Ferrell D. Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.8]
b. Cal 1849
9
Elizabeth Carr
[1.1.7.2.1.2.2.1.9]
b. Cal 1858
8
Martha Winston Carr
[1.1.7.2.1.2.2.2]
b. 20 May 1813
George Washington Clive
b. 12 Mar 1809 d. 12 Apr 1883
9
Mary Waters Clive
[1.1.7.2.1.2.2.2.1]
b. Cal 1837
John Pryor Allison
b. 1832
10
Patricia Winston Allison
[1.1.7.2.1.2.2.2.1.1]
b. Cal 1867
Thomas Nelson Phillips
b. 2 Dec 1850 d. 13 Mar 1921
11
Thomas Milton Phillips
[1.1.7.2.1.2.2.2.1.1.1]
+
Vera Ragan
11
Nelson Allison Phillips
[1.1.7.2.1.2.2.2.1.1.2]
b. 4 Nov 1905 d. 4 Nov 1905
10
William Allison
[1.1.7.2.1.2.2.2.1.2]
b. Cal 1860
10
George Allison
[1.1.7.2.1.2.2.2.1.3]
b. Cal 1865
10
L. P. Allison
[1.1.7.2.1.2.2.2.1.4]
9
Catherine Davis Clive
[1.1.7.2.1.2.2.2.2]
b. 27 Jun 1857 d. 25 Nov 1927
George Murray
b. 5 Oct 1851 d. 15 Nov 1903
10
Mary Carr Murray
[1.1.7.2.1.2.2.2.2.1]
b. 14 Sep 1892 d. 3 Dec 1939
10
Katie Carey Murray
[1.1.7.2.1.2.2.2.2.2]
b. 14 Sep 1892 d. 14 Sep 1892
10
George Lindley Murray
[1.1.7.2.1.2.2.2.2.3]
b. Abt 1893
10
Earl Randolph Murray
[1.1.7.2.1.2.2.2.2.4]
10
Helen Clive Murray
[1.1.7.2.1.2.2.2.2.5]
d. 3 Dec 1939
9
Emily Terrell Clive
[1.1.7.2.1.2.2.2.3]
b. 17 Jun 1847 d. 23 Mar 1931
Elbert Wiley Kirkpatrick
b. 12 Oct 1844 d. 24 Mar 1924
10
Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.1]
b. 17 Jun 1875 d. 3 Jul 1875
10
Ray H. Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.2]
b. 16 Sep 1876 d. 16 Dec 1964
Ella Bell
b. 1878 d. Dec 1939
11
Lloyd Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.2.1]
b. 1904
+
Thelma
11
Kathleen Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.2.2]
b. Cal 1906
+
Paul Schaeffer
10
Alice Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.3]
b. 13 Aug 1878 d. 17 Mar 1969
Charles Waide
b. 7 Oct 1868 d. 29 Oct 1939
11
Martha Waide
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.3.1]
Jay Y. Crum
b. 18 Nov 1910
12
Thomas Crum
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.3.1.1]
12
Jr. Jay Crum
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.3.1.2]
+
Walter H. Schubert
11
Elbert Waide
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.3.2]
+
Freda Virginia Barham
10
Sara Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.4]
b. Jul 1880 d. 1929
10
Jack Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.5]
b. 10 Jul 1882 d. 16 Jan 1883
10
LeRoy Kirkpatrick
[1.1.7.2.1.2.2.2.3.6]
+
Katherine Allen
9
Isabelle F. Clive
[1.1.7.2.1.2.2.2.4]
b. 13 May 1848 d. 10 Feb 1874
9
George Washington Clive, Jr
[1.1.7.2.1.2.2.2.5]
9
William Clive
[1.1.7.2.1.2.2.2.6]
9
Clara Ida V. Clive
[1.1.7.2.1.2.2.2.7]
8
Eleanor Clarissa Carr
[1.1.7.2.1.2.2.3]
+
Thomas Woodson
b. 1798
8
Dorothy Dabney Carr
[1.1.7.2.1.2.2.4]
6
Winston
[1.1.7.2.1.3]
+
Dabney
6
Winston
[1.1.7.2.1.4]
+
Schenck
6
Winston
[1.1.7.2.1.5]
+
Price
6
Horatio Gates Winston
[1.1.7.2.1.6]
6
John Winston
[1.1.7.2.1.7]
+
Nancy Anne Overton
4
Sarah Dabney Carr
[1.1.7.3]
b. 14 Nov 1714 d. 25 Sep 1772
John Vivion Minor
b. 22 Jun 1707 d. 2 Aug 1755
5
James Minor
[1.1.7.3.1]
b. 18 Feb 1745 d. 9 Jun 1791
Mary Carr
b. 14 Sep 1756 d. 7 Jul 1797
6
Ann Minor
[1.1.7.3.1.1]
b. 10 Aug 1784 d. 2 Mar 1806
+
David Yancey
b. 20 Jun 1777 d. Dec 1807
6
Sarah Minor
[1.1.7.3.1.2]
b. 4 Nov 1776 d. 22 Apr 1808
+
William Wardlaw
6
Dabney Minor
[1.1.7.3.1.3]
b. 7 Dec 1774 d. 12 Oct 1824
Eliza Johnson
7
William Wardlaw Minor
[1.1.7.3.1.3.1]
b. 22 Aug 1812 d. 16 May 1887
Mary Waters Terrell
b. 6 Dec 1814 d. 2 Jan 1894
8
Jane Bell Minor
[1.1.7.3.1.3.1.1]
b. 22 Sep 1847 d. 1914
William Cecil Dabney
b. 4 Jul 1869 d. 20 Aug 1894
9
Cecil Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.1]
b. 1884 d. 1913
+
Frances Cole
9
William Minor Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.2]
b. 21 Aug 1873
9
James Cabell Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.3]
b. 8 Oct 1875
Mary Beverley Whittle
10
Mary Beverley Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.3.1]
10
William Minor Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.3.2]
10
Elizabeth Calvert Page Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.3.3]
9
Susan FitzHugh Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.4]
St. George Tucker Grinnan
b. 6 Apr 1870
10
William C. Grinnan
[1.1.7.3.1.3.1.1.4.1]
10
David Grinnan
[1.1.7.3.1.3.1.1.4.2]
10
Jane Bell Grinnan
[1.1.7.3.1.3.1.1.4.3]
10
St. George Tucker Grinnan
[1.1.7.3.1.3.1.1.4.4]
10
Georgia Grinnan
[1.1.7.3.1.3.1.1.4.5]
9
Marian Gordon Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.5]
9
Jane Bell Dabney
[1.1.7.3.1.3.1.1.6]
+
E. Ruffln Jones
7
Catharine Henrietta Minor
[1.1.7.3.1.3.2]
b. 22 Sep 1808 d. 15 Nov 1877
+
Elkhanna Winchester Reinhart
b. 1 Sep 1779 d. 17 May 1841
7
Matilda Wirt Minor
[1.1.7.3.1.3.3]
b. 1 Nov 1815
+
Hudson Martin
7
Sarah Eliza Minor
[1.1.7.3.1.3.4]
b. 21 Sep 1810 d. 4 Oct 1854
7
Mary Minor
[1.1.7.3.1.3.5]
b. 26 Feb 1806 d. 1846
+
Albert Gallatin Quarles
+
M. J. Terrill
6
John Minor
[1.1.7.3.1.4]
b. 2 Apr 1791 d. 4 Apr 1849
+
Jane Bell
b. 26 Sep 1796 d. 28 Jan 1835
6
Mary Minor
[1.1.7.3.1.5]
b. 1 Sep 1780 d. 20 Aug 1805
+
Richard Henry Allen
b. 1774 d. 7 Sep 1805
6
Elizabeth Minor
[1.1.7.3.1.6]
b. 11 Oct 1778 d. 22 Mar 1807
Alexander Garret
7
Mary Anne Garrett
[1.1.7.3.1.6.1]
d. Bef 1825
+
Valentine Wood Southall
b. 1789/1790 d. 22 Aug 1861
6
Barbara Overton Minor
[1.1.7.3.1.7]
b. 25 Nov 1786 d. 27 Jun 1790
6
Jr. James Minor
[1.1.7.3.1.8]
b. 22 Nov 1788 d. 29 Aug 1841
+
Christianna Tompkins
b. 24 Oct 1785 d. 3 Aug 1833
5
Thomas Carr Minor
[1.1.7.3.2]
b. 5 Aug 1740 d. 16 Feb 1816
Mary Dabney
b. 14 Sep 1742 d. 31 Oct 1818
6
Elizabeth Minor
[1.1.7.3.2.1]
b. 26 Sep 1768 d. 7 Jan 1832
Dabney Waller
b. 20 Feb 1772 d. 6 Jun 1849
7
Thomas Carr Waller
[1.1.7.3.2.1.1]
b. 29 Jul 1799
5
Vivian Minor
[1.1.7.3.3]
b. 4 Nov 1750 d. 15 Oct 1798
+
Barbara Overton Cosby
b. 11 Feb 1752 d. 21 Sep 1778
5
William Minor
[1.1.7.3.4]
b. 30 Aug 1738 d. 18 Sep 1750
5
John Carr Minor
[1.1.7.3.5]
b. 18 Nov 1735 d. 21 Mar 1800
Elizabeth Cosby
b. 1736 d. 1800
6
Lancelot Minor
[1.1.7.3.5.1]
b. Abt 1771 d. 1803/1862
Mary Overton Tompkins
b. 1771 d. 1803/1865
7
John B. Minor
[1.1.7.3.5.1.1]
b. Abt 1796 d. 1797/1886
7
Lucien Minor
[1.1.7.3.5.1.2]
b. Abt 1798 d. 1799/1888
7
Charles Minor
[1.1.7.3.5.1.3]
b. Abt 1800 d. 1801/1890
5
Diane Minor
[1.1.7.3.6]
b. 28 Feb 1746/47 d. 28 Mar 1748
5
Dabney Carr Minor
[1.1.7.3.7]
b. 11 Jun 1749 d. 7 Nov 1799
Ann Anderson
b. 30 Jun 1751 d. 27 Mar 1831
6
Jr. Dabney Carr Minor
[1.1.7.3.7.1]
b. 22 Jul 1769 d. 8 Mar 1822
Lucy Herndon
b. 23 Aug 1779 d. 12 Aug 1832
7
Henry Lawrence Minor
[1.1.7.3.7.1.1]
b. 16 Mar 1807 d. 5 Sep 1832
Margaret Whiteley Herndon
b. 23 Mar 1811 d. 1884
8
James Lewis Minor
[1.1.7.3.7.1.1.1]
b. 9 Aug 1831 d. 17 Sep 1832
7
Mary Ann Minor
[1.1.7.3.7.1.2]
b. 25 Mar 1801 d. 21 May 1833
+
Garrett Minor Meriwether
b. 25 Apr 1794 d. 26 Sep 1851
5
Elizabeth Minor
[1.1.7.3.8]
b. 3 Aug 1752 d. 1786
5
Peter Minor
[1.1.7.3.9]
b. 16 Aug 1754 d. 1773
5
Mary Ann Minor
[1.1.7.3.10]
b. 7 Mar 1741 d. 26 Oct 1822
John Joseph Herndon
b. 1 May 1737 d. 28 Oct 1810
6
Dabney Herndon
[1.1.7.3.10.1]
b. 14 Apr 1783 d. 20 Dec 1824
Elizabeth Hull
b. 12 Jan 1789 d. 20 Apr 1825
7
Ann Hull Herndon
[1.1.7.3.10.1.1]
b. 8 Aug 1811 d. 12 Feb 1875
Matthew Fontaine Maury
b. 14 Jan 1806 d. 1 Feb 1873
8
Elizabeth Herndon Maury
[1.1.7.3.10.1.1.1]
b. 25 Jun 1835 d. 1903
8
Diana Fontaine "Nannie" Maury
[1.1.7.3.10.1.1.2]
b. 25 Jun 1837 d. 6 Feb 1900
8
Richard Launcelot Maury
[1.1.7.3.10.1.1.3]
b. 9 Oct 1840 d. 14 Oct 1907
8
John Herndon "Davy" Maury
[1.1.7.3.10.1.1.4]
b. 21 Oct 1842 d. 27 Jan 1863
8
Mary Herndon Maury
[1.1.7.3.10.1.1.5]
b. 13 Nov 1844 d. 17 Nov 1928
8
Eliza Hull "Ellie" Maury
[1.1.7.3.10.1.1.6]
b. 5 Dec 1846 d. 6 Apr 1881
8
Matthew Fontaine Maury, Jr
[1.1.7.3.10.1.1.7]
b. 9 Jan 1849 d. 31 Dec 1886
8
Lucy Minor Maury
[1.1.7.3.10.1.1.8]
b. 8 May 1851 d. 7 Nov 1915
7
Lewis Herndon
[1.1.7.3.10.1.2]
b. Abt 1813
7
Brodie Strachan Herndon
[1.1.7.3.10.1.3]
b. 7 Jul 1810 d. 7 Aug 1886
Lucy Ellen Hansborough
b. 6 Jun 1813 d. 5 Apr 1878
8
Lucy Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.1]
b. 9 Jul 1839 d. 23 Mar 1887
+
Robert Blackie
b. Mar 1820 d. Apr 1890
8
Dabney Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.2]
b. 22 Sep 1831
Mary Zulette Waterhouse
b. 29 Jan 1849
9
John Waterhouse Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.2.1]
b. 12 Jul 1870
8
Sarah Parker Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.3]
b. 25 Nov 1835 d. 6 May 1881
+
George Anderson Nicoll
b. 26 Oct 1830 d. 26 May 1879
8
Jr. Brodie Strachan Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.4]
b. 1 May 1834 d. 28 May 1890
Mary Wallace Gordon
9
Sarah Parker Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.4.1]
b. 13 Apr 1871
9
Brodie Strachan Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.4.2]
b. 3 Aug 1873
Nellie Knight White
b. 25 Sep 1875
10
Brodie Strachan Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.4.2.1]
b. 24 Jan 1901
9
William Gordon Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.4.3]
b. 20 Dec 1876
8
James C. Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.5]
b. 22 Sep 1831 d. 16 Oct 1877
+
Mary Lightfoot
b. Abt 1835 d. 22 Jan 1872
8
Elizabeth Hull Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.6]
b. 12 Sep 1837
+
Maj. Henry Triplett Botts
b. Feb 1838
8
Ann Maury Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.7]
b. 4 Dec 1841 d. 16 Jun 1885
George Anderson Mercer
b. 9 Feb 1835 d. 23 Oct 1907
9
Robert Lee Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.1]
b. 1871
+
Katherine MacKay Stiles
b. 1870
9
Edward Clifford Anderson Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.2]
b. 1873
+
Josephine Freeland
b. 1875
9
Hugh Weedon Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.3]
b. 1863 d. 1871
9
Brodie Herndon Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.4]
b. 1876 d. 1878
9
Nannie Herndon Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.5]
b. 1866
Joseph Muirlang
b. 1861
10
George Mercer Lang Muirlang
[1.1.7.3.10.1.3.7.5.1]
b. 1894
9
Jr. George Anderson Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.6]
b. 2 Mar 1868 d. 14 Nov 1940
Lillian Elizabeth Ciucevich
10
John Herndon Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.6.1]
+
Elizabeth Meltzer
10
Juliana Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.6.2]
10
Nancy Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.6.3]
Mary Ellis Walter
b. 8 Oct 1871 d. 19 Dec 1900
10
George Walter Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.6.4]
b. 20 Apr 1897 d. 18 Jan 1970
10
III George Anderson Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.6.5]
b. 7 Feb 1893 d. 9 Sep 1968
9
Lewis Herndon Mercer
[1.1.7.3.10.1.3.7.7]
b. 1870
8
Margaret Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.8]
b. 25 Dec 1844 d. 2 Jan 1845
8
Mary Elizabeth Herndon
[1.1.7.3.10.1.3.9]
b. 22 Nov 1843 d. 1 Feb 1878
+
Jr. Joseph Clay
b. 10 Dec 1838
7
John Minor Herndon
[1.1.7.3.10.1.4]
b. 14 May 1808 d. 19 Sep 1871
Margaretta Louisa Patton
b. Abt 1808 d. 2 Jul 1852
8
Ellen Mercer Herndon
[1.1.7.3.10.1.4.1]
b. 29 Apr 1836 d. 29 Jan 1888
+
Seth Barton French
b. Abt 1834
8
Elizabeth Fairlie Herndon
[1.1.7.3.10.1.4.2]
b. 4 Nov 1840 d. 3 Jan 1892
8
Ann Gordon Herndon
[1.1.7.3.10.1.4.3]
b. 11 Sep 1838 d. 1 Aug 1862
7
William Lewis Herndon
[1.1.7.3.10.1.5]
b. 25 Oct 1813 d. 12 Sep 1857
Frances Elizabeth Hansbrough
b. 10 Oct 1817 d. 5 Apr 1878
8
Ellen Lewis Herndon
[1.1.7.3.10.1.5.1]
b. 30 Aug 1837 d. 12 Jan 1880
Chester Alan Arthur
b. 5 Oct 1829 d. 18 Nov 1886
9
William Lewis Herndon Arthur
[1.1.7.3.10.1.5.1.1]
b. 10 Dec 1860 d. 7 Jul 1863
9
Chester Alan Arthur, Jr
[1.1.7.3.10.1.5.1.2]
b. 25 Jul 1864 d. 18 Jul 1937
Myra Townsend Fithian
b. 1 Jan 1870 d. 11 Sep 1935
10
Chester A Arthur, III
[1.1.7.3.10.1.5.1.2.1]
b. 21 Mar 1901 d. 28 Apr 1972
+
Esther Knesborough Murphy
b. Abt 1898 d. Jan 1963
+
Charlotte Wilson
b. 1905
+
Rowena Graves Dashwood
b. 8 Nov 1894 d. 18 Jul 1937
9
Ellen Hansbrough Herndon Arthur
[1.1.7.3.10.1.5.1.3]
b. 21 Nov 1871 d. 6 Sep 1915
+
Charles Downing Pinkerton
9
Richard Allen Arthur
[1.1.7.3.10.1.5.1.4]
b. 1861 d. 1915
7
Mary Strachan Herndon
[1.1.7.3.10.1.6]
b. 20 Jan 1816 d. 5 Jul 1908
7
Dabney Herndon
[1.1.7.3.10.1.7]
b. 17 Jan 1820 d. 19 Oct 1870
7
Charles Herndon
[1.1.7.3.10.1.8]
b. 13 Oct 1822 d. 17 Dec 1883
6
Sarah Herndon
[1.1.7.3.10.2]
b. 2 Jul 1766 d. 20 Nov 1784
6
John Minor Herndon
[1.1.7.3.10.3]
b. 28 Feb 1768 d. 12 Jan 1829
6
Mary Herndon
[1.1.7.3.10.4]
b. 4 May 1770
6
Joseph Herndon
[1.1.7.3.10.5]
b. 9 Jun 1772
6
William Herndon
[1.1.7.3.10.6]
b. 29 Dec 1774 d. 1854
6
Peter Herndon
[1.1.7.3.10.7]
b. 6 Mar 1777 d. Oct 1793
6
Reuben Herndon
[1.1.7.3.10.8]
b. 2 Dec 1781 d. 18 Oct 1792
6
Lucy Herndon
[1.1.7.3.10.9]
b. 23 Aug 1779 d. 12 Aug 1832
Jr. Dabney Carr Minor
b. 22 Jul 1769 d. 8 Mar 1822
7
Henry Lawrence Minor
[1.1.7.3.10.9.1]
b. 16 Mar 1807 d. 5 Sep 1832
Margaret Whiteley Herndon
b. 23 Mar 1811 d. 1884
8
James Lewis Minor
[1.1.7.3.10.9.1.1]
b. 9 Aug 1831 d. 17 Sep 1832
7
Mary Ann Minor
[1.1.7.3.10.9.2]
b. 25 Mar 1801 d. 21 May 1833
+
Garrett Minor Meriwether
b. 25 Apr 1794 d. 26 Sep 1851
5
Garrett Minor
[1.1.7.3.11]
b. 4 Mar 1744 d. 8 May 1799
Mary Overton Terrell
b. 22 Mar 1749/50 d. 30 Oct 1830
6
James Minor
[1.1.7.3.11.1]
b. Abt 1770 d. 1828
Mary Watson
b. Abt 1770 d. 1832
7
Maria Louise Minor
[1.1.7.3.11.1.1]
b. 1819 d. 1854
Benjamin Henry Magruder
b. 1808 d. 1885
8
Evelyn May Magruder
[1.1.7.3.11.1.1.1]
b. 8 Nov 1841 d. 2 Jul 1902
+
Jr. Elliotte Hawes Dejarnette
b. 6 Jun 1839 d. 27 Apr 1913
8
Horatio Erskine Magruder
[1.1.7.3.11.1.1.2]
b. Abt 1838 d. 1839/1928
7
Julia Ann Minor
[1.1.7.3.11.1.2]
b. Abt 1821 d. 1837/1915
+
John Z. Holloday
b. Abt 1821 d. 1840/1912
6
Rebecca Minor
[1.1.7.3.11.2]
b. 2 Feb 1774
6
Elizabeth Lewis Minor
[1.1.7.3.11.3]
b. 27 Aug 1776
6
Sarah Minor
[1.1.7.3.11.4]
b. 14 Aug 1781
6
Peter Minor
[1.1.7.3.11.5]
b. 30 Jun 1783 d. 1827
Lucy Walker Gilmer
b. 13 Oct 1785 d. Oct 1848
7
Hugh Walker Minor
[1.1.7.3.11.5.1]
b. 31 Jul 1807 d. 12 Dec 1858
Mary Ann Carr
b. 1815 d. 4 Sep 1875
8
Martha Lee Minor
[1.1.7.3.11.5.1.1]
b. Abt 1836
Jr. Thomas Walker Gilmer
b. 25 Jul 1834
9
III Thomas Walker Gilmer
[1.1.7.3.11.5.1.1.1]
b. 7 Sep 1869
8
George R. Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2]
b. Mar 1839
Sallie
b. 1839
9
Mary W. Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2.1]
b. Cal 1870
Roberts Coles
b. 29 Jun 1862 d. 17 Jan 1935
10
Jr. Roberts Coles
[1.1.7.3.11.5.1.2.1.1]
Doris Rafferty
11
III Roberts Coles
[1.1.7.3.11.5.1.2.1.1.1]
10
George Minor Coles
[1.1.7.3.11.5.1.2.1.2]
+
Jane Stuart Stringfellow
9
Sallie Cook Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2.2]
b. Nov 1868
9
Peter L. Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2.3]
b. Dec 1881
9
Elysa Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2.4]
b. Aug 1874
9
Jr. George R. Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2.5]
b. Oct 1876
9
Frank C. Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2.6]
b. Apr 1880
9
Lawrence Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2.7]
b. Cal 1867
9
Anne L. Minor
[1.1.7.3.11.5.1.2.8]
b. Aug 1865
6
James Minor
[1.1.7.3.11.6]
b. 18 Apr 1785
6
Louisa Minor
[1.1.7.3.11.7]
b. 13 Aug 1787
6
Samuel Overton Minor
[1.1.7.3.11.8]
b. 13 Jun 1790 d. 30 Aug 1838
Lydia Laurie Lewis
b. 15 Mar 1795 d. 8 Aug 1833
7
William Woolfolk Minor
[1.1.7.3.11.8.1]
b. 10 Mar 1817 d. 3 May 1885
Samantha F. Fortune
b. 3 Nov 1826 d. 24 Nov 1882
8
James William Minor
[1.1.7.3.11.8.1.1]
b. 30 Jun 1861 d. 5 Feb 1959
Mary Elizabeth Dandridge
b. 10 Sep 1871 d. 16 Oct 1959
9
Fletcher Vinson Minor
[1.1.7.3.11.8.1.1.1]
b. 14 Jul 1911 d. 27 Sep 1967
10
Margaret Minor
[1.1.7.3.11.8.1.1.1.1]
+
Endicott
6
Anne Minor
[1.1.7.3.11.9]
b. 14 Dec 1771 d. 21 Sep 1820
Thomas Meriwether
b. 24 Apr 1763 d. 21 Sep 1802
7
Francis Thornton Meriwether
[1.1.7.3.11.9.1]
b. 17 Sep 1801 d. 23 May 1804
7
Mary Minor Meriwether
[1.1.7.3.11.9.2]
b. 2 Jun 1798 d. 2 Mar 1831
7
Peter Minor Meriwether
[1.1.7.3.11.9.3]
b. 7 Feb 1797 d. 25 Aug 1851
+
Mary Walker Meriwether
b. 29 Dec 1800 d. 24 Feb 1832
7
Richard Terrell Meriwether
[1.1.7.3.11.9.4]
b. 11 May 1792 d. 7 Dec 1840
+
Elizabeth Edmunds Rivers
b. 18 Dec 1796 d. 1 Apr 1863
7
Thomas Lewis Meriwether
[1.1.7.3.11.9.5]
b. 27 Sep 1799 d. 4 Jul 1838
7
Margaret Nancy Meriwether
[1.1.7.3.11.9.6]
b. 1803
7
Garrett Minor Meriwether
[1.1.7.3.11.9.7]
b. 25 Apr 1794 d. 26 Sep 1851
+
Mary Ann Minor
b. 25 Mar 1801 d. 21 May 1833
4
James Carr
[1.1.7.4]
b. Abt 1708 d. 18 Jun 1749
4
William Carr
[1.1.7.5]
b. 1707 d. 2 Aug 1760
Susannah Brooks
b. 1730 d. Bef 4 Sep 1792
5
Mary Carr
[1.1.7.5.1]
b. Abt 1733 d. 1749/1827
+
Nicholas Crenshaw
b. Abt 1733 d. 1752/1824
5
Susannah Brooks Carr
[1.1.7.5.2]
b. Abt 1737 d. 1753/1831
+
William Crenshaw
b. Abt 1737 d. 1756/1828
Elizabeth Winston
b. 1710 d. 1752
5
(Mary) Ann Winston Carr
[1.1.7.5.3]
b. 4 Apr 1735 d. 25 Jan 1839
George Waller, Jr
b. 8 Feb 1734 d. 18 Nov 1814
6
Mary Winston Waller
[1.1.7.5.3.1]
b. 26 Oct 1763 d. 17 Jul 1828
John Franklin Redd
b. 25 Oct 1755 d. 11 Aug 1850
7
Edmund Burwell Redd
[1.1.7.5.3.1.1]
b. 4 Jun 1808 d. 10 Aug 1850
Sarah Ann Fontaine
b. 5 Nov 1815 d. 9 Feb 1909
8
James Smith Redd
[1.1.7.5.3.1.1.1]
b. Abt 1841
Sarah Hairston
9
Annie Spotswood Redd
[1.1.7.5.3.1.1.1.1]
+
John G. Hulsbush
9
Pocahontas Cabel Redd
[1.1.7.5.3.1.1.1.2]
+
Norman Thomas Mallonee
8
Celeste Tunstall Redd
[1.1.7.5.3.1.1.2]
b. Abt 1843
Samuel Pickney Caldwell
9
Alice Brandon Caldwell
[1.1.7.5.3.1.1.2.1]
8
Annie Elizabeth Redd
[1.1.7.5.3.1.1.3]
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
Patrick Henry Fontaine
b. 1841 d. 1915
9
Matthew Maury Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.1]
9
James Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.2]
b. 1888
9
John Winston Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.3]
b. 1887
9
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
10
Marian Fontaine Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.1]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
11
Jr. James Roy Oliver
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.1.1]
11
Mary Lee Oliver
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.1.2]
11
Marian Aylett Oliver
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.1.3]
10
Alexander Spotswood Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.2]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
10
Samuel Lewis Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.3]
b. 3 Dec 1897
10
Mary Atkinson Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.4]
Newton Vaughan Colston
11
Newton Vaughan Colston
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.4.1]
11
Edward Fontaine Colston
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.4.2]
10
John Winston Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.5]
Elizabeth Stebbins
11
Matthew Henry Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.5.1]
10
Nancie F. Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.6]
10
William Fontaine Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.7]
10
Philip Aylett Creath
[1.1.7.5.3.1.1.3.4.8]
9
William Spotswood Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.5]
b. Abt 1870 d. INFANT
9
Philip Aylett Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.6]
b. 1868
+
Jessie Kerner
9
Edmond Redd Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.7]
b. 1879
9
Ella Redd Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.8]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.7.5.3.1.1.3.9]
b. 1877
8
William Spotswood Redd
[1.1.7.5.3.1.1.4]
b. 1 Mar 1839 d. 1 Nov 1909
Mary Taylor Wootton
b. 27 Aug 1844 d. 26 Apr 1918
9
Ella Spotswood Redd
[1.1.7.5.3.1.1.4.1]
b. 5 Oct 1872 d. 25 Mar 1932
Richard Wordsworth Fischer
10
Grace Brown Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.1]
Frank Beauregard Jenkins
b. Abt 1906 d. Abt 1950
11
Grace Jenkins
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.1.1]
10
Spotswood Redd Gill Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.2]
b. 5 Apr 1896 d. Abt Jun 1923
10
Jr. Richard Wordsworth Fischer, Jr
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.3]
b. 7 Sep 1897 d. 24 Mar 1937
10
Caroline Dorothea Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.4]
IV Jesse Marden
b. 18 Jan 1906 d. 4 Jul 1962
11
Ann Marden
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.4.1]
10
John Gill Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.5]
b. 3 Feb 1901 d. 2 Jan 1950
+
Grace Elizabeth Shelfer
b. 2 Feb 1908 d. 8 Apr 1961
10
Mary Elizabeth Redd Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.6]
+
James Everett Sanner
b. 15 Jul 1896 d. Oct 1968
10
Ann Franklin Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.7]
b. 8 Sep 1905 d. Abt 1909
10
Martha Redd Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.8]
+
Frank Lewis
10
Lucinda Reamey Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.9]
b. 1 Jan 1907 d. 4 Nov 1960
+
Carl Hubbard
+
Ralph Ray Jack Williams
10
Louis Christian Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.10]
10
Matthew Redd Fischer
[1.1.7.5.3.1.1.4.1.11]
b. Abt 1911 d. Bef 1920
9
Lucinda Dabney Redd
[1.1.7.5.3.1.1.4.2]
b. 1 Sep 1866 d. 9 Nov 1912
9
II Edmund Burwell Redd
[1.1.7.5.3.1.1.4.3]
b. 23 Feb 1868 d. CHILD
9
Martha Redd
[1.1.7.5.3.1.1.4.4]
b. 19 Sep 1870 d. 9 Nov 1933
+
Overton Reamey
d. Abt 1898
+
Jack B. Walker
b. 1 Jun 1859
9
Sarah Redd
[1.1.7.5.3.1.1.4.5]
b. 5 Oct 1872 d. 20 Jul 1873
8
John Hairston Redd
[1.1.7.5.3.1.1.5]
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
+
Marian Dandridge Fontaine
b. 19 May 1840 d. 1913
8
Mary Dandridge Redd
[1.1.7.5.3.1.1.6]
b. 8 Jan 1837 d. 10 Sep 1888
John Wayt
b. Abt 1831
9
Martha "Mattie" Frances Wayt
[1.1.7.5.3.1.1.6.1]
b. Jun 1874 d. Feb 1926
William Augustus Osborne
b. 15 Dec 1869 d. Jul 1942
10
Frances West Osborne
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.1]
Hiram Oscar Kerns, Jr
b. 24 May 1893 d. 5 Oct 1964
11
Elizabeth Osborne Kerns
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.1.1]
+
Robert Schlegel Norfleet
b. 20 Dec 1908 d. 3 Feb 1968
11
Hiram Oscar Kerns, III
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.1.2]
Margeret Peery
12
III Hiram Oscar Kerns, IV
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.1.2.1]
[
=>
]
11
Edward Johnson Kerns
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.1.3]
Joy Agusta Burgess
12
Edward Johnson Kerns, Jr
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.1.3.1]
10
William Osborne
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.2]
b. Abt 1908
10
Marion Osborne
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.3]
b. Abt 1908
10
Dorothy Osborne
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.4]
b. Abt 1910
10
Elizabeth Osborne
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.5]
b. Abt 1904
10
Mary Osborne
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.6]
b. Abt 1898
10
Kate Osborne
[1.1.7.5.3.1.1.6.1.7]
b. Abt 1901
8
Edmund Madison Redd
[1.1.7.5.3.1.1.7]
b. 18 Dec 1844 d. 2 Oct 1928
+
Anna Richardson
b. Abt 1859 d. Abt 1929
8
Martha Catherine Redd
[1.1.7.5.3.1.1.8]
b. 3 Apr 1833 d. 15 Sep 1913
+
John Francis Wootton
b. Abt 1827 d. Abt 1888
8
Ella E. Redd
[1.1.7.5.3.1.1.9]
b. Abt 1849 d. Abt 1919
+
Francis Watlington
b. Abt 1847 d. Abt 1917
7
Mary Carr Redd
[1.1.7.5.3.1.2]
b. 5 Dec 1794 d. 26 Sep 1837
John James Fontaine
b. 1788 d. 3 Jan 1852
8
Mary Fontaine
[1.1.7.5.3.1.2.1]
b. Abt 1815
James Edward Waller
9
John Fontaine Waller
[1.1.7.5.3.1.2.1.1]
b. 1842 d. 1909
Martha Malone
10
Mary Alice Waller
[1.1.7.5.3.1.2.1.1.1]
b. 1872 d. 1954
+
David Alexander Shepard
b. 1879 d. 1959
8
Madison Redd Fontaine
[1.1.7.5.3.1.2.2]
b. 1824 d. 1891
Elizabeth Gillespie
b. 1836
9
Martha Redd Fontaine
[1.1.7.5.3.1.2.2.1]
b. Sep 1873
+
Robert Willis Flournoy
b. 22 Sep 1867
9
Elizabeth Fontaine
[1.1.7.5.3.1.2.2.2]
+
Walter C. Harris
7
Martha Waller Redd
[1.1.7.5.3.1.3]
b. 1 Jun 1797 d. 19 Oct 1881
+
William S. Thomas Clark
b. Abt 1795
+
James Moss Smith
b. 8 Feb 1798
7
John Chiles Redd
[1.1.7.5.3.1.4]
b. 2 Dec 1799 d. 31 Dec 1850
+
Apphia Fauntleroy Carter
b. 8 Apr 1807 d. 12 Mar 1851
7
James Madison Redd
[1.1.7.5.3.1.5]
b. 8 Apr 1802 d. 25 Jul 1837
+
Ruth Penn Staples
b. 29 Mar 1801 d. 17 Dec 1872
7
Lucinda Dabney Redd
[1.1.7.5.3.1.6]
b. Abt 1805 d. Abt 1880
+
William Builard
b. Abt 1808
John Taylor Wootton
b. Abt 1800 d. Jun 1845
8
Overton Redd Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1]
b. 1837
Katherine Fontaine
9
Eva Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.1]
9
Nora Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.2]
9
Lucy Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.3]
9
Sallie Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.4]
9
Maude Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.5]
9
Nathaniel Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.6]
9
William Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.7]
9
John Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.8]
9
Hale Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.1.9]
8
Mary Taylor Wootton
[1.1.7.5.3.1.6.2]
b. 27 Aug 1844 d. 26 Apr 1918
William Spotswood Redd
b. 1 Mar 1839 d. 1 Nov 1909
9
Ella Spotswood Redd
[1.1.7.5.3.1.6.2.1]
b. 5 Oct 1872 d. 25 Mar 1932
Richard Wordsworth Fischer
10
Grace Brown Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.1]
Frank Beauregard Jenkins
b. Abt 1906 d. Abt 1950
11
Grace Jenkins
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.1.1]
10
Spotswood Redd Gill Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.2]
b. 5 Apr 1896 d. Abt Jun 1923
10
Jr. Richard Wordsworth Fischer, Jr
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.3]
b. 7 Sep 1897 d. 24 Mar 1937
10
Caroline Dorothea Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.4]
IV Jesse Marden
b. 18 Jan 1906 d. 4 Jul 1962
11
Ann Marden
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.4.1]
10
John Gill Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.5]
b. 3 Feb 1901 d. 2 Jan 1950
+
Grace Elizabeth Shelfer
b. 2 Feb 1908 d. 8 Apr 1961
10
Mary Elizabeth Redd Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.6]
+
James Everett Sanner
b. 15 Jul 1896 d. Oct 1968
10
Ann Franklin Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.7]
b. 8 Sep 1905 d. Abt 1909
10
Martha Redd Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.8]
+
Frank Lewis
10
Lucinda Reamey Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.9]
b. 1 Jan 1907 d. 4 Nov 1960
+
Carl Hubbard
+
Ralph Ray Jack Williams
10
Louis Christian Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.10]
10
Matthew Redd Fischer
[1.1.7.5.3.1.6.2.1.11]
b. Abt 1911 d. Bef 1920
9
Lucinda Dabney Redd
[1.1.7.5.3.1.6.2.2]
b. 1 Sep 1866 d. 9 Nov 1912
9
II Edmund Burwell Redd
[1.1.7.5.3.1.6.2.3]
b. 23 Feb 1868 d. CHILD
9
Martha Redd
[1.1.7.5.3.1.6.2.4]
b. 19 Sep 1870 d. 9 Nov 1933
+
Overton Reamey
d. Abt 1898
+
Jack B. Walker
b. 1 Jun 1859
9
Sarah Redd
[1.1.7.5.3.1.6.2.5]
b. 5 Oct 1872 d. 20 Jul 1873
7
Waller Redd
[1.1.7.5.3.1.7]
b. 8 Jun 1783 d. 22 Sep 1825
+
Keziah Carter Staples
b. Abt 1796 d. Abt 1818
7
Anne Redd
[1.1.7.5.3.1.8]
b. 1786 d. Abt 1856
Thomas Starling
b. 3 Sep 1779 d. 1 Oct 1852
8
Susanna Lyne Starling
[1.1.7.5.3.1.8.1]
7
John Overton Redd
[1.1.7.5.3.1.9]
b. 1788 d. 1858
+
Martha Henry Fontaine
b. 9 Mar 1798 d. 20 Dec 1881
7
Carr Redd
[1.1.7.5.3.1.10]
b. 1790
7
Elizabeth Winston Redd
[1.1.7.5.3.1.11]
b. 12 Jul 1792 d. 17 Sep 1837
Peter Hairston Dillard
b. Abt 1792 d. 1861
8
Mary Waller Dillard
[1.1.7.5.3.1.11.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1898
David Harrison Spencer
b. Abt 1826
9
Elizabeth Redd Spencer
[1.1.7.5.3.1.11.1.1]
+
Rufus Greenville Penn
6
Nancy Annie Waller
[1.1.7.5.3.2]
b. 13 May 1770 d. 20 Jun 1820
6
Carr Waller
[1.1.7.5.3.3]
b. 12 Mar 1769 d. 7 May 1843
6
Edmund Waller
[1.1.7.5.3.4]
b. 10 Dec 1779 d. 19 Nov 1817
6
George Waller, III
[1.1.7.5.3.5]
b. 29 Nov 1773 d. 1838
6
Elizabeth Annie Waller
[1.1.7.5.3.6]
b. 28 Feb 1762 d. 1832
6
William Waller
[1.1.7.5.3.7]
b. 8 May 1775 d. 10 Oct 1819
6
John Waller
[1.1.7.5.3.8]
b. 12 Oct 1765 d. 7 Mar 1842
5
Elizabeth Carr
[1.1.7.5.4]
b. 1740
5
Susannah Brooks Carr
[1.1.7.5.5]
b. 1735 d. 1800
5
Sarah Carr
[1.1.7.5.6]
b. 1734 d. Bef 1760
5
William Carr
[1.1.7.5.7]
b. 1730 d. 1793
4
Mary Carr
[1.1.7.6]
b. 1704 d. 1759
4
Samuel Carr
[1.1.7.7]
b. Abt 1718
4
Agnes Carr
[1.1.7.8]
b. 30 Jan 1712 d. 2 Oct 1778
John Weller
b. 14 Nov 1714 d. 1770
5
Thomas Waller
[1.1.7.8.1]
b. 29 Jul 1732 d. 10 Feb 1788
Sarah Ann Dabney
b. 2 Oct 1740 d. 10 Jan 1822
6
Mary Waller
[1.1.7.8.1.1]
b. 26 Feb 1761 d. 1850
6
Anna Waller
[1.1.7.8.1.2]
b. 11 Nov 1762 d. 5 Aug 1834
Joel Harris
b. 25 Apr 1761 d. 1826
7
Ira Harris
[1.1.7.8.1.2.1]
b. Abt 1785 d. 1863
Sarah Lewis
8
Charles Warner Harris
[1.1.7.8.1.2.1.1]
b. 15 Feb 1822 d. 23 Apr 1860
Angeline Mildred Brown
b. 9 Oct 1832
9
Mary Howell Harris
[1.1.7.8.1.2.1.1.1]
b. 15 Sep 1854 d. 12 Jan 1857
9
Charles Lee Harris
[1.1.7.8.1.2.1.1.2]
b. 24 Jul 1857
8
Waller Harris
[1.1.7.8.1.2.1.2]
+
Mary Frances Brown
8
Mary Ann Harris
[1.1.7.8.1.2.1.3]
Burlington Dabney Brown
b. 17 May 1820 d. 26 Apr 1886
9
Hugh Hescott Brown
[1.1.7.8.1.2.1.3.1]
b. 7 Apr 1846
+
Mary Ann Metier
9
Ira Lewis Brown
[1.1.7.8.1.2.1.3.2]
b. 2 Mar 1848
9
Linn Roy Brown
[1.1.7.8.1.2.1.3.3]
b. 5 Nov 1849 d. 22 Mar 1850
9
Frank Brown
[1.1.7.8.1.2.1.3.4]
+
Bettie French
9
Harry Brown
[1.1.7.8.1.2.1.3.5]
+
Virginia Ann Bishop
9
Ralph Brown
[1.1.7.8.1.2.1.3.6]
9
Hattie Brown
[1.1.7.8.1.2.1.3.7]
+
Samuel Hatcher
9
Nettie Brown
[1.1.7.8.1.2.1.3.8]
+
E .A. Lofton
8
Benjamin Harris
[1.1.7.8.1.2.1.4]
8
Lewis Harris
[1.1.7.8.1.2.1.5]
6
Agnes Waller
[1.1.7.8.1.3]
b. 17 Nov 1764 d. 7 Nov 1817
+
Sharp Smith
b. 1747/1767 d. 1792/1853
6
Sarah Waller
[1.1.7.8.1.4]
b. 24 Jan 1767 d. 22 Mar 1829
+
Joseph Spicer
b. 1750/1770 d. 1795/1856
6
Carr Waller
[1.1.7.8.1.5]
b. 12 Mar 1769 d. 7 May 1843
+
Elizabeth Martin
b. 1765/1785 d. 1800/1869
+
Susannah Edwards
b. 1765/1785 d. 1800/1869
6
Dabney Waller
[1.1.7.8.1.6]
b. 20 Feb 1772 d. 6 Jun 1849
Elizabeth Minor
b. 26 Sep 1768 d. 7 Jan 1832
7
Thomas Carr Waller
[1.1.7.8.1.6.1]
b. 29 Jul 1799
6
Pomfrett Waller
[1.1.7.8.1.7]
b. 8 May 1774 d. 29 Apr 1814
+
Sallie Woolfolk
b. 1770/1789 d. 1805/1873
6
Dorothy Waller
[1.1.7.8.1.8]
b. 31 Mar 1777 d. 2 Dec 1838
+
E. T. Rowzie
b. 1760/1780 d. 1805/1866
6
John Waller
[1.1.7.8.1.9]
b. 10 Feb 1780 d. 10 Sep 1824
6
Elizabeth Waller
[1.1.7.8.1.10]
b. 2 Mar 1783 d. 7 Jun 1872
5
Pomfrett Waller
[1.1.7.8.2]
b. 20 Jan 1747/48 d. 20 Jun 1799
+
Martha Martin
5
Mary Nancy Weller
[1.1.7.8.3]
b. 1730 d. 1816
Jr. James Overton
b. 1726 d. 1816
6
Samuel Overton
[1.1.7.8.3.1]
b. Abt 1752 d. 1753/1842
6
Weller Overton
[1.1.7.8.3.2]
b. Abt 1754 d. 1755/1844
6
John Overton
[1.1.7.8.3.3]
b. Abt 1756 d. 1757/1846
6
Thomas Overton
[1.1.7.8.3.4]
b. Abt 1758 d. 1759/1848
6
Sallie Overton
[1.1.7.8.3.5]
b. Abt 1750 d. 1751/1844
5
Agnes Waller
[1.1.7.8.4]
+
Johnson
5
Ann Waller
[1.1.7.8.5]
+
James Bullock
5
Sarah Waller
[1.1.7.8.6]
+
Clifton Rhodes
b. 1740 d. 1819
5
Dorothy Waller
[1.1.7.8.7]
+
Thomas Goodloe
5
Elizabeth Carr Waller
[1.1.7.8.8]
+
Edmund Eggleston
4
Thomas Carr, III
[1.1.7.9]
b. 25 Nov 1705 d. Aft 5 Jul 1743
Mary Jane Carr
b. Abt 1709 d. 1766/1805
5
Gideon Carr
[1.1.7.9.1]
b. 1752 d. 1753/1842
5
John Carr
[1.1.7.9.2]
b. 1763 d. 1764/1853
5
William Carr
[1.1.7.9.3]
b. 1765 d. 1766/1855
4
Carr
[1.1.7.10]
b. 1690
3
Sarah "Sally" Dabney
[1.1.8]
b. 11 Feb 1682 d. Jun 1714
William Winston
b. 1678 d. Bef Jul 1727
4
Isaac Winston
[1.1.8.1]
b. Bef 12 Apr 1702 d. 1760
4
"Essex" William Winston
[1.1.8.2]
b. 1703 d. Mar 1781
Rebecca Geddes Bobby
b. 1701 d. Feb 1779
5
Geddes Winston
[1.1.8.2.1]
b. Abt 1731 d. 9 Jun 1794
Mary Jordan
b. 1742 d. 9 Dec 1811
6
Sarah "Sally" Winston
[1.1.8.2.1.1]
b. 2 Aug 1769 d. 2 Mar 1839
Thomas Rutherfoord
b. 9 Jan 1766 d. 3 Feb 1852
7
Alexander Hawksley Rutherfoord
[1.1.8.2.1.1.1]
b. 30 Aug 1807 d. 6 Jul 1886
+
Keziah Kitchell Clark
7
Jane Rutherfoord
[1.1.8.2.1.1.2]
d. 2 Oct 1839
+
Hodijah Meade
d. 1 Jan 1791
6
Mary Winston
[1.1.8.2.1.2]
b. 4 Jun 1763 d. 16 Oct 1831
+
John Dubarrow
b. 1759
6
Martha Bikerton Winston
[1.1.8.2.1.3]
b. 17 Feb 1774 d. 19 May 1803
6
Margaret Winston
[1.1.8.2.1.4]
b. 1778 d. 20 Feb 1850
6
William Winston
[1.1.8.2.1.5]
b. 1767 d. 1814
6
Rebecca Winston
[1.1.8.2.1.6]
b. 1762 d. 14 Dec 1780
6
Samuel Jordon Winston
[1.1.8.2.1.7]
b. 1765 d. 22 Feb 1839
6
Rebecca Bobby Winston
[1.1.8.2.1.8]
b. 1761 d. 6 Aug 1820
6
Julia Winston
[1.1.8.2.1.9]
5
Lucy A Winston
[1.1.8.2.2]
b. 1730 d. 28 Nov 1802
5
Sarah Winston
[1.1.8.2.3]
b. 27 Sep 1733 d. 5 Apr 1761
5
Mary Anne Winston
[1.1.8.2.4]
b. 1724 d. 23 Jun 1817
5
Susanna Winston
[1.1.8.2.5]
b. 1728 d. 1823
5
Thomas Winston
[1.1.8.2.6]
b. 1730 d. 1778
5
William Winston
[1.1.8.2.7]
b. 1745 d. 1804
Mary Ann Curd
b. Abt 1750 d. 1802
6
John Geddes Winston
[1.1.8.2.7.1]
b. 1777 d. 6 Jul 1844
+
Lucy B Kenner
b. 1780 d. 1835
6
Lucy Ann Winston
[1.1.8.2.7.2]
b. 1730 d. 1818
6
Edward Winston
[1.1.8.2.7.3]
b. 4 Sep 1770 d. 1817
6
Rebecca Winston
[1.1.8.2.7.4]
5
William Bobby Winston
[1.1.8.2.8]
b. 1758 d. 6 Feb 1822
5
John Winston
[1.1.8.2.9]
b. 25 Sep 1724 d. 1771
5
Mary Elizabeth Winston
[1.1.8.2.10]
b. 1728 d. Jul 1806
John Overton
b. 1730 d. 7 May 1819
6
James Overton
[1.1.8.2.10.1]
b. 1750
6
Sarah B Overton
[1.1.8.2.10.2]
b. 1780 d. 1 Mar 1807
6
James Overton
[1.1.8.2.10.3]
b. 1772
6
Osborn Overton
[1.1.8.2.10.4]
b. 1770
6
Elizabeth Overton
[1.1.8.2.10.5]
b. 1770
6
Rachel Overton
[1.1.8.2.10.6]
b. 1770
6
Polly Mary Overton
[1.1.8.2.10.7]
b. 1770 d. 1854
6
David Overton
[1.1.8.2.10.8]
b. 1768 d. 1836
6
George Overton
[1.1.8.2.10.9]
b. 1767 d. 1848
6
Moses Overton
[1.1.8.2.10.10]
b. 1761
6
Jesse Overton
[1.1.8.2.10.11]
b. 1761 d. 1826
6
John Overton
[1.1.8.2.10.12]
b. 1760 d. 15 Oct 1831
6
Susan Overton
[1.1.8.2.10.13]
b. 1760
6
William Overton
[1.1.8.2.10.14]
b. 1760 d. 1849
6
Matthew Overton
[1.1.8.2.10.15]
b. 1750
6
Moses Overton
[1.1.8.2.10.16]
b. 1750
6
Mary Overton
[1.1.8.2.10.17]
b. 1750 d. 1790
6
Elizabeth Overton
[1.1.8.2.10.18]
b. 1750
6
David Overton
[1.1.8.2.10.19]
b. 1750
6
George Overton
[1.1.8.2.10.20]
b. 1760 d. 1805
6
Richard Overton
[1.1.8.2.10.21]
d. 1816
6
Dabney Carr Overton
[1.1.8.2.10.22]
6
Thomas Overton
[1.1.8.2.10.23]