News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Lucy Stewart
1629 - 1690 (61 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Lucy Stewart
[1]
b. 1629 d. 21 Sep 1690
William Harris
b. 12 Mar 1630 d. 20 Apr 1678
2
Thomas Harris
[1.1]
b. 1669 d. Bef 6 Jul 1730
Mary Jefferson
b. 1679 d. 1 Sep 1745
3
John Harris
[1.1.1]
b. 28 Mar 1703 d. Aft 28 Mar 1749
Ursula Goode
b. 1707 d. Abt 1734
4
Elizabeth Harris
[1.1.1.1]
b. 31 Dec 1729 d. 19 May 1791
Samuel Flournoy
b. 4 Oct 1724 d. 12 Dec 1780
5
Silas F. Flournoy
[1.1.1.1.1]
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
Martha Cannon
b. 1775 d. Oct 1817
6
Alfred Flournoy
[1.1.1.1.1.1]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
7
William Flournoy
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
8
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
8
William Flournoy
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
8
Alfred Flournoy
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
8
Lucien Flournoy
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 22 Feb 1861
7
Alonzo Flournoy
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
8
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
9
Genevieve McRady
[1.1.1.1.1.1.2.1.1]
8
James Patteson Flournoy
[1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
8
Belle Flournoy
[1.1.1.1.1.1.2.3]
8
Theodosia Flournoy
[1.1.1.1.1.1.2.4]
7
James Silas Flournoy
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
7
Eliza Flournoy
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 29 May 1829 d. INFANT
7
Alfred F. Flournoy
[1.1.1.1.1.1.5]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
8
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
8
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 21 Feb 1875
8
Mary Patteson Flournoy
[1.1.1.1.1.1.5.3]
b. 24 Apr 1866
8
Spencer Alston Flournoy
[1.1.1.1.1.1.5.4]
b. Aug 1879
7
Martha Moore Flournoy
[1.1.1.1.1.1.6]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
7
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.1.1.1.1.7]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
8
Alfred F. Wilson
[1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
8
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.1.1.1.1.7.2]
8
Alice Wilson
[1.1.1.1.1.1.7.3]
+
Charles Davis
8
Ruth Wilson
[1.1.1.1.1.1.7.4]
+
B. H. Davis
8
Pattie Wilson
[1.1.1.1.1.1.7.5]
Milton Walker Sims
9
Laura Sims
[1.1.1.1.1.1.7.5.1]
b. 1873
+
J. Fred Smith
b. Abt 1870
9
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.1.1.1.1.7.5.2]
b. 1872
+
Charles Mills
9
Milton Sims
[1.1.1.1.1.1.7.5.3]
b. 1876
9
Bartlett Sims
[1.1.1.1.1.1.7.5.4]
b. May 1878
+
Almaide Priscilla Kerr
8
Laura Wilson
[1.1.1.1.1.1.7.6]
Thomas Bell
9
Mary Bell
[1.1.1.1.1.1.7.6.1]
+
Edward Gleason
8
Mary Wilson
[1.1.1.1.1.1.7.7]
+
Napoleon Davis
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
7
Charles Flournoy
[1.1.1.1.1.1.8]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
7
David Flournoy
[1.1.1.1.1.1.9]
b. 1842 d. 1856
7
Maria Flournoy
[1.1.1.1.1.1.10]
b. 1837 d. 1841
7
Mary Camp Flournoy
[1.1.1.1.1.1.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
7
Martha Flournoy
[1.1.1.1.1.1.12]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
7
Indiana Flournoy
[1.1.1.1.1.1.13]
b. 1847
6
Eliza Susan Flournoy
[1.1.1.1.1.2]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
7
Alfred H. Harris
[1.1.1.1.1.2.1]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
7
Eliza Susan Harris
[1.1.1.1.1.2.2]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
7
Martha Harris
[1.1.1.1.1.2.3]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
6
William Cannon Flournoy
[1.1.1.1.1.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
7
Flournoy
[1.1.1.1.1.3.1]
b. 1833 d. 1833
7
Flournoy
[1.1.1.1.1.3.2]
b. 1829 d. 1829
7
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.1.1.3.3]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
8
Myra Rivers
[1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
8
Julian Rivers
[1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 23 Dec 1868
8
William Cannon Rivers
[1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 11 Jan 1866
8
Tyree Rodes Rivers
[1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
8
John Harper Rivers
[1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
8
Flournoy Rivers
[1.1.1.1.1.3.3.6]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
9
John Avirett Rivers
[1.1.1.1.1.3.3.6.1]
b. 22 Mar 1894
7
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.1.1.1.3.4]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
8
Ezell Flournoy
[1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 9 Dec 1878
8
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.1.1.3.4.2]
b. 13 Sep 1875
8
John Walker Flournoy
[1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 24 Jan 1874
8
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.1.1.3.4.4]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
8
III William Cannon Flournoy
[1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 8 Apr 1872
7
John J. Flournoy
[1.1.1.1.1.3.5]
b. 1838
6
Mary Amanda Flournoy
[1.1.1.1.1.4]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
7
Mary Eliza Field
[1.1.1.1.1.4.1]
b. 1 Jul 1825
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
8
Myra Flournoy Knapp
[1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
8
Maud Officer
[1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 9 May 1847
8
Eustis Field Officer
[1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
8
William P. Officer
[1.1.1.1.1.4.1.4]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
7
James Alexander Field
[1.1.1.1.1.4.2]
b. 30 May 1823
7
Jr. William Hume Field
[1.1.1.1.1.4.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
7
Julian Clarence Field
[1.1.1.1.1.4.4]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
7
Silas Flournoy Field
[1.1.1.1.1.4.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
7
Margaret Julia Field
[1.1.1.1.1.4.6]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
7
Henrietta Field
[1.1.1.1.1.4.7]
b. 1833 d. 1833
7
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.1.1.1.4.8]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
7
Florence Huntley Field
[1.1.1.1.1.4.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
6
Julia Ann Flournoy
[1.1.1.1.1.5]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
7
Hume Rigg Feild
[1.1.1.1.1.5.1]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
7
Eliza Mildred Feild
[1.1.1.1.1.5.2]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
8
Julia Batte
[1.1.1.1.1.5.2.1]
+
W. R. Garrett
8
Mildred Batte
[1.1.1.1.1.5.2.2]
8
E. F. Batte
[1.1.1.1.1.5.2.3]
6
Madison Flournoy
[1.1.1.1.1.6]
b. 1807
6
Martha C. Flournoy
[1.1.1.1.1.7]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
7
Silas Flournoy Trotter
[1.1.1.1.1.7.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
6
Silas Flournoy
[1.1.1.1.1.8]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
7
Mary Flournoy
[1.1.1.1.1.8.1]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
8
Elizabeth Rivers
[1.1.1.1.1.8.1.1]
b. Bef 1865
8
James P. Rivers
[1.1.1.1.1.8.1.2]
b. Bef 1863
8
Mary Rivers
[1.1.1.1.1.8.1.3]
b. Bef 1867
8
Silas Flournoy Rivers
[1.1.1.1.1.8.1.4]
b. Bef 1871
8
William W. Rivers
[1.1.1.1.1.8.1.5]
b. Bef 1869
8
Martha Rivers
[1.1.1.1.1.8.1.6]
b. Bef 1873
7
Camp Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
8
Lucien Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
9
Lillian May Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.1.1]
b. 1906
9
Mary Wise Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.1.2]
b. 1911
9
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.1.3]
9
Laura Louise Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.1.4]
9
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.1.5]
8
John Wise Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
9
Louise Wise Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.2.1]
b. 1907
9
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.2.2]
b. 1912
Minnie Childress Cole
10
Thomas Cole Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.2.2.1]
9
Camp Rogers Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.2.3]
9
Betty McAfee Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.2.4]
8
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
9
Eloise Walker
[1.1.1.1.1.8.2.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
+
Raymond Grady Thomas
9
Newton Flournoy Walker
[1.1.1.1.1.8.2.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
+
Rose Mary Bozeman
+
Valta Irene Gholston
9
Lucien John Walker
[1.1.1.1.1.8.2.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972
Janie Lucile Stallcup
b. 1912
10
Lou Anne Walker
[1.1.1.1.1.8.2.3.3.1]
Duane Tarrant
11
Lucien Clyde Tarrant
[1.1.1.1.1.8.2.3.3.1.1]
+
Dana Hanks
11
Nola Tarrant
[1.1.1.1.1.8.2.3.3.1.2]
+
Wally Newcomb
11
William Rusk Tarrant
[1.1.1.1.1.8.2.3.3.1.3]
+
Andrea Stigdon
+
Frank Casey
9
Jane Louise Walker
[1.1.1.1.1.8.2.3.4]
+
Benjamin Elliot Mosher
9
Jacob Camp Walker
[1.1.1.1.1.8.2.3.5]
+
Ouida Louise Gill
8
Augusta Mary Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
9
Georgia Louia May
[1.1.1.1.1.8.2.4.1]
b. 1899
9
Julia Flournoy May
[1.1.1.1.1.8.2.4.2]
Robert Henry Mays
10
Judy Mays
[1.1.1.1.1.8.2.4.2.1]
10
Robert Mays
[1.1.1.1.1.8.2.4.2.2]
d. INFANT
9
Elizabeth Wise May
[1.1.1.1.1.8.2.4.3]
b. 1902
9
James Kathryn May
[1.1.1.1.1.8.2.4.4]
b. 1902
9
Norma Lucile May
[1.1.1.1.1.8.2.4.5]
b. 1902
8
Julia Rivers Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
9
Lucien Wise Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.1]
9
Andrew Booty Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2]
Mattie Lou Shaw
10
Jr. Andrew Booty Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.1]
Arlene
11
Arthur Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.1.1]
12
Seth Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.1.1.1]
12
Regan Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.1.1.2]
11
Andrew Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.1.2]
11
Jason Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.1.3]
11
Cynthia Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.1.4]
10
Lou Ann Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.2]
Rufus Taylor Higginbotham
11
Rufus Taylor Higginbotham
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.2.1]
11
Andrew Benjamin Higginbotham
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.2.2]
11
Laura Michelle Higginbotham
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.2.3]
10
John Franklin Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.3]
Judy
11
Julia Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.3.1]
11
Jennifer Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.3.2]
10
Gwen Elizabeth Jordan
[1.1.1.1.1.8.2.5.2.4]
8
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
9
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.6.1]
9
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.6.2]
9
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.1.1.1.8.2.6.3]
7
Lucien Flournoy
[1.1.1.1.1.8.3]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
8
Caroline Flournoy
[1.1.1.1.1.8.3.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
7
Elizabeth Flournoy
[1.1.1.1.1.8.4]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
8
Duncan
[1.1.1.1.1.8.4.1]
b. Bef 1870 d. 1876
8
Maude Eustace Duncan
[1.1.1.1.1.8.4.2]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
7
III Silas Flournoy
[1.1.1.1.1.8.5]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
8
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.1.1.8.5.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
8
Silas Camp Flournoy
[1.1.1.1.1.8.5.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
6
Sarah Flournoy
[1.1.1.1.1.9]
b. 1816
6
Louisa Ann Flournoy
[1.1.1.1.1.10]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
7
Laura Ann Yancey
[1.1.1.1.1.10.1]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
8
Leroy M. Black
[1.1.1.1.1.10.1.1]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
8
Louisa Catherine Black
[1.1.1.1.1.10.1.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
9
Mary Lou Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.1]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
10
Robert Lester Gilbert
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.1]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953
Ila Deane Griffin
11
Robert Parks Gilbert
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.1.1]
Betty Carol Huske
12
II Carey Parks Gilbert
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.1.1.1]
[
=>
]
12
Steven Huske Gilbert
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.1.1.2]
12
Virginia Carol Gilbert
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.1.1.3]
[
=>
]
+
Inez Timmerman
10
Sadie Louise Gilbert
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.2]
Harold Leigh Aymett
b. 11 Feb 1884 d. 6 Jul 1948
11
Marilouise Aymett
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.2.1]
John Bateman McClure
12
Jr. John Bateman McClure
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.2.1.1]
10
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.3]
10
Leon Gilbert
[1.1.1.1.1.10.1.2.1.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
9
Ernest M. Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.2]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
9
Leroy Black Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.3]
b. 1864 d. 1934
9
James Carley Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.4]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
10
William Lambeth Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.4.1]
Joan Shuler
b. 3 Nov 1920 d. 25 May 1969
11
Laura Ann Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.4.1.1]
+
Thomas Curry Pollock
10
James Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.4.2]
9
Laura Jane Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.5]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
10
Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.1.1.10.1.2.5.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown
Dorothy
11
Jr. Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.1.1.10.1.2.5.1.1]
11
Frances Dickey
[1.1.1.1.1.10.1.2.5.1.2]
10
Louise Dickey
[1.1.1.1.1.10.1.2.5.2]
b. Jan 1899
Sharp
11
Lester Sharp
[1.1.1.1.1.10.1.2.5.2.1]
11
Gilbert Sharp
[1.1.1.1.1.10.1.2.5.2.2]
9
Frank Leon Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.6]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
10
Richard Leon Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.6.1]
Josephine Elizabeth Martin
11
Jr. Richard Leon Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.6.1.1]
+
Jane Ferrier
11
Frank Martin Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.6.1.2]
+
Margery Wallace
9
Emily Olivia Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.7]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
10
Myra Tatum
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1]
William Weakly Johnson
b. Abt 1895 d. Abt 1940
11
Mary Emily Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.1]
Luther Manly Taylor
12
Emmye Taylor
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.1.1]
12
Myra Jane Taylor
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.1.2]
12
Michael Taylor
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.1.3]
12
John Taylor
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.1.4]
11
Jr. William Weakly Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.2]
Betty Coles
12
III William Weakly Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.2.1]
12
Steven Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.2.2]
12
Linda Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.2.3]
12
Dianne Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.2.4]
11
John Tatum Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.3]
Peggy
12
Jr. John Tatum Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.3.1]
12
Scott Johnson
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.1.3.2]
10
Thomas Leroy Tatum
[1.1.1.1.1.10.1.2.7.2]
9
John A. Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.8]
b. 1873 d. 1874/1963
9
Levair Lester
[1.1.1.1.1.10.1.2.9]
b. Abt 1869
8
Laura Ann Black
[1.1.1.1.1.10.1.3]
7
Flournoy Yancey
[1.1.1.1.1.10.2]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
8
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.1.1.10.2.1]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
9
Martha Lafavre Bishop
[1.1.1.1.1.10.2.1.1]
9
Richard Yancey Bishop
[1.1.1.1.1.10.2.1.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
8
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.1.1.10.2.2]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
9
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.1]
Willie Crook
b. Abt 1901
10
Fergene Dawes Richmond
[1.1.1.1.1.10.2.2.1.1]
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
9
Alice LaFavia Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.2]
+
Glen Carl Moody
9
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3]
Mary Ona Kitchens
10
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1]
Erma Pauline Lively
11
Michael Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.1]
Gabbi
12
Allyson Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.1.1]
11
Susan Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.2]
Jon Ricciardi
12
Sydney Ricciardi
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.2.1]
12
Natalie Ricciardi
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.2.2]
11
Matthew Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.3]
Julie
12
Evan Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.3.1]
12
Emily Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.3.2]
12
Kaylie Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.3.3]
11
Julie Marie Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.4]
Kent Edward Zirker
12
Ethan Zirker
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.4.1]
12
Jenna Zirker
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.1.4.2]
10
Frank Leslie Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.3.2]
+
Linda M Dickey
9
Thomas Asbury Dawes
[1.1.1.1.1.10.2.2.4]
b. 4 Apr 1895
8
Cora Yancey
[1.1.1.1.1.10.2.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
8
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.1.1.10.2.4]
b. Jul 1882
7
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.1.1.10.3]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
8
Lucy M. Yancey
[1.1.1.1.1.10.3.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
9
Rosa Mai Wilson
[1.1.1.1.1.10.3.1.1]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
9
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.1.1.1.10.3.1.2]
b. 1886
9
Thomas Webber Wilson
[1.1.1.1.1.10.3.1.3]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
9
George L Wilson
[1.1.1.1.1.10.3.1.4]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
9
Wilber Wilson
[1.1.1.1.1.10.3.1.5]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
10
Mabel Wilson
[1.1.1.1.1.10.3.1.5.1]
8
Webber Yancey
[1.1.1.1.1.10.3.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
8
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.1.1.10.3.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
7
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.1.1.10.4]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
8
Adella Frances Yancey
[1.1.1.1.1.10.4.1]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
9
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.1.1.1.10.4.1.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
10
Francis Joseph Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.1]
10
John Patrick Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.2]
Paulina D. Lacasella
11
Pamela Ann Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.2.1]
+
Gary Eugene Peters
+
Dickey Leete Sims
11
Gregory Patrick Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.2.2]
11
Ursula Louise Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.2.3]
+
Mark Douglas Thacker
11
Blake Michael Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.2.4]
+
Sarah M Meade
11
Jonathan Randall Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.2.5]
11
Leigh Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.2.6]
b. 3 Nov 1945 d. 15 Apr 1962
10
Jerome Anthony Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.3]
+
Reta Adeline Thibedeau
Doris Holyfield
11
Michael Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.3.1]
11
Patricia Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.3.2]
Ann Capello
11
Jerome Anthony Goodall, Jr.
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.3.3]
+
Catherine Elizabeth Horvay
11
Mary Ann Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.3.4]
b. 25 Jun 1943 d. 25 Jun 1943
11
Anita C Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.3.5]
11
Katherine Elizabeth Goodall
[1.1.1.1.1.10.4.1.1.3.6]
+
Frank G Curran
8
Mamie J. Yancey
[1.1.1.1.1.10.4.2]
b. 8 Dec 1875 d. 18 Sep 1968
Maclovio De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
9
Orman Joe De Arnaz
[1.1.1.1.1.10.4.2.1]
+
Alma Viola
9
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.1.1.1.10.4.2.2]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
8
Robert Lee Yancey
[1.1.1.1.1.10.4.3]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
8
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.1.1.10.4.4]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
8
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.1.1.10.4.5]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
8
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.1.1.10.4.6]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
9
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.1.1.1.10.4.6.1]
Eugenia Joyce Barker
10
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.1]
Wendell Wade Hennigh
11
Joshua Houle Hennigh
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.1.1]
11
Lukas Wade "Luke" Hennigh
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.1.2]
Nicole Amanda Valenzuela
12
Noah Nash Hennigh
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.1.2.1]
12
Maksim Wade Hennigh
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.1.2.2]
10
Jennifer Alberta Houle
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.2]
Richard C. Sandoval
11
Terresita Maria Sandoval
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.2.1]
Russell Nordstedt
12
Riley Nordstedt
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.2.1.1]
11
Emilia Alberta Sandoval
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.2.2]
+
Steven Byrne
10
Winifred Catherine Houle
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.3]
Robert Eugene Cherry
11
Robert Lewis Scott Cherry
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.3.1]
Erin Stobee
12
Finnean Leopold Cherry
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.3.1.1]
12
Greta Cherry
[1.1.1.1.1.10.4.6.1.3.1.2]
9
Anna Josephine Houle
[1.1.1.1.1.10.4.6.2]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
10
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.1.1.1.10.4.6.2.1]
Cathy Ann Glessner
11
Darcy Catherine Currier
[1.1.1.1.1.10.4.6.2.1.1]
William C. Hunter
12
Hannah Hunter
[1.1.1.1.1.10.4.6.2.1.1.1]
12
Jessica Hunter
[1.1.1.1.1.10.4.6.2.1.1.2]
11
Kimberly Darcy Currier
[1.1.1.1.1.10.4.6.2.1.2]
+
Andrew Goldsmith
Darren McAdams
12
Dylan McAdams
[1.1.1.1.1.10.4.6.2.1.2.1]
12
Colin Guy McAdams
[1.1.1.1.1.10.4.6.2.1.2.2]
9
Dorothy Louise Houle
[1.1.1.1.1.10.4.6.3]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
10
John Dennis Scully
[1.1.1.1.1.10.4.6.3.1]
10
Constance L Scully
[1.1.1.1.1.10.4.6.3.2]
+
Newton
10
Brian C. Scully
[1.1.1.1.1.10.4.6.3.3]
9
Alberta Isabel Houle
[1.1.1.1.1.10.4.6.4]
Jeptha Milton Gibbs, III
10
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.1]
Mary Melissa Meyers
11
Jeptha Milton Gibbs, V
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.1.1]
Cathy Helene Cline
12
Mary Taylor Christina Gibbs
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.1.1.1]
11
Mary Melissa Gibbs
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.1.2]
10
Jane Gibbs
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.2]
+
Richard Calvin Torrey
10
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.3]
Jerry Hamilton Guild
11
Matthew Hamilton Guild
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.3.1]
+
Ivy
11
Nancy J. Guild
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.3.2]
11
Christopher Parsons Guild
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.3.3]
11
Peter Christopher Guild
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.3.4]
11
Bonnie C. Guild
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.3.5]
10
Edward Thurston Gibbs
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.4]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
10
William Houle Gibbs
[1.1.1.1.1.10.4.6.4.5]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
8
Edna Emma Yancey
[1.1.1.1.1.10.4.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
9
Anita Ruth Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.1]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
9
Helen May Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.2]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
9
Howard Joseph Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.3]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
10
Anthony Howard Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.3.1]
10
Stephnie Jeane Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.3.2]
+
Joseph Michael Flynn
10
Nicholas Joseph Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.3.3]
+
Johnna M Verardo
+
Edna Mae Thompson
9
Edna Dorothy Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.4]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
9
Norman Francis Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.5]
Margaret (Peggy) Louise Clark
10
Michael Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.1]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
10
Norma Louise Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.2]
Richard Eugene Polen
11
Michael Eugene Polen
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.2.1]
+
Marguerete Paige Thrasher
11
Lisa Ann Polen
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.2.2]
+
Jr. Joseph Warren Wilson, Jr
11
Holly Louise Polen
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.2.3]
+
Mark Thomas Setterberg
11
Amy Elizabeth Polen
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.2.4]
+
David Lance Parrish
10
Nancy Nell Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3]
William Richard Mann
11
Steven Joseph Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.1]
Annette Elizabeth Risso
12
Steven William Farrell Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.1.1]
12
Richard Christopher Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.1.2]
12
Michelle Elizabeth Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.1.3]
11
Gary Allen Francis Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.2]
Cynthia Kay Semmler
12
Christopher Lee Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.2.1]
12
Cheryl Marie Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.2.2]
11
Richard Lee Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.3]
11
Leslie Melinda Mann
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.4]
Patterson
12
Jenna Nichole Patterson
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.3.4.1]
10
Joseph Edward Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.4]
Mary Helen Norman
11
Marilyn Marie Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.4.1]
Theodore Louis Beteta
12
Bryan Douglas Beteta
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.4.1.1]
12
Kevin Thomas Beteta
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.4.1.2]
11
Michael Norman Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.5.4.2]
9
Kathryn Alberta Otero
[1.1.1.1.1.10.4.7.6]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
10
Michael Allen McCune
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.1]
10
Patricia Lee McCune
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.2]
10
Barbara Ruth McCune
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3]
Jewell Ray "Bud" DeShon
11
Linda Lee De Shon
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3.1]
+
Steven Peter Ricketts
Lonnie Jay Simmons
12
Justin Jay Simmons
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3.1.1]
[
=>
]
Gary Jacobs
12
Lacy Nicole Jacobs
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3.1.2]
11
Lori Rae De Shon
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3.2]
Eric Miguel Jewett
12
Nicholas Jewett
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3.2.1]
11
Larry Dean De Shon
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3.3]
Lydia Gail Tooker
12
Tyler Alexander De Shon
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3.3.1]
12
Jordan Taylor De Shon
[1.1.1.1.1.10.4.7.6.3.3.2]
8
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.1.1.10.4.8]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
9
Anita H. Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
10
Edwin Arthur Heacock
[1.1.1.1.1.10.4.8.1.1]
Dorothy Louise
11
Julie Heacock
[1.1.1.1.1.10.4.8.1.1.1]
10
Caroll Jane Heacock
[1.1.1.1.1.10.4.8.1.2]
10
Vivian L. Heacock
[1.1.1.1.1.10.4.8.1.3]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
9
Chester Arthur Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
9
Flournoy Albert Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
9
Stanley St. Clair Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.4]
Eleanor Louise Moore
10
Hollis Eleanor Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.1]
+
Lawrence Terry
Wesley Richard Peterson
11
Logan Sven Peterson
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.1.1]
11
Jordan S. Peterson
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.1.2]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
10
Stanley Robert Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.2]
Evelyn Elizabeth Perkins
11
Robert Erwin William Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.2.1]
+
Linda Corrine Montgomery
+
Barbara Anne Rich
11
Elizabeth Ann Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.2.2]
+
Chesley D. Quaide
10
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.3]
Hugh Washburn Steven
11
Julia Warren Steven
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.3.1]
Donald Laurence Blumenthal
12
David Steven Blumenthal
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.3.1.1]
[
=>
]
11
David Hugh Steven
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.3.2]
Amiee Suzanne Wightman
12
Brooke Heidi Steven
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.3.2.1]
12
Christopher Wightman "Kit" Steven
[1.1.1.1.1.10.4.8.4.3.2.2]
9
Louis Dewey Juch
[1.1.1.1.1.10.4.8.5]
7
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.1.1.10.5]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
7
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.1.1.10.6]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
8
Louisa Yancey
[1.1.1.1.1.10.6.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
9
Rosalie E. McQuade
[1.1.1.1.1.10.6.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
8
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.1.1.10.6.2]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
8
Nellie M Yancey
[1.1.1.1.1.10.6.3]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
8
Edna L. Yancey
[1.1.1.1.1.10.6.4]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
8
William P. Yancey
[1.1.1.1.1.10.6.5]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
8
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.1.1.10.6.6]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
7
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.1.1.10.7]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
7
Mary Julia Yancey
[1.1.1.1.1.10.8]
b. 1834
+
William D. Roberts
5
David Flournoy
[1.1.1.1.2]
b. 14 Apr 1761 d. 30 Jun 1831
+
Elizabeth Mills Britton
b. 17 Oct 1760 d. 30 Jun 1830
5
Gideon Flournoy
[1.1.1.1.3]
b. 20 Feb 1751 d. 15 Feb 1821
+
Jane F DeLisle
Grace B. Tarry
b. 1755 d. 20 Dec 1819
6
"Mattie" Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.1.3.1]
b. 1795 d. 10 Oct 1855
Arthur Woodfin
b. 1790 d. 9 Oct 1855
7
William G. Woodfin
[1.1.1.1.3.1.1]
b. 1817
7
Richard M. Woodfin
[1.1.1.1.3.1.2]
b. 1817
7
Thomas E Woodfin
[1.1.1.1.3.1.3]
b. 1818
7
John James Woodfin
[1.1.1.1.3.1.4]
b. 19 Mar 1820 d. 23 Sep 1860
7
Charles Newton Woodfin
[1.1.1.1.3.1.5]
b. 31 Jul 1824 d. 2 Jul 1912
7
Mary Elizabeth Susan Woodfin
[1.1.1.1.3.1.6]
b. 12 Jun 1829 d. 23 Nov 1890
7
Arthur Woodfin
[1.1.1.1.3.1.7]
b. 1832
7
Harriet Woodfin
[1.1.1.1.3.1.8]
b. 1836
7
Martha Woodfin
[1.1.1.1.3.1.9]
b. 1838
6
Martha Ann Flournoy
[1.1.1.1.3.2]
b. Abt 1798 d. 1847
Thomas Woodfin
b. 1795 d. 1853
7
William Thomas Woodfin
[1.1.1.1.3.2.1]
b. 16 Sep 1822 d. 3 Aug 1894
7
Samuel Flournoy Woodfin
[1.1.1.1.3.2.2]
b. 4 Aug 1824 d. 14 Feb 1866
7
James Edward Woodfin
[1.1.1.1.3.2.3]
b. 1826 d. 1889
7
Jane Woodfin
[1.1.1.1.3.2.4]
b. 1828 d. 1892
7
Frances Woodfin
[1.1.1.1.3.2.5]
b. 1830
7
George Washington Woodfin
[1.1.1.1.3.2.6]
b. 15 Mar 1832 d. 3 Aug 1895
7
Martha Woodfin
[1.1.1.1.3.2.7]
b. 1834
7
Rebecca Woodfin
[1.1.1.1.3.2.8]
b. 18 Dec 1836 d. 16 Aug 1860
5
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.1.4]
b. 25 Nov 1765
+
Isham Britton
b. Bef 1761
5
Julia Briton Flournoy
[1.1.1.1.5]
b. Abt 1770
5
John Flournoy
[1.1.1.1.6]
b. 29 Apr 1754
5
Thomas Flournoy
[1.1.1.1.7]
b. Bef 1767
5
Ursula Harris Flournoy
[1.1.1.1.8]
b. 15 May 1749
James Bailey Harris
b. 1749
6
III James Harris
[1.1.1.1.8.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
7
Alfred Turpin Harris
[1.1.1.1.8.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
8
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.1.1.8.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
6
Samuel Harris
[1.1.1.1.8.2]
b. Abt 1774
6
Elizabeth Harris
[1.1.1.1.8.3]
b. Abt 1776
6
Mary Harris
[1.1.1.1.8.4]
b. Abt 1778
5
Hannah Flournoy
[1.1.1.1.9]
b. Abt 1762
5
Jordan Flournoy
[1.1.1.1.10]
b. 20 Sep 1763 d. 21 Jun 1833
+
Judith Farrar
b. 21 Apr 1756 d. 1828
5
Samuel Flournoy
[1.1.1.1.11]
b. 9 Dec 1758 d. 19 Aug 1818
Nancy Ann Martin
b. 1765
6
Samuel Martin Flournoy
[1.1.1.1.11.1]
b. 1799 d. 1878
+
Minerva Ann Wadlington
b. 1814 d. 1858
+
Harriett Elvira Fenley
b. 24 Jan 1820
6
Agnes Flournoy
[1.1.1.1.11.2]
b. 1799
6
Martha Flournoy
[1.1.1.1.11.3]
b. 15 Aug 1813 d. 1891
Randolph Allen Hankla
b. 1 Feb 1803
7
Minerva Nancy Hankla
[1.1.1.1.11.3.1]
b. 29 Mar 1837 d. 1 Apr 1898
7
Pendleton Flournoy Hankla
[1.1.1.1.11.3.2]
b. 24 Mar 1831
7
James Marion F. Hankla
[1.1.1.1.11.3.3]
b. 8 Feb 1833
7
John Hankla
[1.1.1.1.11.3.4]
b. 21 Feb 1835
7
Mary Francis Hankla
[1.1.1.1.11.3.5]
b. 29 Dec 1839
7
Martha Matilda Hankla
[1.1.1.1.11.3.6]
b. 17 Jul 1844
7
Joseph Randolph Hankla
[1.1.1.1.11.3.7]
b. 5 Nov 1847
7
William Harrison Hankla
[1.1.1.1.11.3.8]
b. 17 Feb 1849
7
Ella Eugenia Hankla
[1.1.1.1.11.3.9]
b. 24 Jul 1853
7
Eliza Hankla
[1.1.1.1.11.3.10]
b. 2 Dec 1841 d. 7 Aug 1919
6
Matthews Flournoy
[1.1.1.1.11.4]
b. 1789 d. 1833
6
James Flournoy
[1.1.1.1.11.5]
b. 1 Jan 1791 d. 3 Mar 1855
+
Martha Halloway
b. 1790 d. 1871
6
Jack Flournoy
[1.1.1.1.11.6]
b. 1799 d. 1818
6
Nancy Flournoy
[1.1.1.1.11.7]
b. 1795
6
Rachel Flournoy
[1.1.1.1.11.8]
b. 1797
6
Amelia Flournoy
[1.1.1.1.11.9]
b. 1786
6
Emily Flournoy
[1.1.1.1.11.10]
b. 1801
6
Patsy Flournoy
[1.1.1.1.11.11]
b. 1793
6
Cassandra Flournoy
[1.1.1.1.11.12]
b. 1803
5
Martha Flournoy
[1.1.1.1.12]
b. Feb 1768
5
Mary Flournoy
[1.1.1.1.13]
b. Bef 1756
4
John Jordan Harris
[1.1.1.2]
b. 1732 d. Bef 19 Nov 1800
Anne Obedience Turpin
b. 17 Sep 1734 d. 8 Aug 1800
5
Mary Elizabeth Josepha Harris
[1.1.1.2.1]
b. 1767
5
Lucy Harris
[1.1.1.2.2]
b. 1756 d. 1832
Obadiah Smith
b. Abt 1756
6
Mary Burke Smith
[1.1.1.2.2.1]
b. 9 Jun 1781
5
Judith Harris
[1.1.1.2.3]
b. 1760
+
John Crittenden
b. Abt 1759
5
Jordan Turpin Harris
[1.1.1.2.4]
b. 20 May 1763 d. 1826
Elizabeth Mosby Cannon
b. Abt 1763
6
James Madison Harris
[1.1.1.2.4.1]
b. 1776
Caroline John
b. Abt 1776
7
Md William Jordan Harris
[1.1.1.2.4.1.1]
b. Abt 1800
+
Mary Helen Epes
b. Abt 1800
6
Horatio Turpin Harris
[1.1.1.2.4.2]
b. 1799 d. 1855
+
Keturah
b. Abt 1799
6
John Francis Harris
[1.1.1.2.4.3]
b. 1808 d. 1880
+
Mary Duke Patten
b. Abt 1808
+
Ann Price
b. Abt 1763
5
John Turpin Harris
[1.1.1.2.5]
b. 12 Oct 1758 d. 1815
Rebecca Britton
b. Abt 1770
6
Hiram Harris
[1.1.1.2.5.1]
b. 15 Sep 1796 d. 3 Jun 1867
Margaret Christian Harris
b. Abt 1796 d. Mar 1825
7
Henry Benskin Christian Harris
[1.1.1.2.5.1.1]
b. 3 Feb 1825
Elizabeth Ann Daniels
b. 17 Oct 1842
8
Pauline B. Harris
[1.1.1.2.5.1.1.1]
8
Robert D. Harris
[1.1.1.2.5.1.1.2]
b. 31 Mar 1875 d. 8 Oct 1875
8
Sallie Tilden Harris
[1.1.1.2.5.1.1.3]
b. 9 Sep 1877 d. 1952
+
James Henry Brown
b. 1869 d. 1949
8
Mary Harris
[1.1.1.2.5.1.1.4]
b. 15 Jun 1880
Robert Granville Gaunt
b. Abt 1880
9
Mary Gladys Gaunt
[1.1.1.2.5.1.1.4.1]
b. Abt 1902
8
Margaret Christian Harris
[1.1.1.2.5.1.1.5]
b. 10 Jan 1871
+
James A. Gaunt
b. Abt 1870
8
William Henry "Hiram" Harris
[1.1.1.2.5.1.1.6]
b. 7 May 1879 d. 1944
Anna E. Ogden
b. 1884 d. 1941
9
Miles Franklin Harris
[1.1.1.2.5.1.1.6.1]
8
Jesse B. Harris
[1.1.1.2.5.1.1.7]
b. Mar 1882
Sarah C. Calvert
b. 9 Mar 1834/1835 d. 18 Mar 1865
8
Hiram Henry Harris
[1.1.1.2.5.1.1.8]
b. 31 Jul 1855
8
Martha W. Harris
[1.1.1.2.5.1.1.9]
b. 7 Aug 1859
+
Jesse Gordon Roach
b. 1855 d. 1937
8
James Clay Harris
[1.1.1.2.5.1.1.10]
b. 16 Oct 1868
+
Sarah A. Farris
+
Mary Anderson
b. Abt 1868
8
Catherine B. Harris
[1.1.1.2.5.1.1.11]
b. Aug 1861
+
William T. Barnett
b. Abt 1861
8
Rebecca D Harris
[1.1.1.2.5.1.1.12]
b. 20 May 1852
+
Spencer L Barnes
b. Abt 1852
7
Rebecca Ann Harris
[1.1.1.2.5.1.2]
b. 3 Mar 1823
+
John Wilson
b. Abt 1823
+
Alfred Douglas
b. Abt 1823
Margaret Wilson
b. Abt 1796 d. Abt 1827
7
Mary Eleanor Harris
[1.1.1.2.5.1.3]
b. 28 Sep 1827
Elizabeth George
b. Abt 1796
7
Jr. Hiram Harris
[1.1.1.2.5.1.4]
b. 1840
+
Frances Gordon
b. Abt 1840
7
Mary Eleanor Harris
[1.1.1.2.5.1.5]
b. Abt 1845
+
McRae
b. Abt 1845
7
Margaret Elizabeth Harris
[1.1.1.2.5.1.6]
b. 1847
John E. Benson
b. Abt 1847
8
Eleanor Harris Benson
[1.1.1.2.5.1.6.1]
b. Abt 1870
7
John Wilson Harris
[1.1.1.2.5.1.7]
b. 1837 d. Aft 1867
+
Frances Gordon
b. Abt 1825
5
Polly Harris
[1.1.1.2.6]
b. 1774
5
Francis Turpin Harris
[1.1.1.2.7]
b. 7 May 1768 d. 5 Dec 1836
+
Sally Gaines
b. Abt 1768
5
Carolina Matilda Harris
[1.1.1.2.8]
b. 1 Dec 1756 d. 1815
+
Thomas Harris
b. Abt 1756
4
Ursula Harris
[1.1.1.3]
b. Abt 1731
4
William Harris
[1.1.1.4]
b. Abt 1728
+
Osborne
b. Abt 1727
+
Elizabeth Evans
b. Abt 1745
Elizabeth Robards
b. Abt 1700
4
Jesse Harris
[1.1.1.5]
c. 14 Jun 1741
3
Mary Harris
[1.1.2]
b. Abt 1698 d. 17 Dec 1759
+
Francis James
b. Abt 1694
John Goode
b. Abt 1698
4
Bennett Goode
[1.1.2.1]
b. Abt 1710 d. 1771
Martha Jefferson
b. Abt 1712 d. 20 Oct 1796
5
Martha Goode
[1.1.2.1.1]
b. 1760 d. 1810
Charles Povall
b. 1763 d. 1803
6
Martha Povall
[1.1.2.1.1.1]
b. 1 Nov 1784
William Carrington
b. 20 Aug 1774 d. 21 May 1825
7
Ellen Theodosia Carrington
[1.1.2.1.1.1.1]
b. 1813 d. 1896
William Royal Bradley
b. 1804 d. 1889
8
Martha Carrington Bradley
[1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 1826/1847 d. 1862/1933
Thomas Pride Shields
b. 1808/1837 d. 1862/1922
9
Martha Tomasia Shields
[1.1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 21 Aug 1859 d. 15 Aug 1944
Joseph Cosgray Sweeney
b. 23 Dec 1859 d. 2 Apr 1945
10
Richmond Carrington Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1]
b. 18 Sep 1896 d. 12 Aug 1966
10
Ruth Virginia Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.2]
10
Thomas Shields Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3]
Hildred Ashbaugh
11
Dorathea Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.1]
Eugene C. Werst
12
Linda Bassler Werst
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.1.1]
[
=>
]
12
Karen Madsen Werst
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.1.2]
[
=>
]
12
Robert Werst
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.1.3]
11
Jr. Thomas Shields Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.2]
Dorthy Schiderer
12
Larry Shields Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.2.1]
[
=>
]
12
Patricia Marie Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.2.2]
12
Barbara Jeanne Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.2.3]
[
=>
]
10
James Chamberlain Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4]
Helen Armstrong
b. 5 Aug 1897 d. 6 Aug 1970
11
James Carrington Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1]
Elizabeth Boehmer
12
Shawn Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.1]
[
=>
]
12
Shannon Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.2]
[
=>
]
12
Kate Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.3]
12
Sam Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.4]
[
=>
]
11
Helen Jean Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 30 Jul 1921 d. 1928
11
Robert Stewart Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 4 Nov 1925 d. 30 Sep 1964
Beverly Jean Willis
12
Jr. Robert Stewart Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.3.1]
[
=>
]
12
Kathaleen Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.3.2]
12
Michael Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.3.3]
[
=>
]
12
Carolyn Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.3.4]
11
Ruth Beverly Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.4]
William Reese Swift
12
Kimberly Swift
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
12
Jr. William Reese Swift
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.4.2]
[
=>
]
12
Susan Gaye Swift
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.4.3]
[
=>
]
11
John Armstrong Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.5]
Inez Elane Potter
12
Brian Wade Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.5.1]
[
=>
]
12
James C. Sweeney
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.5.2]
7
Martha Ann Carrington
[1.1.2.1.1.1.2]
b. 26 Feb 1806 d. 29 Apr 1865
Codrington Carrington
b. 23 Oct 1801 d. 10 Sep 1859
8
Willie Ann Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.1]
b. 13 Jun 1833
8
Robert Codrington Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2]
b. 6 Sep 1842
Hellen C. Walton
b. Cal 1846
9
Nathaniel W. Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.1]
b. Jul 1868
Anna V. Woodson
b. Oct 1868 d. Bef 1910
10
Robert Miller Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.1.1]
10
William Blair Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.1.2]
+
Bessie Patterson
10
Alvin Roy Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.1.3]
b. 3 Nov 1900 d. Feb 1970
+
Carrie S.
10
James N. Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.1.4]
10
Lilly Marie Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.1.5]
+
Walton
+
Myrtle H.
9
Bernard Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.2]
b. Feb 1879
9
Rose Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.3]
b. Abt 1880
9
Collin Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.4]
b. Cal 1870
9
Lillian Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.5]
b. Cal 1874
9
Minnie M. Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.6]
b. Cal 1872
9
Martha Elvira Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.2.7]
b. 10 Sep 1867
8
Ellen Maria Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.3]
b. 22 Mar 1836 d. 14 Jul 1873
+
Fox
8
Cornelia Booker Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.4]
b. 1 Feb 1845
+
T. B. S. Walton
8
Martha Virginia Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.5]
b. 2 Apr 1839
+
E. C. Mayo
8
William A. Carrington
[1.1.2.1.1.1.2.6]
b. 22 Sep 1843 d. 25 Sep 1843
3
Edith Harris
[1.1.3]
b. Abt 1700 d. Abt 1745
+
John Osborne
b. Abt 1684
+
Peter Fitzpatrick
b. Abt 1684
+
Henry Trent
b. 1676 d. 5 Sep 1726
3
Francis Harris
[1.1.4]
b. Abt 1692 d. Jul 1743
3
Jr. Thomas Harris, Jr
[1.1.5]
b. Abt 1690 d. Bef 1 Aug 1741
3
Sarah Harris
[1.1.6]
b. Abt 1696 d. Bef 24 Sep 1753
3
Ann Harris
[1.1.7]
b. 1708
Booth
b. Abt 1700
4
Anne Booth
[1.1.7.1]
b. Abt 1735 d. 1758
Samuel Yeargain
b. Abt 1735 d. Aft 24 Dec 1784
5
Sarah Ann Yeargain
[1.1.7.1.1]
b. 1752 d. 1786
William Alston
b. 1748 d. 1789
6
John Joseph Alston
[1.1.7.1.1.1]
b. Abt 1775 d. 1 Apr 1831
Elizabeth Jones
b. Abt 1775
7
Mary Ann Alston
[1.1.7.1.1.1.1]
b. Abt 1802
James Taylor
b. Abt 1802
8
Joe Taylor
[1.1.7.1.1.1.1.1]
b. Abt 1838
+
Anna Alston
b. Abt 1838
+
Thomas Degraaffenreidt
b. Abt 1802
7
Nancy Alston
[1.1.7.1.1.1.2]
b. Abt 1800
+
John Degraaffenreidt
b. Abt 1800
6
William Chancy Alston
[1.1.7.1.1.2]
b. Abt 1777 d. 1789
6
Samuel Yeargan Alston
[1.1.7.1.1.3]
b. Abt 1779 d. Bef 1789
6
Oroondates Davis Alston
[1.1.7.1.1.4]
b. Abt 1781 d. 15 May 1851
+
Medley Medley
b. Abt 1781
6
Nancy Ann Alston
[1.1.7.1.1.5]
b. Abt 1783 d. 1860
+
Robert Palmer
b. Abt 1783
6
Mary Ann Alston
[1.1.7.1.1.6]
b. 9 Jun 1785 d. 8 Sep 1867
Edwards Rives
b. 19 Mar 1775 d. 2 Feb 1840
7
Anna Rives
[1.1.7.1.1.6.1]
b. 14 Feb 1810
+
William Goldson Harris
b. Abt 1810
7
Robert Edwards Rives
[1.1.7.1.1.6.2]
b. 24 May 1812 d. 1861
+
Mary Antoinette Brown
b. 16 Jun 1833
7
Thomas T. Rives
[1.1.7.1.1.6.3]
b. 28 Jul 1814
7
James Franklin Rives
[1.1.7.1.1.6.4]
b. 13 Jun 1820
7
Mary Edwards Rives
[1.1.7.1.1.6.5]
b. 27 Dec 1827 d. 13 Nov 1873
+
Aaron Gaston Headen
b. 21 Aug 1822 d. 1 Mar 1907
7
Sarah G. Rives
[1.1.7.1.1.6.6]
b. 11 Sep 1801 d. Bef 1830
7
William Alston Rives
[1.1.7.1.1.6.7]
b. 1 Nov 1803
7
Martha K. Rives
[1.1.7.1.1.6.8]
b. Oct 1806
+
John Jackson Goldston
b. Abt 1806
7
Oran D. Rives
[1.1.7.1.1.6.9]
b. 24 Sep 1808
+
Samuel Yeargain
b. 1707 d. 24 Dec 1784
3
Phoebe Harris
[1.1.8]
b. Abt 1689 d. Between 1697 and 1800
3
James Harris
[1.1.9]
b. Abt 1702 d. Bef 27 Jul 1767
Sarah Bailey
b. Abt 1704
4
James Bailey Harris
[1.1.9.1]
b. 1749
Ursula Harris Flournoy
b. 15 May 1749
5
III James Harris
[1.1.9.1.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
6
Alfred Turpin Harris
[1.1.9.1.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
7
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.9.1.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
5
Samuel Harris
[1.1.9.1.2]
b. Abt 1774
5
Elizabeth Harris
[1.1.9.1.3]
b. Abt 1776
5
Mary Harris
[1.1.9.1.4]
b. Abt 1778
4
John Bailey Harris
[1.1.9.2]
b. Abt 1732
4
Francis Bailey Harris
[1.1.9.3]
b. Abt 1758
+
Ann Diugud
b. Abt 1760
4
Mary Harris
[1.1.9.4]
b. Abt 1736
4
Phoebe Bailey Harris
[1.1.9.5]
b. Abt 1734
M.B.C.R. Joseph Royal Farrar
b. Abt 1734 d. 1796
5
Mary Farrar
[1.1.9.5.1]
b. Abt 1766
+
William Wager Harris
b. Abt 1766
4
Thomas Bailey Harris
[1.1.9.6]
b. Abt 1738 d. Bef 22 Nov 1810
+
Frances Moseley
b. Abt 1732
4
William Bailey Harris
[1.1.9.7]
b. 1757 d. Abt 1816
+
Mary Pollard
b. Abt 1760 d. Abt 1830
3
William Samuel Harris
[1.1.10]
b. Abt 1696 d. Bef 18 Dec 1794
Martha Osborne
b. Abt 1700
4
Mary Harris
[1.1.10.1]
b. Abt 1720
+
Bernard Markham
b. Abt 1720
4
Elizabeth Harris
[1.1.10.2]
b. Abt 1750
+
Vincent Markham
b. Abt 1750
+
Elizabeth Ward
b. Abt 1696
Martha Ward
b. Abt 1700
4
Thomas Harris
[1.1.10.3]
b. Abt 1756
+
Carolina Matilda Harris
b. 1 Dec 1756 d. 1815
3
Benjamin Harris
[1.1.11]
b. Abt 1710 d. Aft 24 Apr 1776
Priscilla Wager
b. Abt 1710
4
Phoebe Harris
[1.1.11.1]
b. 1755
Nathaniel Carrington
b. 28 Feb 1743/44 d. Nov 1803
5
Frances Ann Carrington
[1.1.11.1.1]
5
Henningham Carrington
[1.1.11.1.2]
4
Edith Harris
[1.1.11.2]
b. 1757 d. Aft 18 Nov 1779
4
Henson Wager Harris
[1.1.11.3]
b. 1753
+
Edward Moseley
b. Abt 1753
4
William Wager Harris
[1.1.11.4]
b. Abt 1766
+
Mary Farrar
b. Abt 1766
Frances Platt
b. Abt 1710
4
Mary Harris
[1.1.11.5]
b. Abt 1744
+
Sion Spencer
b. Abt 1744
4
Anne Harris
[1.1.11.6]
b. 1745
+
Joel Estes
b. 1741 d. 1825
3
Martha Harris
[1.1.12]
b. Abt 1706 d. 1743
+
William Pasture
b. Abt 1702
3
Timothy Harris
[1.1.13]
b. 1691 d. Jun 1743
2
Elizabeth Ann Harris
[1.2]
b. 2 Nov 1658 d. 15 Oct 1729