News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Register for a User Account
Home
Search
Login
Find
Surnames
What's New
Most Wanted
Reports
Cemeteries
Media
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
•
First Name:
Last Name:
ID:
Mary Bourchier
1593 - 1666 (73 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Mary Bourchier
[1]
b. 1593 d. 1666
Jabez Whitaker
b. 6 Dec 1595 d. 1626
2
William Whitaker
[1.1]
b. 1617 d. Bef Oct 1666
Mary Elizabeth Camm
b. 1621 d. 1682
3
Aaron Whitaker
[1.1.1]
b. 1640 d. 27 Nov 1713
Catherine
b. 1640 d. 25 Nov 1713
4
John Whitacre
[1.1.1.1]
b. 1661 d. 30 Nov 1713
Catherine McComas
b. 1665 d. 25 Nov 1713
5
Charles Whitaker
[1.1.1.1.1]
b. 10 Oct 1693 d. 3 Oct 1739
Mary Kimball
b. Abt 1695 d. 30 Aug 1739
6
John Whitaker
[1.1.1.1.1.1]
b. 2 Jul 1722 d. 13 Feb 1797
+
Mary McComas
b. 8 May 1722 d. 1802
5
Abraham Whitacre
[1.1.1.1.2]
b. 17 Sep 1702 d. 31 Dec 1739
+
Ann Poteet
5
Hannah Whittacre
[1.1.1.1.3]
b. 9 Nov 1713 d. 18 Oct 1792
+
Thomas Miles
b. Abt 1704
Daniel Alexander McComas, Jr.
b. 14 Sep 1692 d. 4 Feb 1761
6
Hannah McComas
[1.1.1.1.3.1]
b. 25 Mar 1730 d. Bef 1804
+
Jacob Miles
6
Aquilla McComas
[1.1.1.1.3.2]
b. 15 May 1731 d. 21 Oct 1771
+
Sarah Preston
6
Priscilla McComas
[1.1.1.1.3.3]
b. 1733 d. 1803
Thomas Simmons
b. 5 Sep 1719 d. 5 Oct 1794
7
Sarah Simmons
[1.1.1.1.3.3.1]
b. Abt 1754
7
Martha Simmons
[1.1.1.1.3.3.2]
b. 2 Sep 1754 d. 1826
7
Thomas Simmons
[1.1.1.1.3.3.3]
b. Abt 1756
7
Priscilla Simmons
[1.1.1.1.3.3.4]
b. 1756 d. 1821
7
Keziah Simmons
[1.1.1.1.3.3.5]
b. Abt 1768 d. 2 Feb 1802
Thomas Yancey
b. 15 Dec 1769 d. Bef 12 Nov 1803
8
James L Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.1]
b. Abt 1790
+
Frances Fuller
8
Tryon Milton Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2]
b. 1794 d. Aft 1860
Louisa Ann Flournoy
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
9
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
10
Robert Lee Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.1]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
10
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
11
Anita H. Juch
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
12
Vivian L. Heacock
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.1.1]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
12
Caroll Jane Heacock
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.1.2]
12
Edwin Arthur Heacock
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.1.3]
[
=>
]
11
Chester Arthur Juch
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
11
Flournoy Albert Juch
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
11
Stanley St. Clair Juch
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.4]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
12
Stanley Robert Juch
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.4.1]
[
=>
]
12
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.4.2]
[
=>
]
Eleanor M Juch
12
Hollis Eleanor Juch
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.4.3]
[
=>
]
11
Louis Dewey Juch
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.5]
10
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.3]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
10
Adella Frances Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.4]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
11
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.4.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
12
Jerome Anthony Goodall
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.4.1.1]
[
=>
]
12
John Patrick Goodall
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.4.1.2]
[
=>
]
12
Francis Joseph Goodall
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.4.1.3]
+
Frank G Curran
10
Mary Anna "Mayme" Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.5]
b. 8 Dec 1874 d. 18 Sep 1968
Maclovio Danislao De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
11
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.5.1]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
11
Orman Joe De Arnaz
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.5.2]
+
Alma Viola
10
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.6]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
10
Edna Emma Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
11
Helen May Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.1]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
11
Edna Dorothy Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.2]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
11
Anita Ruth Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.3]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
11
Norman Francis Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.4]
Margaret (Peggy) Louise Clark
12
Nancy Nell Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.4.1]
[
=>
]
12
Joseph Edward Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.4.2]
[
=>
]
12
Norma Louise Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.4.3]
[
=>
]
12
Michael Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.4.4]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
11
Kathryn Alberta Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.5]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
12
Patricia Lee McCune
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.5.1]
12
Barbara Ruth McCune
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.5.2]
[
=>
]
12
Michael Allen McCune
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.5.3]
11
Howard Joseph Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.6]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
12
Anthony Howard Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.6.1]
12
Stephnie Jeane Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.6.2]
12
Nicholas Joseph Otero
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.7.6.3]
+
Edna Mae Thompson
10
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
11
Alberta Isabel Houle
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.1]
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
Jeptha Milton Gibbs, III
b. 17 Jan 1901 d. 9 Nov 1973
12
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.1.1]
[
=>
]
12
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.1.2]
[
=>
]
12
Edward Thurston Gibbs
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.1.3]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
12
William Houle Gibbs
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.1.4]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
12
Jane Gibbs
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.1.5]
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
b. 24 Feb 1900 d. Feb 1973
11
Dorothy Louise Houle
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.2]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
12
Constance L Scully
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.2.1]
12
John Dennis Scully
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.2.2]
12
Brian C. Scully
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.2.3]
11
Anna Josephine Houle
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.3]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
12
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.3.1]
[
=>
]
11
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.4]
Eugenia Joyce Barker
12
Winifred Catherine Houle
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.4.1]
[
=>
]
12
Jennifer Alberta Houle
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.4.2]
[
=>
]
12
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.1.1.3.3.5.2.1.8.4.3]
[
=>
]
9
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.2]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
9
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.1.3.3.5.2.3]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
10
Louisa Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.3.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
11
Rosalie E. McQuade
[1.1.1.1.3.3.5.2.3.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
10
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.3.2]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
10
Edna L. Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.3.3]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
10
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.3.4]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
10
Nellie M Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.3.5]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
10
William P. Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.3.6]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
9
Laura Ann Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.4]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
10
Laura Ann Black
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.1]
10
Louisa Catherine Black
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
11
Leroy Black Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.1]
b. 1864 d. 1934
11
Mary Lou Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.2]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
12
Sadie Louise Gilbert
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.2.1]
[
=>
]
12
Robert Lester Gilbert
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.2.2]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953 [
=>
]
12
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.2.3]
12
Leon Gilbert
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.2.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
11
Laura Jane Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.3]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
12
Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.3.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown [
=>
]
12
Louise Dickey
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.3.2]
b. Jan 1899 [
=>
]
11
Emily Olivia Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.4]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
12
Thomas Leroy Tatum
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.4.1]
12
Myra Tatum
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.4.2]
[
=>
]
11
Levair Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.5]
b. Abt 1869
11
John A. Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.6]
b. 1873 d. 1874/1963
11
Ernest M. Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.7]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
11
Frank Leon Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.8]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
12
Richard Leon Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.8.1]
[
=>
]
11
James Carley Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.9]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
12
William Lambeth Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.9.1]
[
=>
]
12
James Lester
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.2.9.2]
10
Leroy M. Black
[1.1.1.1.3.3.5.2.4.3]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
9
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.5]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
9
Mary Julia Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.6]
b. 1834
+
William D. Roberts
9
Flournoy Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.7]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
10
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.1]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
11
Thomas Asbury Dawes
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.1.1]
b. 4 Apr 1895
11
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.1.2]
b. 29 Jan 1897 d. 24 Nov 1973
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
Willie Crook
b. Abt 1901
12
Fergene Dawes Richmond
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.1.2.1]
11
Alice LaFavia Dawes
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.1.3]
+
Glen Carl Moody
11
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.1.4]
b. 20 Mar 1902 d. 19 Apr 1974
Mary Ona Kitchens
12
Frank Leslie Dawes
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.1.4.1]
12
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.1.4.2]
[
=>
]
10
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.2]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
11
Martha Lafavre Bishop
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.2.1]
11
Richard Yancey Bishop
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.2.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
10
Cora Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
10
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.7.4]
b. Jul 1882
9
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.8]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
10
Lucy M. Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
11
George L Wilson
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.1.1]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
11
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.1.2]
b. 1886
11
Rosa Mai Wilson
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.1.3]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
11
Wilber Wilson
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.1.4]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
12
Mabel Wilson
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.1.4.1]
11
Thomas Webber Wilson
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.1.5]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
10
Webber Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
10
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.1.3.3.5.2.8.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
8
Priscilla Simmons Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.3]
b. 14 Feb 1796 d. 28 Dec 1862
John Graves Howard
b. 3 Nov 1792 d. 17 Apr 1874
9
Nancy Slade Howard
[1.1.1.1.3.3.5.3.1]
b. 11 Nov 1817 d. 27 Jul 1846
9
Elizabeth C Howard
[1.1.1.1.3.3.5.3.2]
b. 25 Oct 1824 d. 30 Nov 1898
9
Artelia A. Howard
[1.1.1.1.3.3.5.3.3]
b. 2 Apr 1828 d. 7 Jun 1875
8
Nancey Yancey
[1.1.1.1.3.3.5.4]
b. 19 Aug 1798 d. 18 Jan 1858
Ambrose Knox Ramsey
b. 22 Jan 1795 d. 30 Nov 1885
9
Thomas Yancy Ramsey
[1.1.1.1.3.3.5.4.1]
b. 2 Sep 1818 d. 15 Mar 1891
9
Minerva Ann Ramsey
[1.1.1.1.3.3.5.4.2]
b. 7 Jan 1823 d. 7 May 1878
9
Mary Graves Ramsey
[1.1.1.1.3.3.5.4.3]
b. 1826 d. 1899
9
John Milton Ramsey
[1.1.1.1.3.3.5.4.4]
b. 4 Apr 1827 d. 7 May 1891
9
Ambrose Knox Ramsey
[1.1.1.1.3.3.5.4.5]
b. 1833 d. 1881
9
William Ragsdale Ramsey
[1.1.1.1.3.3.5.4.6]
b. 16 May 1836 d. 26 Jun 1874
9
Edward Tryon Ramsey
[1.1.1.1.3.3.5.4.7]
b. 7 Feb 1841 d. 25 Apr 1912
7
Hannah Simmons
[1.1.1.1.3.3.6]
b. Abt 1768 d. 1802
Thomas Graves
b. 1757 d. Bef Apr 1799
8
John Graves
[1.1.1.1.3.3.6.1]
b. 1773 d. Bef 1815
+
Penelope Yancey
b. Abt 1791 d. Aft 1817
Mary Yancey
b. Abt 1768
9
Fannie Yancey Graves
[1.1.1.1.3.3.6.1.1]
b. Abt 1795
9
Sally Yancey Graves
[1.1.1.1.3.3.6.1.2]
b. Abt 1798
7
Alexander Simmons
[1.1.1.1.3.3.7]
b. Abt 1772