News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Mary Elizabeth Camm
1621 - 1682 (61 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Mary Elizabeth Camm
[1]
b. 1621 d. 1682
William Whitaker
b. 1617 d. Bef Oct 1666
2
Aaron Whitaker
[1.1]
b. 1640 d. 27 Nov 1713
Catherine
b. 1640 d. 25 Nov 1713
3
John Whitacre
[1.1.1]
b. 1661 d. 30 Nov 1713
Catherine McComas
b. 1665 d. 25 Nov 1713
4
Abraham Whitacre
[1.1.1.1]
b. 17 Sep 1702 d. 31 Dec 1739
+
Ann Poteet
4
Hannah Whittacre
[1.1.1.2]
b. 9 Nov 1713 d. 18 Oct 1792
+
Thomas Miles
b. Abt 1704
Daniel Alexander McComas, Jr.
b. 14 Sep 1692 d. 4 Feb 1761
5
Hannah McComas
[1.1.1.2.1]
b. 25 Mar 1730 d. Bef 1804
+
Jacob Miles
5
Aquilla McComas
[1.1.1.2.2]
b. 15 May 1731 d. 21 Oct 1771
+
Sarah Preston
5
Priscilla McComas
[1.1.1.2.3]
b. 1733 d. 1803
Thomas Simmons
b. 5 Sep 1719 d. 5 Oct 1794
6
Keziah Simmons
[1.1.1.2.3.1]
b. Abt 1768 d. 2 Feb 1802
Thomas Yancey
b. 15 Dec 1769 d. Bef 12 Nov 1803
7
James L Yancey
[1.1.1.2.3.1.1]
b. Abt 1790
+
Frances Fuller
7
Nancey Yancey
[1.1.1.2.3.1.2]
b. 19 Aug 1798 d. 18 Jan 1858
Ambrose Knox Ramsey
b. 22 Jan 1795 d. 30 Nov 1885
8
Thomas Yancy Ramsey
[1.1.1.2.3.1.2.1]
b. 2 Sep 1818 d. 15 Mar 1891
8
Minerva Ann Ramsey
[1.1.1.2.3.1.2.2]
b. 7 Jan 1823 d. 7 May 1878
8
William Ragsdale Ramsey
[1.1.1.2.3.1.2.3]
b. 16 May 1836 d. 26 Jun 1874
8
Edward Tryon Ramsey
[1.1.1.2.3.1.2.4]
b. 7 Feb 1841 d. 25 Apr 1912
8
John Milton Ramsey
[1.1.1.2.3.1.2.5]
b. 4 Apr 1827 d. 7 May 1891
8
Mary Graves Ramsey
[1.1.1.2.3.1.2.6]
b. 1826 d. 1899
8
Ambrose Knox Ramsey
[1.1.1.2.3.1.2.7]
b. 1833 d. 1881
7
Priscilla Simmons Yancey
[1.1.1.2.3.1.3]
b. 14 Feb 1796 d. 28 Dec 1862
John Graves Howard
b. 3 Nov 1792 d. 17 Apr 1874
8
Artelia A. Howard
[1.1.1.2.3.1.3.1]
b. 2 Apr 1828 d. 7 Jun 1875
8
Nancy Slade Howard
[1.1.1.2.3.1.3.2]
b. 11 Nov 1817 d. 27 Jul 1846
8
Elizabeth C Howard
[1.1.1.2.3.1.3.3]
b. 25 Oct 1824 d. 30 Nov 1898
7
Tryon Milton Yancey
[1.1.1.2.3.1.4]
b. 1794 d. Aft 1860
Louisa Ann Flournoy
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
8
Laura Ann Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.1]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
9
Leroy M. Black
[1.1.1.2.3.1.4.1.1]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
9
Louisa Catherine Black
[1.1.1.2.3.1.4.1.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
10
Mary Lou Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.1]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
11
Robert Lester Gilbert
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.1.1]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953
Ila Deane Griffin
12
Robert Parks Gilbert
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.1.1.1]
[
=>
]
+
Inez Timmerman
11
Sadie Louise Gilbert
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.1.2]
Harold Leigh Aymett
b. 11 Feb 1884 d. 6 Jul 1948
12
Marilouise Aymett
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.1.2.1]
[
=>
]
11
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.1.3]
11
Leon Gilbert
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.1.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
10
Ernest M. Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.2]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
10
Leroy Black Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.3]
b. 1864 d. 1934
10
James Carley Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.4]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
11
William Lambeth Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.4.1]
Joan Shuler
b. 3 Nov 1920 d. 25 May 1969
12
Laura Ann Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.4.1.1]
11
James Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.4.2]
10
Laura Jane Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.5]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
11
Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.5.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown
Dorothy
12
Jr. Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.5.1.1]
12
Frances Dickey
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.5.1.2]
11
Louise Dickey
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.5.2]
b. Jan 1899
Sharp
12
Lester Sharp
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.5.2.1]
12
Gilbert Sharp
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.5.2.2]
10
Frank Leon Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.6]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
11
Richard Leon Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.6.1]
Josephine Elizabeth Martin
12
Jr. Richard Leon Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.6.1.1]
12
Frank Martin Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.6.1.2]
10
Emily Olivia Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.7]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
11
Myra Tatum
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.7.1]
William Weakly Johnson
b. Abt 1895 d. Abt 1940
12
Mary Emily Johnson
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.7.1.1]
[
=>
]
12
Jr. William Weakly Johnson
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.7.1.2]
[
=>
]
12
John Tatum Johnson
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.7.1.3]
[
=>
]
11
Thomas Leroy Tatum
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.7.2]
10
John A. Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.8]
b. 1873 d. 1874/1963
10
Levair Lester
[1.1.1.2.3.1.4.1.2.9]
b. Abt 1869
9
Laura Ann Black
[1.1.1.2.3.1.4.1.3]
8
Flournoy Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.2]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
9
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.2.1]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
10
Martha Lafavre Bishop
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.1]
10
Richard Yancey Bishop
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
9
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.2.2]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
10
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.1]
Willie Crook
b. Abt 1901
11
Fergene Dawes Richmond
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.1.1]
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
10
Alice LaFavia Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.2]
+
Glen Carl Moody
10
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.3]
Mary Ona Kitchens
11
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.3.1]
Erma Pauline Lively
12
Michael Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.3.1.1]
[
=>
]
12
Susan Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.3.1.2]
[
=>
]
12
Matthew Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.3.1.3]
[
=>
]
12
Julie Marie Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.3.1.4]
[
=>
]
11
Frank Leslie Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.3.2]
+
Linda M Dickey
10
Thomas Asbury Dawes
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.4]
b. 4 Apr 1895
9
Cora Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.2.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
9
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.2.4]
b. Jul 1882
8
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.3]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
9
Lucy M. Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.3.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
10
Rosa Mai Wilson
[1.1.1.2.3.1.4.3.1.1]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
10
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.1.2.3.1.4.3.1.2]
b. 1886
10
Thomas Webber Wilson
[1.1.1.2.3.1.4.3.1.3]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
10
George L Wilson
[1.1.1.2.3.1.4.3.1.4]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
10
Wilber Wilson
[1.1.1.2.3.1.4.3.1.5]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
11
Mabel Wilson
[1.1.1.2.3.1.4.3.1.5.1]
9
Webber Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.3.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
9
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.2.3.1.4.3.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
8
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
9
Adella Frances Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4.1]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
10
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
11
Francis Joseph Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.1]
11
John Patrick Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.2]
Paulina D. Lacasella
12
Pamela Ann Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.2.1]
12
Gregory Patrick Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.2.2]
12
Ursula Louise Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.2.3]
12
Blake Michael Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.2.4]
12
Jonathan Randall Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.2.5]
12
Leigh Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.2.6]
b. 3 Nov 1945 d. 15 Apr 1962
11
Jerome Anthony Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.3]
+
Reta Adeline Thibedeau
Doris Holyfield
12
Michael Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.3.1]
12
Patricia Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.3.2]
Ann Capello
12
Jerome Anthony Goodall, Jr.
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.3.3]
12
Mary Ann Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.3.4]
b. 25 Jun 1943 d. 25 Jun 1943
12
Anita C Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.3.5]
12
Katherine Elizabeth Goodall
[1.1.1.2.3.1.4.4.1.1.3.6]
+
Frank G Curran
9
Mamie J. Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4.2]
b. 8 Dec 1875 d. 18 Sep 1968
Maclovio De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
10
Orman Joe De Arnaz
[1.1.1.2.3.1.4.4.2.1]
+
Alma Viola
10
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.1.2.3.1.4.4.2.2]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
9
Robert Lee Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4.3]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
9
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4.4]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
9
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4.5]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
9
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4.6]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
10
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1]
Eugenia Joyce Barker
11
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1.1]
Wendell Wade Hennigh
12
Joshua Houle Hennigh
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1.1.1]
12
Lukas Wade "Luke" Hennigh
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1.1.2]
[
=>
]
11
Jennifer Alberta Houle
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1.2]
Richard C. Sandoval
12
Terresita Maria Sandoval
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1.2.1]
[
=>
]
12
Emilia Alberta Sandoval
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1.2.2]
11
Winifred Catherine Houle
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1.3]
Robert Eugene Cherry
12
Robert Lewis Scott Cherry
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.1.3.1]
[
=>
]
10
Anna Josephine Houle
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.2]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
11
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.2.1]
Cathy Ann Glessner
12
Darcy Catherine Currier
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.2.1.1]
[
=>
]
12
Kimberly Darcy Currier
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.2.1.2]
[
=>
]
10
Dorothy Louise Houle
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.3]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
11
John Dennis Scully
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.3.1]
11
Constance L Scully
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.3.2]
+
Newton
11
Brian C. Scully
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.3.3]
10
Alberta Isabel Houle
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4]
Jeptha Milton Gibbs, III
11
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.1]
Mary Melissa Meyers
12
Jeptha Milton Gibbs, V
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.1.1]
[
=>
]
12
Mary Melissa Gibbs
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.1.2]
11
Jane Gibbs
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.2]
+
Richard Calvin Torrey
11
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.3]
Jerry Hamilton Guild
12
Matthew Hamilton Guild
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.3.1]
12
Nancy J. Guild
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.3.2]
12
Christopher Parsons Guild
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.3.3]
12
Peter Christopher Guild
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.3.4]
12
Bonnie C. Guild
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.3.5]
11
Edward Thurston Gibbs
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.4]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
11
William Houle Gibbs
[1.1.1.2.3.1.4.4.6.4.5]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
9
Edna Emma Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
10
Anita Ruth Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.1]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
10
Helen May Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.2]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
10
Howard Joseph Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.3]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
11
Anthony Howard Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.3.1]
11
Stephnie Jeane Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.3.2]
+
Joseph Michael Flynn
11
Nicholas Joseph Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.3.3]
+
Johnna M Verardo
+
Edna Mae Thompson
10
Edna Dorothy Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.4]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
10
Norman Francis Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5]
Margaret (Peggy) Louise Clark
11
Michael Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.1]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
11
Norma Louise Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.2]
Richard Eugene Polen
12
Michael Eugene Polen
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.2.1]
12
Lisa Ann Polen
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.2.2]
12
Holly Louise Polen
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.2.3]
12
Amy Elizabeth Polen
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.2.4]
11
Nancy Nell Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.3]
William Richard Mann
12
Steven Joseph Mann
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.3.1]
[
=>
]
12
Gary Allen Francis Mann
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.3.2]
[
=>
]
12
Richard Lee Mann
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.3.3]
12
Leslie Melinda Mann
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.3.4]
[
=>
]
11
Joseph Edward Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.4]
Mary Helen Norman
12
Marilyn Marie Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.4.1]
[
=>
]
12
Michael Norman Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.5.4.2]
10
Kathryn Alberta Otero
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.6]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
11
Michael Allen McCune
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.6.1]
11
Patricia Lee McCune
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.6.2]
11
Barbara Ruth McCune
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.6.3]
Jewell Ray "Bud" DeShon
12
Linda Lee De Shon
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.6.3.1]
[
=>
]
12
Lori Rae De Shon
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.6.3.2]
[
=>
]
12
Larry Dean De Shon
[1.1.1.2.3.1.4.4.7.6.3.3]
[
=>
]
9
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.4.8]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
10
Anita H. Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
11
Edwin Arthur Heacock
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.1.1]
Dorothy Louise
12
Julie Heacock
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.1.1.1]
11
Caroll Jane Heacock
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.1.2]
11
Vivian L. Heacock
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.1.3]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
10
Chester Arthur Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
10
Flournoy Albert Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
10
Stanley St. Clair Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4]
Eleanor Louise Moore
11
Hollis Eleanor Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.1]
+
Lawrence Terry
Wesley Richard Peterson
12
Logan Sven Peterson
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.1.1]
12
Jordan S. Peterson
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.1.2]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
11
Stanley Robert Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.2]
Evelyn Elizabeth Perkins
12
Robert Erwin William Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.2.1]
12
Elizabeth Ann Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.2.2]
11
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.3]
Hugh Washburn Steven
12
Julia Warren Steven
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.3.1]
[
=>
]
12
David Hugh Steven
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.4.3.2]
[
=>
]
10
Louis Dewey Juch
[1.1.1.2.3.1.4.4.8.5]
8
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.5]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
8
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.2.3.1.4.6]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
9
Louisa Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.6.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
10
Rosalie E. McQuade
[1.1.1.2.3.1.4.6.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
9
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.6.2]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
9
Nellie M Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.6.3]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
9
Edna L. Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.6.4]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
9
William P. Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.6.5]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
9
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.6.6]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
8
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.7]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
8
Mary Julia Yancey
[1.1.1.2.3.1.4.8]
b. 1834
+
William D. Roberts
6
Sarah Simmons
[1.1.1.2.3.2]
b. Abt 1754
6
Thomas Simmons
[1.1.1.2.3.3]
b. Abt 1756
6
Martha Simmons
[1.1.1.2.3.4]
b. 2 Sep 1754 d. 1826
6
Priscilla Simmons
[1.1.1.2.3.5]
b. 1756 d. 1821
6
Hannah Simmons
[1.1.1.2.3.6]
b. Abt 1768 d. 1802
Thomas Graves
b. 1757 d. Bef Apr 1799
7
John Graves
[1.1.1.2.3.6.1]
b. 1773 d. Bef 1815
Mary Yancey
b. Abt 1768
8
Sally Yancey Graves
[1.1.1.2.3.6.1.1]
b. Abt 1798
8
Fannie Yancey Graves
[1.1.1.2.3.6.1.2]
b. Abt 1795
+
Penelope Yancey
b. Abt 1791 d. Aft 1817
6
Alexander Simmons
[1.1.1.2.3.7]
b. Abt 1772
4
Charles Whitaker
[1.1.1.3]
b. 10 Oct 1693 d. 3 Oct 1739
Mary Kimball
b. Abt 1695 d. 30 Aug 1739
5
John Whitaker
[1.1.1.3.1]
b. 2 Jul 1722 d. 13 Feb 1797
+
Mary McComas
b. 8 May 1722 d. 1802