News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Register for a User Account
Home
Search
Login
Find
Surnames
What's New
Most Wanted
Reports
Cemeteries
Media
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
•
First Name:
Last Name:
ID:
Edward Harris
1550 - 1621 (71 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Edward Harris
[1]
b. 1550 d. 1621
Mary Anne Josselyn
b. 1565 d. 18 Jun 1585
2
Thomas Harris
[1.1]
b. 10 Jun 1585 d. 10 Jun 1658
Adria Gurganey
b. 1598 d. 11 Sep 1626
3
Mary Harris
[1.1.1]
b. 1625 d. 18 Mar 1703
3
Richard Harris
[1.1.2]
b. 1630
Joane Vicent Osborne
b. 28 Jan 1597 d. 11 Sep 1635
3
Thomas Harris
[1.1.3]
b. 1627 d. 1701
3
William Harris
[1.1.4]
b. 12 Mar 1630 d. 20 Apr 1678
Lucy Stewart
b. 1629 d. 21 Sep 1690
4
Elizabeth Ann Harris
[1.1.4.1]
b. 2 Nov 1658 d. 15 Oct 1729
4
Thomas Harris
[1.1.4.2]
b. 1669 d. Bef 6 Jul 1730
Mary Jefferson
b. 1679 d. 1 Sep 1745
5
Phoebe Harris
[1.1.4.2.1]
b. Abt 1689 d. Between 1697 and 1800
5
Jr. Thomas Harris, Jr
[1.1.4.2.2]
b. Abt 1690 d. Bef 1 Aug 1741
5
Timothy Harris
[1.1.4.2.3]
b. 1691 d. Jun 1743
5
Francis Harris
[1.1.4.2.4]
b. Abt 1692 d. Jul 1743
5
Sarah Harris
[1.1.4.2.5]
b. Abt 1696 d. Bef 24 Sep 1753
5
William Samuel Harris
[1.1.4.2.6]
b. Abt 1696 d. Bef 18 Dec 1794
+
Elizabeth Ward
b. Abt 1696
Martha Osborne
b. Abt 1700
6
Mary Harris
[1.1.4.2.6.1]
b. Abt 1720
+
Bernard Markham
b. Abt 1720
6
Elizabeth Harris
[1.1.4.2.6.2]
b. Abt 1750
+
Vincent Markham
b. Abt 1750
Martha Ward
b. Abt 1700
6
Thomas Harris
[1.1.4.2.6.3]
b. Abt 1756
+
Carolina Matilda Harris
b. 1 Dec 1756 d. 1815
5
Mary Harris
[1.1.4.2.7]
b. Abt 1698 d. 17 Dec 1759
+
Francis James
b. Abt 1694
John Goode
b. Abt 1698
6
Bennett Goode
[1.1.4.2.7.1]
b. Abt 1710 d. 1771
Martha Jefferson
b. Abt 1712 d. 20 Oct 1796
7
Martha Goode
[1.1.4.2.7.1.1]
b. 1760 d. 1810
Charles Povall
b. 1763 d. 1803
8
Martha Povall
[1.1.4.2.7.1.1.1]
b. 1 Nov 1784
William Carrington
b. 20 Aug 1774 d. 21 May 1825
9
Martha Ann Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1]
b. 26 Feb 1806 d. 29 Apr 1865
Codrington Carrington
b. 23 Oct 1801 d. 10 Sep 1859
10
Willie Ann Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.1]
b. 13 Jun 1833
10
Ellen Maria Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.2]
b. 22 Mar 1836 d. 14 Jul 1873
+
Fox
10
Martha Virginia Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.3]
b. 2 Apr 1839
+
E. C. Mayo
10
Robert Codrington Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4]
b. 6 Sep 1842
Hellen C. Walton
b. Cal 1846
11
Martha Elvira Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.1]
b. 10 Sep 1867
11
Nathaniel W. Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.2]
b. Jul 1868
+
Myrtle H.
Anna V. Woodson
b. Oct 1868 d. Bef 1910
12
Robert Miller Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.2.1]
12
Lilly Marie Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.2.2]
12
William Blair Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.2.3]
12
Alvin Roy Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.2.4]
b. 3 Nov 1900 d. Feb 1970
12
James N. Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.2.5]
11
Collin Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.3]
b. Cal 1870
11
Minnie M. Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.4]
b. Cal 1872
11
Lillian Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.5]
b. Cal 1874
11
Bernard Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.6]
b. Feb 1879
11
Rose Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.4.7]
b. Abt 1880
10
William A. Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.5]
b. 22 Sep 1843 d. 25 Sep 1843
10
Cornelia Booker Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.1.6]
b. 1 Feb 1845
+
T. B. S. Walton
9
Ellen Theodosia Carrington
[1.1.4.2.7.1.1.1.2]
b. 1813 d. 1896
William Royal Bradley
b. 1804 d. 1889
10
Martha Carrington Bradley
[1.1.4.2.7.1.1.1.2.1]
b. 1826/1847 d. 1862/1933
Thomas Pride Shields
b. 1808/1837 d. 1862/1922
11
Martha Tomasia Shields
[1.1.4.2.7.1.1.1.2.1.1]
b. 21 Aug 1859 d. 15 Aug 1944
Joseph Cosgray Sweeney
b. 23 Dec 1859 d. 2 Apr 1945
12
James Chamberlain Sweeney
[1.1.4.2.7.1.1.1.2.1.1.1]
[
=>
]
12
Thomas Shields Sweeney
[1.1.4.2.7.1.1.1.2.1.1.2]
b. 19 Dec 1894 d. 27 Apr 1974 [
=>
]
12
Richmond Carrington Sweeney
[1.1.4.2.7.1.1.1.2.1.1.3]
b. 18 Sep 1896 d. 12 Aug 1966
12
Ruth Virginia Sweeney
[1.1.4.2.7.1.1.1.2.1.1.4]
5
Edith Harris
[1.1.4.2.8]
b. Abt 1700 d. Abt 1745
+
Henry Trent
b. 1676 d. 5 Sep 1726
+
John Osborne
b. Abt 1684
+
Peter Fitzpatrick
b. Abt 1684
5
James Harris
[1.1.4.2.9]
b. Abt 1702 d. Bef 27 Jul 1767
Sarah Bailey
b. Abt 1704
6
John Bailey Harris
[1.1.4.2.9.1]
b. Abt 1732
6
Phoebe Bailey Harris
[1.1.4.2.9.2]
b. Abt 1734
M.B.C.R. Joseph Royal Farrar
b. Abt 1734 d. 1796
7
Mary Farrar
[1.1.4.2.9.2.1]
b. Abt 1766
+
William Wager Harris
b. Abt 1766
6
Mary Harris
[1.1.4.2.9.3]
b. Abt 1736
6
Thomas Bailey Harris
[1.1.4.2.9.4]
b. Abt 1738 d. Bef 22 Nov 1810
+
Frances Moseley
b. Abt 1732
6
James Bailey Harris
[1.1.4.2.9.5]
b. 1749
Ursula Harris Flournoy
b. 15 May 1749
7
III James Harris
[1.1.4.2.9.5.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
8
Alfred Turpin Harris
[1.1.4.2.9.5.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
9
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.4.2.9.5.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
7
Samuel Harris
[1.1.4.2.9.5.2]
b. Abt 1774
7
Elizabeth Harris
[1.1.4.2.9.5.3]
b. Abt 1776
7
Mary Harris
[1.1.4.2.9.5.4]
b. Abt 1778
6
William Bailey Harris
[1.1.4.2.9.6]
b. 1757 d. Abt 1816
+
Mary Pollard
b. Abt 1760 d. Abt 1830
6
Francis Bailey Harris
[1.1.4.2.9.7]
b. Abt 1758
+
Ann Diugud
b. Abt 1760
5
John Harris
[1.1.4.2.10]
b. 28 Mar 1703 d. Aft 28 Mar 1749
Ursula Goode
b. 1707 d. Abt 1734
6
William Harris
[1.1.4.2.10.1]
b. Abt 1728
+
Osborne
b. Abt 1727
+
Elizabeth Evans
b. Abt 1745
6
Elizabeth Harris
[1.1.4.2.10.2]
b. 31 Dec 1729 d. 19 May 1791
Samuel Flournoy
b. 4 Oct 1724 d. 12 Dec 1780
7
Ursula Harris Flournoy
[1.1.4.2.10.2.1]
b. 15 May 1749
James Bailey Harris
b. 1749
8
III James Harris
[1.1.4.2.10.2.1.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
9
Alfred Turpin Harris
[1.1.4.2.10.2.1.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
10
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.4.2.10.2.1.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
8
Samuel Harris
[1.1.4.2.10.2.1.2]
b. Abt 1774
8
Elizabeth Harris
[1.1.4.2.10.2.1.3]
b. Abt 1776
8
Mary Harris
[1.1.4.2.10.2.1.4]
b. Abt 1778
7
Gideon Flournoy
[1.1.4.2.10.2.2]
b. 20 Feb 1751 d. 15 Feb 1821
+
Jane F DeLisle
Grace B. Tarry
b. 1755 d. 20 Dec 1819
8
"Mattie" Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.4.2.10.2.2.1]
b. 1795 d. 10 Oct 1855
Arthur Woodfin
b. 1790 d. 9 Oct 1855
9
William G. Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.1]
b. 1817
9
Richard M. Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.2]
b. 1817
9
Thomas E Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.3]
b. 1818
9
John James Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.4]
b. 19 Mar 1820 d. 23 Sep 1860
9
Charles Newton Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.5]
b. 31 Jul 1824 d. 2 Jul 1912
9
Mary Elizabeth Susan Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.6]
b. 12 Jun 1829 d. 23 Nov 1890
9
Arthur Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.7]
b. 1832
9
Harriet Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.8]
b. 1836
9
Martha Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.1.9]
b. 1838
8
Martha Ann Flournoy
[1.1.4.2.10.2.2.2]
b. Abt 1798 d. 1847
Thomas Woodfin
b. 1795 d. 1853
9
William Thomas Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.2.1]
b. 16 Sep 1822 d. 3 Aug 1894
9
Samuel Flournoy Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.2.2]
b. 4 Aug 1824 d. 14 Feb 1866
9
James Edward Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.2.3]
b. 1826 d. 1889
9
Jane Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.2.4]
b. 1828 d. 1892
9
Frances Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.2.5]
b. 1830
9
George Washington Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.2.6]
b. 15 Mar 1832 d. 3 Aug 1895
9
Martha Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.2.7]
b. 1834
9
Rebecca Woodfin
[1.1.4.2.10.2.2.2.8]
b. 18 Dec 1836 d. 16 Aug 1860
7
John Flournoy
[1.1.4.2.10.2.3]
b. 29 Apr 1754
7
Mary Flournoy
[1.1.4.2.10.2.4]
b. Bef 1756
7
Samuel Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5]
b. 9 Dec 1758 d. 19 Aug 1818
Nancy Ann Martin
b. 1765
8
Amelia Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.1]
b. 1786
8
Matthews Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.2]
b. 1789 d. 1833
8
James Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.3]
b. 1 Jan 1791 d. 3 Mar 1855
+
Martha Halloway
b. 1790 d. 1871
8
Patsy Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.4]
b. 1793
8
Nancy Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.5]
b. 1795
8
Rachel Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.6]
b. 1797
8
Samuel Martin Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.7]
b. 1799 d. 1878
+
Minerva Ann Wadlington
b. 1814 d. 1858
+
Harriett Elvira Fenley
b. 24 Jan 1820
8
Agnes Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.8]
b. 1799
8
Jack Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.9]
b. 1799 d. 1818
8
Emily Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.10]
b. 1801
8
Cassandra Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.11]
b. 1803
8
Martha Flournoy
[1.1.4.2.10.2.5.12]
b. 15 Aug 1813 d. 1891
Randolph Allen Hankla
b. 1 Feb 1803
9
Pendleton Flournoy Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.1]
b. 24 Mar 1831
9
James Marion F. Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.2]
b. 8 Feb 1833
9
John Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.3]
b. 21 Feb 1835
9
Minerva Nancy Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.4]
b. 29 Mar 1837 d. 1 Apr 1898
9
Mary Francis Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.5]
b. 29 Dec 1839
9
Eliza Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.6]
b. 2 Dec 1841 d. 7 Aug 1919
9
Martha Matilda Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.7]
b. 17 Jul 1844
9
Joseph Randolph Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.8]
b. 5 Nov 1847
9
William Harrison Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.9]
b. 17 Feb 1849
9
Ella Eugenia Hankla
[1.1.4.2.10.2.5.12.10]
b. 24 Jul 1853
7
David Flournoy
[1.1.4.2.10.2.6]
b. 14 Apr 1761 d. 30 Jun 1831
+
Elizabeth Mills Britton
b. 17 Oct 1760 d. 30 Jun 1830
7
Hannah Flournoy
[1.1.4.2.10.2.7]
b. Abt 1762
7
Jordan Flournoy
[1.1.4.2.10.2.8]
b. 20 Sep 1763 d. 21 Jun 1833
+
Judith Farrar
b. 21 Apr 1756 d. 1828
7
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.4.2.10.2.9]
b. 25 Nov 1765
+
Isham Britton
b. Bef 1761
7
Thomas Flournoy
[1.1.4.2.10.2.10]
b. Bef 1767
7
Martha Flournoy
[1.1.4.2.10.2.11]
b. Feb 1768
7
Julia Briton Flournoy
[1.1.4.2.10.2.12]
b. Abt 1770
7
Silas F. Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13]
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
Martha Cannon
b. 1775 d. Oct 1817
8
Eliza Susan Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.1]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
9
Martha Harris
[1.1.4.2.10.2.13.1.1]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
9
Alfred H. Harris
[1.1.4.2.10.2.13.1.2]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
9
Eliza Susan Harris
[1.1.4.2.10.2.13.1.3]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
8
Alfred Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
9
Alonzo Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.1]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
10
Belle Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.1.1]
10
Theodosia Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.1.2]
10
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.1.3]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
11
Genevieve McRady
[1.1.4.2.10.2.13.2.1.3.1]
10
James Patteson Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.1.4]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
9
William Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.2]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
10
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.2.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
10
William Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.2.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
10
Alfred Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.2.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
10
Lucien Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.2.4]
b. 22 Feb 1861
9
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.3]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
10
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.1]
10
Alice Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.2]
+
Charles Davis
10
Ruth Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.3]
+
B. H. Davis
10
Pattie Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.4]
Milton Walker Sims
11
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.4.1]
b. 1872
+
Charles Mills
11
Laura Sims
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.4.2]
b. 1873
+
J. Fred Smith
b. Abt 1870
11
Milton Sims
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.4.3]
b. 1876
11
Bartlett Sims
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.4.4]
b. May 1878
+
Almaide Priscilla Kerr
10
Laura Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.5]
Thomas Bell
11
Mary Bell
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.5.1]
+
Edward Gleason
10
Mary Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.6]
+
Napoleon Davis
10
Alfred F. Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.2.3.7]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
9
Martha Moore Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.4]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
9
Eliza Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.5]
b. 29 May 1829 d. INFANT
9
James Silas Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.6]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
9
Alfred F. Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.7]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
10
Mary Patteson Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.7.1]
b. 24 Apr 1866
10
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.7.2]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
10
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.7.3]
b. 21 Feb 1875
10
Spencer Alston Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.7.4]
b. Aug 1879
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
9
Maria Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.8]
b. 1837 d. 1841
9
David Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.9]
b. 1842 d. 1856
9
Charles Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.10]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
9
Mary Camp Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
9
Indiana Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.12]
b. 1847
9
Martha Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.2.13]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
8
William Cannon Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
9
Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.1]
b. 1829 d. 1829
9
Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.2]
b. 1833 d. 1833
9
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.3]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
10
Mary Lou Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.3.1]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
10
III William Cannon Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.3.2]
b. 8 Apr 1872
10
John Walker Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.3.3]
b. 24 Jan 1874
10
Martha Julia Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.3.4]
b. 13 Sep 1875
10
Ezell Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.3.5]
b. 9 Dec 1878
9
John J. Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.4]
b. 1838
9
Martha Julia Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.3.5]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
10
Flournoy Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.3.5.1]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
11
John Avirett Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.3.5.1.1]
b. 22 Mar 1894
10
John Harper Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.3.5.2]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
10
Tyree Rodes Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.3.5.3]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
10
William Cannon Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.3.5.4]
b. 11 Jan 1866
10
Julian Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.3.5.5]
b. 23 Dec 1868
10
Myra Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.3.5.6]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
8
Martha C. Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.4]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
9
Silas Flournoy Trotter
[1.1.4.2.10.2.13.4.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
8
Louisa Ann Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.5]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
9
Joseph Trotter Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
10
Robert Lee Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.1]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
10
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
11
Anita H. Juch
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
12
Vivian L. Heacock
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.1.1]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
12
Caroll Jane Heacock
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.1.2]
12
Edwin Arthur Heacock
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.1.3]
[
=>
]
11
Chester Arthur Juch
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
11
Flournoy Albert Juch
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
11
Stanley St. Clair Juch
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.4]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
12
Stanley Robert Juch
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.4.1]
[
=>
]
12
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.4.2]
[
=>
]
Eleanor M Juch
12
Hollis Eleanor Juch
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.4.3]
[
=>
]
11
Louis Dewey Juch
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.2.5]
10
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.3]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
10
Adella Frances Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.4]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
11
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.4.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
12
Jerome Anthony Goodall
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.4.1.1]
[
=>
]
12
John Patrick Goodall
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.4.1.2]
[
=>
]
12
Francis Joseph Goodall
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.4.1.3]
+
Frank G Curran
10
Mary Anna "Mayme" Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.5]
b. 8 Dec 1874 d. 18 Sep 1968
Maclovio Danislao De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
11
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.5.1]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
11
Orman Joe De Arnaz
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.5.2]
+
Alma Viola
10
Anita Josephine Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.6]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
10
Edna Emma Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
11
Helen May Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.1]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
11
Edna Dorothy Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.2]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
11
Anita Ruth Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.3]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
11
Norman Francis Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.4]
Margaret (Peggy) Louise Clark
12
Nancy Nell Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.4.1]
[
=>
]
12
Joseph Edward Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.4.2]
[
=>
]
12
Norma Louise Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.4.3]
[
=>
]
12
Michael Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.4.4]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
11
Kathryn Alberta Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.5]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
12
Patricia Lee McCune
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.5.1]
12
Barbara Ruth McCune
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.5.2]
[
=>
]
12
Michael Allen McCune
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.5.3]
11
Howard Joseph Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.6]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
12
Anthony Howard Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.6.1]
12
Stephnie Jeane Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.6.2]
12
Nicholas Joseph Otero
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.7.6.3]
+
Edna Mae Thompson
10
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
11
Alberta Isabel Houle
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.1]
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
Jeptha Milton Gibbs, III
b. 17 Jan 1901 d. 9 Nov 1973
12
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.1.1]
[
=>
]
12
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.1.2]
[
=>
]
12
Edward Thurston Gibbs
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.1.3]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
12
William Houle Gibbs
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.1.4]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
12
Jane Gibbs
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.1.5]
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
b. 24 Feb 1900 d. Feb 1973
11
Dorothy Louise Houle
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.2]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
12
Constance L Scully
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.2.1]
12
John Dennis Scully
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.2.2]
12
Brian C. Scully
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.2.3]
11
Anna Josephine Houle
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.3]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
12
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.3.1]
[
=>
]
11
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.4]
Eugenia Joyce Barker
12
Winifred Catherine Houle
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.4.1]
[
=>
]
12
Jennifer Alberta Houle
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.4.2]
[
=>
]
12
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.4.2.10.2.13.5.1.8.4.3]
[
=>
]
9
Simon Bolivar Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.2]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
9
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.4.2.10.2.13.5.3]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
10
Louisa Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.3.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
11
Rosalie E. McQuade
[1.1.4.2.10.2.13.5.3.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
10
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.3.2]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
10
Edna L. Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.3.3]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
10
Henry Crowell Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.3.4]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
10
Nellie M Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.3.5]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
10
William P. Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.3.6]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
9
Laura Ann Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.4]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
10
Laura Ann Black
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.1]
10
Louisa Catherine Black
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
11
Leroy Black Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.1]
b. 1864 d. 1934
11
Mary Lou Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.2]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
12
Sadie Louise Gilbert
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.2.1]
[
=>
]
12
Robert Lester Gilbert
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.2.2]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953 [
=>
]
12
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.2.3]
12
Leon Gilbert
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.2.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
11
Laura Jane Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.3]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
12
Gilbert Buford Dickey
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.3.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown [
=>
]
12
Louise Dickey
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.3.2]
b. Jan 1899 [
=>
]
11
Emily Olivia Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.4]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
12
Thomas Leroy Tatum
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.4.1]
12
Myra Tatum
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.4.2]
[
=>
]
11
Levair Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.5]
b. Abt 1869
11
John A. Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.6]
b. 1873 d. 1874/1963
11
Ernest M. Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.7]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
11
Frank Leon Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.8]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
12
Richard Leon Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.8.1]
[
=>
]
11
James Carley Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.9]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
12
William Lambeth Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.9.1]
[
=>
]
12
James Lester
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.2.9.2]
10
Leroy M. Black
[1.1.4.2.10.2.13.5.4.3]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
9
Martha Keziah Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.5]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
9
Mary Julia Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.6]
b. 1834
+
William D. Roberts
9
Flournoy Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.7]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
10
Alice Fletcher Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.1]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
11
Thomas Asbury Dawes
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.1.1]
b. 4 Apr 1895
11
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.1.2]
b. 29 Jan 1897 d. 24 Nov 1973
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
Willie Crook
b. Abt 1901
12
Fergene Dawes Richmond
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.1.2.1]
11
Alice LaFavia Dawes
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.1.3]
+
Glen Carl Moody
11
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.1.4]
b. 20 Mar 1902 d. 19 Apr 1974
Mary Ona Kitchens
12
Frank Leslie Dawes
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.1.4.1]
12
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.1.4.2]
[
=>
]
10
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.2]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
11
Martha Lafavre Bishop
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.2.1]
11
Richard Yancey Bishop
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.2.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
10
Cora Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
10
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.7.4]
b. Jul 1882
9
Thomas Leroy Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.8]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
10
Lucy M. Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
11
George L Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.1.1]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
11
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.1.2]
b. 1886
11
Rosa Mai Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.1.3]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
11
Wilber Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.1.4]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
12
Mabel Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.1.4.1]
11
Thomas Webber Wilson
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.1.5]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
10
Webber Yancey
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
10
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.4.2.10.2.13.5.8.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
8
Mary Amanda Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.6]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
9
James Alexander Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.1]
b. 30 May 1823
9
Mary Eliza Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.2]
b. 1 Jul 1825
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
10
Maud Officer
[1.1.4.2.10.2.13.6.2.1]
b. 9 May 1847
10
Eustis Field Officer
[1.1.4.2.10.2.13.6.2.2]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
10
William P. Officer
[1.1.4.2.10.2.13.6.2.3]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
10
Myra Flournoy Knapp
[1.1.4.2.10.2.13.6.2.4]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
9
Jr. William Hume Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
9
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.4]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
9
Silas Flournoy Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
9
Henrietta Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.6]
b. 1833 d. 1833
9
Margaret Julia Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.7]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
9
Julian Clarence Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.8]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
9
Florence Huntley Field
[1.1.4.2.10.2.13.6.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
8
Madison Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.7]
b. 1807
8
Julia Ann Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.8]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
9
Eliza Mildred Feild
[1.1.4.2.10.2.13.8.1]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
10
Julia Batte
[1.1.4.2.10.2.13.8.1.1]
+
W. R. Garrett
10
Mildred Batte
[1.1.4.2.10.2.13.8.1.2]
10
E. F. Batte
[1.1.4.2.10.2.13.8.1.3]
9
Hume Rigg Feild
[1.1.4.2.10.2.13.8.2]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
8
Silas Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
9
III Silas Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.1]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
10
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.1.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
10
Silas Camp Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.1.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
9
Lucien Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.2]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
10
Caroline Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.2.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
9
Mary Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.3]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
10
James P. Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.9.3.1]
b. Bef 1863
10
Elizabeth Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.9.3.2]
b. Bef 1865
10
Mary Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.9.3.3]
b. Bef 1867
10
William W. Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.9.3.4]
b. Bef 1869
10
Silas Flournoy Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.9.3.5]
b. Bef 1871
10
Martha Rivers
[1.1.4.2.10.2.13.9.3.6]
b. Bef 1873
9
Camp Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
10
Lucien Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
11
Lillian May Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.1.1]
b. 1906
11
Mary Wise Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.1.2]
b. 1911
11
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.1.3]
b. 1914
11
Laura Louise Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.1.4]
11
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.1.5]
10
John Wise Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
11
Louise Wise Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.2.1]
b. 1907
11
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.2.2]
b. 1912
Minnie Childress Cole
12
Thomas Cole Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.2.2.1]
11
Camp Rogers Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.2.3]
11
Betty McAfee Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.2.4]
10
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
11
Eloise Walker
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
+
Raymond Grady Thomas
11
Newton Flournoy Walker
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
+
Rose Mary Bozeman
+
Valta Irene Gholston
11
Lucien John Walker
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972
Janie Lucile Stallcup
b. 1912
12
Lou Anne Walker
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.3.3.1]
[
=>
]
11
Jane Louise Walker
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.3.4]
+
Benjamin Elliot Mosher
11
Jacob Camp Walker
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.3.5]
+
Ouida Louise Gill
10
Augusta Mary Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
11
Georgia Louia May
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.4.1]
b. 1899
11
Elizabeth Wise May
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.4.2]
b. 1902
11
James Kathryn May
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.4.3]
b. 1902
11
Norma Lucile May
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.4.4]
b. 1902
11
Julia Flournoy May
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.4.5]
Robert Henry Mays
12
Judy Mays
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.4.5.1]
12
Robert Mays
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.4.5.2]
d. INFANT
10
Julia Rivers Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
11
Andrew Booty Jordan
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.5.1]
Mattie Lou Shaw
12
Jr. Andrew Booty Jordan
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.5.1.1]
[
=>
]
12
Lou Ann Jordan
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.5.1.2]
[
=>
]
12
John Franklin Jordan
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.5.1.3]
[
=>
]
12
Gwen Elizabeth Jordan
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.5.1.4]
11
Lucien Wise Jordan
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.5.2]
b. 1914
10
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
11
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.6.1]
11
Mary Louise Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.6.2]
11
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.4.6.3]
9
Elizabeth Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.9.5]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
10
Maude Eustace Duncan
[1.1.4.2.10.2.13.9.5.1]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
10
Duncan
[1.1.4.2.10.2.13.9.5.2]
b. Bef 1870 d. 1876
8
Sarah Flournoy
[1.1.4.2.10.2.13.10]
b. 1816
6
Ursula Harris
[1.1.4.2.10.3]
b. Abt 1731
6
John Jordan Harris
[1.1.4.2.10.4]
b. 1732 d. Bef 19 Nov 1800
Anne Obedience Turpin
b. 17 Sep 1734 d. 8 Aug 1800
7
Lucy Harris
[1.1.4.2.10.4.1]
b. 1756 d. 1832
Obadiah Smith
b. Abt 1756
8
Mary Burke Smith
[1.1.4.2.10.4.1.1]
b. 9 Jun 1781
7
Carolina Matilda Harris
[1.1.4.2.10.4.2]
b. 1 Dec 1756 d. 1815
+
Thomas Harris
b. Abt 1756
7
John Turpin Harris
[1.1.4.2.10.4.3]
b. 12 Oct 1758 d. 1815
Rebecca Britton
b. Abt 1770
8
Hiram Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1]
b. 15 Sep 1796 d. 3 Jun 1867
Margaret Christian Harris
b. Abt 1796 d. Mar 1825
9
Rebecca Ann Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.1]
b. 3 Mar 1823
+
Alfred Douglas
b. Abt 1823
+
John Wilson
b. Abt 1823
9
Henry Benskin Christian Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2]
b. 3 Feb 1825
Sarah C. Calvert
b. 9 Mar 1834/1835 d. 18 Mar 1865
10
Rebecca D Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.1]
b. 20 May 1852
+
Spencer L Barnes
b. Abt 1852
10
Hiram Henry Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.2]
b. 31 Jul 1855
10
Martha W. Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.3]
b. 7 Aug 1859
+
Jesse Gordon Roach
b. 1855 d. 1937
10
Catherine B. Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.4]
b. Aug 1861
+
William T. Barnett
b. Abt 1861
10
James Clay Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.5]
b. 16 Oct 1868
+
Mary Anderson
b. Abt 1868
+
Sarah A. Farris
Elizabeth Ann Daniels
b. 17 Oct 1842
10
Margaret Christian Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.6]
b. 10 Jan 1871
+
James A. Gaunt
b. Abt 1870
10
Pauline B. Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.7]
b. 20 Apr 1873 d. 29 Oct 1974
10
Robert D. Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.8]
b. 31 Mar 1875 d. 8 Oct 1875
10
Sallie Tilden Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.9]
b. 9 Sep 1877 d. 1952
+
James Henry Brown
b. 1869 d. 1949
10
William Henry "Hiram" Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.10]
b. 7 May 1879 d. 1944
Anna E. Ogden
b. 1884 d. 1941
11
Miles Franklin Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.10.1]
10
Mary Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.11]
b. 15 Jun 1880
Robert Granville Gaunt
b. Abt 1880
11
Mary Gladys Gaunt
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.11.1]
b. Abt 1902
10
Jesse B. Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.2.12]
b. Mar 1882
Margaret Wilson
b. Abt 1796 d. Abt 1827
9
Mary Eleanor Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.3]
b. 28 Sep 1827
Elizabeth George
b. Abt 1796
9
John Wilson Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.4]
b. 1837 d. Aft 1867
9
Jr. Hiram Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.5]
b. 1840
+
Frances Gordon
b. Abt 1840
9
Mary Eleanor Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.6]
b. Abt 1845
+
McRae
b. Abt 1845
9
Margaret Elizabeth Harris
[1.1.4.2.10.4.3.1.7]
b. 1847
John E. Benson
b. Abt 1847
10
Eleanor Harris Benson
[1.1.4.2.10.4.3.1.7.1]
b. Abt 1870
+
Frances Gordon
b. Abt 1825
7
Judith Harris
[1.1.4.2.10.4.4]
b. 1760
+
John Crittenden
b. Abt 1759
7
Jordan Turpin Harris
[1.1.4.2.10.4.5]
b. 20 May 1763 d. 1826
Elizabeth Mosby Cannon
b. Abt 1763
8
James Madison Harris
[1.1.4.2.10.4.5.1]
b. 1776
Caroline John
b. Abt 1776
9
Md William Jordan Harris
[1.1.4.2.10.4.5.1.1]
b. Abt 1800
+
Mary Helen Epes
b. Abt 1800
8
Horatio Turpin Harris
[1.1.4.2.10.4.5.2]
b. 1799 d. 1855
+
Keturah
b. Abt 1799
8
John Francis Harris
[1.1.4.2.10.4.5.3]
b. 1808 d. 1880
+
Mary Duke Patten
b. Abt 1808
+
Ann Price
b. Abt 1763
7
Mary Elizabeth Josepha Harris
[1.1.4.2.10.4.6]
b. 1767
7
Francis Turpin Harris
[1.1.4.2.10.4.7]
b. 7 May 1768 d. 5 Dec 1836
+
Sally Gaines
b. Abt 1768
7
Polly Harris
[1.1.4.2.10.4.8]
b. 1774
Elizabeth Robards
b. Abt 1700
6
Jesse Harris
[1.1.4.2.10.5]
c. 14 Jun 1741
5
Martha Harris
[1.1.4.2.11]
b. Abt 1706 d. 1743
+
William Pasture
b. Abt 1702
5
Ann Harris
[1.1.4.2.12]
b. 1708
Booth
b. Abt 1700
6
Anne Booth
[1.1.4.2.12.1]
b. Abt 1735 d. 1758
Samuel Yeargain
b. Abt 1735 d. Aft 24 Dec 1784
7
Sarah Ann Yeargain
[1.1.4.2.12.1.1]
b. 1752 d. 1786
William Alston
b. 1748 d. 1789
8
John Joseph Alston
[1.1.4.2.12.1.1.1]
b. Abt 1775 d. 1 Apr 1831
Elizabeth Jones
b. Abt 1775
9
Nancy Alston
[1.1.4.2.12.1.1.1.1]
b. Abt 1800
+
John Degraaffenreidt
b. Abt 1800
9
Mary Ann Alston
[1.1.4.2.12.1.1.1.2]
b. Abt 1802
+
Thomas Degraaffenreidt
b. Abt 1802
James Taylor
b. Abt 1802
10
Joe Taylor
[1.1.4.2.12.1.1.1.2.1]
b. Abt 1838
+
Anna Alston
b. Abt 1838
8
William Chancy Alston
[1.1.4.2.12.1.1.2]
b. Abt 1777 d. 1789
8
Samuel Yeargan Alston
[1.1.4.2.12.1.1.3]
b. Abt 1779 d. Bef 1789
8
Oroondates Davis Alston
[1.1.4.2.12.1.1.4]
b. Abt 1781 d. 15 May 1851
+
Medley Medley
b. Abt 1781
8
Nancy Ann Alston
[1.1.4.2.12.1.1.5]
b. Abt 1783 d. 1860
+
Robert Palmer
b. Abt 1783
8
Mary Ann Alston
[1.1.4.2.12.1.1.6]
b. 9 Jun 1785 d. 8 Sep 1867
Edwards Rives
b. 19 Mar 1775 d. 2 Feb 1840
9
Sarah G. Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.1]
b. 11 Sep 1801 d. Bef 1830
9
William Alston Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.2]
b. 1 Nov 1803
9
Martha K. Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.3]
b. Oct 1806
+
John Jackson Goldston
b. Abt 1806
9
Oran D. Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.4]
b. 24 Sep 1808
9
Anna Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.5]
b. 14 Feb 1810
+
William Goldson Harris
b. Abt 1810
9
Robert Edwards Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.6]
b. 24 May 1812 d. 1861
+
Mary Antoinette Brown
b. 16 Jun 1833
9
Thomas T. Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.7]
b. 28 Jul 1814
9
James Franklin Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.8]
b. 13 Jun 1820
9
Mary Edwards Rives
[1.1.4.2.12.1.1.6.9]
b. 27 Dec 1827 d. 13 Nov 1873
+
Aaron Gaston Headen
b. 21 Aug 1822 d. 1 Mar 1907
+
Samuel Yeargain
b. 1707 d. 24 Dec 1784
5
Benjamin Harris
[1.1.4.2.13]
b. Abt 1710 d. Aft 24 Apr 1776
Frances Platt
b. Abt 1710
6
Mary Harris
[1.1.4.2.13.1]
b. Abt 1744
+
Sion Spencer
b. Abt 1744
6
Anne Harris
[1.1.4.2.13.2]
b. 1745
+
Joel Estes
b. 1741 d. 1825
Priscilla Wager
b. Abt 1710
6
Henson Wager Harris
[1.1.4.2.13.3]
b. 1753
+
Edward Moseley
b. Abt 1753
6
Phoebe Harris
[1.1.4.2.13.4]
b. 1755
Nathaniel Carrington
b. 28 Feb 1743/44 d. Nov 1803
7
Frances Ann Carrington
[1.1.4.2.13.4.1]
7
Henningham Carrington
[1.1.4.2.13.4.2]
6
Edith Harris
[1.1.4.2.13.5]
b. 1757 d. Aft 18 Nov 1779
6
William Wager Harris
[1.1.4.2.13.6]
b. Abt 1766
+
Mary Farrar
b. Abt 1766
3
Edward Harris
[1.1.5]
b. 1631