News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Mary Hatton
1610 - 1657 (47 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Mary Hatton
[1]
b. 1610 d. 29 Aug 1657
John Whitath
b. 1605
2
Elizabeth Whitath
[1.1]
b. 1630 d. Abt 1714
John Williams
b. 5 Aug 1615 d. 1686
3
James Williams
[1.1.1]
b. 1663 d. 1696
Elizabeth Buckner
b. 1675 d. 1740
4
Elizebeth Williams
[1.1.1.1]
b. 27 Aug 1693
4
Mary Williams
[1.1.1.2]
b. 25 Dec 1695 d. 25 Mar 1740
Jean Jacques Flournoy
b. 17 Nov 1686 d. 23 Mar 1740
5
Rachel Flournoy
[1.1.1.2.1]
b. 25 Sep 1730 d. 28 Aug 1741
5
David Flournoy
[1.1.1.2.2]
b. 3 Sep 1728 d. 18 Oct 1757
5
Mathews Flournoy
[1.1.1.2.3]
b. 21 Jun 1732 d. 1785
Elizabeth Ann Pryor
b. 1739 d. Jun 1798
6
Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.2.3.1]
b. 13 May 1763 d. 5 Jul 1825
Mary Willis Cobbs
b. 15 Apr 1777 d. 8 Feb 1829
7
Howell Cobb Flournoy
[1.1.1.2.3.1.1]
b. 21 Mar 1813 d. 1872
7
Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.2.3.1.2]
b. 5 Mar 1811 d. 24 Aug 1894
Amanda Cullens
b. 1816 d. Bef 1858
8
Elizabeth M. Flournoy
[1.1.1.2.3.1.2.1]
b. 24 Jul 1844
A. E. Andrews
9
Robert Watkins Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.1.1]
b. 1867 d. Bef 1900
Anna Roberta Flournoy
b. Dec 1868 d. Aft 1900
10
Albert R. Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.1.1.1]
b. 1869
10
Elizabeth F. Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.1.1.2]
b. 1882
10
Gasaway Knight Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.1.1.3]
b. 1887
10
Haynes Cullens Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.1.1.4]
8
Jr. Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.2.3.1.2.2]
b. 13 Dec 1841 d. 8 Jun 1869
Ophelia C. Tucker
b. 6 Oct 1844 d. Aft 1900
9
Robert Willis Flournoy
[1.1.1.2.3.1.2.2.1]
b. 22 Sep 1867
+
Martha Redd Fontaine
b. Sep 1873
9
Anna Roberta Flournoy
[1.1.1.2.3.1.2.2.2]
b. Dec 1868 d. Aft 1900
Robert Watkins Andrews
b. 1867 d. Bef 1900
10
Albert R. Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.2.2.1]
b. 1869
10
Elizabeth F. Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.2.2.2]
b. 1882
10
Gasaway Knight Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.2.2.3]
b. 1887
10
Haynes Cullens Andrews
[1.1.1.2.3.1.2.2.2.4]
Louisa St. Clair Cullens
b. 9 Feb 1838 d. 9 Oct 1916
8
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.2.3.1.2.3]
b. 24 Sep 1858 d. 14 May 1929
James Wilson Bell
b. 6 May 1853 d. 27 Oct 1925
9
Rosa Wilson Bell
[1.1.1.2.3.1.2.3.1]
+
Robert Lee Campbell
b. 25 Nov 1882 d. 11 Aug 1952
9
Mary Cobb Bell
[1.1.1.2.3.1.2.3.2]
b. 17 Jan 1885 d. 8 Mar 1965
+
Erskine Miller Carr
b. 22 Jan 1883 d. 17 Oct 1932
9
Watkins Flournoy Bell
[1.1.1.2.3.1.2.3.3]
b. Jan 1895 d. Bef 1950
+
Whitfield King
d. Bef 1950
9
Lillian Tennille Bell
[1.1.1.2.3.1.2.3.4]
+
Henry Pittman Hurt
b. 26 Feb 1872 d. 20 Nov 1944
9
Robert Flournoy Bell
[1.1.1.2.3.1.2.3.5]
b. 27 Apr 1879 d. 30 Jun 1896
9
James Bell
[1.1.1.2.3.1.2.3.6]
b. 6 May 1891 d. 27 Jan 1893
9
Mary Louise Bell
[1.1.1.2.3.1.2.3.7]
b. 3 Jun 1877 d. 6 Nov 1878
7
Marcus Aurelius Flournoy
[1.1.1.2.3.1.3]
b. 9 Oct 1795
7
Thomas Howell Flournoy
[1.1.1.2.3.1.4]
b. 19 Mar 1797 d. 1797
7
Elizabeth America Flournoy
[1.1.1.2.3.1.5]
b. 18 May 1800 d. INFANT
7
Robert Willis Flournoy
[1.1.1.2.3.1.6]
b. 11 Dec 1802 d. Jan 1845
7
Mary Mildred Flournoy
[1.1.1.2.3.1.7]
b. 8 Jan 1805 d. 1874
+
Nathaniel Alexander Adams
d. 28 Aug 1849
7
John James Flournoy
[1.1.1.2.3.1.8]
b. 15 Aug 1808
7
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.2.3.1.9]
b. 25 May 1815 d. 14 Apr 1844
Charles G. McKinley
8
William M. McKinley
[1.1.1.2.3.1.9.1]
b. 1 May 1835
8
Mary Elizabeth McKinley
[1.1.1.2.3.1.9.2]
b. 16 Sep 1840 d. 25 Apr 1845
8
Elizabeth Julia McKinley
[1.1.1.2.3.1.9.3]
d. 25 Apr 1845
6
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.2.3.2]
b. 1768 d. 1813
William Gustavus Henry
b. 1761 d. 1824
7
William Henry
[1.1.1.2.3.2.1]
b. 1793 d. 1847
Cornelia VaVasour Gano
b. 20 Apr 1801 d. 2 Mar 1887
8
Robert William Henry
[1.1.1.2.3.2.1.1]
b. 1823 d. 1862
Martha Douglas Cocke
b. 17 Dec 1822 d. 28 Mar 1850
9
Martha Douglas Henry
[1.1.1.2.3.2.1.1.1]
b. 24 Feb 1850 d. 29 Jan 1924
Leonidas Armstead Sypert
b. 1832 d. 1893
10
Susan Jouett Sypert
[1.1.1.2.3.2.1.1.1.1]
b. 1881 d. 1 Sep 1954
Charles Washington Johnston
b. 1871 d. 1 Dec 1958
11
Abraham Russel Johnston
[1.1.1.2.3.2.1.1.1.1.1]
b. 31 Aug 1914 d. 14 Dec 1943
Jane Roberta White
12
Jr. Abraham Russel Johnston
[1.1.1.2.3.2.1.1.1.1.1.1]
7
Matthews Winston Henry
[1.1.1.2.3.2.2]
b. 11 Jan 1790
6
Martha Caroline Flournoy
[1.1.1.2.3.3]
b. 1764 d. 1803/1806
John Thomas Wells
b. 1760 d. 1802
7
Francis Flournoy Wells
[1.1.1.2.3.3.1]
b. Abt 1800 d. Nov 1866
Martha McNutt
8
Robert Williamsom Wells
[1.1.1.2.3.3.1.1]
b. 3 Aug 1849
8
Lucky Francis Wells
[1.1.1.2.3.3.1.2]
b. 18 May 1846 d. 1915
Francis M. Sutherland
9
Flora S. Wells
[1.1.1.2.3.3.1.2.1]
b. Feb 1881
9
Thomas J. Wells
[1.1.1.2.3.3.1.2.2]
b. Oct 1878
9
Robert W. Wells
[1.1.1.2.3.3.1.2.3]
b. Sep 1875
8
Flora Adelia Wells
[1.1.1.2.3.3.1.3]
b. 31 Dec 1833 d. 25 Dec 1914
George F. Simons
b. 14 Feb 1834
9
George F. Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1]
b. Jul 1872
Mary Lula Rose
b. 31 May 1874
10
Mattie L. Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.1]
+
Andrew J. Garner
b. Abt 1883
10
Volney Rose Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.2]
Elizabeth Cooper
11
Nancy Lois Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.2.1]
10
Steele White Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.3]
Elizabeth Winston
11
Dennis Steele Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.3.1]
Kay Lynn Wolters
12
Ann Elizabeth Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.3.1.1]
12
Susan Lynn Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.3.1.2]
11
Suzanne Elizabeth Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.3.2]
10
George Wells Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.1.4]
b. 1912
9
F. Wells Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.2]
b. Aug 1868
Susan Ann Rose
b. Apr 1871
10
George F. Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.2.1]
b. Apr 1898
10
Flora L. Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.2.2]
b. Jul 1894
9
William U. Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.3]
b. 1866
9
Courtney Stuart Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.4]
b. 1865
10
Jr. Courtney Stuart Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.4.1]
10
Kerr Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.4.2]
b. Yes, date unknown
9
Martha W. Simons
[1.1.1.2.3.3.1.3.5]
b. 1861
8
Elizabeth Casandra Wells
[1.1.1.2.3.3.1.4]
b. 1828
8
Laura Martha McNutt Wells
[1.1.1.2.3.3.1.5]
b. 13 Jul 1827
Clark Lewis Owen
b. 6 Jun 1807 d. 6 Apr 1862
9
Owen
[1.1.1.2.3.3.1.5.1]
b. 1852
9
Laura Minta Owen
[1.1.1.2.3.3.1.5.2]
b. 1850 d. Mar 1885
John Owen Rowlett
b. 6 Aug 1847 d. 21 Oct 1918
10
Henry J. Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.1]
b. 1879
10
A. Owen Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.2]
b. 1880 d. 1942
10
Mary Laura Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.3]
b. 1873
10
John O. II Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.4]
b. 1875
10
Ruth I. Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.5]
b. 1876 d. Sep 1957
10
George Simons Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.6]
b. 4 Sep 1884 d. 1956
Mattie Virginia Richey
11
Myrtle Flora Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.6.1]
Rex Emmett Lovejoy
12
Lovejoy
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.6.1.1]
b. 22 Jun 1937 d. 1937
11
Grover Owen Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.6.2]
+
Ann
Carrie Nell Savage
12
Owen Blinsky
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.6.2.1]
[
=>
]
12
Lawrence Neal Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.6.2.2]
10
Flora Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.7]
10
Pansy Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.8]
10
Laura Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.9]
10
Daniel Rowlett
[1.1.1.2.3.3.1.5.2.10]
7
Lewis Wells
[1.1.1.2.3.3.2]
7
Martha Wells
[1.1.1.2.3.3.3]
7
Cassandra Wells
[1.1.1.2.3.3.4]
7
Frank Wells
[1.1.1.2.3.3.5]
7
John J. Wells
[1.1.1.2.3.3.6]
7
Thomas Flournoy Wells
[1.1.1.2.3.3.7]
5
John Flournoy
[1.1.1.2.4]
b. 9 Dec 1726 d. 19 Jan 1825
+
Camilla Ballexserd
b. 1722 d. 1743
5
Thomas Flournoy
[1.1.1.2.5]
b. 20 Nov 1738 d. 25 Feb 1801
Anne Martin
d. 1814
6
Lucy Faris Flournoy
[1.1.1.2.5.1]
b. 1786 d. 1836
William Booker Morton
b. 3 Sep 1775 d. 10 Aug 1816
7
Elvira Henry Morton
[1.1.1.2.5.1.1]
b. 1806 d. 1840
William Peter Barksdale
b. 1799 d. 1854
8
Louisa Frances Barksdale
[1.1.1.2.5.1.1.1]
b. 1830 d. 1907
John Bullock Crews
b. 1814 d. 1882
9
Louise Barksdale Crews
[1.1.1.2.5.1.1.1.1]
9
Frances Sydnor Crews
[1.1.1.2.5.1.1.1.2]
9
Rosa Crews
[1.1.1.2.5.1.1.1.3]
+
Nicholas Hairston
7
Anne Martin Morton
[1.1.1.2.5.1.2]
b. 1804
William Henry Dennis
b. 1801 d. 1866
8
Jacob Dennis
[1.1.1.2.5.1.2.1]
7
Mary Elizabeth Morton
[1.1.1.2.5.1.3]
b. 24 Apr 1808 d. 13 Dec 1889
William Sydnor Barksdale
b. 7 May 1806 d. 10 Sep 1874
8
Lucy Ann Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.1]
b. 4 Oct 1828 d. 11 Jan 1906
James Woodford Arendall
b. 20 Jan 1820 d. 17 Mar 1871
9
Lucy Flournoy Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.1]
b. 5 Jun 1862 d. 11 Dec 1888
9
Judith Williams Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.2]
b. 16 Sep 1865 d. 31 Aug 1896
Robert V. Farmer
10
Maude M. Farmer
[1.1.1.2.5.1.3.1.2.1]
b. 10 Mar 1885
9
Elizabeth Frances Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.3]
b. 23 May 1867 d. 12 Jun 1895
W. G. Slayton
10
Hattie S. Slayton
[1.1.1.2.5.1.3.1.3.1]
b. 15 Jan 1885 d. 12 Sep 1886
9
Virginia Alice Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.4]
b. 26 Dec 1869
Charles King Petty
10
Henry T. Petty
[1.1.1.2.5.1.3.1.4.1]
b. 3 Oct 1896
9
William Barksdale Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5]
b. 25 Apr 1849 d. 11 Nov 1911
Phebe Pennich Dixon
d. 11 Jul 1898
10
Agis Lycurgus Lafayette Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.1]
b. 16 Dec 1871
10
Thomas Frank Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.2]
b. 30 May 1874
+
E. Lillian Walker
10
Morton Armistead Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.3]
b. 2 Aug 1877 d. 2 Aug 1879
10
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.4]
b. 8 Jan 1880
+
William H. Douglas
10
Alice M. Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.5]
b. 10 Jun 1884
10
Lou Boyd Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.6]
b. 27 Jul 1888 d. 11 Sep 1889
10
Rosa Crews Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.7]
b. 18 Mar 1891 d. Jan 1970
Christopher Columbus Tankersley
b. 10 Sep 1884 d. 1921
11
Earl Willard Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.7.1]
+
Wilsie Alma Ferguson
11
Lorine Edith Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.7.2]
+
James Dillard Pruitt
11
Irvin W. Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.7.3]
11
Annie Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.5.7.4]
9
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.6]
b. 23 Apr 1851 d. 28 Sep 1853
9
Ann Catherine Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.7]
b. 7 Mar 1853 d. 15 Jul 1882
Alexander D. Thompson
10
Sandy S. Thompson
[1.1.1.2.5.1.3.1.7.1]
b. 5 Jul 1878
10
Adel May Thompson
[1.1.1.2.5.1.3.1.7.2]
b. 30 Apr 1881 d. 18 Mar 1882
10
Maud Iola Thompson
[1.1.1.2.5.1.3.1.7.3]
b. 16 Feb 1879
10
John Armistead Thompson
[1.1.1.2.5.1.3.1.7.4]
b. 9 Oct 1876 d. 20 Jun 1878
10
Charles Woodford Thompson
[1.1.1.2.5.1.3.1.7.5]
b. 10 Oct 1873
10
William M.B. Thompson
[1.1.1.2.5.1.3.1.7.6]
b. 25 Jun 1875
9
John Armstead Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8]
b. 12 Jan 1855 d. 1 Jul 1935
Alice Madison Cole
b. 3 Feb 1854 d. 29 Jan 1940
10
John William Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.1]
b. 19 Nov 1885 d. 31 Mar 1936
Marguerite A. Krebs
d. 27 Jun 1919
11
John Madison Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.1.1]
+
Virginia Mae Chappelle
b. 24 May 1919
11
Alice Marguerite Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.1.2]
11
Annette Elaine Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.1.3]
10
James Newton Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.2]
b. 11 Jul 1877
10
Luella T. Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.3]
b. 6 Oct 1879 d. 10 Sep 1964
Luther A. Irby
b. 11 May 1871 d. 29 Jul 1953
11
John Ferman Irby
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.3.1]
+
Katherine Womack
11
Jr. Luther A. Irby
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.3.2]
11
Samuel Irby
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.3.3]
11
Floyd Irby
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.3.4]
10
Patsy Cole Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.4]
b. 6 Oct 1888
10
Kathleen Kent Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.5]
b. 23 Apr 1896
10
Allie Lovelace Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.8.6]
b. 24 Jul 1894
9
Thomas Syndor Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.9]
b. 11 May 1857 d. 1940
Virginia Lee Shields
b. Abt 1862
10
Jake Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.9.1]
b. Abt 1885
Ruth Conway
b. Abt 1894
11
James Conway Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.9.1.1]
11
Julian Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.9.1.2]
b. Abt 1917 d. Abt 1918
+
Sarah Hunter Beaman
b. Abt 1900
9
James Morton Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10]
b. 29 Feb 1860 d. 14 Dec 1938
Jennie Sarah Farmer
b. 29 Sep 1865 d. 12 Apr 1948
10
Sue Brown Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.1]
+
Willie Claude Shelton
10
John Carson Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.2]
+
Pattye Myrtle Lewis
+
Edna Wilson Moore
10
Minnie Gunn Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.3]
+
Walter Henry Spencer
b. 14 Aug 1904 d. 1940
10
James Herbert Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4]
b. 25 Dec 1883 d. 16 Feb 1961
Mamie Lettica Atkinson
b. 6 Apr 1883 d. 22 Feb 1955
11
Raleigh Thomas Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4.1]
b. 11 May 1916 d. 23 Jul 1966
+
Minnie Ruth Guthrie
11
Oliver Twister Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4.2]
b. 18 Apr 1918 d. 12 Apr 1972
+
Elsie Mae Reaves
11
James Washington Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4.3]
b. 28 Aug 1905 d. Aug 1971
11
Henry Clyde Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4.4]
+
Marguerite Wilson Short
11
Albert Thorton Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4.5]
b. 23 Mar 1909 d. 13 Apr 1949
+
Virginia Elizabeth Epps
11
Mabel Pearl Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4.6]
b. 18 Nov 1910 d. 26 Jan 1965
+
Walter Thomas Epps
b. 16 Aug 1892 d. 10 Aug 1971
11
Lettie Ann Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4.7]
+
Joseph Cline Owen
b. 24 Nov 1907
11
Lem Carter Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.4.8]
+
Cordie White Atkinson
10
Molly B. Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.5]
b. 25 Nov 1888 d. 28 Dec 1972
Doctor Cooper Smith
b. 23 Apr 1882 d. 6 May 1968
11
Mary Virginia Smith
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.5.1]
11
Mae Louise Smith
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.5.2]
+
Samuel Riddle
11
Belva Dunn Smith
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.5.3]
11
Manuel Cooper Smith
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.5.4]
10
Emma Carter Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6]
Osa Perrow Roark
b. 17 Jun 1888 d. 18 Sep 1968
11
Bertha Mae Roark
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6.1]
+
David E. Wimm
11
Mildred Gunn Roark
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6.2]
+
Laskey Eagon
+
Clarence Johnson
11
Ida Evelyn Roark
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6.3]
+
Harry Fisher
+
Kimball Vaughn
d. 1939
+
Wendell S. Harnish
11
Tapley Clinton Roark
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6.4]
b. 13 May 1918 d. 22 Mar 1948
+
Ruby Bray
11
Ralph Wiggington Roark
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6.5]
11
Wilmer Ryland Roark
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6.6]
+
Sudie McDowell
11
John Morton Roark
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6.7]
11
Verona Pearl Roark
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.6.8]
b. 25 Dec 1922 d. 14 Feb 1923
10
Tap McDowell Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.7]
b. 4 Jul 1896 d. 14 Oct 1962
+
Hattie Owen McDowell
b. 24 Jul 1885 d. 10 May 1968
10
Bettie Arendall
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.8]
Leslie A. Anderson
11
Ruby Anderson
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.8.1]
b. 13 Aug 1911
11
Artie H. Anderson
[1.1.1.2.5.1.3.1.10.8.2]
8
John Thomas Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.2]
b. 9 Mar 1844
8
Mary Susan Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.3]
b. 22 Jun 1846
8
Alice Sydnor Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.4]
b. 31 Oct 1848
8
Flournoy X. Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.5]
b. 23 Jun 1852
8
Judith Williams Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.6]
b. 16 Mar 1831
8
Elizabeth Armistead Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.7]
b. 3 Aug 1833
8
William Morton Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.8]
b. 2 Jan 1837
8
Elvira Frances Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.9]
b. 28 Jul 1839
8
Anthony Sydnor Barksdale
[1.1.1.2.5.1.3.10]
b. 29 Nov 1841
7
William Booker Morton
[1.1.1.2.5.1.4]
b. 1811
+
Faris
6
David Flournoy
[1.1.1.2.5.2]
b. Abt 1780
Mary Morton
b. Abt 1782
7
Thomas Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1]
b. 25 Jul 1804 d. 27 Dec 1892
Frances Matthews Venable
b. Abt 1810 d. 16 Aug 1863
8
Martha Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.1]
b. 28 Jul 1837
+
William Henry Venable
8
Nathaniel Abraham Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.2]
b. 20 Jan 1839
Laura Lewis
9
John Herbert Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.2.1]
Florence Wilson
10
John Wilson Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.2.1.1]
9
Fannie Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.2.2]
+
Charles Kimbro Taylor
9
Norborne Lewis Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.2.3]
9
Thomas Lewis Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.2.4]
+
Lois Latimer
8
II David Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.3]
b. 20 May 1829 d. 20 Nov 1895
Martha Daniel Bouldin
b. 11 Jan 1852
9
Fannie Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.3.1]
b. 3 Jul 1872
9
Thomas Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.3.2]
b. 12 Oct 1877 d. 19 Sep 1947
+
Mary Harvey Hamlin
b. 22 Jun 1873 d. 25 Jul 1967
9
Martha Daniel Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.3.3]
b. 15 Mar 1871
8
Frances Watkins Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.4]
b. 24 Sep 1830 d. 1900
Jr. Thomas Tyler Bouldin
b. 24 Mar 1813 d. 1891
9
Ellen Barksdale Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.1]
b. 10 Feb 1860
9
Fanny Louis Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.2]
+
Preston Buford
9
Mary Willie Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.3]
9
Henry Wood Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.4]
Lilla Coles
10
Fanny Lewis Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.4.1]
+
Thomas Spratly
10
Lilla Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.4.2]
+
Oska Shoemake
10
Thomas Tyler Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.4.3]
+
Louise Coles
9
Martha Cabell Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.5]
+
Gentry
9
Flournoy Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.6]
Annie White
10
Elizabeth Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.6.1]
b. Abt 1895
9
Clairborne Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.7]
Mary Crump
10
Alice Good Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.7.1]
10
Thomas Tyler Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.7.2]
10
Mary Crump Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.7.3]
10
Jr. Clairborne Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.7.4]
9
John Lewis Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.8]
+
Hetty Jones
9
Annie Venable Bouldin
[1.1.1.2.5.2.1.4.9]
+
Thomas W. Daniel
8
Amanda Nantz Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.5]
b. 8 May 1835
8
William Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.6]
b. 29 Nov 1835 d. 30 Mar 1836
8
Mary Agnes Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.7]
b. 23 Aug 1828
William H. Marshall
9
Pattie Venable Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.1]
+
Wood Dunham
9
Amanda F. Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.2]
9
James Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.3]
Carey Knox
10
James Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.3.1]
10
Ruth Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.3.2]
9
Louise Cabell Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.4]
Matthews Fink
10
Marshall Scott Fink
[1.1.1.2.5.2.1.7.4.1]
10
Paul Fink
[1.1.1.2.5.2.1.7.4.2]
10
Miriam Fink
[1.1.1.2.5.2.1.7.4.3]
9
Sallie Anne Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.5]
Judson Lloyd
10
Mary Lloyd
[1.1.1.2.5.2.1.7.5.1]
Wade
11
James S. Wade
[1.1.1.2.5.2.1.7.5.1.1]
10
John Lloyd
[1.1.1.2.5.2.1.7.5.2]
10
Kathleen Lloyd
[1.1.1.2.5.2.1.7.5.3]
Arthur Field
11
Mary Agnes Field
[1.1.1.2.5.2.1.7.5.3.1]
11
Sarah Field
[1.1.1.2.5.2.1.7.5.3.2]
10
Robert Lloyd
[1.1.1.2.5.2.1.7.5.4]
9
Fannie T. Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.6]
William H. Marshall
10
Pattie Venable Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.6.1]
10
James Marshall
[1.1.1.2.5.2.1.7.6.2]
8
Jacob Morton Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.8]
b. 7 Oct 1843
Mildred Coles Carrington
b. Abt 1845
9
Walter Carrington Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.8.1]
b. Abt 1875 d. 1896
9
Thomas Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.8.2]
9
Anna Lightfoot Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.8.3]
9
Elizabeth Morton Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.8.4]
8
William Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.9]
b. 24 Oct 1846
8
Louisa Cabell Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.10]
b. 2 Nov 1841
Richard Field
9
Louise Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.1]
+
Albert McCracken
9
Meade Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.2]
9
George Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.3]
9
Martha Venable Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.4]
9
Anna Morton Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.5]
+
William Moran
9
Nona Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.6]
+
Sandridge
9
Kate Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.7]
+
Horace Hayden
9
Fanny Venable Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.8]
+
Oscar Collins
9
Sally Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.9]
9
David Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.10]
9
Eva Field
[1.1.1.2.5.2.1.10.11]
+
Robert E. Lee Morton
8
Elizabeth Anne Flournoy
[1.1.1.2.5.2.1.11]
b. 26 Nov 1840
Reubin Booth Hicks
9
Thomas Hicks
[1.1.1.2.5.2.1.11.1]
Jennie Bowber
10
Elizabeth Baten Hicks
[1.1.1.2.5.2.1.11.1.1]
10
Francis Venable Hicks
[1.1.1.2.5.2.1.11.1.2]
10
Thomas Flournoy Hicks
[1.1.1.2.5.2.1.11.1.3]
10
Reubin Booth Hicks
[1.1.1.2.5.2.1.11.1.4]
+
Sally Edmunds Hicks
b. Abt 1827
+
Agnes Woodson Watkins
b. 28 Feb 1774
6
Anne Farish Flournoy
[1.1.1.2.5.3]
b. Abt 1772
Archer Womack
b. 1777 d. 1816
7
Julia Ann Womack
[1.1.1.2.5.3.1]
b. 22 Sep 1815 d. 1 Jan 1887
Joseph Richard Bailey
b. 1815 d. 28 Aug 1857
8
David Flournoy Bailey
[1.1.1.2.5.3.1.1]
b. 1845
Sarah Eleanor Preston
b. 1843
9
Julia Bailey
[1.1.1.2.5.3.1.1.1]
+
William T. Tillar
8
Louise Bailey
[1.1.1.2.5.3.1.2]
b. Cal 1844
8
Anna A. Bailey
[1.1.1.2.5.3.1.3]
b. Cal 1850
6
Julia Elizabeth Flournoy
[1.1.1.2.5.4]
b. 7 Sep 1767 d. 5 Nov 1836
George Wells Foster
7
Ann Martin Foster
[1.1.1.2.5.4.1]
b. Abt 1788
+
Lovick Pierce
6
John James Flournoy
[1.1.1.2.5.5]
b. 15 Oct 1782 d. 1862
Ann Carrington Cabell
b. 20 Sep 1787 d. 7 Jul 1854
7
Ann Eliza Flournoy
[1.1.1.2.5.5.1]
b. 1808
+
Henry Wood
7
William Cabell Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2]
b. 31 Dec 1809 d. 31 Mar 1861
Martha Watkins Venable
b. 5 Jun 1816 d. 1905
8
William Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.1]
b. Abt 1839 d. Abt 1842
8
Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2]
b. 4 Mar 1850
Susan Cabell Cobbs
b. 5 Nov 1864
9
Mildred Cobbs Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.1]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
9
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.2]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
9
Mary Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.3]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
9
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.4]
b. 20 Sep 1890
9
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.5]
b. 24 Oct 1896
Martha G. Givens
b. 1858 d. 9 May 1884
9
Martha Watkins Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.6]
b. 24 Dec 1882
9
Sarah Wright Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.7]
b. 9 Apr 1881
+
Butts
9
Florida Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.8]
b. 31 Aug 1879
9
Bessie Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.2.9]
b. 29 Jan 1878
+
Brown
8
George Mallory Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1853
8
Charles Bruce Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.4]
b. 11 Nov 1854
+
Virginia Dalby
8
Alice Eliza Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.5]
b. 4 Nov 1852
+
Littleton Fitzgerald
8
Sarah Venable Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.6]
b. 12 Aug 1845
+
J. C. Painter
8
Benjamin Stanhope Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.7]
b. Abt 1841 d. Abt 1842
8
II John James Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.8]
b. 13 Apr 1837 d. 7 Jan 1875
8
Ann Cabell Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.9]
b. Abt 1835 d. Abt 1837
8
Frances Florida Flournoy
[1.1.1.2.5.5.2.10]
b. 6 Jul 1843
+
John P. Fitzgerald
7
Patrick Henry Flournoy
[1.1.1.2.5.5.3]
b. 4 Mar 1813 d. 3 Mar 1887
Susan Edmunds
8
Nicholas Edmunds Flournoy
[1.1.1.2.5.5.3.1]
b. 23 Mar 1841
+
Catharine Patrick Wood
8
William Stanhope Flournoy
[1.1.1.2.5.5.3.2]
b. 23 Dec 1845
+
Bettie A. Wilson
8
Ann Cabell Flournoy
[1.1.1.2.5.5.3.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1848
7
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4]
b. 15 Dec 1811 d. 12 Mar 1883
Susan Ann Love
d. 21 Apr 1848
8
Mary P. Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.1]
b. 11 Sep 1838 d. 1874
John F. Cobbs
9
Susan Cabell Cobbs
[1.1.1.2.5.5.4.1.1]
b. 5 Nov 1864
Landon Cabell Flournoy
b. 4 Mar 1850
10
Mildred Cobbs Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.1.1.1]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
10
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.1.1.2]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
10
Mary Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.1.1.3]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
10
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.1.1.4]
b. 20 Sep 1890
10
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.1.1.5]
b. 24 Oct 1896
8
Cabell Edward Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.2]
b. 30 Jun 1840 d. 1864
8
John James Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.3]
b. 11 Apr 1842
8
Louisa Cabell Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.4]
b. 3 May 1844
+
William W. Cobbs
8
Henry Wood Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.5]
b. 6 Jun 1846
+
Rose Buena Wood
8
Allen Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.6]
d. Abt 1849
Mildred H. Coles
d. 1901
8
Helen Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.7]
b. 9 May 1856
+
John R. Patton
8
Ann Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.8]
b. Abt 1858 d. Abt 1862
8
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.9]
b. 8 May 1860
8
Cole Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.10]
b. 1 Oct 1862
8
Lettice Carrington Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.11]
b. 21 Aug 1865
8
Charles Carrington Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.12]
b. 17 Feb 1871
8
Walter Cole Flournoy
[1.1.1.2.5.5.4.13]
6
Mary Flournoy
[1.1.1.2.5.6]
6
Marcia Martin Flournoy
[1.1.1.2.5.7]
5
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.2.6]
b. 5 Dec 1721 d. Jul 1793
Thomas Spencer
b. 5 Dec 1721 d. 2 Dec 1793
6
Jr. Thomas Spencer
[1.1.1.2.6.1]
b. 1751 d. 1806
Lucy A. Watkins
b. 1759 d. 1847
7
Thomas J. Spencer
[1.1.1.2.6.1.1]
b. 1795 d. 1822
Ann Eliza Eastham
b. 1803 d. 1881
8
James T. Spencer
[1.1.1.2.6.1.1.1]
b. 1821 d. 1886
Mary Elizabeth Leach
b. 1822 d. 1876
9
Fannie Venable Spencer
[1.1.1.2.6.1.1.1.1]
+
A. G. McIlwaine
9
Ann Thomas Spencer
[1.1.1.2.6.1.1.1.2]
+
F. H. Armistead
6
John Spencer
[1.1.1.2.6.2]
b. 16 Dec 1745 d. 26 May 1826
6
Samuel Flournoy Spencer
[1.1.1.2.6.3]
b. 5 Dec 1755 d. 9 Dec 1838
Agnes Woodson Daniel
b. 1754 d. 1799
7
Mary Phena "Polly" Spencer
[1.1.1.2.6.3.1]
b. 1796
7
Alexander R Spencer
[1.1.1.2.6.3.2]
b. 1816 d. 1908
6
Mary Spencer
[1.1.1.2.6.4]
b. 20 Oct 1742 d. 5 Mar 1829
6
Sion Spencer
[1.1.1.2.6.5]
b. 12 Apr 1744 d. 4 Dec 1775
6
Elizabeth Julia Spencer
[1.1.1.2.6.6]
b. 18 Jun 1747 d. 1832
6
Ann Spencer
[1.1.1.2.6.7]
b. 13 Jul 1749 d. 1780
6
Martha Owen Spencer
[1.1.1.2.6.8]
b. 7 Sep 1757 d. 5 Jun 1836
6
Gideon Spencer
[1.1.1.2.6.9]
b. 21 May 1760 d. 8 May 1822
5
Flournoy
[1.1.1.2.7]
b. 25 Nov 1736 d. Jan 1736/37
5
Gédéon Flournoy
[1.1.1.2.8]
b. 19 Mar 1722 d. 1754
Jane Frances Sabourin
b. 21 Jul 1730 d. 1797
6
Gédéon Flournoy
[1.1.1.2.8.1]
b. 21 Sep 1753 d. 25 Sep 1821
Jeanne-Françoise Delisle
b. 10 Nov 1755 d. 4 May 1832
7
Gédéon Jean François Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1]
b. 15 Jul 1784 d. 22 Jul 1863
Elizabeth Pernette Covelle
b. 17 Aug 1797 d. 2 Jan 1880
8
Alexandre Antoine Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1]
b. 10 Jan 1818 d. 9 Aug 1890
Caroline Claparède
b. 1831 d. 1875
9
Paul-Eugène-Edmond Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.1]
b. 2 Jan 1863 d. 6 Jul 1936
9
Théodore Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2]
b. 15 Aug 1854 d. 5 Nov 1920
Marie Helene Burnier
b. 15 Aug 1856 d. 22 Aug 1909
10
Berthe-Alice Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.1]
b. 1 Mar 1881 d. 3 Jul 1965
10
Blanche Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.2]
b. 15 Jun 1882 d. 20 Apr 1905
10
Henri Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.3]
b. 28 Mar 1886 d. 6 May 1955
Jeanne Elisabeth Richard
11
Elisabeth-Marie-Julie Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.3.1]
Curtis Wilmot-Allistone
12
Denis Pierre Henri Wilmot-Allistone
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.3.1.1]
[
=>
]
12
Caroline Laurie Wilmot-Allistone
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.3.1.2]
b. 30 Sep 1956 d. 9 Aug 1962
11
Olivier-Louis-Théodore Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.3.2]
Liliane Picctiotto
12
Frédérique Manuella Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.3.2.1]
10
Hélène Olga Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.4]
b. 28 Mar 1891 d. 1 Jan 1972
10
Ariane Dorothée Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.5]
Raymond de Saussure
b. 1884 d. 1970
11
Bertrand de Saussure
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.5.1]
11
Gerard de Saussure
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.5.2]
Barbara Lee Halpern
12
Marc Henri de Saussure
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.5.2.1]
12
Claire de Saussure
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.5.2.2]
10
Marguerite Flournoy
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6]
b. 31 Oct 1883 d. 10 Jun 1963
Albert Jean Alexandre Mottu
b. 21 Nov 1874 d. 10 Mar 1951
11
Yolande Renée Mottu
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6.1]
Léonard Alexandre Jean-Jacques Ami Pittard
12
Claire Hélène Marguerite Pittard
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6.1.1]
12
Danielle Anne-Marie Pittard
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6.1.2]
[
=>
]
12
Jean-Claude Eugène Pittard
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6.1.3]
[
=>
]
12
Alain Pierre Albert Pittard
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6.1.4]
[
=>
]
11
Théodore Auguste Roger Mottu
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6.2]
Josette Blanche Antoinette Morin
12
Marie-Yolande Mottu
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6.2.1]
[
=>
]
12
Anne Marguerite Agnès Mottu
[1.1.1.2.8.1.1.1.2.6.2.2]
[
=>
]
5
Mary Flournoy
[1.1.1.2.9]
b. 23 Feb 1735 d. 8 Sep 1798
William Booker
b. 1720 d. 10 Oct 1783
6
Jane Davis Booker
[1.1.1.2.9.1]
b. 1755 d. 1800
Jacob Morton
b. 29 Jan 1751 d. 22 May 1829
7
William Booker Morton
[1.1.1.2.9.1.1]
b. 3 Sep 1775 d. 10 Aug 1816
Lucy Faris Flournoy
b. 1786 d. 1836
8
Elvira Henry Morton
[1.1.1.2.9.1.1.1]
b. 1806 d. 1840
William Peter Barksdale
b. 1799 d. 1854
9
Louisa Frances Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.1.1]
b. 1830 d. 1907
John Bullock Crews
b. 1814 d. 1882
10
Louise Barksdale Crews
[1.1.1.2.9.1.1.1.1.1]
10
Frances Sydnor Crews
[1.1.1.2.9.1.1.1.1.2]
10
Rosa Crews
[1.1.1.2.9.1.1.1.1.3]
+
Nicholas Hairston
8
Anne Martin Morton
[1.1.1.2.9.1.1.2]
b. 1804
William Henry Dennis
b. 1801 d. 1866
9
Jacob Dennis
[1.1.1.2.9.1.1.2.1]
8
Mary Elizabeth Morton
[1.1.1.2.9.1.1.3]
b. 24 Apr 1808 d. 13 Dec 1889
William Sydnor Barksdale
b. 7 May 1806 d. 10 Sep 1874
9
Lucy Ann Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.1]
b. 4 Oct 1828 d. 11 Jan 1906
James Woodford Arendall
b. 20 Jan 1820 d. 17 Mar 1871
10
Lucy Flournoy Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.1]
b. 5 Jun 1862 d. 11 Dec 1888
10
Judith Williams Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.2]
b. 16 Sep 1865 d. 31 Aug 1896
Robert V. Farmer
11
Maude M. Farmer
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.2.1]
b. 10 Mar 1885
10
Elizabeth Frances Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.3]
b. 23 May 1867 d. 12 Jun 1895
W. G. Slayton
11
Hattie S. Slayton
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.3.1]
b. 15 Jan 1885 d. 12 Sep 1886
10
Virginia Alice Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.4]
b. 26 Dec 1869
Charles King Petty
11
Henry T. Petty
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.4.1]
b. 3 Oct 1896
10
William Barksdale Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5]
b. 25 Apr 1849 d. 11 Nov 1911
Phebe Pennich Dixon
d. 11 Jul 1898
11
Agis Lycurgus Lafayette Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.1]
b. 16 Dec 1871
11
Thomas Frank Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.2]
b. 30 May 1874
+
E. Lillian Walker
11
Morton Armistead Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.3]
b. 2 Aug 1877 d. 2 Aug 1879
11
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.4]
b. 8 Jan 1880
+
William H. Douglas
11
Alice M. Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.5]
b. 10 Jun 1884
11
Lou Boyd Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.6]
b. 27 Jul 1888 d. 11 Sep 1889
11
Rosa Crews Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.7]
b. 18 Mar 1891 d. Jan 1970
Christopher Columbus Tankersley
b. 10 Sep 1884 d. 1921
12
Earl Willard Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.7.1]
12
Lorine Edith Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.7.2]
12
Irvin W. Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.7.3]
12
Annie Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.5.7.4]
10
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.6]
b. 23 Apr 1851 d. 28 Sep 1853
10
Ann Catherine Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.7]
b. 7 Mar 1853 d. 15 Jul 1882
Alexander D. Thompson
11
Sandy S. Thompson
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.7.1]
b. 5 Jul 1878
11
Adel May Thompson
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.7.2]
b. 30 Apr 1881 d. 18 Mar 1882
11
Maud Iola Thompson
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.7.3]
b. 16 Feb 1879
11
John Armistead Thompson
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.7.4]
b. 9 Oct 1876 d. 20 Jun 1878
11
Charles Woodford Thompson
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.7.5]
b. 10 Oct 1873
11
William M.B. Thompson
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.7.6]
b. 25 Jun 1875
10
John Armstead Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8]
b. 12 Jan 1855 d. 1 Jul 1935
Alice Madison Cole
b. 3 Feb 1854 d. 29 Jan 1940
11
John William Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.1]
b. 19 Nov 1885 d. 31 Mar 1936
Marguerite A. Krebs
d. 27 Jun 1919
12
John Madison Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.1.1]
12
Alice Marguerite Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.1.2]
12
Annette Elaine Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.1.3]
11
James Newton Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.2]
b. 11 Jul 1877
11
Luella T. Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.3]
b. 6 Oct 1879 d. 10 Sep 1964
Luther A. Irby
b. 11 May 1871 d. 29 Jul 1953
12
John Ferman Irby
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.3.1]
12
Jr. Luther A. Irby
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.3.2]
12
Samuel Irby
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.3.3]
12
Floyd Irby
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.3.4]
11
Patsy Cole Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.4]
b. 6 Oct 1888
11
Kathleen Kent Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.5]
b. 23 Apr 1896
11
Allie Lovelace Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.8.6]
b. 24 Jul 1894
10
Thomas Syndor Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.9]
b. 11 May 1857 d. 1940
Virginia Lee Shields
b. Abt 1862
11
Jake Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.9.1]
b. Abt 1885
Ruth Conway
b. Abt 1894
12
James Conway Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.9.1.1]
12
Julian Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.9.1.2]
b. Abt 1917 d. Abt 1918
+
Sarah Hunter Beaman
b. Abt 1900
10
James Morton Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10]
b. 29 Feb 1860 d. 14 Dec 1938
Jennie Sarah Farmer
b. 29 Sep 1865 d. 12 Apr 1948
11
Sue Brown Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.1]
+
Willie Claude Shelton
11
John Carson Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.2]
+
Pattye Myrtle Lewis
+
Edna Wilson Moore
11
Minnie Gunn Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.3]
+
Walter Henry Spencer
b. 14 Aug 1904 d. 1940
11
James Herbert Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4]
b. 25 Dec 1883 d. 16 Feb 1961
Mamie Lettica Atkinson
b. 6 Apr 1883 d. 22 Feb 1955
12
Raleigh Thomas Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4.1]
b. 11 May 1916 d. 23 Jul 1966
12
Oliver Twister Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4.2]
b. 18 Apr 1918 d. 12 Apr 1972
12
James Washington Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4.3]
b. 28 Aug 1905 d. Aug 1971
12
Henry Clyde Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4.4]
12
Albert Thorton Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4.5]
b. 23 Mar 1909 d. 13 Apr 1949
12
Mabel Pearl Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4.6]
b. 18 Nov 1910 d. 26 Jan 1965
12
Lettie Ann Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4.7]
12
Lem Carter Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.4.8]
11
Molly B. Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.5]
b. 25 Nov 1888 d. 28 Dec 1972
Doctor Cooper Smith
b. 23 Apr 1882 d. 6 May 1968
12
Mary Virginia Smith
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.5.1]
12
Mae Louise Smith
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.5.2]
12
Belva Dunn Smith
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.5.3]
12
Manuel Cooper Smith
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.5.4]
11
Emma Carter Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6]
Osa Perrow Roark
b. 17 Jun 1888 d. 18 Sep 1968
12
Bertha Mae Roark
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6.1]
12
Mildred Gunn Roark
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6.2]
12
Ida Evelyn Roark
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6.3]
12
Tapley Clinton Roark
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6.4]
b. 13 May 1918 d. 22 Mar 1948
12
Ralph Wiggington Roark
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6.5]
12
Wilmer Ryland Roark
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6.6]
12
John Morton Roark
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6.7]
12
Verona Pearl Roark
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.6.8]
b. 25 Dec 1922 d. 14 Feb 1923
11
Tap McDowell Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.7]
b. 4 Jul 1896 d. 14 Oct 1962
+
Hattie Owen McDowell
b. 24 Jul 1885 d. 10 May 1968
11
Bettie Arendall
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.8]
Leslie A. Anderson
12
Ruby Anderson
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.8.1]
b. 13 Aug 1911
12
Artie H. Anderson
[1.1.1.2.9.1.1.3.1.10.8.2]
9
John Thomas Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.2]
b. 9 Mar 1844
9
Mary Susan Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.3]
b. 22 Jun 1846
9
Alice Sydnor Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.4]
b. 31 Oct 1848
9
Flournoy X. Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.5]
b. 23 Jun 1852
9
Judith Williams Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.6]
b. 16 Mar 1831
9
Elizabeth Armistead Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.7]
b. 3 Aug 1833
9
William Morton Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.8]
b. 2 Jan 1837
9
Elvira Frances Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.9]
b. 28 Jul 1839
9
Anthony Sydnor Barksdale
[1.1.1.2.9.1.1.3.10]
b. 29 Nov 1841
8
William Booker Morton
[1.1.1.2.9.1.1.4]
b. 1811
7
Robert Morton
[1.1.1.2.9.1.2]
Marcia M. Flournoy
8
Robert A. Morton
[1.1.1.2.9.1.2.1]
Sallie Ann Collins
9
Sallie C. Morton
[1.1.1.2.9.1.2.1.1]
+
Frank W. Cunningham
6
William Flournoy Booker
[1.1.1.2.9.2]
b. 12 May 1761 d. 21 Nov 1807
+
Elizabeth Moore
b. 15 Oct 1774 d. 1805
6
Rebecca Booker
[1.1.1.2.9.3]
b. 7 Apr 1773 d. 21 Apr 1818
+
Jr. Robert Smith
b. 10 Oct 1765 d. 26 Mar 1830
6
Frances Booker
[1.1.1.2.9.4]
b. 1771 d. 1793
+
Nathaniel Price
6
Gideon Booker
[1.1.1.2.9.5]
b. 1756 d. 28 Jul 1794
6
John D. Booker
[1.1.1.2.9.6]
b. 1755 d. 1825
+
Martha Jane Watkins
b. 1771 d. 1852
6
Eliza Julia Booker
[1.1.1.2.9.7]
b. 1764 d. 30 May 1828
+
Thomas Embra Green
b. Abt 1760 d. 30 Sep 1827
6
Thomas Booker
[1.1.1.2.9.8]
d. 1789
6
Nancy Rochet
[1.1.1.2.9.9]
6
Mary Williams Booker
[1.1.1.2.9.10]
d. 1789
5
Samuel Flournoy
[1.1.1.2.10]
b. 4 Oct 1724 d. 12 Dec 1780
Elizabeth Harris
b. 31 Dec 1729 d. 19 May 1791
6
Silas F. Flournoy
[1.1.1.2.10.1]
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
Martha Cannon
b. 1775 d. Oct 1817
7
Alfred Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
8
William Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.1]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
9
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
9
William Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.1.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
9
Alfred Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.1.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
9
Lucien Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.1.4]
b. 22 Feb 1861
8
Alonzo Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.2]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
9
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.2.1]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
10
Genevieve McRady
[1.1.1.2.10.1.1.2.1.1]
9
James Patteson Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.2.2]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
9
Belle Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.2.3]
9
Theodosia Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.2.4]
8
James Silas Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.3]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
8
Eliza Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.4]
b. 29 May 1829 d. INFANT
8
Alfred F. Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.5]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
9
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.5.1]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
9
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.5.2]
b. 21 Feb 1875
9
Mary Patteson Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.5.3]
b. 24 Apr 1866
9
Spencer Alston Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.5.4]
b. Aug 1879
8
Martha Moore Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.6]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
8
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.7]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
9
Alfred F. Wilson
[1.1.1.2.10.1.1.7.1]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
9
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.1.2.10.1.1.7.2]
9
Alice Wilson
[1.1.1.2.10.1.1.7.3]
+
Charles Davis
9
Ruth Wilson
[1.1.1.2.10.1.1.7.4]
+
B. H. Davis
9
Pattie Wilson
[1.1.1.2.10.1.1.7.5]
Milton Walker Sims
10
Laura Sims
[1.1.1.2.10.1.1.7.5.1]
b. 1873
+
J. Fred Smith
b. Abt 1870
10
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.1.2.10.1.1.7.5.2]
b. 1872
+
Charles Mills
10
Milton Sims
[1.1.1.2.10.1.1.7.5.3]
b. 1876
10
Bartlett Sims
[1.1.1.2.10.1.1.7.5.4]
b. May 1878
+
Almaide Priscilla Kerr
9
Laura Wilson
[1.1.1.2.10.1.1.7.6]
Thomas Bell
10
Mary Bell
[1.1.1.2.10.1.1.7.6.1]
+
Edward Gleason
9
Mary Wilson
[1.1.1.2.10.1.1.7.7]
+
Napoleon Davis
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
8
Charles Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.8]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
8
David Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.9]
b. 1842 d. 1856
8
Maria Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.10]
b. 1837 d. 1841
8
Mary Camp Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
8
Martha Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.12]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
8
Indiana Flournoy
[1.1.1.2.10.1.1.13]
b. 1847
7
Eliza Susan Flournoy
[1.1.1.2.10.1.2]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
8
Alfred H. Harris
[1.1.1.2.10.1.2.1]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
8
Eliza Susan Harris
[1.1.1.2.10.1.2.2]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
8
Martha Harris
[1.1.1.2.10.1.2.3]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
7
William Cannon Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
8
Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.1]
b. 1833 d. 1833
8
Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.2]
b. 1829 d. 1829
8
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.3]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
9
Myra Rivers
[1.1.1.2.10.1.3.3.1]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
9
Julian Rivers
[1.1.1.2.10.1.3.3.2]
b. 23 Dec 1868
9
William Cannon Rivers
[1.1.1.2.10.1.3.3.3]
b. 11 Jan 1866
9
Tyree Rodes Rivers
[1.1.1.2.10.1.3.3.4]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
9
John Harper Rivers
[1.1.1.2.10.1.3.3.5]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
9
Flournoy Rivers
[1.1.1.2.10.1.3.3.6]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
10
John Avirett Rivers
[1.1.1.2.10.1.3.3.6.1]
b. 22 Mar 1894
8
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.4]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
9
Ezell Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.4.1]
b. 9 Dec 1878
9
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.4.2]
b. 13 Sep 1875
9
John Walker Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.4.3]
b. 24 Jan 1874
9
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.4.4]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
9
III William Cannon Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.4.5]
b. 8 Apr 1872
8
John J. Flournoy
[1.1.1.2.10.1.3.5]
b. 1838
7
Mary Amanda Flournoy
[1.1.1.2.10.1.4]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
8
Mary Eliza Field
[1.1.1.2.10.1.4.1]
b. 1 Jul 1825
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
9
Myra Flournoy Knapp
[1.1.1.2.10.1.4.1.1]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
9
Maud Officer
[1.1.1.2.10.1.4.1.2]
b. 9 May 1847
9
Eustis Field Officer
[1.1.1.2.10.1.4.1.3]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
9
William P. Officer
[1.1.1.2.10.1.4.1.4]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
8
James Alexander Field
[1.1.1.2.10.1.4.2]
b. 30 May 1823
8
Jr. William Hume Field
[1.1.1.2.10.1.4.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
8
Julian Clarence Field
[1.1.1.2.10.1.4.4]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
8
Silas Flournoy Field
[1.1.1.2.10.1.4.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
8
Margaret Julia Field
[1.1.1.2.10.1.4.6]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
8
Henrietta Field
[1.1.1.2.10.1.4.7]
b. 1833 d. 1833
8
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.1.2.10.1.4.8]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
8
Florence Huntley Field
[1.1.1.2.10.1.4.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
7
Julia Ann Flournoy
[1.1.1.2.10.1.5]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
8
Hume Rigg Feild
[1.1.1.2.10.1.5.1]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
8
Eliza Mildred Feild
[1.1.1.2.10.1.5.2]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
9
Julia Batte
[1.1.1.2.10.1.5.2.1]
+
W. R. Garrett
9
Mildred Batte
[1.1.1.2.10.1.5.2.2]
9
E. F. Batte
[1.1.1.2.10.1.5.2.3]
7
Madison Flournoy
[1.1.1.2.10.1.6]
b. 1807
7
Martha C. Flournoy
[1.1.1.2.10.1.7]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
8
Silas Flournoy Trotter
[1.1.1.2.10.1.7.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
7
Silas Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
8
Mary Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.1]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
9
Elizabeth Rivers
[1.1.1.2.10.1.8.1.1]
b. Bef 1865
9
James P. Rivers
[1.1.1.2.10.1.8.1.2]
b. Bef 1863
9
Mary Rivers
[1.1.1.2.10.1.8.1.3]
b. Bef 1867
9
Silas Flournoy Rivers
[1.1.1.2.10.1.8.1.4]
b. Bef 1871
9
William W. Rivers
[1.1.1.2.10.1.8.1.5]
b. Bef 1869
9
Martha Rivers
[1.1.1.2.10.1.8.1.6]
b. Bef 1873
8
Camp Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
9
Lucien Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
10
Lillian May Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.1.1]
b. 1906
10
Mary Wise Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.1.2]
b. 1911
10
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.1.3]
10
Laura Louise Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.1.4]
10
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.1.5]
9
John Wise Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
10
Louise Wise Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.2.1]
b. 1907
10
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.2.2]
b. 1912
Minnie Childress Cole
11
Thomas Cole Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.2.2.1]
10
Camp Rogers Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.2.3]
10
Betty McAfee Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.2.4]
9
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
10
Eloise Walker
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
+
Raymond Grady Thomas
10
Newton Flournoy Walker
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
+
Rose Mary Bozeman
+
Valta Irene Gholston
10
Lucien John Walker
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972
Janie Lucile Stallcup
b. 1912
11
Lou Anne Walker
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.3.1]
Duane Tarrant
12
Lucien Clyde Tarrant
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.3.1.1]
12
Nola Tarrant
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.3.1.2]
12
William Rusk Tarrant
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.3.1.3]
+
Frank Casey
10
Jane Louise Walker
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.4]
+
Benjamin Elliot Mosher
10
Jacob Camp Walker
[1.1.1.2.10.1.8.2.3.5]
+
Ouida Louise Gill
9
Augusta Mary Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
10
Georgia Louia May
[1.1.1.2.10.1.8.2.4.1]
b. 1899
10
Julia Flournoy May
[1.1.1.2.10.1.8.2.4.2]
Robert Henry Mays
11
Judy Mays
[1.1.1.2.10.1.8.2.4.2.1]
11
Robert Mays
[1.1.1.2.10.1.8.2.4.2.2]
d. INFANT
10
Elizabeth Wise May
[1.1.1.2.10.1.8.2.4.3]
b. 1902
10
James Kathryn May
[1.1.1.2.10.1.8.2.4.4]
b. 1902
10
Norma Lucile May
[1.1.1.2.10.1.8.2.4.5]
b. 1902
9
Julia Rivers Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
10
Lucien Wise Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.1]
10
Andrew Booty Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2]
Mattie Lou Shaw
11
Jr. Andrew Booty Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.1]
Arlene
12
Arthur Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.1.1]
[
=>
]
12
Andrew Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.1.2]
12
Jason Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.1.3]
12
Cynthia Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.1.4]
11
Lou Ann Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.2]
Rufus Taylor Higginbotham
12
Rufus Taylor Higginbotham
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.2.1]
12
Andrew Benjamin Higginbotham
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.2.2]
12
Laura Michelle Higginbotham
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.2.3]
11
John Franklin Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.3]
Judy
12
Julia Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.3.1]
12
Jennifer Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.3.2]
11
Gwen Elizabeth Jordan
[1.1.1.2.10.1.8.2.5.2.4]
9
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
10
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.6.1]
10
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.6.2]
10
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.2.6.3]
8
Lucien Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.3]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
9
Caroline Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.3.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
8
Elizabeth Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.4]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
9
Duncan
[1.1.1.2.10.1.8.4.1]
b. Bef 1870 d. 1876
9
Maude Eustace Duncan
[1.1.1.2.10.1.8.4.2]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
8
III Silas Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.5]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
9
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.5.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
9
Silas Camp Flournoy
[1.1.1.2.10.1.8.5.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
7
Sarah Flournoy
[1.1.1.2.10.1.9]
b. 1816
7
Louisa Ann Flournoy
[1.1.1.2.10.1.10]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
8
Laura Ann Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.1]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
9
Leroy M. Black
[1.1.1.2.10.1.10.1.1]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
9
Louisa Catherine Black
[1.1.1.2.10.1.10.1.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
10
Mary Lou Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.1]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
11
Robert Lester Gilbert
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.1.1]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953
Ila Deane Griffin
12
Robert Parks Gilbert
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.1.1.1]
[
=>
]
+
Inez Timmerman
11
Sadie Louise Gilbert
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.1.2]
Harold Leigh Aymett
b. 11 Feb 1884 d. 6 Jul 1948
12
Marilouise Aymett
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.1.2.1]
[
=>
]
11
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.1.3]
11
Leon Gilbert
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.1.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
10
Ernest M. Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.2]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
10
Leroy Black Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.3]
b. 1864 d. 1934
10
James Carley Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.4]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
11
William Lambeth Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.4.1]
Joan Shuler
b. 3 Nov 1920 d. 25 May 1969
12
Laura Ann Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.4.1.1]
11
James Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.4.2]
10
Laura Jane Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.5]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
11
Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.5.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown
Dorothy
12
Jr. Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.5.1.1]
12
Frances Dickey
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.5.1.2]
11
Louise Dickey
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.5.2]
b. Jan 1899
Sharp
12
Lester Sharp
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.5.2.1]
12
Gilbert Sharp
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.5.2.2]
10
Frank Leon Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.6]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
11
Richard Leon Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.6.1]
Josephine Elizabeth Martin
12
Jr. Richard Leon Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.6.1.1]
12
Frank Martin Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.6.1.2]
10
Emily Olivia Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.7]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
11
Myra Tatum
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.7.1]
William Weakly Johnson
b. Abt 1895 d. Abt 1940
12
Mary Emily Johnson
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.7.1.1]
[
=>
]
12
Jr. William Weakly Johnson
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.7.1.2]
[
=>
]
12
John Tatum Johnson
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.7.1.3]
[
=>
]
11
Thomas Leroy Tatum
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.7.2]
10
John A. Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.8]
b. 1873 d. 1874/1963
10
Levair Lester
[1.1.1.2.10.1.10.1.2.9]
b. Abt 1869
9
Laura Ann Black
[1.1.1.2.10.1.10.1.3]
8
Flournoy Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.2]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
9
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.2.1]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
10
Martha Lafavre Bishop
[1.1.1.2.10.1.10.2.1.1]
10
Richard Yancey Bishop
[1.1.1.2.10.1.10.2.1.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
9
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.2.2]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
10
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.1]
Willie Crook
b. Abt 1901
11
Fergene Dawes Richmond
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.1.1]
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
10
Alice LaFavia Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.2]
+
Glen Carl Moody
10
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.3]
Mary Ona Kitchens
11
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.3.1]
Erma Pauline Lively
12
Michael Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.3.1.1]
[
=>
]
12
Susan Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.3.1.2]
[
=>
]
12
Matthew Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.3.1.3]
[
=>
]
12
Julie Marie Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.3.1.4]
[
=>
]
11
Frank Leslie Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.3.2]
+
Linda M Dickey
10
Thomas Asbury Dawes
[1.1.1.2.10.1.10.2.2.4]
b. 4 Apr 1895
9
Cora Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.2.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
9
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.2.4]
b. Jul 1882
8
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.3]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
9
Lucy M. Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.3.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
10
Rosa Mai Wilson
[1.1.1.2.10.1.10.3.1.1]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
10
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.1.2.10.1.10.3.1.2]
b. 1886
10
Thomas Webber Wilson
[1.1.1.2.10.1.10.3.1.3]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
10
George L Wilson
[1.1.1.2.10.1.10.3.1.4]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
10
Wilber Wilson
[1.1.1.2.10.1.10.3.1.5]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
11
Mabel Wilson
[1.1.1.2.10.1.10.3.1.5.1]
9
Webber Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.3.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
9
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.2.10.1.10.3.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
8
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
9
Adella Frances Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4.1]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
10
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
11
Francis Joseph Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.1]
11
John Patrick Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.2]
Paulina D. Lacasella
12
Pamela Ann Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.2.1]
12
Gregory Patrick Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.2.2]
12
Ursula Louise Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.2.3]
12
Blake Michael Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.2.4]
12
Jonathan Randall Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.2.5]
12
Leigh Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.2.6]
b. 3 Nov 1945 d. 15 Apr 1962
11
Jerome Anthony Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.3]
+
Reta Adeline Thibedeau
Doris Holyfield
12
Michael Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.3.1]
12
Patricia Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.3.2]
Ann Capello
12
Jerome Anthony Goodall, Jr.
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.3.3]
12
Mary Ann Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.3.4]
b. 25 Jun 1943 d. 25 Jun 1943
12
Anita C Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.3.5]
12
Katherine Elizabeth Goodall
[1.1.1.2.10.1.10.4.1.1.3.6]
+
Frank G Curran
9
Mamie J. Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4.2]
b. 8 Dec 1875 d. 18 Sep 1968
Maclovio De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
10
Orman Joe De Arnaz
[1.1.1.2.10.1.10.4.2.1]
+
Alma Viola
10
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.1.2.10.1.10.4.2.2]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
9
Robert Lee Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4.3]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
9
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4.4]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
9
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4.5]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
9
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4.6]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
10
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1]
Eugenia Joyce Barker
11
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1.1]
Wendell Wade Hennigh
12
Joshua Houle Hennigh
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1.1.1]
12
Lukas Wade "Luke" Hennigh
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1.1.2]
[
=>
]
11
Jennifer Alberta Houle
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1.2]
Richard C. Sandoval
12
Terresita Maria Sandoval
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1.2.1]
[
=>
]
12
Emilia Alberta Sandoval
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1.2.2]
11
Winifred Catherine Houle
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1.3]
Robert Eugene Cherry
12
Robert Lewis Scott Cherry
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.1.3.1]
[
=>
]
10
Anna Josephine Houle
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.2]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
11
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.2.1]
Cathy Ann Glessner
12
Darcy Catherine Currier
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.2.1.1]
[
=>
]
12
Kimberly Darcy Currier
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.2.1.2]
[
=>
]
10
Dorothy Louise Houle
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.3]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
11
John Dennis Scully
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.3.1]
11
Constance L Scully
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.3.2]
+
Newton
11
Brian C. Scully
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.3.3]
10
Alberta Isabel Houle
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4]
Jeptha Milton Gibbs, III
11
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.1]
Mary Melissa Meyers
12
Jeptha Milton Gibbs, V
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.1.1]
[
=>
]
12
Mary Melissa Gibbs
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.1.2]
11
Jane Gibbs
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.2]
+
Richard Calvin Torrey
11
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.3]
Jerry Hamilton Guild
12
Matthew Hamilton Guild
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.3.1]
12
Nancy J. Guild
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.3.2]
12
Christopher Parsons Guild
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.3.3]
12
Peter Christopher Guild
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.3.4]
12
Bonnie C. Guild
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.3.5]
11
Edward Thurston Gibbs
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.4]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
11
William Houle Gibbs
[1.1.1.2.10.1.10.4.6.4.5]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
9
Edna Emma Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
10
Anita Ruth Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.1]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
10
Helen May Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.2]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
10
Howard Joseph Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.3]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
11
Anthony Howard Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.3.1]
11
Stephnie Jeane Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.3.2]
+
Joseph Michael Flynn
11
Nicholas Joseph Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.3.3]
+
Johnna M Verardo
+
Edna Mae Thompson
10
Edna Dorothy Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.4]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
10
Norman Francis Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5]
Margaret (Peggy) Louise Clark
11
Michael Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.1]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
11
Norma Louise Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.2]
Richard Eugene Polen
12
Michael Eugene Polen
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.2.1]
12
Lisa Ann Polen
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.2.2]
12
Holly Louise Polen
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.2.3]
12
Amy Elizabeth Polen
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.2.4]
11
Nancy Nell Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.3]
William Richard Mann
12
Steven Joseph Mann
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.3.1]
[
=>
]
12
Gary Allen Francis Mann
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.3.2]
[
=>
]
12
Richard Lee Mann
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.3.3]
12
Leslie Melinda Mann
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.3.4]
[
=>
]
11
Joseph Edward Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.4]
Mary Helen Norman
12
Marilyn Marie Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.4.1]
[
=>
]
12
Michael Norman Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.5.4.2]
10
Kathryn Alberta Otero
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.6]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
11
Michael Allen McCune
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.6.1]
11
Patricia Lee McCune
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.6.2]
11
Barbara Ruth McCune
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.6.3]
Jewell Ray "Bud" DeShon
12
Linda Lee De Shon
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.6.3.1]
[
=>
]
12
Lori Rae De Shon
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.6.3.2]
[
=>
]
12
Larry Dean De Shon
[1.1.1.2.10.1.10.4.7.6.3.3]
[
=>
]
9
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.4.8]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
10
Anita H. Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
11
Edwin Arthur Heacock
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.1.1]
Dorothy Louise
12
Julie Heacock
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.1.1.1]
11
Caroll Jane Heacock
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.1.2]
11
Vivian L. Heacock
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.1.3]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
10
Chester Arthur Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
10
Flournoy Albert Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
10
Stanley St. Clair Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4]
Eleanor Louise Moore
11
Hollis Eleanor Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.1]
+
Lawrence Terry
Wesley Richard Peterson
12
Logan Sven Peterson
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.1.1]
12
Jordan S. Peterson
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.1.2]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
11
Stanley Robert Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.2]
Evelyn Elizabeth Perkins
12
Robert Erwin William Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.2.1]
12
Elizabeth Ann Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.2.2]
11
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.3]
Hugh Washburn Steven
12
Julia Warren Steven
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.3.1]
[
=>
]
12
David Hugh Steven
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.4.3.2]
[
=>
]
10
Louis Dewey Juch
[1.1.1.2.10.1.10.4.8.5]
8
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.5]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
8
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.2.10.1.10.6]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
9
Louisa Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.6.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
10
Rosalie E. McQuade
[1.1.1.2.10.1.10.6.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
9
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.6.2]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
9
Nellie M Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.6.3]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
9
Edna L. Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.6.4]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
9
William P. Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.6.5]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
9
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.6.6]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
8
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.7]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
8
Mary Julia Yancey
[1.1.1.2.10.1.10.8]
b. 1834
+
William D. Roberts
6
David Flournoy
[1.1.1.2.10.2]
b. 14 Apr 1761 d. 30 Jun 1831
+
Elizabeth Mills Britton
b. 17 Oct 1760 d. 30 Jun 1830
6
Gideon Flournoy
[1.1.1.2.10.3]
b. 20 Feb 1751 d. 15 Feb 1821
+
Jane F DeLisle
Grace B. Tarry
b. 1755 d. 20 Dec 1819
7
"Mattie" Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.2.10.3.1]
b. 1795 d. 10 Oct 1855
Arthur Woodfin
b. 1790 d. 9 Oct 1855
8
William G. Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.1]
b. 1817
8
Richard M. Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.2]
b. 1817
8
Thomas E Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.3]
b. 1818
8
John James Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.4]
b. 19 Mar 1820 d. 23 Sep 1860
8
Charles Newton Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.5]
b. 31 Jul 1824 d. 2 Jul 1912
8
Mary Elizabeth Susan Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.6]
b. 12 Jun 1829 d. 23 Nov 1890
8
Arthur Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.7]
b. 1832
8
Harriet Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.8]
b. 1836
8
Martha Woodfin
[1.1.1.2.10.3.1.9]
b. 1838
7
Martha Ann Flournoy
[1.1.1.2.10.3.2]
b. Abt 1798 d. 1847
Thomas Woodfin
b. 1795 d. 1853
8
William Thomas Woodfin
[1.1.1.2.10.3.2.1]
b. 16 Sep 1822 d. 3 Aug 1894
8
Samuel Flournoy Woodfin
[1.1.1.2.10.3.2.2]
b. 4 Aug 1824 d. 14 Feb 1866
8
James Edward Woodfin
[1.1.1.2.10.3.2.3]
b. 1826 d. 1889
8
Jane Woodfin
[1.1.1.2.10.3.2.4]
b. 1828 d. 1892
8
Frances Woodfin
[1.1.1.2.10.3.2.5]
b. 1830
8
George Washington Woodfin
[1.1.1.2.10.3.2.6]
b. 15 Mar 1832 d. 3 Aug 1895
8
Martha Woodfin
[1.1.1.2.10.3.2.7]
b. 1834
8
Rebecca Woodfin
[1.1.1.2.10.3.2.8]
b. 18 Dec 1836 d. 16 Aug 1860
6
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.2.10.4]
b. 25 Nov 1765
+
Isham Britton
b. Bef 1761
6
Julia Briton Flournoy
[1.1.1.2.10.5]
b. Abt 1770
6
John Flournoy
[1.1.1.2.10.6]
b. 29 Apr 1754
6
Thomas Flournoy
[1.1.1.2.10.7]
b. Bef 1767
6
Ursula Harris Flournoy
[1.1.1.2.10.8]
b. 15 May 1749
James Bailey Harris
b. 1749
7
III James Harris
[1.1.1.2.10.8.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
8
Alfred Turpin Harris
[1.1.1.2.10.8.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
9
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.1.2.10.8.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
7
Samuel Harris
[1.1.1.2.10.8.2]
b. Abt 1774
7
Elizabeth Harris
[1.1.1.2.10.8.3]
b. Abt 1776
7
Mary Harris
[1.1.1.2.10.8.4]
b. Abt 1778
6
Hannah Flournoy
[1.1.1.2.10.9]
b. Abt 1762
6
Jordan Flournoy
[1.1.1.2.10.10]
b. 20 Sep 1763 d. 21 Jun 1833
+
Judith Farrar
b. 21 Apr 1756 d. 1828
6
Samuel Flournoy
[1.1.1.2.10.11]
b. 9 Dec 1758 d. 19 Aug 1818
Nancy Ann Martin
b. 1765
7
Samuel Martin Flournoy
[1.1.1.2.10.11.1]
b. 1799 d. 1878
+
Minerva Ann Wadlington
b. 1814 d. 1858
+
Harriett Elvira Fenley
b. 24 Jan 1820
7
Agnes Flournoy
[1.1.1.2.10.11.2]
b. 1799
7
Martha Flournoy
[1.1.1.2.10.11.3]
b. 15 Aug 1813 d. 1891
Randolph Allen Hankla
b. 1 Feb 1803
8
Minerva Nancy Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.1]
b. 29 Mar 1837 d. 1 Apr 1898
8
Pendleton Flournoy Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.2]
b. 24 Mar 1831
8
James Marion F. Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.3]
b. 8 Feb 1833
8
John Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.4]
b. 21 Feb 1835
8
Mary Francis Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.5]
b. 29 Dec 1839
8
Martha Matilda Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.6]
b. 17 Jul 1844
8
Joseph Randolph Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.7]
b. 5 Nov 1847
8
William Harrison Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.8]
b. 17 Feb 1849
8
Ella Eugenia Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.9]
b. 24 Jul 1853
8
Eliza Hankla
[1.1.1.2.10.11.3.10]
b. 2 Dec 1841 d. 7 Aug 1919
7
Matthews Flournoy
[1.1.1.2.10.11.4]
b. 1789 d. 1833
7
James Flournoy
[1.1.1.2.10.11.5]
b. 1 Jan 1791 d. 3 Mar 1855
+
Martha Halloway
b. 1790 d. 1871
7
Jack Flournoy
[1.1.1.2.10.11.6]
b. 1799 d. 1818
7
Nancy Flournoy
[1.1.1.2.10.11.7]
b. 1795
7
Rachel Flournoy
[1.1.1.2.10.11.8]
b. 1797
7
Amelia Flournoy
[1.1.1.2.10.11.9]
b. 1786
7
Emily Flournoy
[1.1.1.2.10.11.10]
b. 1801
7
Patsy Flournoy
[1.1.1.2.10.11.11]
b. 1793
7
Cassandra Flournoy
[1.1.1.2.10.11.12]
b. 1803
6
Martha Flournoy
[1.1.1.2.10.12]
b. Feb 1768
6
Mary Flournoy
[1.1.1.2.10.13]
b. Bef 1756
+
Orlando Jones
b. 31 Dec 1681 d. 12 Jun 1719
+
Richard Hatton
b. 1605 d. 1649
+
Thomas Chamberlaine
b. 1606 d. 7 Jun 1642