News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Françoise Bardet
Abt 1530 - 1595 (65 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Françoise Bardet
[1]
b. Abt 1530 d. 6 Apr 1595
Jean LeGrand
b. 26 Feb 1532 d. 1572
2
Anne LeGrand
[1.1]
b. 12 May 1556 d. 24 May 1636
Simon Mussard
b. 1554 d. 22 Nov 1616
3
Emile François Marie Mussard
[1.1.1]
b. 3 Jul 1579 d. 3 Nov 1618
Jean Flournoy
b. 21 May 1574 d. 3 Jun 1657
4
Mie Flournoy
[1.1.1.1]
b. 11 Feb 1605/06 d. 13 Jul 1629
+
Laurent Legare
4
Judith Flournoy
[1.1.1.2]
b. 3 Jan 1616/17
+
Simon Honnie
4
Francoise Flournoy
[1.1.1.3]
b. 23 Nov 1614 d. 20 Feb 1616/17
4
Andre Flournoy
[1.1.1.4]
b. 17 Nov 1613 d. 9 Jan 1613/14
4
Marguerite Flournoy
[1.1.1.5]
b. 8 Sep 1611 d. 20 May 1695
+
Frederic Canadelle
4
Esther Flournoy
[1.1.1.6]
b. 22 Dec 1600 d. 17 Oct 1601
4
Jeanne Flournoy
[1.1.1.7]
b. 23 Feb 1603/04 d. 14 Apr 1681
+
Etienne Gando
4
Marie Flournoy
[1.1.1.8]
b. 13 Aug 1602 d. 31 Dec 1668
+
Jean Henri Esther
4
Gabriel Flournoy
[1.1.1.9]
b. 10 Oct 1618 d. 18 Oct 1618
4
Jean Flournoy
[1.1.1.10]
b. 30 Oct 1599
+
Judith Payari
d. 16 Apr 1673
4
Jacques Flournoy
[1.1.1.11]
b. 19 Jul 1608 d. 19 Mar 1675
Judith Puerari
b. 8 Apr 1624 d. 14 Nov 1675
5
Sara Flournoy
[1.1.1.11.1]
b. 3 Jun 1647 d. 14 Jan 1647/48
5
Jeanne Flournoy
[1.1.1.11.2]
b. 27 Nov 1645 d. 14 Nov 1688
+
Pierre Archimbaud
5
Jeanne-Marie Flournoy
[1.1.1.11.3]
b. 3 May 1651 d. 29 Aug 1724
+
Jaques Cartier
5
Delie Flournoy
[1.1.1.11.4]
b. 31 Oct 1648
Goy
6
Jacqueline Goy
[1.1.1.11.4.1]
d. 1701
5
Anne-Gabrielle Flournoy
[1.1.1.11.5]
b. 3 Dec 1655 d. 17 Dec 1687
+
Jean Thomegay
5
Elisabeth Flournoy
[1.1.1.11.6]
b. 26 Aug 1653
+
Michel Barrilliet
5
Esaie Flournoy
[1.1.1.11.7]
b. 13 Jan 1659/60 d. 23 Jul 1714
+
Christina Eggens
5
Henry Flournoy
[1.1.1.11.8]
b. 19 Aug 1666
5
Jacob Flournoy
[1.1.1.11.9]
b. 5 Jan 1663 d. Nov 1731
+
Magdeleine Prodhom
b. 24 Jun 1658
Marthe Morel
b. 1667 d. Abt 1695
6
Francois Flournoy
[1.1.1.11.9.1]
b. 31 Jan 1686/87 d. Bef 5 Mar 1773
Mary Gibson
b. 1691
7
Gibson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1]
b. 1 May 1735 d. Bef 6 Jan 1812
Mary Frances Farmer
b. Abt 1736 d. Abt 1817
8
Jr. Gibson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.1]
b. Abt 1768 d. Abt 1806
Martha Ashurst
b. Abt 1772 d. 1801
9
William Henry Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.1.1]
b. Abt 1795 d. 15 Sep 1822
9
Martha Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.1.2]
b. Abt 1797
9
Jane Frances Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.1.3]
b. 17 Jul 1793 d. 14 Feb 1833
Irby Hudson
b. 26 May 1786 d. 12 Apr 1844
10
Caroline Frances Hudson
[1.1.1.11.9.1.1.1.3.1]
b. 5 May 1821 d. 10 Feb 1884
+
Robert Carter Jenkins
b. 15 Nov 1817 d. 2 May 1888
10
Martha Hudson
[1.1.1.11.9.1.1.1.3.2]
b. 23 Nov 1813
10
Elizabeth Hudson
[1.1.1.11.9.1.1.1.3.3]
b. 18 Nov 1815
10
Jane Ann Hudson
[1.1.1.11.9.1.1.1.3.4]
b. 5 Jun 1819 d. 11 Aug 1877
10
Sarah Hudson
[1.1.1.11.9.1.1.1.3.5]
b. 13 Dec 1822
8
Peter Farmer Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.2]
b. Abt 1770
Frances Shipp
9
Permelia Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.2.1]
b. 17 Dec 1797 d. 24 Oct 1870
+
Enoch George Brown
9
Samantha Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.2.2]
9
Whitfield Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.2.3]
9
Maddison Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.2.4]
8
Lawrence M Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3]
b. 1783 d. 1818
Mary Bradford
b. 1785 d. 17 Jan 1816
9
Laura Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.1]
b. 1814 d. 10 Nov 1881
+
Estes
9
Thomas Gibson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2]
b. 14 Aug 1809 d. 1896
Rosannah Stephens
b. 4 Jan 1810 d. 1893
10
Mordicai Gibson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.1]
b. 20 Aug 1836 d. 29 Jun 1920
+
Martha J. Murchison
10
Frances Narcissa Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.2]
b. 23 Jul 1843 d. 8 Jul 1868
10
Isaac Laurence Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.3]
b. 1 Jun 1838 d. 10 May 1862
10
Gideon Davis Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.4]
b. 25 Nov 1839 d. 24 Oct 1915
10
Nancy J. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.5]
b. 23 Jul 1843
10
James Bradford Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.6]
b. 1 Sep 1836 d. 24 Aug 1922
+
Celia Ann Rutland
b. 3 May 1837 d. 30 Jan 1918
10
Jacob "Jake" Ashland Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7]
b. 17 Sep 1841 d. 7 Oct 1919
Eulah M Varner
b. 1 Dec 1846 d. 24 Nov 1915
11
John Walter Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1]
b. 27 Mar 1869 d. 9 Feb 1963
Lenora Abie Calloway
b. 12 Mar 1878 d. 12 Oct 1956
12
Luther Woodrow Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.1]
12
Ralph Burnet Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.2]
12
Frank Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.3]
b. Abt 1911
12
Lenora Bell Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.4]
12
Walter Grady Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.5]
b. 12 Oct 1902 d. 2 Mar 1966 [
=>
]
12
Roy G Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.6]
12
Eulia M Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.7]
12
Homer Monroe Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.8]
12
Archer Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.9]
12
Frank Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.10]
11
Edward Burnett Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.2]
b. 22 Aug 1880 d. 15 Jun 1969
11
James Monroe Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.3]
b. Jan 1886 d. 2 Feb 1971
11
William W Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.4]
b. Oct 1888 d. 12 Mar 1970
11
Mattie Bell Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.5]
b. 13 Aug 1876 d. 23 Jun 1916
11
Jacob Gidden Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.6]
b. 21 Oct 1883 d. 3 Oct 1956
+
Vertie B
b. 30 Jan 1893 d. 23 Apr 1957
11
George Gibson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.7]
b. 16 Apr 1875 d. 23 Dec 1950
Lily E Ashburn
b. 26 Apr 1885 d. 13 Jun 1962
12
George G Flournoy, Jr
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.7.1]
b. Abt 1908
12
L Flourney
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.7.2]
b. 1906
12
Floyd Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.7.3]
b. 1908
12
Sarah E Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.7.7.4]
10
Martha R. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.2.8]
b. Bef 1847
9
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.3]
b. 26 Jun 1812 d. 14 Nov 1888
+
Mariah Louisa Steed
b. 15 Nov 1817 d. 24 Aug 1908
9
Caroline Elizabeth Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.4]
b. 10 Aug 1817 d. 22 Feb 1900
9
Louisa Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.5]
b. 13 Mar 1816 d. 10 Nov 1881
9
Mary Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.3.6]
8
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.4]
b. Abt 1780
8
Phoebe Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.5]
b. 28 Feb 1764 d. 2 Mar 1819
+
William Hill
b. Abt 1760 d. Abt 1850
8
Mary Frances Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.6]
b. 18 Jan 1766 d. Aft 1803
William Pleasant
b. 30 Jun 1767
9
Pleasant
[1.1.1.11.9.1.1.6.1]
b. 15 Jun 1803
9
Thomas Pleasant
[1.1.1.11.9.1.1.6.2]
+
Mary Durham
8
John Francis Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7]
b. 1757 d. 7 May 1842
Mary Ashurst
b. Abt 1770 d. Aft Nov 1834
9
Robert F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.1]
b. 10 Dec 1797 d. 27 Oct 1834
+
Martha Lawton
9
Martha E. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.2]
b. Aft 1793 d. Abt 1859
+
Lewis W. King
d. 1 May 1815
+
Jabez Pleiades Marshall
+
II Irby Hudson
9
Josiah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3]
b. 17 Mar 1789 d. 25 Jan 1842
Martha Dixon "Patsy" Manley
b. 14 Oct 1789 d. 27 Apr 1877
10
Martha Elizabeth Ann Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1]
b. 1827
Walter Richardson Branham
b. 18 Nov 1813 d. 2 Sep 1894
11
Edward Vance Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.1]
b. 18 Nov 1843 d. 10 Aug 1902
Julia Billups
b. 1858 d. 1907
12
Hal Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.1.1]
b. 1888
12
Emmee Connelly Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.1.2]
11
Junius Wingfield Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.2]
b. 1841
Laura Sasnett
b. Abt 1845
12
William Sasnett Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.1]
b. 26 Oct 1866 d. 8 Dec 1930 [
=>
]
12
III Walter Richardson Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.2]
b. 1870 [
=>
]
12
Flournoy Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.3]
b. 1874
12
Bolling Sasnett Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.4]
b. 16 Jul 1880
11
Elizabeth Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.3]
b. Mar 1848
Henry Emory
12
Walter Emory
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Annie Emory
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.3.2]
12
Julia Emory
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.3.3]
11
Jr. Walter Richardson Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.4]
b. Feb 1850
11
Martha Manley Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.5]
b. 3 Jun 1857
11
Henry Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.6]
b. 11 May 1860
+
Sadie Harwell
11
Virlinda Branham
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.1.7]
10
Josiah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.2]
b. 14 Oct 1817 d. 27 Jul 1840
Evelina Powels
11
Georgianne Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.2.1]
11
Samuel Josiah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.2.2]
+
Mary E. Toney
E. J. Toney
12
Roper Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.2.2.1]
b. Abt 1870
Martha W. Rossier
b. 1820 d. 14 Feb 1852
11
Georgianna Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.2.3]
+
Van A. Leonard
11
Samuel Josiah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.2.4]
10
Robert A. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3]
b. 6 May 1825 d. 27 Oct 1896
Eugenia Moffett
b. 8 Feb 1836 d. 4 Jul 1902
11
Dora Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3.1]
b. 14 Sep 1856
+
Jr. Henry H. Epping
b. Cal 1856
11
Thomas Moffett Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3.2]
b. 12 Aug 1859 d. 28 Nov 1913
Araminta Lee Long
12
Robert Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.1]
b. 16 Aug 1900
12
Mary Nisbet Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.2]
b. 1 Jan 1903
12
Rebecca Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.3]
b. 23 Oct 1905
12
Jr. Thomas Moffett Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.4]
12
Eugenia Moffett Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.5]
b. 1 Dec 1893
12
Arminta Long Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.6]
b. 5 Nov 1895
10
Martha D. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.4]
b. 1829
10
Frances 'Fannie' Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.5]
b. 23 Aug 1821 d. 20 Mar 1899
Joel Early Hurt
b. Abt 1821 d. 1865
11
Julia Flournoy Hurt
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.5.1]
d. 31 Dec 1891
+
Peyton Colquitt
+
Lee Jordan
10
Thomas F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6]
b. 1 Dec 1809 d. 29 Jan 1859
Caroline Elizabeth Rogers
b. Abt 1814 d. 23 May 1854
11
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1]
b. 1 Dec 1832 d. 12 Nov 1893
Robert Rutherford Howard
b. 14 Feb 1824 d. 20 Nov 1897
12
John Robert Howard
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.1]
b. 19 Dec 1873 d. 9 May 1948
12
Sallie Howard
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.2]
b. 31 Aug 1851 d. 23 Aug 1902
12
Jennie Howard
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.3]
b. 16 Jun 1859 d. 20 Oct 1920
12
Caroline E. Howard
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.4]
b. Abt 1863
12
Alice V. Howard
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.5]
b. Abt 1865 d. 4 Jul 1944
12
Alice Vivian Howard
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.6]
b. 23 Apr 1865 d. 4 Jul 1944
12
Virginia Moore Howard
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.7]
b. 16 Jun 1860 d. 20 Oct 1920
12
Elizabeth Howard
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.8]
11
Robert Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.2]
b. 25 Nov 1834 d. 24 Jul 1867
Susan B. McKenzie
b. 21 Apr 1838 d. 6 Nov 1889
12
Walter Burch Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.2.1]
b. 15 Oct 1858
12
Ava Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.2.2]
b. 25 Oct 1864
12
Robert Ernest Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.2.3]
b. 6 Dec 1866
12
Charles M. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.2.4]
b. Apr 1860 d. Nov 1864
11
Martha Virginia Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.3]
b. 14 Jul 1838 d. 8 Mar 1907
+
John Castle Moore
11
Caroline Elizabeth Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.4]
b. 16 Aug 1840 d. 12 Sep 1927
+
Bethume Beaton McKenzie
b. 11 Oct 1837
11
Frances Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.5]
b. 9 Jul 1842 d. 29 Feb 1924
+
Frank W. Edison
11
Osborne Rogers Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.6]
b. 1835
+
Fletcher Hardin
b. Abt 1844
+
Mattie Flournoy
11
Thomas Josiah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.6.7]
b. 1 Aug 1846 d. 1885
10
Elizabeth J. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7]
b. Feb 1827 d. 1904
Robert S. Flournoy
b. 1825 d. 1870
11
George Henry Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.1]
b. 14 May 1850 d. 12 Feb 1941
11
Sarah E. "Sallie" Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.2]
b. Dec 1848 d. 26 Sep 1927
11
Martha L. O. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.3]
b. Dec 1856 d. 20 Jul 1922
11
Margaritte L. F. "Maggie" Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.4]
b. Oct 1858 d. 23 Nov 1931
11
Wilson P. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.5]
b. 2 Mar 1855 d. 9 Sep 1939
Emma N.
b. Apr 1871
12
Robert Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.5.1]
b. Oct 1895
12
George F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.5.2]
b. May 1899
12
Tillman Russell Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.5.3]
b. 3 Nov 1898 d. Aug 1971
11
James Pierce Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.6]
b. 1845 d. 20 Nov 1898
11
J. R. F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.7]
b. Abt 1848
11
M. C. F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.7.8]
b. Cal 1856
10
Mary Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.8]
b. 12 Jul 1811 d. 27 Nov 1835
+
Lawrence C. Toombs
d. 3 Sep 1829
+
Gabrial Toombs
10
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.9]
b. 26 Jun 1812 d. 14 Nov 1888
10
John Manly Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10]
b. 14 Jan 1814 d. 14 Sep 1859
Mary Ann Gordon
b. 10 Mar 1823 d. 28 Jul 1886
11
Mary Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.1]
b. 7 May 1852 d. 20 Feb 1875
+
Francis Maury Fontaine
b. 4 Sep 1871 d. 24 Apr 1894
11
Virginia Abercrombie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.2]
b. 7 Oct 1855 d. 20 Aug 1857
11
Charles Gordon Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.3]
b. 24 Dec 1844 d. 5 Apr 1902
+
Addie Gallespie
b. 10 Oct 1859 d. 9 Jan 1920
11
John Francis Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4]
b. 13 Mar 1847 d. 15 Jul 1936
Rebecca Epping
12
Rebecca Epping Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.1]
b. 16 May 1873 d. 27 Jan 1963 [
=>
]
12
Jr. John Francis Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.2]
b. 19 Sep 1871 d. 17 Sep 1937 [
=>
]
Mary Welch Reynolds
b. 1 May 1852 d. 11 Mar 1926
12
Mallory Reynolds Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.3]
b. 15 Oct 1882 [
=>
]
12
Maud Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.4]
b. Apr 1884
12
Josiah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.5]
b. Mar 1886 d. 13 Jan 1954 [
=>
]
12
Gordon Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.6]
b. Dec 1887 d. 4 Feb 1930 [
=>
]
12
Mary Hannah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.7]
b. Apr 1890
12
John Manly Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.8]
b. Dec 1891
12
Walker Reynolds Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.9]
b. Dec 1892 d. 25 Mar 1962 [
=>
]
10
Louisa Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.11]
b. 13 Mar 1816 d. 10 Nov 1881
10
John Manly Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.12]
b. 14 Oct 1817 d. 27 Jul 1840
10
Catherine Caroline Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.13]
b. 5 Oct 1812 d. 28 Sep 1900
+
Willilam Hurt
Nathan Bass
b. 19 Oct 1808 d. 22 Sep 1890
11
Julia Bass
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.13.1]
+
Zachary Taylor Leavell
b. Abt 1847
10
Amanda Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.14]
b. 9 Aug 1815 d. 4 Oct 1816
10
Thomas Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.15]
b. 1826
10
Robert Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.3.16]
b. 6 May 1826 d. 27 Oct 1896
9
Elizabeth A. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.4]
+
Obediah Echols
9
Mary Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.5]
d. Bef 1834
+
John H. Posey
9
Emily Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.7.6]
d. Bef 1834
8
William F. J. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.8]
b. Abt 1775 d. 6 Jun 1831
Nancy Hubart
b. Abt 1776 d. 17 Jun 1829
9
Matthew H. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.8.1]
b. Abt 1801 d. 11 Feb 1828
Elizabeth P. Wright
d. Aft 1829
10
Mary Ann Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.8.1.1]
b. 1827
9
John P. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.8.2]
Agnes Grant
10
Agnes Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.8.2.1]
d. 31 Jul 1840
10
John P. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.8.2.2]
d. 16 Jun 1835
9
William B. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.8.3]
9
Everlina Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.8.4]
+
Mark A. Cooper
8
Daniel Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9]
b. Abt 1777 d. Abt 1830
Sarah P. Wooldridge
9
Augustus Wooldridge Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.1]
b. Abt 1811
+
Anna Eliza Holland
9
John Gibson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.2]
b. 24 Jan 1812 d. Nov 1892
Martha Ann S. Bass
10
Homer Edwin Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.2.1]
11
Bertie Rosa Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.2.1.1]
9
Alvinah Sarah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.3]
+
Peter Williams
9
Virginia Ann Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.4]
+
Robert W. Menefee
9
William Spencer Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.5]
+
Cornelia Bell
b. Abt 1823
9
Hannah Catherine Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.6]
+
Richard Elam Snelling
9
Caroline Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.7]
9
George Morion Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.8]
9
Richard Lafayette Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.9]
9
Ann Spencer Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.10]
9
Elizabeth F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.11]
+
Ball
Judith Flournoy
9
Phoebe Marshall Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.12]
b. Abt 1800 d. Abt 1865
Moab Elam
10
Adolphas Gustovus Elam
[1.1.1.11.9.1.1.9.12.1]
b. 31 Aug 1820
Rebecca Flournoy
11
William Sam Elam
[1.1.1.11.9.1.1.9.12.1.1]
b. Abt 1846
Ezra Seldon Howard
10
Lucy Jane Howard
[1.1.1.11.9.1.1.9.12.2]
10
Susan Emma Howard
[1.1.1.11.9.1.1.9.12.3]
10
Virginia Flournoy Howard
[1.1.1.11.9.1.1.9.12.4]
10
Irby H. Howard
[1.1.1.11.9.1.1.9.12.5]
9
Creed Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.13]
9
Daniel Henry Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.14]
9
Judith Watson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.9.15]
8
Mary Ann Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.10]
b. Abt 1766 d. 1 Jan 1846
+
Peter Mahone
b. 20 Apr 1763 d. Bef 1807
8
Virginia Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.11]
b. Abt 1762
+
Mordecai Jacobs
8
Jane Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.12]
b. Abt 1783
8
David Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.13]
8
Josiah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.1.14]
7
James Flournoy
[1.1.1.11.9.1.2]
b. Abt 1736
7
Josiah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.3]
b. Abt 1738
7
Martha Flournoy
[1.1.1.11.9.1.4]
b. Abt 1740 d. Dec 1805
III Andrew Laprade
b. 1733 d. Aft 29 Apr 1797
8
Nancy Laprade
[1.1.1.11.9.1.4.1]
b. 4 Jun 1765 d. 27 May 1827
William P. Owen
b. 7 Jul 1761 d. 9 Nov 1823
9
Nancy Owen
[1.1.1.11.9.1.4.1.1]
b. 11 Sep 1798 d. 5 Jan 1853
John W. Walker
b. 22 Mar 1792 d. 6 Jan 1871
10
Davis Andrew Walker
[1.1.1.11.9.1.4.1.1.1]
b. 13 Jul 1828 d. 20 Jun 1891
Sarah Adaline Herrin
b. 13 Jul 1828 d. Jan 1859
11
Montgomery Hamilton Walker
[1.1.1.11.9.1.4.1.1.1.1]
b. 24 Mar 1852
Annie America Blythe
d. 30 Oct 1870
12
Alton Edgar Walker
[1.1.1.11.9.1.4.1.1.1.1.1]
b. 3 Oct 1877 d. 28 Oct 1939 [
=>
]
7
Sarah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.5]
b. 1735 d. May 1806
William Wooldridge
b. 1709 d. 1798
8
Sarah Flournoy Wooldridge
[1.1.1.11.9.1.5.1]
b. Abt 1765 d. 1849
+
David Hudspeth
8
Gibson Wooldridge
[1.1.1.11.9.1.5.2]
b. 1750/1755 d. Oct 1816
+
Lucy Elizabeth Hudspeth
+
Mrs. Leah Pool
8
Thomas Flournoy Wooldridge
[1.1.1.11.9.1.5.3]
b. 1756 d. 1836
+
Cheriah Davis
+
Martha Easter
8
Edward Wooldridge
[1.1.1.11.9.1.5.4]
b. 1760/1770 d. 1828
+
Sarah Vining
8
Martha Wooldridge
[1.1.1.11.9.1.5.5]
b. Abt 1770
Joseph T. Davis
b. 1758
9
Thomas W. Davis
[1.1.1.11.9.1.5.5.1]
b. 1791
9
Absalom Davis
[1.1.1.11.9.1.5.5.2]
b. 1793
9
William Davis
[1.1.1.11.9.1.5.5.3]
b. 1796
9
Sarah F. Davis
[1.1.1.11.9.1.5.5.4]
b. 1798
Mary Baugh
b. Abt 1687
7
Jacob Flournoy
[1.1.1.11.9.1.6]
b. Abt 1717
7
Francis Flournoy
[1.1.1.11.9.1.7]
b. Abt 1719
7
William Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8]
b. Abt 1726 d. Aft 1773
Edith Friend
b. 31 May 1754 d. 8 Feb 1805
8
Simon Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1]
b. 1779 d. 6 Aug 1856
Catherine Lucinda Langham
b. 1794 d. Aft 1880
9
Joseph B Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1]
b. Dec 1825 d. 3 Jun 1909
Louisa Denham
b. Oct 1823 d. Aft 1910
10
Joanna Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.1]
b. 1858
10
James Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.2]
b. Mar 1864
Sarah
b. Sep 1872
11
Lizzie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.2.1]
b. May 1886
11
Liza Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.2.2]
b. Jul 1890
11
Jack Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.2.3]
b. Sep 1892
11
Sarah J. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.2.4]
b. Jun 1898
10
William Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.3]
b. 1861
10
Davis Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.4]
b. 1850
10
Joseph Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.5]
b. 1858
+
Victoria Quick
b. 1861
10
Louis Andrew Jackson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6]
b. 23 Feb 1859 d. 19 Jan 1960
Joanna J. Flournoy
b. Aug 1878 d. 6 Mar 1936
11
Mollie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.1]
b. 1887
11
Terrell Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.2]
b. 1892
11
Florence Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.3]
b. 1896
11
Carrie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.4]
b. 1897
11
Eugene Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.5]
b. 1900
11
Sallie B. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.6]
b. 1902
11
Andrew Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.7]
b. 11 Jun 1895 d. 9 Sep 1968
Nancy Hill Pinson
12
Raymond Rockmore Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.7.1]
11
Walker Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.8]
b. 1893
Annie
b. 1900
12
Julius Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.8.1]
12
J.T. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.6.8.2]
10
John F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7]
b. 11 Sep 1840 d. 20 Jan 1937
Aldine Pike
b. 1839
11
Joseph Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.1]
b. Feb 1862 d. 19 Oct 1946
Dolly (Sallie) Daniel
b. 1871
12
Warner Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.1]
b. 29 Aug 1899 d. 15 Jan 1969 [
=>
]
12
Eva M. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.2]
b. Aug 1895 [
=>
]
12
Virgil M. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.3]
[
=>
]
Willie Kerns
b. 1890
12
Olin Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.4]
12
Obediah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.5]
b. 1910
11
John J. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.2]
b. 6 Mar 1877 d. 25 Dec 1956
Mattie Bowen
b. 1881
12
Bessie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.1]
b. 1906
12
Clarence Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.2]
b. 1906
12
John Henry Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.3]
b. 1909
12
Ripley (Walter) Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.4]
b. 1910
12
Mattie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.5]
12
Thomas J. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.6]
11
William F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.3]
b. Jul 1875 d. 13 Feb 1950
Ineza
b. Mar 1881 d. 29 Mar 1955
12
Eley E. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.3.1]
[
=>
]
12
Stenson Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.7.3.2]
b. 1911
10
Mary Lou Ellen Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.8]
b. 26 Sep 1856 d. 6 Apr 1945
John Whitley
b. Cal 1850
11
James Whitley
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.8.1]
b. Cal 1872
11
Joseph Whitley
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.8.2]
b. Cal 1875
11
Mary Whitley
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.8.3]
b. Cal 1876
11
Madison Whitley
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.8.4]
b. Jun 1879
Thomas
11
Mary Lou Ellen Thomas
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.8.5]
+
Stillwell
+
Wade
10
Simon Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.9]
b. 1849 d. 29 Dec 1935
Eliza Ann Pike
b. 1847
11
James Franklin Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.9.1]
b. 15 Jan 1874 d. 13 Jan 1964
Mary Ann Pitts
b. Sep 1879
12
Jr. James Franklin Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.9.1.1]
b. 8 Jul 1899
11
Mattie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.9.2]
b. Cal 1877
11
Simon Matthew Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.1.9.3]
+
Effie Harbuck
+
Sallie Moore
9
William Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.2]
b. Abt 1810 d. Aft 1880
9
Joannah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.3]
b. 1820 d. Aft 1880
9
Sarah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.4]
b. 1821
9
Jr. Simon Flournoy, Jr
[1.1.1.11.9.1.8.1.5]
b. Jan 1812 d. 6 Aug 1856
Martha Ann Teal
b. 1827 d. 1904
10
Sarah E Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.1]
b. 1844
10
Simon F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.2]
b. Mar 1852 d. 13 Mar 1919
Sallie
b. 1852
11
Sallie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.2.1]
b. 1880
10
Joseph B J Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.3]
b. 17 Mar 1868 d. 27 Jun 1923
+
Mattie
b. May 1866
10
Peter F Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.4]
b. 2 Apr 1868 d. 25 Nov 1942
Lucy A Pitts
b. Dec 1860
11
Frankie May Flonrnoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.4.1]
b. Jul 1883
11
Lucius Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.4.2]
b. Abt 1895
11
John Flonrnoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.4.3]
b. Apr 1884
10
Jo Anna Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.5]
b. 1864
10
John Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.6]
b. 1861
10
James Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.7]
b. 13 Nov 1860 d. 1 Jun 1931
10
Mary Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.8]
b. 1857
10
Tillman F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9]
b. Jul 1849 d. 20 Jan 1935
Mary Jane Chatman
b. Oct 1851 d. 1932
11
Joanna J. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1]
b. Aug 1878 d. 6 Mar 1936
Louis Andrew Jackson Flournoy
b. 23 Feb 1859 d. 19 Jan 1960
12
Mollie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.1]
b. 1887
12
Terrell Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.2]
b. 1892
12
Florence Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.3]
b. 1896
12
Carrie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.4]
b. 1897
12
Eugene Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.5]
b. 1900
12
Sallie B. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.6]
b. 1902
12
Andrew Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.7]
b. 11 Jun 1895 d. 9 Sep 1968 [
=>
]
12
Walker Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.8]
b. 1893 [
=>
]
11
William S. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.2]
b. Sep 1881
11
Catherine "Kittie" Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.3]
b. 7 Sep 1884 d. 25 Jun 1960
+
George McCoy
11
Isaac Tillman Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.4]
b. 24 Jul 1886 d. 30 Jul 1935
11
Lucy Ann Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.5]
+
Jr. James Thomas Mealor
b. 27 Jan 1879 d. 15 Sep 1967
11
Mary Mehatibel Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.6]
b. 12 Jul 1892 d. 3 Jun 1964
John Warren Brown
b. 12 Nov 1889 d. 23 Feb 1948
12
Margaret Brown
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.6.1]
12
Lizzie Brown
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.6.2]
b. Abt 1911
12
Blanche Brown
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.6.3]
12
John Warren Brown, Jr
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.6.4]
11
Walker Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.7]
b. Jul 1893 d. 25 Mar 1962
11
Martha Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.8]
b. 5 Aug 1895 d. 9 Jan 1898
+
John W. McGouirk
11
Henry Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.9]
b. Aug 1897
11
James Franklin "Frank" Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.10]
b. 15 Oct 1877 d. 13 Jan 1964
Mary Ann Pitts
b. Sep 1879
12
May Bell Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.10.1]
b. Cal 1904
12
James F Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.10.2]
b. Jul 1899
12
Emmett C Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.10.3]
b. Abt 1901
12
George W Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.9.10.4]
b. Abt 1903
10
Joel L. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10]
b. 9 Sep 1846 d. 14 Dec 1932
Nancy Elizabeth Calhoun
b. 17 Aug 1856 d. 17 Mar 1942
11
Clarence Dewey Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.1]
11
Susie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.2]
11
Egrilma Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.3]
b. Jul 1895
11
Ilga Mattie Flourney
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.4]
b. Oct 1898 d. 17 Apr 1959
11
Mollie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.5]
b. Abt 1896
11
Minnie Lee Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.6]
b. 31 Oct 1891 d. 8 Sep 1967
11
Mattebell Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.7]
b. Feb 1885 d. 17 Apr 1959
11
Isaac Chaney Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.8]
b. 24 Sep 1880 d. 28 Oct 1918
11
Hattie Ethel Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.9]
b. Abt 1902 d. 2 Dec 1961
11
Luella Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.10]
b. Aug 1883 d. 11 Jan 1958
11
Willie Duke Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.11]
b. 1 Apr 1889 d. 18 May 1970
11
Brock Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.12]
11
Callie Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.13]
Mary Jane "Bertie" Moody
b. 2 Feb 1843
11
Marion Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.14]
b. Feb 1872 d. 31 Jan 1937
11
George Hamilton "Hamp" Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15]
b. Abt 1863 d. 24 Apr 1953
Ada Elizabeth Milam
b. Abt 1880 d. 1943
12
George W. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.1]
b. Cal 1902
12
Claude Hamilton Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.2]
b. Abt 1895
12
Maud Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.3]
b. Abt 1898
12
Royce G. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.4]
12
Robert Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.5]
12
Eddie B Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.6]
b. Abt 1907
12
Earnest Grady Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.7]
b. Abt 1909
12
Eunice V Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.8]
12
Bertha B Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.9]
11
John Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.5.10.16]
9
Catherine Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.6]
b. 1812
9
Ameraca Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.7]
9
Ellen Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.1.8]
8
Francis Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.2]
b. Abt 1776
8
Jane F. Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.3]
b. Abt 1783
8
Greene Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.4]
b. Abt 1786
8
Edith Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.5]
b. 1788
8
Margaret Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.6]
b. 1794
8
Ann Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.7]
8
John Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.8]
8
Martha Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.9]
8
Mary Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.10]
8
Sarah Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.11]
8
Thomas Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.12]
8
Jr. William Flournoy
[1.1.1.11.9.1.8.13]
+
Phoebe Farrar
b. Abt 1769
7
Jane Flournoy
[1.1.1.11.9.1.9]
b. 1726 d. 1806
+
Simon Hancock
7
Mary Flournoy
[1.1.1.11.9.1.10]
b. Abt 1713
+
Edward Wooldridge
b. 1711 d. 10 Oct 1808
7
Jean Flournoy
[1.1.1.11.9.1.11]
b. Abt 1715
6
Jacques Flournoy
[1.1.1.11.9.2]
b. 14 Dec 1688 d. 1740
6
Marie Flournoy
[1.1.1.11.9.3]
b. 3 Jun 1690 d. Abt May 1700
6
Jeanne-Marie Flournoy
[1.1.1.11.9.4]
b. 19 Jan 1692/93 d. 23 Jan 1692/93
6
Jeanne Francoise Flournoy
[1.1.1.11.9.5]
b. 28 Mar 1695 d. Abt 1717
Robert Ashurst
7
Jacob Ashurst
[1.1.1.11.9.5.1]
6
Magdalaine Flournoy
[1.1.1.11.9.6]
b. Abt 1685 d. Aft 1731
5
Jacques Jean Flournoy
[1.1.1.11.10]
b. 15 Sep 1657 d. 22 Feb 1725
Julia Eyrand
b. 16 Aug 1664 d. 16 Aug 1756
6
Julie Flournoy
[1.1.1.11.10.1]
b. 29 Nov 1699 d. 30 Nov 1699
6
Gedeon Flournoy
[1.1.1.11.10.2]
b. 2 Dec 1691
+
Jeanne Francoise Comparet
b. 4 Feb 1689/90
6
David Flournoy
[1.1.1.11.10.3]
b. 8 Nov 1698 d. 2 Jul 1745
6
Flournoy
[1.1.1.11.10.4]
b. 5 Aug 1693 d. 5 Aug 1693
6
Rachel Flournoy
[1.1.1.11.10.5]
b. 7 Apr 1685
6
Jean Jacques Flournoy
[1.1.1.11.10.6]
b. 17 Nov 1686 d. 23 Mar 1740
Mary Williams
b. 25 Dec 1695 d. 25 Mar 1740
7
Rachel Flournoy
[1.1.1.11.10.6.1]
b. 25 Sep 1730 d. 28 Aug 1741
7
David Flournoy
[1.1.1.11.10.6.2]
b. 3 Sep 1728 d. 18 Oct 1757
7
Mathews Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3]
b. 21 Jun 1732 d. 1785
Elizabeth Ann Pryor
b. 1739 d. Jun 1798
8
Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1]
b. 13 May 1763 d. 5 Jul 1825
Mary Willis Cobbs
b. 15 Apr 1777 d. 8 Feb 1829
9
Howell Cobb Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.1]
b. 21 Mar 1813 d. 1872
9
Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.2]
b. 5 Mar 1811 d. 24 Aug 1894
Amanda Cullens
b. 1816 d. Bef 1858
10
Elizabeth M. Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.1]
b. 24 Jul 1844
A. E. Andrews
11
Robert Watkins Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.1.1]
b. 1867 d. Bef 1900
Anna Roberta Flournoy
b. Dec 1868 d. Aft 1900
12
Albert R. Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.1.1.1]
b. 1869
12
Elizabeth F. Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.1.1.2]
b. 1882
12
Gasaway Knight Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.1.1.3]
b. 1887
12
Haynes Cullens Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.1.1.4]
10
Jr. Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.2]
b. 13 Dec 1841 d. 8 Jun 1869
Ophelia C. Tucker
b. 6 Oct 1844 d. Aft 1900
11
Robert Willis Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.2.1]
b. 22 Sep 1867
+
Martha Redd Fontaine
b. Sep 1873
11
Anna Roberta Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.2.2]
b. Dec 1868 d. Aft 1900
Robert Watkins Andrews
b. 1867 d. Bef 1900
12
Albert R. Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.2.2.1]
b. 1869
12
Elizabeth F. Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.2.2.2]
b. 1882
12
Gasaway Knight Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.2.2.3]
b. 1887
12
Haynes Cullens Andrews
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.2.2.4]
Louisa St. Clair Cullens
b. 9 Feb 1838 d. 9 Oct 1916
10
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.3]
b. 24 Sep 1858 d. 14 May 1929
James Wilson Bell
b. 6 May 1853 d. 27 Oct 1925
11
Rosa Wilson Bell
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.3.1]
+
Robert Lee Campbell
b. 25 Nov 1882 d. 11 Aug 1952
11
Mary Cobb Bell
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.3.2]
b. 17 Jan 1885 d. 8 Mar 1965
+
Erskine Miller Carr
b. 22 Jan 1883 d. 17 Oct 1932
11
Watkins Flournoy Bell
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.3.3]
b. Jan 1895 d. Bef 1950
+
Whitfield King
d. Bef 1950
11
Lillian Tennille Bell
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.3.4]
+
Henry Pittman Hurt
b. 26 Feb 1872 d. 20 Nov 1944
11
Robert Flournoy Bell
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.3.5]
b. 27 Apr 1879 d. 30 Jun 1896
11
James Bell
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.3.6]
b. 6 May 1891 d. 27 Jan 1893
11
Mary Louise Bell
[1.1.1.11.10.6.3.1.2.3.7]
b. 3 Jun 1877 d. 6 Nov 1878
9
Marcus Aurelius Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.3]
b. 9 Oct 1795
9
Thomas Howell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.4]
b. 19 Mar 1797 d. 1797
9
Elizabeth America Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.5]
b. 18 May 1800 d. INFANT
9
Robert Willis Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.6]
b. 11 Dec 1802 d. Jan 1845
9
Mary Mildred Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.7]
b. 8 Jan 1805 d. 1874
+
Nathaniel Alexander Adams
d. 28 Aug 1849
9
John James Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.8]
b. 15 Aug 1808
9
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.1.9]
b. 25 May 1815 d. 14 Apr 1844
Charles G. McKinley
10
William M. McKinley
[1.1.1.11.10.6.3.1.9.1]
b. 1 May 1835
10
Mary Elizabeth McKinley
[1.1.1.11.10.6.3.1.9.2]
b. 16 Sep 1840 d. 25 Apr 1845
10
Elizabeth Julia McKinley
[1.1.1.11.10.6.3.1.9.3]
d. 25 Apr 1845
8
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.2]
b. 1768 d. 1813
William Gustavus Henry
b. 1761 d. 1824
9
William Henry
[1.1.1.11.10.6.3.2.1]
b. 1793 d. 1847
Cornelia VaVasour Gano
b. 20 Apr 1801 d. 2 Mar 1887
10
Robert William Henry
[1.1.1.11.10.6.3.2.1.1]
b. 1823 d. 1862
Martha Douglas Cocke
b. 17 Dec 1822 d. 28 Mar 1850
11
Martha Douglas Henry
[1.1.1.11.10.6.3.2.1.1.1]
b. 24 Feb 1850 d. 29 Jan 1924
Leonidas Armstead Sypert
b. 1832 d. 1893
12
Susan Jouett Sypert
[1.1.1.11.10.6.3.2.1.1.1.1]
b. 1881 d. 1 Sep 1954 [
=>
]
9
Matthews Winston Henry
[1.1.1.11.10.6.3.2.2]
b. 11 Jan 1790
8
Martha Caroline Flournoy
[1.1.1.11.10.6.3.3]
b. 1764 d. 1803/1806
John Thomas Wells
b. 1760 d. 1802
9
Francis Flournoy Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1]
b. Abt 1800 d. Nov 1866
Martha McNutt
10
Robert Williamsom Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.1]
b. 3 Aug 1849
10
Lucky Francis Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.2]
b. 18 May 1846 d. 1915
Francis M. Sutherland
11
Flora S. Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.2.1]
b. Feb 1881
11
Thomas J. Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.2.2]
b. Oct 1878
11
Robert W. Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.2.3]
b. Sep 1875
10
Flora Adelia Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3]
b. 31 Dec 1833 d. 25 Dec 1914
George F. Simons
b. 14 Feb 1834
11
George F. Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.1]
b. Jul 1872
Mary Lula Rose
b. 31 May 1874
12
Mattie L. Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.1]
12
Volney Rose Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.2]
[
=>
]
12
Steele White Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.3]
[
=>
]
12
George Wells Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.4]
b. 1912
11
F. Wells Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.2]
b. Aug 1868
Susan Ann Rose
b. Apr 1871
12
George F. Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.2.1]
b. Apr 1898
12
Flora L. Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.2.2]
b. Jul 1894
11
William U. Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.3]
b. 1866
11
Courtney Stuart Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.4]
b. 1865
12
Jr. Courtney Stuart Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.4.1]
12
Kerr Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.4.2]
b. Yes, date unknown
11
Martha W. Simons
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.3.5]
b. 1861
10
Elizabeth Casandra Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.4]
b. 1828
10
Laura Martha McNutt Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5]
b. 13 Jul 1827
Clark Lewis Owen
b. 6 Jun 1807 d. 6 Apr 1862
11
Owen
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.1]
b. 1852
11
Laura Minta Owen
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2]
b. 1850 d. Mar 1885
John Owen Rowlett
b. 6 Aug 1847 d. 21 Oct 1918
12
Henry J. Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.1]
b. 1879
12
A. Owen Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.2]
b. 1880 d. 1942
12
Mary Laura Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.3]
b. 1873
12
John O. II Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.4]
b. 1875
12
Ruth I. Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.5]
b. 1876 d. Sep 1957
12
George Simons Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.6]
b. 4 Sep 1884 d. 1956 [
=>
]
12
Flora Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.7]
12
Pansy Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.8]
12
Laura Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.9]
12
Daniel Rowlett
[1.1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.10]
9
Lewis Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.2]
9
Martha Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.3]
9
Cassandra Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.4]
9
Frank Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.5]
9
John J. Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.6]
9
Thomas Flournoy Wells
[1.1.1.11.10.6.3.3.7]
7
John Flournoy
[1.1.1.11.10.6.4]
b. 9 Dec 1726 d. 19 Jan 1825
+
Camilla Ballexserd
b. 1722 d. 1743
7
Thomas Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5]
b. 20 Nov 1738 d. 25 Feb 1801
Anne Martin
d. 1814
8
Lucy Faris Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.1]
b. 1786 d. 1836
William Booker Morton
b. 3 Sep 1775 d. 10 Aug 1816
9
Elvira Henry Morton
[1.1.1.11.10.6.5.1.1]
b. 1806 d. 1840
William Peter Barksdale
b. 1799 d. 1854
10
Louisa Frances Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.1.1]
b. 1830 d. 1907
John Bullock Crews
b. 1814 d. 1882
11
Louise Barksdale Crews
[1.1.1.11.10.6.5.1.1.1.1]
11
Frances Sydnor Crews
[1.1.1.11.10.6.5.1.1.1.2]
11
Rosa Crews
[1.1.1.11.10.6.5.1.1.1.3]
+
Nicholas Hairston
9
Anne Martin Morton
[1.1.1.11.10.6.5.1.2]
b. 1804
William Henry Dennis
b. 1801 d. 1866
10
Jacob Dennis
[1.1.1.11.10.6.5.1.2.1]
9
Mary Elizabeth Morton
[1.1.1.11.10.6.5.1.3]
b. 24 Apr 1808 d. 13 Dec 1889
William Sydnor Barksdale
b. 7 May 1806 d. 10 Sep 1874
10
Lucy Ann Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1]
b. 4 Oct 1828 d. 11 Jan 1906
James Woodford Arendall
b. 20 Jan 1820 d. 17 Mar 1871
11
Lucy Flournoy Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.1]
b. 5 Jun 1862 d. 11 Dec 1888
11
Judith Williams Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.2]
b. 16 Sep 1865 d. 31 Aug 1896
Robert V. Farmer
12
Maude M. Farmer
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.2.1]
b. 10 Mar 1885
11
Elizabeth Frances Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.3]
b. 23 May 1867 d. 12 Jun 1895
W. G. Slayton
12
Hattie S. Slayton
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.3.1]
b. 15 Jan 1885 d. 12 Sep 1886
11
Virginia Alice Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.4]
b. 26 Dec 1869
Charles King Petty
12
Henry T. Petty
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.4.1]
b. 3 Oct 1896
11
William Barksdale Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.5]
b. 25 Apr 1849 d. 11 Nov 1911
Phebe Pennich Dixon
d. 11 Jul 1898
12
Agis Lycurgus Lafayette Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.1]
b. 16 Dec 1871
12
Thomas Frank Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.2]
b. 30 May 1874
12
Morton Armistead Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.3]
b. 2 Aug 1877 d. 2 Aug 1879
12
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.4]
b. 8 Jan 1880
12
Alice M. Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.5]
b. 10 Jun 1884
12
Lou Boyd Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.6]
b. 27 Jul 1888 d. 11 Sep 1889
12
Rosa Crews Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.7]
b. 18 Mar 1891 d. Jan 1970 [
=>
]
11
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.6]
b. 23 Apr 1851 d. 28 Sep 1853
11
Ann Catherine Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.7]
b. 7 Mar 1853 d. 15 Jul 1882
Alexander D. Thompson
12
Sandy S. Thompson
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.1]
b. 5 Jul 1878
12
Adel May Thompson
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.2]
b. 30 Apr 1881 d. 18 Mar 1882
12
Maud Iola Thompson
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.3]
b. 16 Feb 1879
12
John Armistead Thompson
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.4]
b. 9 Oct 1876 d. 20 Jun 1878
12
Charles Woodford Thompson
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.5]
b. 10 Oct 1873
12
William M.B. Thompson
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.6]
b. 25 Jun 1875
11
John Armstead Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.8]
b. 12 Jan 1855 d. 1 Jul 1935
Alice Madison Cole
b. 3 Feb 1854 d. 29 Jan 1940
12
John William Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.1]
b. 19 Nov 1885 d. 31 Mar 1936 [
=>
]
12
James Newton Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.2]
b. 11 Jul 1877
12
Luella T. Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.3]
b. 6 Oct 1879 d. 10 Sep 1964 [
=>
]
12
Patsy Cole Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.4]
b. 6 Oct 1888
12
Kathleen Kent Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.5]
b. 23 Apr 1896
12
Allie Lovelace Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.6]
b. 24 Jul 1894
11
Thomas Syndor Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.9]
b. 11 May 1857 d. 1940
Virginia Lee Shields
b. Abt 1862
12
Jake Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.9.1]
b. Abt 1885 [
=>
]
11
James Morton Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10]
b. 29 Feb 1860 d. 14 Dec 1938
Jennie Sarah Farmer
b. 29 Sep 1865 d. 12 Apr 1948
12
Sue Brown Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.1]
12
John Carson Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.2]
12
Minnie Gunn Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.3]
12
James Herbert Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4]
b. 25 Dec 1883 d. 16 Feb 1961 [
=>
]
12
Molly B. Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.5]
b. 25 Nov 1888 d. 28 Dec 1972 [
=>
]
12
Emma Carter Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6]
[
=>
]
12
Tap McDowell Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.7]
b. 4 Jul 1896 d. 14 Oct 1962
12
Bettie Arendall
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.8]
[
=>
]
10
John Thomas Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.2]
b. 9 Mar 1844
10
Mary Susan Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.3]
b. 22 Jun 1846
10
Alice Sydnor Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.4]
b. 31 Oct 1848
10
Flournoy X. Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.5]
b. 23 Jun 1852
10
Judith Williams Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.6]
b. 16 Mar 1831
10
Elizabeth Armistead Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.7]
b. 3 Aug 1833
10
William Morton Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.8]
b. 2 Jan 1837
10
Elvira Frances Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.9]
b. 28 Jul 1839
10
Anthony Sydnor Barksdale
[1.1.1.11.10.6.5.1.3.10]
b. 29 Nov 1841
9
William Booker Morton
[1.1.1.11.10.6.5.1.4]
b. 1811
+
Faris
8
David Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2]
b. Abt 1780
Mary Morton
b. Abt 1782
9
Thomas Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1]
b. 25 Jul 1804 d. 27 Dec 1892
Frances Matthews Venable
b. Abt 1810 d. 16 Aug 1863
10
Martha Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.1]
b. 28 Jul 1837
+
William Henry Venable
10
Nathaniel Abraham Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.2]
b. 20 Jan 1839
Laura Lewis
11
John Herbert Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.2.1]
Florence Wilson
12
John Wilson Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.2.1.1]
11
Fannie Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.2.2]
+
Charles Kimbro Taylor
11
Norborne Lewis Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.2.3]
11
Thomas Lewis Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.2.4]
+
Lois Latimer
10
II David Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.3]
b. 20 May 1829 d. 20 Nov 1895
Martha Daniel Bouldin
b. 11 Jan 1852
11
Fannie Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.3.1]
b. 3 Jul 1872
11
Thomas Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.3.2]
b. 12 Oct 1877 d. 19 Sep 1947
+
Mary Harvey Hamlin
b. 22 Jun 1873 d. 25 Jul 1967
11
Martha Daniel Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.3.3]
b. 15 Mar 1871
10
Frances Watkins Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4]
b. 24 Sep 1830 d. 1900
Jr. Thomas Tyler Bouldin
b. 24 Mar 1813 d. 1891
11
Ellen Barksdale Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.1]
b. 10 Feb 1860
11
Fanny Louis Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.2]
+
Preston Buford
11
Mary Willie Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.3]
11
Henry Wood Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.4]
Lilla Coles
12
Fanny Lewis Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.4.1]
12
Lilla Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.4.2]
12
Thomas Tyler Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.4.3]
11
Martha Cabell Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.5]
+
Gentry
11
Flournoy Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.6]
Annie White
12
Elizabeth Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.6.1]
b. Abt 1895
11
Clairborne Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.7]
Mary Crump
12
Alice Good Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.7.1]
12
Thomas Tyler Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.7.2]
12
Mary Crump Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.7.3]
12
Jr. Clairborne Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.7.4]
11
John Lewis Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.8]
+
Hetty Jones
11
Annie Venable Bouldin
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.4.9]
+
Thomas W. Daniel
10
Amanda Nantz Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.5]
b. 8 May 1835
10
William Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.6]
b. 29 Nov 1835 d. 30 Mar 1836
10
Mary Agnes Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7]
b. 23 Aug 1828
William H. Marshall
11
Pattie Venable Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.1]
+
Wood Dunham
11
Amanda F. Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.2]
11
James Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.3]
Carey Knox
12
James Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.3.1]
12
Ruth Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.3.2]
11
Louise Cabell Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.4]
Matthews Fink
12
Marshall Scott Fink
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.4.1]
12
Paul Fink
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.4.2]
12
Miriam Fink
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.4.3]
11
Sallie Anne Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.5]
Judson Lloyd
12
Mary Lloyd
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.1]
[
=>
]
12
John Lloyd
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.2]
12
Kathleen Lloyd
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.3]
[
=>
]
12
Robert Lloyd
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.4]
11
Fannie T. Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.6]
William H. Marshall
12
Pattie Venable Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.6.1]
12
James Marshall
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.7.6.2]
10
Jacob Morton Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.8]
b. 7 Oct 1843
Mildred Coles Carrington
b. Abt 1845
11
Walter Carrington Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.8.1]
b. Abt 1875 d. 1896
11
Thomas Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.8.2]
11
Anna Lightfoot Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.8.3]
11
Elizabeth Morton Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.8.4]
10
William Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.9]
b. 24 Oct 1846
10
Louisa Cabell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10]
b. 2 Nov 1841
Richard Field
11
Louise Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.1]
+
Albert McCracken
11
Meade Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.2]
11
George Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.3]
11
Martha Venable Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.4]
11
Anna Morton Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.5]
+
William Moran
11
Nona Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.6]
+
Sandridge
11
Kate Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.7]
+
Horace Hayden
11
Fanny Venable Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.8]
+
Oscar Collins
11
Sally Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.9]
11
David Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.10]
11
Eva Field
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.10.11]
+
Robert E. Lee Morton
10
Elizabeth Anne Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.11]
b. 26 Nov 1840
Reubin Booth Hicks
11
Thomas Hicks
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.11.1]
Jennie Bowber
12
Elizabeth Baten Hicks
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.11.1.1]
12
Francis Venable Hicks
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.11.1.2]
12
Thomas Flournoy Hicks
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.11.1.3]
12
Reubin Booth Hicks
[1.1.1.11.10.6.5.2.1.11.1.4]
+
Sally Edmunds Hicks
b. Abt 1827
+
Agnes Woodson Watkins
b. 28 Feb 1774
8
Anne Farish Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.3]
b. Abt 1772
Archer Womack
b. 1777 d. 1816
9
Julia Ann Womack
[1.1.1.11.10.6.5.3.1]
b. 22 Sep 1815 d. 1 Jan 1887
Joseph Richard Bailey
b. 1815 d. 28 Aug 1857
10
David Flournoy Bailey
[1.1.1.11.10.6.5.3.1.1]
b. 1845
Sarah Eleanor Preston
b. 1843
11
Julia Bailey
[1.1.1.11.10.6.5.3.1.1.1]
+
William T. Tillar
10
Louise Bailey
[1.1.1.11.10.6.5.3.1.2]
b. Cal 1844
10
Anna A. Bailey
[1.1.1.11.10.6.5.3.1.3]
b. Cal 1850
8
Julia Elizabeth Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.4]
b. 7 Sep 1767 d. 5 Nov 1836
George Wells Foster
9
Ann Martin Foster
[1.1.1.11.10.6.5.4.1]
b. Abt 1788
+
Lovick Pierce
8
John James Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5]
b. 15 Oct 1782 d. 1862
Ann Carrington Cabell
b. 20 Sep 1787 d. 7 Jul 1854
9
Ann Eliza Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.1]
b. 1808
+
Henry Wood
9
William Cabell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2]
b. 31 Dec 1809 d. 31 Mar 1861
Martha Watkins Venable
b. 5 Jun 1816 d. 1905
10
William Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.1]
b. Abt 1839 d. Abt 1842
10
Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2]
b. 4 Mar 1850
Susan Cabell Cobbs
b. 5 Nov 1864
11
Mildred Cobbs Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.1]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
11
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.2]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
11
Mary Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.3]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
11
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.4]
b. 20 Sep 1890
11
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.5]
b. 24 Oct 1896
Martha G. Givens
b. 1858 d. 9 May 1884
11
Martha Watkins Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.6]
b. 24 Dec 1882
11
Sarah Wright Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.7]
b. 9 Apr 1881
+
Butts
11
Florida Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.8]
b. 31 Aug 1879
11
Bessie Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.2.9]
b. 29 Jan 1878
+
Brown
10
George Mallory Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1853
10
Charles Bruce Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.4]
b. 11 Nov 1854
+
Virginia Dalby
10
Alice Eliza Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.5]
b. 4 Nov 1852
+
Littleton Fitzgerald
10
Sarah Venable Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.6]
b. 12 Aug 1845
+
J. C. Painter
10
Benjamin Stanhope Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.7]
b. Abt 1841 d. Abt 1842
10
II John James Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.8]
b. 13 Apr 1837 d. 7 Jan 1875
10
Ann Cabell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.9]
b. Abt 1835 d. Abt 1837
10
Frances Florida Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.2.10]
b. 6 Jul 1843
+
John P. Fitzgerald
9
Patrick Henry Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.3]
b. 4 Mar 1813 d. 3 Mar 1887
Susan Edmunds
10
Nicholas Edmunds Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.3.1]
b. 23 Mar 1841
+
Catharine Patrick Wood
10
William Stanhope Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.3.2]
b. 23 Dec 1845
+
Bettie A. Wilson
10
Ann Cabell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.3.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1848
9
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4]
b. 15 Dec 1811 d. 12 Mar 1883
Susan Ann Love
d. 21 Apr 1848
10
Mary P. Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.1]
b. 11 Sep 1838 d. 1874
John F. Cobbs
11
Susan Cabell Cobbs
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.1.1]
b. 5 Nov 1864
Landon Cabell Flournoy
b. 4 Mar 1850
12
Mildred Cobbs Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.1]
b. 6 Sep 1892
12
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.2]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
12
Mary Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.3]
b. 9 Mar 1889
12
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.4]
b. 20 Sep 1890
12
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.5]
b. 24 Oct 1896
10
Cabell Edward Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.2]
b. 30 Jun 1840 d. 1864
10
John James Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.3]
b. 11 Apr 1842
10
Louisa Cabell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.4]
b. 3 May 1844
+
William W. Cobbs
10
Henry Wood Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.5]
b. 6 Jun 1846
+
Rose Buena Wood
10
Allen Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.6]
d. Abt 1849
Mildred H. Coles
d. 1901
10
Helen Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.7]
b. 9 May 1856
+
John R. Patton
10
Ann Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.8]
b. Abt 1858 d. Abt 1862
10
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.9]
b. 8 May 1860
10
Cole Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.10]
b. 1 Oct 1862
10
Lettice Carrington Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.11]
b. 21 Aug 1865
10
Charles Carrington Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.12]
b. 17 Feb 1871
10
Walter Cole Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.5.4.13]
8
Mary Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.6]
8
Marcia Martin Flournoy
[1.1.1.11.10.6.5.7]
7
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.11.10.6.6]
b. 5 Dec 1721 d. Jul 1793
Thomas Spencer
b. 5 Dec 1721 d. 2 Dec 1793
8
Jr. Thomas Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.1]
b. 1751 d. 1806
Lucy A. Watkins
b. 1759 d. 1847
9
Thomas J. Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.1.1]
b. 1795 d. 1822
Ann Eliza Eastham
b. 1803 d. 1881
10
James T. Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.1.1.1]
b. 1821 d. 1886
Mary Elizabeth Leach
b. 1822 d. 1876
11
Fannie Venable Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.1.1.1.1]
+
A. G. McIlwaine
11
Ann Thomas Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.1.1.1.2]
+
F. H. Armistead
8
John Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.2]
b. 16 Dec 1745 d. 26 May 1826
8
Samuel Flournoy Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.3]
b. 5 Dec 1755 d. 9 Dec 1838
Agnes Woodson Daniel
b. 1754 d. 1799
9
Mary Phena "Polly" Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.3.1]
b. 1796
9
Alexander R Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.3.2]
b. 1816 d. 1908
8
Mary Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.4]
b. 20 Oct 1742 d. 5 Mar 1829
8
Sion Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.5]
b. 12 Apr 1744 d. 4 Dec 1775
8
Elizabeth Julia Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.6]
b. 18 Jun 1747 d. 1832
8
Ann Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.7]
b. 13 Jul 1749 d. 1780
8
Martha Owen Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.8]
b. 7 Sep 1757 d. 5 Jun 1836
8
Gideon Spencer
[1.1.1.11.10.6.6.9]
b. 21 May 1760 d. 8 May 1822
7
Flournoy
[1.1.1.11.10.6.7]
b. 25 Nov 1736 d. Jan 1736/37
7
Gédéon Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8]
b. 19 Mar 1722 d. 1754
Jane Frances Sabourin
b. 21 Jul 1730 d. 1797
8
Gédéon Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1]
b. 21 Sep 1753 d. 25 Sep 1821
Jeanne-Françoise Delisle
b. 10 Nov 1755 d. 4 May 1832
9
Gédéon Jean François Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1]
b. 15 Jul 1784 d. 22 Jul 1863
Elizabeth Pernette Covelle
b. 17 Aug 1797 d. 2 Jan 1880
10
Alexandre Antoine Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1]
b. 10 Jan 1818 d. 9 Aug 1890
Caroline Claparède
b. 1831 d. 1875
11
Paul-Eugène-Edmond Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1.1]
b. 2 Jan 1863 d. 6 Jul 1936
11
Théodore Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1.2]
b. 15 Aug 1854 d. 5 Nov 1920
Marie Helene Burnier
b. 15 Aug 1856 d. 22 Aug 1909
12
Berthe-Alice Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.1]
b. 1 Mar 1881 d. 3 Jul 1965
12
Blanche Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.2]
b. 15 Jun 1882 d. 20 Apr 1905
12
Henri Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.3]
b. 28 Mar 1886 d. 6 May 1955 [
=>
]
12
Hélène Olga Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.4]
b. 28 Mar 1891 d. 1 Jan 1972
12
Ariane Dorothée Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.5]
[
=>
]
12
Marguerite Flournoy
[1.1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.6]
b. 31 Oct 1883 d. 10 Jun 1963 [
=>
]
7
Mary Flournoy
[1.1.1.11.10.6.9]
b. 23 Feb 1735 d. 8 Sep 1798
William Booker
b. 1720 d. 10 Oct 1783
8
Jane Davis Booker
[1.1.1.11.10.6.9.1]
b. 1755 d. 1800
Jacob Morton
b. 29 Jan 1751 d. 22 May 1829
9
William Booker Morton
[1.1.1.11.10.6.9.1.1]
b. 3 Sep 1775 d. 10 Aug 1816
Lucy Faris Flournoy
b. 1786 d. 1836
10
Elvira Henry Morton
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.1]
b. 1806 d. 1840
William Peter Barksdale
b. 1799 d. 1854
11
Louisa Frances Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.1.1]
b. 1830 d. 1907
John Bullock Crews
b. 1814 d. 1882
12
Louise Barksdale Crews
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.1.1.1]
12
Frances Sydnor Crews
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.1.1.2]
12
Rosa Crews
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.1.1.3]
10
Anne Martin Morton
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.2]
b. 1804
William Henry Dennis
b. 1801 d. 1866
11
Jacob Dennis
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.2.1]
10
Mary Elizabeth Morton
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3]
b. 24 Apr 1808 d. 13 Dec 1889
William Sydnor Barksdale
b. 7 May 1806 d. 10 Sep 1874
11
Lucy Ann Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1]
b. 4 Oct 1828 d. 11 Jan 1906
James Woodford Arendall
b. 20 Jan 1820 d. 17 Mar 1871
12
Lucy Flournoy Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.1]
b. 5 Jun 1862 d. 11 Dec 1888
12
Judith Williams Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.2]
b. 16 Sep 1865 d. 31 Aug 1896 [
=>
]
12
Elizabeth Frances Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.3]
b. 23 May 1867 d. 12 Jun 1895 [
=>
]
12
Virginia Alice Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.4]
b. 26 Dec 1869 [
=>
]
12
William Barksdale Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5]
b. 25 Apr 1849 d. 11 Nov 1911 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.6]
b. 23 Apr 1851 d. 28 Sep 1853
12
Ann Catherine Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.7]
b. 7 Mar 1853 d. 15 Jul 1882 [
=>
]
12
John Armstead Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.8]
b. 12 Jan 1855 d. 1 Jul 1935 [
=>
]
12
Thomas Syndor Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.9]
b. 11 May 1857 d. 1940 [
=>
]
12
James Morton Arendall
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10]
b. 29 Feb 1860 d. 14 Dec 1938 [
=>
]
11
John Thomas Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.2]
b. 9 Mar 1844
11
Mary Susan Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.3]
b. 22 Jun 1846
11
Alice Sydnor Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.4]
b. 31 Oct 1848
11
Flournoy X. Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.5]
b. 23 Jun 1852
11
Judith Williams Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.6]
b. 16 Mar 1831
11
Elizabeth Armistead Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.7]
b. 3 Aug 1833
11
William Morton Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.8]
b. 2 Jan 1837
11
Elvira Frances Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.9]
b. 28 Jul 1839
11
Anthony Sydnor Barksdale
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.3.10]
b. 29 Nov 1841
10
William Booker Morton
[1.1.1.11.10.6.9.1.1.4]
b. 1811
9
Robert Morton
[1.1.1.11.10.6.9.1.2]
Marcia M. Flournoy
10
Robert A. Morton
[1.1.1.11.10.6.9.1.2.1]
Sallie Ann Collins
11
Sallie C. Morton
[1.1.1.11.10.6.9.1.2.1.1]
+
Frank W. Cunningham
8
William Flournoy Booker
[1.1.1.11.10.6.9.2]
b. 12 May 1761 d. 21 Nov 1807
+
Elizabeth Moore
b. 15 Oct 1774 d. 1805
8
Rebecca Booker
[1.1.1.11.10.6.9.3]
b. 7 Apr 1773 d. 21 Apr 1818
+
Jr. Robert Smith
b. 10 Oct 1765 d. 26 Mar 1830
8
Frances Booker
[1.1.1.11.10.6.9.4]
b. 1771 d. 1793
+
Nathaniel Price
8
Gideon Booker
[1.1.1.11.10.6.9.5]
b. 1756 d. 28 Jul 1794
8
John D. Booker
[1.1.1.11.10.6.9.6]
b. 1755 d. 1825
+
Martha Jane Watkins
b. 1771 d. 1852
8
Eliza Julia Booker
[1.1.1.11.10.6.9.7]
b. 1764 d. 30 May 1828
+
Thomas Embra Green
b. Abt 1760 d. 30 Sep 1827
8
Thomas Booker
[1.1.1.11.10.6.9.8]
d. 1789
8
Nancy Rochet
[1.1.1.11.10.6.9.9]
8
Mary Williams Booker
[1.1.1.11.10.6.9.10]
d. 1789
7
Samuel Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10]
b. 4 Oct 1724 d. 12 Dec 1780
Elizabeth Harris
b. 31 Dec 1729 d. 19 May 1791
8
Silas F. Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1]
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
Martha Cannon
b. 1775 d. Oct 1817
9
Alfred Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
10
William Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.1]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
11
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
11
William Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.1.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
11
Alfred Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.1.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
11
Lucien Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.1.4]
b. 22 Feb 1861
10
Alonzo Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.2]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
11
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.2.1]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
12
Genevieve McRady
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.2.1.1]
11
James Patteson Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.2.2]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
11
Belle Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.2.3]
11
Theodosia Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.2.4]
10
James Silas Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.3]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
10
Eliza Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.4]
b. 29 May 1829 d. INFANT
10
Alfred F. Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.5]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
11
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.5.1]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
11
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.5.2]
b. 21 Feb 1875
11
Mary Patteson Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.5.3]
b. 24 Apr 1866
11
Spencer Alston Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.5.4]
b. Aug 1879
10
Martha Moore Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.6]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
10
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
11
Alfred F. Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.1]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
11
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.2]
11
Alice Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.3]
+
Charles Davis
11
Ruth Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.4]
+
B. H. Davis
11
Pattie Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.5]
Milton Walker Sims
12
Laura Sims
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.5.1]
b. 1873
12
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.5.2]
b. 1872
12
Milton Sims
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.5.3]
b. 1876
12
Bartlett Sims
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.5.4]
b. May 1878
11
Laura Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.6]
Thomas Bell
12
Mary Bell
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.6.1]
11
Mary Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.7.7]
+
Napoleon Davis
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
10
Charles Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.8]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
10
David Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.9]
b. 1842 d. 1856
10
Maria Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.10]
b. 1837 d. 1841
10
Mary Camp Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
10
Martha Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.12]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
10
Indiana Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.1.13]
b. 1847
9
Eliza Susan Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.2]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
10
Alfred H. Harris
[1.1.1.11.10.6.10.1.2.1]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
10
Eliza Susan Harris
[1.1.1.11.10.6.10.1.2.2]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
10
Martha Harris
[1.1.1.11.10.6.10.1.2.3]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
9
William Cannon Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
10
Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.1]
b. 1833 d. 1833
10
Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.2]
b. 1829 d. 1829
10
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.3]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
11
Myra Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.3.1]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
11
Julian Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.3.2]
b. 23 Dec 1868
11
William Cannon Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.3.3]
b. 11 Jan 1866
11
Tyree Rodes Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.3.4]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
11
John Harper Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.3.5]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
11
Flournoy Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.3.6]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
12
John Avirett Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.3.6.1]
b. 22 Mar 1894
10
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.4]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
11
Ezell Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.4.1]
b. 9 Dec 1878
11
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.4.2]
b. 13 Sep 1875
11
John Walker Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.4.3]
b. 24 Jan 1874
11
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.4.4]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
11
III William Cannon Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.4.5]
b. 8 Apr 1872
10
John J. Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.3.5]
b. 1838
9
Mary Amanda Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.4]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
10
Mary Eliza Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.1]
b. 1 Jul 1825
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
11
Myra Flournoy Knapp
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.1.1]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
11
Maud Officer
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.1.2]
b. 9 May 1847
11
Eustis Field Officer
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.1.3]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
11
William P. Officer
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.1.4]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
10
James Alexander Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.2]
b. 30 May 1823
10
Jr. William Hume Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
10
Julian Clarence Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.4]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
10
Silas Flournoy Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
10
Margaret Julia Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.6]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
10
Henrietta Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.7]
b. 1833 d. 1833
10
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.8]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
10
Florence Huntley Field
[1.1.1.11.10.6.10.1.4.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
9
Julia Ann Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.5]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
10
Hume Rigg Feild
[1.1.1.11.10.6.10.1.5.1]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
10
Eliza Mildred Feild
[1.1.1.11.10.6.10.1.5.2]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
11
Julia Batte
[1.1.1.11.10.6.10.1.5.2.1]
+
W. R. Garrett
11
Mildred Batte
[1.1.1.11.10.6.10.1.5.2.2]
11
E. F. Batte
[1.1.1.11.10.6.10.1.5.2.3]
9
Madison Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.6]
b. 1807
9
Martha C. Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.7]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
10
Silas Flournoy Trotter
[1.1.1.11.10.6.10.1.7.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
9
Silas Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
10
Mary Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.1]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
11
Elizabeth Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.1.1]
b. Bef 1865
11
James P. Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.1.2]
b. Bef 1863
11
Mary Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.1.3]
b. Bef 1867
11
Silas Flournoy Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.1.4]
b. Bef 1871
11
William W. Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.1.5]
b. Bef 1869
11
Martha Rivers
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.1.6]
b. Bef 1873
10
Camp Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
11
Lucien Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
12
Lillian May Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.1]
b. 1906
12
Mary Wise Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.2]
b. 1911
12
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.3]
12
Laura Louise Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.4]
12
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.5]
11
John Wise Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
12
Louise Wise Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.1]
b. 1907
12
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.2]
b. 1912 [
=>
]
12
Camp Rogers Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.3]
12
Betty McAfee Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.4]
11
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
12
Eloise Walker
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
12
Newton Flournoy Walker
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
12
Lucien John Walker
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972 [
=>
]
12
Jane Louise Walker
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.4]
12
Jacob Camp Walker
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.5]
11
Augusta Mary Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
12
Georgia Louia May
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.1]
b. 1899
12
Julia Flournoy May
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.2]
[
=>
]
12
Elizabeth Wise May
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.3]
b. 1902
12
James Kathryn May
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.4]
b. 1902
12
Norma Lucile May
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.5]
b. 1902
11
Julia Rivers Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
12
Lucien Wise Jordan
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.5.1]
12
Andrew Booty Jordan
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.5.2]
[
=>
]
11
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
12
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.6.1]
12
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.6.2]
12
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.2.6.3]
10
Lucien Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.3]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
11
Caroline Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.3.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
10
Elizabeth Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.4]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
11
Duncan
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.4.1]
b. Bef 1870 d. 1876
11
Maude Eustace Duncan
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.4.2]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
10
III Silas Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.5]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
11
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.5.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
11
Silas Camp Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.8.5.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
9
Sarah Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.9]
b. 1816
9
Louisa Ann Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.1.10]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
10
Laura Ann Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
11
Leroy M. Black
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.1]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
11
Louisa Catherine Black
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
12
Mary Lou Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.1]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927 [
=>
]
12
Ernest M. Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.2]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
12
Leroy Black Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.3]
b. 1864 d. 1934
12
James Carley Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.4]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956 [
=>
]
12
Laura Jane Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.5]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900 [
=>
]
12
Frank Leon Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.6]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943 [
=>
]
12
Emily Olivia Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.7]
b. 1869 d. 1887/1963 [
=>
]
12
John A. Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.8]
b. 1873 d. 1874/1963
12
Levair Lester
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.9]
b. Abt 1869
11
Laura Ann Black
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.1.3]
10
Flournoy Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
11
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.1]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
12
Martha Lafavre Bishop
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.1.1]
12
Richard Yancey Bishop
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.1.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
11
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.2]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
12
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.1]
[
=>
]
12
Alice LaFavia Dawes
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.2]
12
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.3]
[
=>
]
12
Thomas Asbury Dawes
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.4]
b. 4 Apr 1895
11
Cora Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
11
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.2.4]
b. Jul 1882
10
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
11
Lucy M. Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
12
Rosa Mai Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.1]
b. May 1888 d. Nov 1967
12
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.2]
b. 1886
12
Thomas Webber Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.3]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
12
George L Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.4]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
12
Wilber Wilson
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.5]
b. Jan 1893 [
=>
]
11
Webber Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
11
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.3.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
10
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
11
Adella Frances Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.1]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
12
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.1.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971 [
=>
]
11
Mamie J. Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.2]
b. 8 Dec 1875 d. 18 Sep 1968
Maclovio De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
12
Orman Joe De Arnaz
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.2.1]
12
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.2.2]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
11
Robert Lee Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.3]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
11
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.4]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
11
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.5]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
11
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.6]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
12
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.1]
[
=>
]
12
Anna Josephine Houle
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.2]
[
=>
]
12
Dorothy Louise Houle
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.3]
[
=>
]
12
Alberta Isabel Houle
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.4]
[
=>
]
11
Edna Emma Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
12
Anita Ruth Otero
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.1]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
12
Helen May Otero
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.2]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
12
Howard Joseph Otero
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.3]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961 [
=>
]
12
Edna Dorothy Otero
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.4]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
12
Norman Francis Otero
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.5]
[
=>
]
12
Kathryn Alberta Otero
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.6]
[
=>
]
11
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.8]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
12
Anita H. Juch
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949 [
=>
]
12
Chester Arthur Juch
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
12
Flournoy Albert Juch
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
12
Stanley St. Clair Juch
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.4]
[
=>
]
12
Louis Dewey Juch
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.5]
10
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.5]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
10
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.6]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
11
Louisa Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.6.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
12
Rosalie E. McQuade
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.6.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
11
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.6.2]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
11
Nellie M Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.6.3]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
11
Edna L. Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.6.4]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
11
William P. Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.6.5]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
11
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.6.6]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
10
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.7]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
10
Mary Julia Yancey
[1.1.1.11.10.6.10.1.10.8]
b. 1834
+
William D. Roberts
8
David Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.2]
b. 14 Apr 1761 d. 30 Jun 1831
+
Elizabeth Mills Britton
b. 17 Oct 1760 d. 30 Jun 1830
8
Gideon Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.3]
b. 20 Feb 1751 d. 15 Feb 1821
+
Jane F DeLisle
Grace B. Tarry
b. 1755 d. 20 Dec 1819
9
"Mattie" Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.3.1]
b. 1795 d. 10 Oct 1855
Arthur Woodfin
b. 1790 d. 9 Oct 1855
10
William G. Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.1]
b. 1817
10
Richard M. Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.2]
b. 1817
10
Thomas E Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.3]
b. 1818
10
John James Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.4]
b. 19 Mar 1820 d. 23 Sep 1860
10
Charles Newton Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.5]
b. 31 Jul 1824 d. 2 Jul 1912
10
Mary Elizabeth Susan Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.6]
b. 12 Jun 1829 d. 23 Nov 1890
10
Arthur Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.7]
b. 1832
10
Harriet Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.8]
b. 1836
10
Martha Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.1.9]
b. 1838
9
Martha Ann Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.3.2]
b. Abt 1798 d. 1847
Thomas Woodfin
b. 1795 d. 1853
10
William Thomas Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.2.1]
b. 16 Sep 1822 d. 3 Aug 1894
10
Samuel Flournoy Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.2.2]
b. 4 Aug 1824 d. 14 Feb 1866
10
James Edward Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.2.3]
b. 1826 d. 1889
10
Jane Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.2.4]
b. 1828 d. 1892
10
Frances Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.2.5]
b. 1830
10
George Washington Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.2.6]
b. 15 Mar 1832 d. 3 Aug 1895
10
Martha Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.2.7]
b. 1834
10
Rebecca Woodfin
[1.1.1.11.10.6.10.3.2.8]
b. 18 Dec 1836 d. 16 Aug 1860
8
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.4]
b. 25 Nov 1765
+
Isham Britton
b. Bef 1761
8
Julia Briton Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.5]
b. Abt 1770
8
John Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.6]
b. 29 Apr 1754
8
Thomas Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.7]
b. Bef 1767
8
Ursula Harris Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.8]
b. 15 May 1749
James Bailey Harris
b. 1749
9
III James Harris
[1.1.1.11.10.6.10.8.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
10
Alfred Turpin Harris
[1.1.1.11.10.6.10.8.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
11
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.1.11.10.6.10.8.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
9
Samuel Harris
[1.1.1.11.10.6.10.8.2]
b. Abt 1774
9
Elizabeth Harris
[1.1.1.11.10.6.10.8.3]
b. Abt 1776
9
Mary Harris
[1.1.1.11.10.6.10.8.4]
b. Abt 1778
8
Hannah Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.9]
b. Abt 1762
8
Jordan Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.10]
b. 20 Sep 1763 d. 21 Jun 1833
+
Judith Farrar
b. 21 Apr 1756 d. 1828
8
Samuel Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11]
b. 9 Dec 1758 d. 19 Aug 1818
Nancy Ann Martin
b. 1765
9
Samuel Martin Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.1]
b. 1799 d. 1878
+
Minerva Ann Wadlington
b. 1814 d. 1858
+
Harriett Elvira Fenley
b. 24 Jan 1820
9
Agnes Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.2]
b. 1799
9
Martha Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.3]
b. 15 Aug 1813 d. 1891
Randolph Allen Hankla
b. 1 Feb 1803
10
Minerva Nancy Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.1]
b. 29 Mar 1837 d. 1 Apr 1898
10
Pendleton Flournoy Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.2]
b. 24 Mar 1831
10
James Marion F. Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.3]
b. 8 Feb 1833
10
John Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.4]
b. 21 Feb 1835
10
Mary Francis Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.5]
b. 29 Dec 1839
10
Martha Matilda Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.6]
b. 17 Jul 1844
10
Joseph Randolph Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.7]
b. 5 Nov 1847
10
William Harrison Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.8]
b. 17 Feb 1849
10
Ella Eugenia Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.9]
b. 24 Jul 1853
10
Eliza Hankla
[1.1.1.11.10.6.10.11.3.10]
b. 2 Dec 1841 d. 7 Aug 1919
9
Matthews Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.4]
b. 1789 d. 1833
9
James Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.5]
b. 1 Jan 1791 d. 3 Mar 1855
+
Martha Halloway
b. 1790 d. 1871
9
Jack Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.6]
b. 1799 d. 1818
9
Nancy Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.7]
b. 1795
9
Rachel Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.8]
b. 1797
9
Amelia Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.9]
b. 1786
9
Emily Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.10]
b. 1801
9
Patsy Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.11]
b. 1793
9
Cassandra Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.11.12]
b. 1803
8
Martha Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.12]
b. Feb 1768
8
Mary Flournoy
[1.1.1.11.10.6.10.13]
b. Bef 1756
6
Jacques Flournoy
[1.1.1.11.10.7]
b. 2 Feb 1702/03 d. Aft 2 Feb 1702/03
6
Julie Flournoy
[1.1.1.11.10.8]
b. 9 Jul 1690 d. 14 Feb 1690/91
6
Julie Flournoy
[1.1.1.11.10.9]
b. 7 Oct 1692 d. 14 Oct 1692
6
Marie Flournoy
[1.1.1.11.10.10]
b. 1 May 1689 d. 16 Aug 1689
Elisabeth Boussens
b. 1620 d. 24 Jun 1644
5
Elisabeth Flournoy
[1.1.1.11.11]
b. 7 Mar 1642/43 d. 13 Jul 1714
+
Antoine Marcet
5
Jean Flournoy
[1.1.1.11.12]
b. 21 Dec 1640 d. 25 Mar 1642
5
Michel Flournoy
[1.1.1.11.13]
b. 8 Dec 1638 d. 29 Jan 1638/39
4
Jean Flournoy
[1.1.1.12]
b. 19 Mar 1597/98 d. 16 Aug 1599