News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Francis Moryson
1601 -
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Francis Moryson
[1]
b. 1601
2
Edith Moryson
[1.1]
b. 8 May 1631 d. Abt 1678
Cornelius Dabney
b. 2 May 1631 d. 30 Apr 1694
3
James Dabney
[1.1.1]
b. 24 May 1657 d. 11 Sep 1739
Ann Sherwood
4
Welthan Dabney
[1.1.1.1]
b. Bef 8 Jan 1698/99
James Ellett
5
Dabney Ellett
[1.1.1.1.1]
4
Cornelius Dabney
[1.1.1.2]
d. Bef 1745
Lucy Winston
b. Abt 1707 d. 1784
5
William Dabney
[1.1.1.2.1]
b. 14 Jul 1722 d. 21 May 1803
Philadelphia Gwathmey
b. 10 Dec 1722 d. 15 Mar 1812
6
Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.1]
b. 15 Aug 1749 d. 24 Feb 1834
Ann Hill
b. 11 Jul 1749 d. 14 May 1827
7
William Dabney
[1.1.1.2.1.1.1]
b. 22 Feb 1770 d. 18 Apr 1856
Hannah Temple Dabney
b. 4 Sep 1767 d. 5 Oct 1853
8
Diana Dabney
[1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 21 Jun 1788 d. 16 Sep 1862
Cornelius Dabney
b. 14 May 1774 d. 24 Jul 1856
9
William Winston Dabney
[1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 17 Aug 1807 d. 10 Dec 1877
Elizabeth Jennings Dabney
b. 16 Mar 1791 d. 17 Apr 1874
10
Elizabeth Louise Dabney
[1.1.1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 15 Sep 1828 d. 3 Feb 1904
8
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 26 Jun 1790 d. 2 Aug 1863
7
Humphrey Dabney
[1.1.1.2.1.1.2]
b. 2 Nov 1772 d. 6 Jun 1858
Katherine Collins
8
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 10 Dec 1797 d. 26 Nov 1879
Susan Hill Segar
b. 10 Apr 1765 d. 22 Sep 1846
9
John Collins Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. 21 Feb 1793 d. 16 Apr 1875
Florence Henry Miller
b. 1837/1865 d. 1854/1948
10
Margaret Henry Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.1.1]
+
S. Barksdale Penick
10
Miller Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.1.2]
10
Frederick Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.1.3]
9
Susan Segar Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.2]
b. 15 Mar 1795 d. 26 Jun 1878
9
Humphrey Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.3]
b. 4 Jan 1791 d. 25 Jun 1872
+
Roberta Blanks
9
Emma Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.4]
b. 11 Apr 1787 d. 17 Jun 1844
9
David Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.5]
b. 3 Feb 1789 d. 13 Jun 1865
9
Albert Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.1.6]
8
Katherine Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 21 Aug 1803 d. 4 Feb 1884
8
Sarah Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.3]
b. 15 Feb 1801 d. 24 Oct 1885
8
Mary Ann Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.4]
b. 4 May 1805 d. 14 Sep 1888
8
Susan Hill Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.5]
b. 17 Jul 1799 d. 21 Nov 1880
8
Saville Dabney
[1.1.1.2.1.1.2.6]
7
Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.1.3]
b. 15 Jul 1774 d. 26 Sep 1862
7
Robert Dabney
[1.1.1.2.1.1.4]
b. 16 Mar 1768 d. 4 Jul 1841
7
Frances Dabney
[1.1.1.2.1.1.5]
b. 5 Jun 1780 d. 15 Jul 1867
John Segar
b. 7 Dec 1780 d. 13 Mar 1858
8
Susan Hill Segar
[1.1.1.2.1.1.5.1]
b. 10 Apr 1765 d. 22 Sep 1846
Albert Gallatin Dabney
b. 10 Dec 1797 d. 26 Nov 1879
9
John Collins Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.1]
b. 21 Feb 1793 d. 16 Apr 1875
Florence Henry Miller
b. 1837/1865 d. 1854/1948
10
Margaret Henry Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.1]
+
S. Barksdale Penick
10
Miller Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.2]
10
Frederick Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.3]
9
Susan Segar Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.2]
b. 15 Mar 1795 d. 26 Jun 1878
9
Humphrey Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.3]
b. 4 Jan 1791 d. 25 Jun 1872
+
Roberta Blanks
9
Emma Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.4]
b. 11 Apr 1787 d. 17 Jun 1844
9
David Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.5]
b. 3 Feb 1789 d. 13 Jun 1865
9
Albert Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.1.6]
8
Rebecca Ann Segar
[1.1.1.2.1.1.5.2]
b. 14 Apr 1788 d. 15 May 1879
8
Sarah Frances Segar
[1.1.1.2.1.1.5.3]
b. 17 Apr 1771 d. 19 Oct 1852
Richard Dabney
b. 25 Sep 1775 d. 19 Feb 1854
8
Catherine Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.4]
b. 10 Oct 1805 d. 19 Sep 1871
+
John Hilliard
8
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.1.5.5]
b. 10 Oct 1803 d. 16 Nov 1888
+
Elizabeth Smelt
6
Cornelius Dabney
[1.1.1.2.1.2]
b. 7 Jul 1744 d. 21 Oct 1825
Elizabeth Smith
b. 11 Jul 1744 d. 14 May 1831
7
Isaac Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.1]
b. 3 May 1768 d. 13 Aug 1842
Hannah Winston
b. 21 Oct 1767 d. 10 Apr 1846
8
Eliza Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.1]
b. 6 Jul 1793 d. 11 Sep 1874
+
Henry Hughs
8
Catherine Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.2]
b. 24 Sep 1805 d. 1 May 1879
+
Albert Meriwether
8
Dorothy Ann Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.3]
b. 3 Oct 1803 d. 6 Dec 1888
+
Thomas Meriwether
8
Hannah Gwathmey Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4]
b. 10 Feb 1791 d. 12 Mar 1877
Edwin Winston Dabney
b. 1821
9
Ann Eliza Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.1]
9
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.2]
9
Hannah Elizabeth Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.3]
9
Edwin Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.4]
9
Thomas Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.5]
9
Emma Juliet Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.6]
9
Cornelius Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.7]
9
John Bledsoe Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.8]
9
Robert Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.9]
9
George Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.10]
9
Virginia Louisa Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.4.11]
8
Martha Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.5]
b. 18 Aug 1795 d. 2 Oct 1876
+
Henry Hughes
b. 19 Sep 1795 d. 26 Oct 1884
8
Albert Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.6]
8
Urath Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.7]
8
Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.1.8]
7
William Spotswood Dabney
[1.1.1.2.1.2.2]
b. 25 Mar 1767 d. 2 Sep 1849
7
Cornelius Dabney
[1.1.1.2.1.2.3]
b. 13 May 1764 d. 29 Sep 1831
Mary Eggleston Catlett
b. 4 Jul 1763 d. 15 Feb 1823
8
Charles Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.1]
b. 21 Mar 1787 d. 17 May 1861
8
Ann Eliza Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.2]
b. 4 Jun 1791 d. 5 Sep 1865
+
Wiley Jones
8
Caroline Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.3]
b. 12 Jun 1789 d. 13 Jul 1862
8
Cornelius Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4]
b. 2 Mar 1785 d. 7 Aug 1844
Anne Harris
b. 6 Jul 1765 d. 17 Nov 1839
9
Celia Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4.1]
b. 25 Mar 1813 d. 29 Jul 1902
9
Ann Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4.2]
b. 16 Jan 1809 d. 25 Jun 1891
9
Polly Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4.3]
b. 22 Feb 1811 d. 30 May 1896
9
John Dabney
[1.1.1.2.1.2.3.4.4]
b. 11 Jun 1807 d. 7 Sep 1891
7
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4]
b. 17 Sep 1765 d. 18 Oct 1827
Ann Elizabeth Catlett
8
Cornelius Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1]
b. 24 Nov 1826
Susan Garnett
9
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.1]
9
James Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.2]
9
Cornelius Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.3]
9
Edwin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.4]
9
Henry Thomas Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.5]
9
Fannie Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.6]
9
Susan Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.7]
9
Eustacia Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.8]
+
Lou Hill
9
Annie Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.1.9]
8
Edwin Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2]
b. 1821
Hannah Gwathmey Dabney
b. 10 Feb 1791 d. 12 Mar 1877
9
Ann Eliza Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.1]
9
Albert Gallatin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.2]
9
Hannah Elizabeth Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.3]
9
Edwin Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.4]
9
Thomas Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.5]
9
Emma Juliet Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.6]
9
Cornelius Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.7]
9
John Bledsoe Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.8]
9
Robert Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.9]
9
George Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.10]
9
Virginia Louisa Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.2.11]
8
Thomas Catlett Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.3]
b. 20 Sep 1823 d. 1886
8
Albert Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4]
Pamela Middleton
9
James Middleton Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4.1]
9
John Catlett Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4.2]
9
Albert Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4.3]
9
Harriet Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.4.4]
8
John Temple Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.5]
8
Ann Maria Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.6]
8
Elizabeth Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.7]
+
Walter Lewis
8
Juliet Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.8]
+
Robert Meriwether
8
Walter Scales Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.9]
8
Joseph Whorton Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.10]
8
William Spotswood Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.11]
8
Virginia Louisa Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.12]
8
Robert Owen Dabney
[1.1.1.2.1.2.4.13]
+
Elizabeth Eggleston
7
Elizabeth Smith Dabney
[1.1.1.2.1.2.5]
b. 18 May 1770 d. 12 Oct 1861
+
Methodist Clergyman Stuart
7
Martha Winston Dabney
[1.1.1.2.1.2.6]
b. 5 Jun 1772 d. 2 Jul 1840
+
Thomas Cooper
6
William Dabney
[1.1.1.2.1.3]
b. 24 Sep 1747 d. 13 Mar 1832
Sarah Gwathmey
b. 1766
7
Mordecai Booth Dabney
[1.1.1.2.1.3.1]
b. 22 Jun 1776 d. 10 Sep 1861
7
Martha Washington Dabney
[1.1.1.2.1.3.2]
b. 2 Feb 1768 d. 16 Jul 1842
7
Cornelius Dabney
[1.1.1.2.1.3.3]
b. 14 May 1774 d. 24 Jul 1856
Diana Dabney
b. 21 Jun 1788 d. 16 Sep 1862
8
William Winston Dabney
[1.1.1.2.1.3.3.1]
b. 17 Aug 1807 d. 10 Dec 1877
Elizabeth Jennings Dabney
b. 16 Mar 1791 d. 17 Apr 1874
9
Elizabeth Louise Dabney
[1.1.1.2.1.3.3.1.1]
b. 15 Sep 1828 d. 3 Feb 1904
7
William Dabney
[1.1.1.2.1.3.4]
b. 27 Apr 1772 d. 21 Aug 1853
7
Bushrod Dabney
[1.1.1.2.1.3.5]
b. 23 Mar 1770 d. 4 May 1847
7
Washington Dabney
[1.1.1.2.1.3.6]
b. 28 Jul 1778 d. 5 Sep 1864
6
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.4]
b. 18 Feb 1745 d. 7 Jun 1836
Diana Gwathmey
b. 1 Nov 1755 d. 14 Aug 1824
7
Owen Dabney
[1.1.1.2.1.4.1]
b. 11 Dec 1781 d. 16 May 1863
7
Lucy Dabney
[1.1.1.2.1.4.2]
b. 7 Sep 1771 d. 19 Mar 1855
+
John Merritt
7
Hannah Temple Dabney
[1.1.1.2.1.4.3]
b. 4 Sep 1767 d. 5 Oct 1853
William Dabney
b. 22 Feb 1770 d. 18 Apr 1856
8
Diana Dabney
[1.1.1.2.1.4.3.1]
b. 21 Jun 1788 d. 16 Sep 1862
Cornelius Dabney
b. 14 May 1774 d. 24 Jul 1856
9
William Winston Dabney
[1.1.1.2.1.4.3.1.1]
b. 17 Aug 1807 d. 10 Dec 1877
Elizabeth Jennings Dabney
b. 16 Mar 1791 d. 17 Apr 1874
10
Elizabeth Louise Dabney
[1.1.1.2.1.4.3.1.1.1]
b. 15 Sep 1828 d. 3 Feb 1904
8
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.4.3.2]
b. 26 Jun 1790 d. 2 Aug 1863
7
Anna Dabney
[1.1.1.2.1.4.4]
b. 14 Jun 1785 d. 15 Jul 1867
7
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.4.5]
b. 25 Sep 1775 d. 19 Feb 1854
Frances Dabney
b. 5 Jun 1780 d. 15 Jul 1867
8
Catherine Dabney
[1.1.1.2.1.4.5.1]
b. 10 Oct 1805 d. 19 Sep 1871
+
John Hilliard
8
Richard Dabney
[1.1.1.2.1.4.5.2]
b. 10 Oct 1803 d. 16 Nov 1888
7
Temple Dabney
[1.1.1.2.1.4.6]
b. 13 Nov 1779 d. 2 Apr 1859
+
Hannah Temple Gwathmey
b. 29 Dec 1791 d. 21 Dec 1825
7
Joseph Dabney
[1.1.1.2.1.4.7]
b. 28 Oct 1777 d. 27 Mar 1856
7
Isaac Dabney
[1.1.1.2.1.4.8]
b. 21 Jan 1783 d. 15 Jun 1868
7
Benjamin Dabney
[1.1.1.2.1.4.9]
b. 4 Aug 1773 d. 8 Feb 1851
Nancy Armistead
8
Thomas Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.1]
b. 4 Jan 1798
8
Philip Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.2]
b. 4 Mar 1800
8
Martha Burnell Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.3]
b. 15 Sep 1802
8
William Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.4]
b. 5 Jan 1805 d. Mar 1809
8
James Dabney
[1.1.1.2.1.4.9.5]
b. 1 Nov 1806
7
Henry Dabney
[1.1.1.2.1.4.10]
b. 27 Nov 1769 d. 28 Dec 1841
+
Ann Jackson
6
Lucy Dabney
[1.1.1.2.1.5]
6
Owen Dabney
[1.1.1.2.1.6]
6
Gwathmey Dabney
[1.1.1.2.1.7]
+
Elizabeth Maddox
6
Lewis Dabney
[1.1.1.2.1.8]
6
Sarah Dabney
[1.1.1.2.1.9]
6
Philadelphia Dabney
[1.1.1.2.1.10]
3
John Dabney
[1.1.2]
b. Abt 1665 d. 1688
Sarah Ann Jennings
b. Abt 1670
4
Susanna Dabney
[1.1.2.1]
b. 1696
Francis Thornton Strother
b. 1700 d. 17 Apr 1752
5
William Strother
[1.1.2.1.1]
b. 30 Apr 1726 d. 5 Nov 1808
Sarah Bayly
b. Abt 1720
6
Sarah Dabney Strother
[1.1.2.1.1.1]
b. 14 Dec 1760 d. 13 Dec 1822
Richard Taylor
b. 3 Apr 1744 d. 19 Jan 1829
7
Zachary Taylor
[1.1.2.1.1.1.1]
b. 24 Nov 1784 d. 9 Jul 1850
Margaret Mackall Smith
b. 1787 d. 1852
8
Mary Elizabeth Taylor
[1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 20 Apr 1824 d. 25 Jul 1909
+
Philip Pendleton Dandridge
b. 2 Oct 1817 d. 28 Oct 1881
+
William Smith Bliss
b. 1815 d. 1853
4
Sarah Dabney
[1.1.2.2]
b. Abt 1698
3
Elizabeth Dabney
[1.1.3]
b. Abt 1655 d. 4 Apr 1688
3
George Dabney
[1.1.4]
b. 11 Sep 1653 d. 24 Oct 1729
Elizabeth Anderson
b. 7 Aug 1665 d. 8 Sep 1739
4
Sarah Dabney
[1.1.4.1]
b. 16 May 1695 d. 17 Apr 1767
William "Langloo" Winston
b. 12 Apr 1702 d. 1760
5
Mary Ann Winston
[1.1.4.1.1]
b. Abt 1735
John Walker
6
Benjamin Walker
[1.1.4.1.1.1]
6
John Walker
[1.1.4.1.1.2]
6
Frances Walker
[1.1.4.1.1.3]
6
Edmund Walker
[1.1.4.1.1.4]
5
Elizabeth Louise Winston
[1.1.4.1.2]
b. 17 Dec 1734 d. Abt 1772
Jr. Peter Fontaine, Jr
b. 15 Sep 1724 d. 1772
6
John Smith Fontaine
[1.1.4.1.2.1]
b. 6 Aug 1750 d. 14 Apr 1792
Martha "Patsy" Henry
b. Jun 1755 d. Oct 1818
7
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.4.1.2.1.1]
b. 30 Jan 1779 d. Jan 1818
+
Anne Carrington
b. 9 Nov 1787
7
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2]
b. 22 Feb 1775 d. 2 Oct 1852
Nancy Dabney Miller
b. 16 Aug 1775 d. 5 Jun 1862
8
Nancy Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.1]
b. 10 Dec 1802 d. 8 Sep 1856
John Thomas Brooks
d. 1872
9
John Fontaine Brooks
[1.1.4.1.2.1.2.1.1]
b. Cal 1844 d. 21 Jan 1918
10
Jr. John Fontaine Brooks
[1.1.4.1.2.1.2.1.1.1]
b. 19 Sep 1887
8
Elizabeth Louisa Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.2]
b. 17 Sep 1804 d. 1892
Edmund Dabney Winston
b. 17 Sep 1799 d. 21 Sep 1875
9
Nancy Miller Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.1]
b. 5 Mar 1825
+
Oliver H. Black
9
John Dabney Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.2]
b. 21 Feb 1822
9
William Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3]
b. 21 Jul 1828 d. 13 Aug 1878
Emma Eloise Furr
b. 1842 d. 9 Feb 1892
10
Edmund Tobias Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.1]
b. 22 Jul 1871 d. 26 Dec 1944
Florence Theresa Seale
b. 9 Feb 1876 d. 28 Jun 1959
11
Eloise Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.1.1]
b. 7 Mar 1899
Ozeph Chester Taylor
b. 1 Jul 1867
12
Edmund Warren Taylor
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.1.1.1]
[
=>
]
12
Dorothy Eloise Taylor
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.1.1.2]
[
=>
]
10
Galen Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.2]
b. 8 Feb 1873 d. 1928
+
Aurelia Odile Despommer
10
Masina Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.3.3]
b. 28 Aug 1875 d. 1928
+
Henry Henesler
9
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.4]
b. 8 Mar 1831 d. 1852
9
George Dabney Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.5]
b. 17 Sep 1833
+
Mrs. Iola Overton
9
Patrick Fontaine Winston
[1.1.4.1.2.1.2.2.6]
b. 5 Mar 1845 d. 1 Apr 1906
8
John Dabney Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.3]
b. 26 Mar 1799 d. 17 Feb 1822
8
Sally Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.4]
b. 28 Jan 1801 d. 27 Jul 1804
8
Charles D. Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.5]
b. 7 Nov 1806 d. 23 Apr 1807
8
Edward Benjamin Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6]
b. 5 Aug 1814 d. 19 Jan 1884
Mary Ann "Nancy" Swisher
b. 7 Jan 1821 d. 13 Jul 1855
9
Edward Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.1]
b. 4 Aug 1849
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2]
b. Abt 1845 d. 16 Mar 1888
Mary "Molly" Elizabeth Meade
b. Abt 1850 d. 29 Jun 1889
10
Mary Bogard "Bertie" Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1]
b. 8 Dec 1869
Henry Dick Lester
b. 17 Apr 1842
11
Houston Fontaine Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.1]
Georgia Gordon
12
Gayle Elliott Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.1.1]
[
=>
]
12
Alan Maury Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.1.2]
[
=>
]
12
Clayton Fontaine Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.1.3]
11
Henry Dick Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2]
Sarah Stewart Thornton
12
Jr. Henry Dick Lester, Jr
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2.1]
[
=>
]
12
James Owen Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2.2]
12
Judith Ann Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2.3]
12
Mary Kathleen Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.2.4]
[
=>
]
11
Maury Todd Fontaine Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.3]
b. Abt 1910
11
Ann "Annie" Fontaine Lester
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.1.4]
b. 5 Jul 1898
10
William Meade Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.2]
b. Mar 1871
11
John Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.2.1]
10
Annie Meade Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3]
b. Abt 1872
Joseph Gibson Ford
b. 18 Dec 1874 d. 13 Oct 1927
11
Minnie K Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.1]
b. 1906
+
Taylor
11
Alva Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.2]
b. 1908
+
Traylor
11
Joseph Gibson Ford, Jr.
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.3]
b. 1903
Helen Ford
b. Abt 1908
12
Helen A Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.3.1]
12
Betty J Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.3.2]
11
William F Ford
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.3.4]
b. 1904
10
Louisa Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.4]
b. Feb 1880
10
Edward Meade Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.2.5]
9
Jacques Mirabeau Bonaparte Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3]
b. 11 Oct 1841 d. 1 Oct 1921
Llemuella Smith Brickell
b. 7 May 1843 d. 7 Jan 1922
10
James Francis Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.1]
b. 25 Jul 1875
Teen Ratliff
11
Jeanie Katherine Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.1.1]
+
Edward Maddox Stubblefield
d. 4 Jun 1962
11
James Francis Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.1.2]
11
Mary Elizabeth Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.1.3]
10
Annie Gale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.2]
b. 26 Feb 1877 d. 28 Jul 1907
+
A. L. Chapman
10
Llemuella Moore Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3]
b. 11 Jul 1879
Alexander Smith
11
Jeanie Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.1]
b. 20 Oct 1897 d. 26 Jul 1907
11
Elizabeth Brickell Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2]
b. 2 Dec 1899
Charles M. Henderson
12
Charles Henderson
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2.1]
b. 1 Jan
12
Mary Jane Henderson
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2.2]
12
L'Moore Patricia Henderson
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2.3]
12
Barbara Ann Henderson
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.2.4]
11
Alexander Moore Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.3]
11
Robert Grey Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.4]
Beatrice Jones
12
Alice Montelle Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.4.1]
[
=>
]
12
Ross Alex Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.4.2]
Inez
12
Frances Louise Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.4.3]
11
Lamar Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.5]
Carolyn Lipscom
12
Carolyn Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.5.1]
[
=>
]
12
Sara Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.5.2]
11
Evander Frierson Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.6]
Alice Hall
12
Evander Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.6.1]
12
Phyllis Elenis
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.6.2]
11
Troy Cheairs Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.7]
12
Mary Lee Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.7.1]
11
L'Moore Smith
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.8]
Dale Alford
12
Dale Alford
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.8.1]
12
Anne Maury Alford
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.8.2]
12
L'Moore Fontaine Alford
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.3.8.3]
10
Henry Boursuoine Brickell Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4]
b. 1 Apr 1868
Idonda Hate
b. 1 Jul 1873 d. 13 Jun 1898
11
Mary Ella Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1]
b. 10 Feb 1892
Guy H. Price
12
Jeanella Frances Price
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1.1]
12
George Hartwell Price
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1.2]
12
Mary Fontaine Price
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1.3]
[
=>
]
12
Charles Henry Guy Price
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.1.4]
11
Jr. Henry Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.2]
b. 16 Sep 1894
Frances Elizabeth Swenn
b. 14 Nov 1893
12
Henry Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.2.1]
b. 29 Sep 1921 d. Jan 1922
12
Charles Temple Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.2.2]
12
Mary Elizabeth Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.2.3]
11
Edward Armstrong Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.4.3]
b. 8 Dec 1895
10
Edward Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.5]
b. 22 Feb 1871
Rebecca Cheatham Barksdale
11
William Barksdale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.5.1]
Helen Mosal
12
Jr. William Barksdale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.5.1.1]
12
Judith Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.5.1.2]
10
Mary Agnes Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.6]
b. 23 Apr 1874
John S. Mays
11
John Fontaine Mays
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.6.1]
b. 19 Sep 1900
Anne Duvall
12
John Terriberry Mays
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.6.1.1]
12
David Duvall Mays
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.6.1.2]
10
Jeanie Wilson Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.7]
b. 25 Aug 1869
10
Jr. Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8]
b. 26 Mar 1882 d. 1 Aug 1934
Kathryn Mary Martin
11
Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.1]
+
Patricia
11
Kathryn Martin Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.2]
Frank Gotch
12
Fontaine Gotch
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.2.1]
12
Faith Gotch
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.2.2]
12
Frank Robert Gotch
[1.1.4.1.2.1.2.6.3.8.2.3]
Mrs. Susan Catherine Britton
b. 1829 d. 28 May 1908
9
John Eaton Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4]
b. 12 Dec 1860 d. 20 Aug 1908
Adelle Armenta Stokes
b. 22 Dec 1844 d. 14 Feb 1923
10
John Eaton Fontaine, Jr.
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1]
b. 23 Jul 1889 d. 29 Aug 1962
Sydney Hosford Latimer
11
III John Eaton Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.1]
Eleanor Anne Haldeman
12
Anne Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.1.1]
12
Martha Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.1.2]
12
IV John Eaton Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.1.3]
[
=>
]
11
Douglass Latimer Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.2]
Bertha Van Landingham
12
Jr. Douglass Latimer Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.2.1]
[
=>
]
12
Rebecca VanLandingham Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.2.2]
[
=>
]
12
Patrick Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.4.1.2.3]
+
Alice Louise Jamison
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.5]
b. 15 Dec 1869 d. 10 Jan 1959
+
Ernestine Doll
9
Susan Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.6.6]
b. Cal 1865
+
F. R. Sawyer
8
Mary Boursiquot Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.7]
b. 13 Jun 1808 d. 27 May 1891
Jesse Perkins
b. 29 Mar 1798 d. 27 Nov 1872
9
Arthur Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1]
b. 29 Nov 1844 d. 4 Jul 1909
Annie Laurie Shotwell
b. 15 Jan 1851 d. 18 Jul 1911
10
Ellen Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.1]
b. 8 May 1875
10
Annie Shotwell Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.2]
b. 1882
Arch M. Crump
11
Anne Perkins Crump
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.2.1]
b. 31 Jul 1916 d. 24 Dec 1962
Leighton Smylie Miller
12
George Crump Miller
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.2.1.1]
[
=>
]
10
Laura Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.3]
b. 29 Dec 1871
10
Jessie C. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.1.4]
b. 1888
+
McDonald
9
Virginia Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.2]
b. 12 Jan 1831 d. 5 Jun 1905
Frisby Augustin Freeland
d. 1857
10
Mary Fontaine Freeland
[1.1.4.1.2.1.2.7.2.1]
b. 27 Oct 1853 d. 1912
10
Thomas Freeland
[1.1.4.1.2.1.2.7.2.2]
b. 6 Nov 1856 d. 1910
+
Jennie Wilkerson
+
Andrew Dewees Banks
b. 6 Jan 1833 d. 21 Jul 1881
9
Jessie Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.3]
b. 19 Feb 1848 d. 14 Dec 1902
James Brownlow Yellowley
b. 17 Oct 1848 d. 6 Jun 1914
10
Edward Clements Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.1]
b. 12 Aug 1873
+
Callie Hays
10
Maury Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2]
Joanna Willcoxen
11
Julia Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.1]
James Majors
12
Joanna Fontaine Majors
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.1.1]
12
James Franklin Majors
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.1.2]
11
Jessie Fontaine Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.2]
Will Wilkerson
12
Wllliam Archer Wilkerson
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.2.1]
12
Robert Fontaine Wilkerson
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.2.2]
12
Maury Archer Wilkerson
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.2.2.3]
10
Jesse Perkins Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.3]
b. 23 Oct 1882
Maggie Bell McCall
11
Jr. Jesse Perkins Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.3.1]
11
Edward Clements Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.3.2]
10
James Brownlow Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.4]
b. 12 Sep 1879
+
Margaret
10
Mary Fontaine Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.5]
10
Douglas Crittenden Yellowley
[1.1.4.1.2.1.2.7.3.6]
9
Mary Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.4]
b. 29 Dec 1832 d. 3 Aug 1892
Abner Green Gale
10
Jessie Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.1]
b. 1859
+
Marcy Johnson
10
Thomas Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2]
b. 23 Feb 1857 d. 24 Sep 1934
Anne Sue Thornton
11
Freeland Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.1]
b. 15 Jul 1888 d. 28 Mar 1945
Ethel Richardson
12
Mary Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.1.1]
[
=>
]
12
Jean Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.1.2]
[
=>
]
11
Gertrude Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.2]
b. 21 Jun 1890 d. 14 Dec 1969
Charles Edward McDonnell
12
William Thornton McDonnell
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.2.1]
12
Charles Edward McDonnell
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.2.2]
[
=>
]
11
Ada Thornton Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.3]
b. 24 Apr 1887 d. 30 Jul 1887
11
William Thornton Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.4]
b. 24 Apr 1892 d. 27 Dec 1894
11
Douglas Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.5]
b. 24 Jul 1894 d. 24 Nov 1916
11
Sidney Moore Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.6]
b. 24 Mar 1896 d. 1896
11
Mary Perkins Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.2.7]
+
William Graham Cline
10
Jennie Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.3]
10
Ida Gale
[1.1.4.1.2.1.2.7.4.4]
9
Nancy Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.5]
b. 1835 d. 1835
9
James Lawrence Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6]
b. 3 Aug 1841 d. 8 Sep 1914
Mathilda Jane Sillers
b. 1856 d. Aug 1888
10
Jr. James Lawrence Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.1]
b. 1882
Alice Smith
11
James Edward Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.1.1]
Felice
12
Douglas Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.1.1.1]
12
Steven Ernest Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.1.1.2]
[
=>
]
10
Arthur Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.2]
b. 1880 d. 1882
10
Mary Belle Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3]
b. 9 Apr 1884 d. 1 May 1969
Wallace Bruce Colbert
b. 18 Mar 1877 d. 19 Jan 1936
11
Dorothea Spottswood Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.1]
11
Ella Jeanne Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.2]
11
Anita Perkins Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.3]
12
R. J. Whitley
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.3.1]
11
James Perkins Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.4]
11
Mary Belle Colbert
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.3.5]
10
Anna Mathilda Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.4]
+
Oscar Pate
10
Edgar Allen Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.5]
b. Dec 1896 d. CHILD
10
Ione Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.6]
b. Jan 1891 d. Abt 1910
Florence F. Mayfield
b. Jun 1856
10
Jr. James Lawrence Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.7]
b. 1882
Alice Smith
11
James Edward Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.7.1]
Felice
12
Douglas Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.7.1.1]
12
Steven Ernest Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.7.1.2]
[
=>
]
10
Edgar Allen Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.8]
b. Dec 1896 d. CHILD
10
Ione Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.7.6.9]
b. Jan 1891 d. Abt 1910
8
Martha Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.8]
b. 9 Mar 1798 d. 20 Dec 1881
William H. Perkins
b. 2 Aug 1800 d. 31 Jan 1871
9
Cowan Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.1]
b. 1834
9
John Dabney Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2]
b. 14 Mar 1831 d. 1 Feb 1917
Julia Franklin Brown
b. 28 Aug 1843 d. 11 Sep 1928
10
Elbert West Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1]
b. 1 Oct 1867 d. 16 Oct 1938
Jessie Elizabeth Muir
b. 3 Jul 1872 d. 27 Jan 1955
11
Erwin Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.1]
Gladys Myrtle Brown
12
Evelyn Elizabeth Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.1.1]
[
=>
]
11
Waldo Muir Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.2]
Jeanette "Nettie" Julia Jones
12
Barbara Lee Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.2.1]
[
=>
]
11
Marjorie A. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.3]
b. Apr 1897 d. 13 Nov 1928
Clair Barnhart Fish
b. 23 Aug 1898 d. 25 Sep 1970
12
Marion C. Fish
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.3.1]
[
=>
]
12
Jean Adrene Fish
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.1.3.2]
10
Martha "Mattie" Warren Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2]
b. 27 Sep 1861 d. 19 Sep 1944
Alfred Edwin Smith
b. 25 Dec 1857 d. 20 Aug 1939
11
Edwin Fordt Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.1]
Lila Elizabeth Oliver
12
Barbara Mae Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.1.1]
[
=>
]
12
Lyle Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.1.2]
11
Alma Louise Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.2]
b. 11 Oct 1893 d. 9 Apr 1937
Harry Bishop Taylor
b. 15 Apr 1887 d. 1 Dec 1966
12
Garth Bishop Taylor
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.2.1]
12
Robert F Taylor
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.2.2]
11
Elbert Perkins Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.3]
b. 20 Sep 1885 d. 18 Oct 1972
Bertha Maude Taylor
12
Donald Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.3.1]
b. Abt 1908
12
Virgil Wesley Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.3.2]
12
Warren Taylor Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.3.3]
[
=>
]
11
Ira Fontaine Smith
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.2.4]
b. 2 Oct 1887 d. 23 Dec 1963
+
Bertha Fisher McKean
b. 26 Sep 1893 d. 30 Jan 1960
10
John William Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.2.3]
b. 18 Jul 1860 d. Feb 1870
9
Edward Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3]
b. 13 Sep 1833 d. 4 Apr 1905
Jennie F. Garrett
b. 4 Oct 1838 d. 14 Aug 1874
10
W. Clyde Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.1]
b. 28 Nov 1867 d. 11 Apr 1869
10
Thomas Ira Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.2]
b. 3 Apr 1870 d. 14 May 1876
10
Jr. Edward Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.3]
b. 12 Feb 1873 d. 21 Sep 1873
10
Lillard Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.4]
b. Abt 1860 d. Aft 1892
10
Edna May Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.5]
b. Abt 1865 d. Aft 1880
10
Fontelle L Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.6]
b. Abt 1863 d. Aft 1880
10
Jennie Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.7]
b. 20 Jul 1874 d. 20 Jul 1874
Sarah Catherine "Kate" E McNeiley
b. Sep 1842 d. 24 Sep 1931
10
Annie Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.3.8]
b. 4 Aug 1877 d. 11 Jun 1964
+
McMichael
9
Patrick Henry "Park" Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4]
b. 22 Jan 1829 d. 14 Apr 1910
Mary Jane Guthrie
b. Between 1836 and 1837 d. 1 Mar 1865
10
Fannie Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.1]
b. 12 Oct 1867 d. 20 Feb 1908
10
William Flood Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.2]
b. 1872 d. 1930
10
Charles Edgar Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.3]
b. Abt 1858
10
Lula Eliza Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.4]
b. Abt 1860
George D. Pruit
11
Adie Jouett Pruit
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.4.1]
10
Burton Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.5]
10
Henry Olean Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.6]
10
Robert Lee Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.7]
10
II William Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.8]
Martha Ann Flood
b. 7 Sep 1840 d. 25 Apr 1914
10
Fannie Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.9]
b. 12 Oct 1867 d. 20 Feb 1908
10
Minneola Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.10]
b. Abt 1869
+
George Bloom
10
William Flood Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.11]
b. 1872 d. 1930
10
Charles Edgar Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.12]
b. Abt 1858
10
Burton Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.13]
10
Henry Olean Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.14]
10
II William Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.4.15]
9
Louisa Ann Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.5]
b. 18 Jun 1825 d. 25 Aug 1852
Benjamin Franklin Crawley
b. 16 Sep 1822 d. 1900
10
Martha Henry Crawley
[1.1.4.1.2.1.2.8.5.1]
b. 23 Mar 1847 d. 18 Oct 1920
+
Nathaniel Cyrus Dryden
b. 23 Jan 1873 d. 21 Sep 1915
+
Nathaniel C Dryden
b. Dec 1844
10
Henry Wayne Crawley
[1.1.4.1.2.1.2.8.5.2]
b. Apr 1852
Mary
11
Rosalie Crawley
[1.1.4.1.2.1.2.8.5.2.1]
10
Lena E Crawley
[1.1.4.1.2.1.2.8.5.3]
b. Jul 1862
9
Rosalie Spottswood Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.6]
b. 11 Mar 1839 d. 17 Jan 1909
+
John H. Bradley
9
Mary Lightfoot Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.7]
b. 5 Sep 1836 d. 18 Apr 1904
John McNaught Home
b. 1830 d. 1865
10
Lewis Olean Home
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.1]
b. 1856
Eliza Jane Moore
b. 1859
11
Frances Ralston Home
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.1.1]
b. 21 Jun 1888
+
Guy R. Stowell
b. 31 May 1888
11
Mary Catherine Home
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.1.2]
+
Lewis Reed
David Irvine Stephenson, M.D.
b. 14 Aug 1829 d. 1901
10
Rosalie I. Stephenson
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.2]
b. 25 Oct 1872 d. 3 Mar 1936
Frank Thomas Ransom
b. 25 Jun 1873 d. 9 Oct 1950
11
Mary Margaret "Marg" Ransom
[1.1.4.1.2.1.2.8.7.2.1]
9
William Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.8]
b. 6 Oct 1841 d. 10 Aug 1861
9
Charles Archelaus Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9]
b. 28 Apr 1827 d. 18 May 1904
Eusebia M. Strange
b. 16 Sep 1825 d. 16 Dec 1915
10
James M. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.1]
b. Aug 1857
Mary (Molly) F
b. Dec 1864
11
Jerimy Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.1.1]
b. Jun 1894
11
William C Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.1.2]
b. Oct 1889
11
Mary Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.1.3]
b. Aug 1891
10
Mary Fontaine Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.2]
b. 1850
10
William Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.3]
b. 1851 d. Bef 17 Jul 1860
10
Annie Louise Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.4]
b. 1855
Benjamin Allen
11
Clarence Allen
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.4.1]
10
Archelaus Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.5]
b. Jan 1860
10
Sallie Mitchell Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6]
b. 15 May 1861 d. Nov 1938
Talbot McNeiley
b. Abt 1860 d. Dec 1941
11
Susan Deette McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.1]
b. 1902 d. 1965
11
Rosalie Cordelia McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.2]
Kenneth R. Miner
12
Mildred Alene Minor
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.2.1]
11
Neville Sperry McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.3]
Joseph Martin Nord
12
Mac D. Nord
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.3.1]
12
Edwin J. Nord
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.3.2]
11
Winifred McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.4]
b. 23 Dec 1889 d. 10 May 1964
+
Glen Edwin Stover
11
Charles Thomas McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.5]
b. 14 Oct 1888 d. 25 Jul 1965
+
Frances Creason
11
Naomi Catherine McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.6]
b. Mar 1882 d. 1965
11
Norman McNeiley
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.6.7]
b. Abt 1881
10
Henry S. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.7]
b. 20 Aug 1857 d. 10 Nov 1939
F. H.
11
Charles N. Perkins
[1.1.4.1.2.1.2.8.9.7.1]
b. 17 Jan 1882 d. 30 Aug 1882
+
John Overton Redd
b. 1788 d. 1858
8
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9]
b. 28 Dec 1817 d. 20 Aug 1871
Sarah Ann "Sally" Dandridge
b. 1823 d. Aft 1880
9
Charles Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.1]
b. 1846
9
John Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2]
b. 14 Aug 1841 d. 3 Sep 1925
Sarah Amanda "Dallie" Duncan
b. Jul 1849 d. Nov 1940
10
John Brooks "Little Jack" Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1]
b. 14 Oct 1871 d. 13 Aug 1967
Catherine English Crawford
11
Charles English Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1.1]
Grace May Fleming
12
Charles English Fontaine, Jr.
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1.1.1]
12
Margaret Crawford Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1.1.2]
11
Jack Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.1.2]
10
Charles De La Bouley Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.2]
b. 26 Oct 1873 d. 20 Oct 1916
10
Andrew Duncan Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.3]
b. 21 Oct 1875 d. 5 May 1954
10
Maury Blackwell Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.2.4]
b. Jun 1879 d. 1946
9
Mary Chaillon Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.3]
b. 1852 d. 1933
9
Bettie Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.4]
b. 1854
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.5]
b. 1855 d. 1896
9
Sarah M "Sally" Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.6]
b. 1857 d. 1943
9
Francis Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.7]
b. 14 Feb 1843 d. 8 Aug 1844
9
Frances Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.8]
b. 14 Mar 1845 d. 29 Oct 1845
9
Ann Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.9]
b. 27 Feb 1848 d. 19 May 1849
9
Benjamin Lamar Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.10]
b. Abt 1849 d. 15 Jun 1931
9
Edward Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.11]
b. 26 Oct 1858 d. 9 Apr 1859
9
Martha "Patty" S Fontaine
[1.1.4.1.2.1.2.9.12]
b. 1862
7
William Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3]
b. 25 Nov 1786 d. 1816
Martha Hale Dandridge
b. 23 Sep 1795 d. 7 Apr 1875
8
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1]
b. 18 May 1813 d. 3 Nov 1845
Sarah Miller Cole
b. 14 Feb 1815 d. 2 Mar 1892
9
Samuel Cole Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1]
b. 1 May 1835 d. 3 Jun 1891
Mary Morton Anderson
b. 16 Apr 1852 d. 9 Jan 1904
10
Robert Anderson Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.1]
b. 7 Mar 1879 d. 1955
Genevieve Kearfott
11
Nancy Herr Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.1.1]
b. 13 Aug 1916 d. 30 Jun 1947
10
William Hale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.2]
b. 7 Mar 1882 d. 1883/1972
10
Jr. Samuel Cole Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.3]
b. 1883 d. 1884/1973
10
Justina Cole Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.1.4]
b. 1887 d. 1969
+
Arthur B. Richardson
b. 1882 d. 1903/1973
9
Watson Hale Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.2]
9
Nathaniel Cole Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.3]
9
Katherine Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.4]
Overton Redd Wootton
b. 1837
10
Eva Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.1]
10
Nora Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.2]
10
Lucy Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.3]
10
Sallie Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.4]
10
Maude Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.5]
10
Nathaniel Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.6]
10
William Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.7]
10
John Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.8]
10
Hale Wootton
[1.1.4.1.2.1.3.1.4.9]
9
Unity Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.1.5]
+
Edward Estes
8
Anne Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.2]
b. 1810/1838 d. 1807/1918
8
William Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3]
b. 7 Nov 1810 d. 1882
Sarah Shelton Aylett
b. 24 Jun 1811 d. 5 Mar 1875
9
Sarah Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.1]
b. 18 Jan 1848
Henry Sampson
b. 10 Mar 1847 d. 18 Sep 1915
10
Cornelia Dandridge Sampson
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1]
b. 1 Apr 1874 d. 13 Sep 1903
Malcolm Graham
b. Feb 1865
11
Sarah Aylett Graham
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.1]
Frank W. Simpson
12
Jr. Frank W. Simpson
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.1.1]
12
Geary Graham Simpson
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.1.2]
[
=>
]
12
William A. Simpson
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.1.3]
+
Powell
11
Malcolm Montrose Graham
[1.1.4.1.2.1.3.3.1.1.2]
b. 16 Sep 1898
9
William Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2]
b. 27 Nov 1834 d. 2 Nov 1917
Mary Adelaide Burrows
b. 4 Jan 1838 d. 28 Mar 1887
10
Elizabeth Adelaide Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.1]
b. 6 Jan 1873 d. 19 Nov 1916
10
John Lansing Burrows Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.2]
b. 18 Jun 1868 d. 11 May 1913
+
Elizabeth Rose Waggener
b. 12 Apr 1870 d. 9 Oct 1925
10
William Winston Spottswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.3]
b. 16 Mar 1870 d. 19 Aug 1939
Florence West Evans
b. Mar 1877 d. 21 Jan 1928
11
Evan-Burrows Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.3.1]
Cornelius Vanderbilt Whitney
12
Neil “Sonny” Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.3.1.1]
[
=>
]
+
Sterling Lawrence Adair
b. 18 Dec 1894 d. 14 Jan 1921
Harold “Stubby” Herman Kruger
b. 23 Sep 1898 d. 7 Oct 1965
12
Robert "Bobby" Kruger
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.3.1.2]
+
Jack Lynch
+
Mabel Kathleen Lawrence
b. Abt 1890
10
William Spottswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.4]
b. 27 Feb 1862 d. 28 Jul 1863
10
Mary Aylett Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.5]
b. 13 May 1866 d. 8 Aug 1933
10
Marion Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.2.6]
b. 10 Jan 1880 d. 10 Jan 1880
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3]
b. 1841 d. 1915
Annie Elizabeth Redd
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.1]
10
James Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.2]
b. 1888
10
John Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.3]
b. 1887
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.1]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.1.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.1.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.1.3]
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.2]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.3]
b. 3 Dec 1897
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.4]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.4.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.4.2]
11
John Winston Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.5]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.5.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.6]
11
William Fontaine Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.7]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.4.8]
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.5]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.6]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.7]
b. 1879
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.8]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.3.9]
b. 1877
9
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.4]
b. 1838 d. 1856
9
Philip Aylett Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.5]
b. 1845 d. 1862
9
Marian Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.6]
b. 19 May 1840 d. 1913
+
John Hairston Redd
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
9
Alexander Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.7]
b. Abt 1836 d. CHILD
9
Elizabeth Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.3.8]
b. 28 Jun 1833
+
Elizabeth Henry Aylett
b. Nov 1798 d. 14 Nov 1818
8
Sarah Ann Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4]
b. 5 Nov 1815 d. 9 Feb 1909
Edmund Burwell Redd
b. 4 Jun 1808 d. 10 Aug 1850
9
James Smith Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.1]
b. Abt 1841
Sarah Hairston
10
Annie Spotswood Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.1.1]
+
John G. Hulsbush
10
Pocahontas Cabel Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.1.2]
+
Norman Thomas Mallonee
9
Celeste Tunstall Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.2]
b. Abt 1843
Samuel Pickney Caldwell
10
Alice Brandon Caldwell
[1.1.4.1.2.1.3.4.2.1]
9
Annie Elizabeth Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.3]
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
Patrick Henry Fontaine
b. 1841 d. 1915
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.1]
10
James Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.2]
b. 1888
10
John Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.3]
b. 1887
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.1]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.1.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.1.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.1.3]
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.2]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.3]
b. 3 Dec 1897
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.4]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.4.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.4.2]
11
John Winston Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.5]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.5.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.6]
11
William Fontaine Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.7]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.4.8]
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.5]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.6]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.7]
b. 1879
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.8]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.3.4.3.9]
b. 1877
9
William Spotswood Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4]
b. 1 Mar 1839 d. 1 Nov 1909
Mary Taylor Wootton
b. 27 Aug 1844 d. 26 Apr 1918
10
Ella Spotswood Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1]
b. 5 Oct 1872 d. 25 Mar 1932
Richard Wordsworth Fischer
11
Grace Brown Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.1]
Frank Beauregard Jenkins
b. Abt 1906 d. Abt 1950
12
Grace Jenkins
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.1.1]
11
Spotswood Redd Gill Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.2]
b. 5 Apr 1896 d. Abt Jun 1923
11
Jr. Richard Wordsworth Fischer, Jr
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.3]
b. 7 Sep 1897 d. 24 Mar 1937
11
Caroline Dorothea Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.4]
IV Jesse Marden
b. 18 Jan 1906 d. 4 Jul 1962
12
Ann Marden
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.4.1]
11
John Gill Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.5]
b. 3 Feb 1901 d. 2 Jan 1950
+
Grace Elizabeth Shelfer
b. 2 Feb 1908 d. 8 Apr 1961
11
Mary Elizabeth Redd Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.6]
+
James Everett Sanner
b. 15 Jul 1896 d. Oct 1968
11
Ann Franklin Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.7]
b. 8 Sep 1905 d. Abt 1909
11
Martha Redd Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.8]
+
Frank Lewis
11
Lucinda Reamey Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.9]
b. 1 Jan 1907 d. 4 Nov 1960
+
Carl Hubbard
+
Ralph Ray Jack Williams
11
Louis Christian Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.10]
11
Matthew Redd Fischer
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.1.11]
b. Abt 1911 d. Bef 1920
10
Lucinda Dabney Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.2]
b. 1 Sep 1866 d. 9 Nov 1912
10
II Edmund Burwell Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.3]
b. 23 Feb 1868 d. CHILD
10
Martha Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.4]
b. 19 Sep 1870 d. 9 Nov 1933
+
Overton Reamey
d. Abt 1898
+
Jack B. Walker
b. 1 Jun 1859
10
Sarah Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.4.5]
b. 5 Oct 1872 d. 20 Jul 1873
9
John Hairston Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.5]
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
+
Marian Dandridge Fontaine
b. 19 May 1840 d. 1913
9
Mary Dandridge Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.6]
b. 8 Jan 1837 d. 10 Sep 1888
John Wayt
b. Abt 1831
10
Martha "Mattie" Frances Wayt
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1]
b. Jun 1874 d. Feb 1926
William Augustus Osborne
b. 15 Dec 1869 d. Jul 1942
11
Frances West Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.1]
Hiram Oscar Kerns, Jr
b. 24 May 1893 d. 5 Oct 1964
12
Elizabeth Osborne Kerns
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.1.1]
12
Hiram Oscar Kerns, III
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.1.2]
[
=>
]
12
Edward Johnson Kerns
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.1.3]
[
=>
]
11
William Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.2]
b. Abt 1908
11
Marion Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.3]
b. Abt 1908
11
Dorothy Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.4]
b. Abt 1910
11
Elizabeth Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.5]
b. Abt 1904
11
Mary Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.6]
b. Abt 1898
11
Kate Osborne
[1.1.4.1.2.1.3.4.6.1.7]
b. Abt 1901
9
Edmund Madison Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.7]
b. 18 Dec 1844 d. 2 Oct 1928
+
Anna Richardson
b. Abt 1859 d. Abt 1929
9
Martha Catherine Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.8]
b. 3 Apr 1833 d. 15 Sep 1913
+
John Francis Wootton
b. Abt 1827 d. Abt 1888
9
Ella E. Redd
[1.1.4.1.2.1.3.4.9]
b. Abt 1849 d. Abt 1919
+
Francis Watlington
b. Abt 1847 d. Abt 1917
7
Martha Henry Fontaine
[1.1.4.1.2.1.4]
b. 4 Jul 1781 d. 12 Sep 1845
II Nathaniel West Dandridge
b. 14 Jan 1771 d. 26 Jul 1847
8
III Nathaniel West Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.1]
b. 1824
Harriett A. Wylie
b. Abt 1828 d. 1815/1910
9
William B. Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.1.1]
b. Abt 1853
9
Mary Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.1.2]
b. Abt 1849
8
William Fontaine Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2]
b. 1804
Susan C. Stith
b. Abt 1809 d. 1830/1898
9
Catherine Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.1]
b. Abt 1826
9
John W. Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.2]
b. Abt 1829
9
Mona H. Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.3]
b. Abt 1835
9
Morrison Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.4]
b. Abt 1838
9
Spotswood Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.2.5]
b. Abt 1841
8
Charles Fontaine Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.3]
b. 1806 d. 1866
Tabitha Ann McGee
b. 1794/1829 d. 1815/1910
9
McGee Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.3.1]
d. 7 Apr 1861
8
Henry Bolling Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4]
b. 1823 d. Aft 1885
Caroline Wylie
9
Mary Jane Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.1]
b. Abt 1829
9
Zelia Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.2]
b. Abt 1832
+
E. H. Lewis
9
Matilda Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.3]
b. Abt 1834
9
Elizabeth Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.4]
b. Abt 1836
+
William P. Ome
9
Martha Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.5]
b. Abt 1838
9
Bolling Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.6]
b. Abt 1839
Adeline Kenon Wilbourn
b. 1818/1843 d. 1865/1931
9
Lightfoot Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.7]
b. 17 Apr 1874 d. 13 Dec 1928
Henry Woodson Baker
b. 26 Jan 1859 d. 24 Dec 1929
10
Katie Jenkins Baker
[1.1.4.1.2.1.4.4.7.1]
Marvin N. Fogleman
11
Mary Kate Fogleman
[1.1.4.1.2.1.4.4.7.1.1]
Thomas Dove Copeland
12
Connie Sue Copeland
[1.1.4.1.2.1.4.4.7.1.1.1]
[
=>
]
12
Sharon Diane Copeland
[1.1.4.1.2.1.4.4.7.1.1.2]
[
=>
]
9
Nannie Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.8]
b. 1844/1872 d. 1849/1954
9
Jr. Henry Bolling Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.4.9]
b. 1844/1872 d. 1850/1951
8
Rosalie Spotswood Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.5]
b. 1825 d. 1898
+
William Daugherty Bradford
b. 1785/1820 d. 1811/1900
8
Martha Lightfoot Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.6]
b. 1821 d. 3 Jun 1850
Richard Bolton
b. 1785/1820 d. 1811/1900
9
William Bolton
[1.1.4.1.2.1.4.6.1]
8
Eliza Ann Dandridge
[1.1.4.1.2.1.4.7]
b. 1800 d. 1855
+
William Herford
b. 1765/1797 d. 1822/1884
7
John James Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5]
b. 1788 d. 3 Jan 1852
Mary Carr Redd
b. 5 Dec 1794 d. 26 Sep 1837
8
Mary Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5.1]
b. Abt 1815
James Edward Waller
9
John Fontaine Waller
[1.1.4.1.2.1.5.1.1]
b. 1842 d. 1909
Martha Malone
10
Mary Alice Waller
[1.1.4.1.2.1.5.1.1.1]
b. 1872 d. 1954
+
David Alexander Shepard
b. 1879 d. 1959
8
Madison Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5.2]
b. 1824 d. 1891
Elizabeth Gillespie
b. 1836
9
Martha Redd Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5.2.1]
b. Sep 1873
+
Robert Willis Flournoy
b. 22 Sep 1867
9
Elizabeth Fontaine
[1.1.4.1.2.1.5.2.2]
+
Walter C. Harris
7
Edward Winston Fontaine
[1.1.4.1.2.1.6]
b. 12 Feb 1776 d. 12 Feb 1792
7
Dorothea Spotswood Fontaine
[1.1.4.1.2.1.7]
b. 1791 d. 1793
6
Edmund Fontaine
[1.1.4.1.2.2]
b. 1754 d. 1759
6
Sarah Fontaine
[1.1.4.1.2.3]
b. 1755 d. 1776
Charles Rose
b. Abt 1751
7
Alexander Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.3.1]
b. 1780 d. 1831
Sarah Rose Fontaine
b. 21 Sep 1796 d. 1863
8
Lawrence Berry Rose
[1.1.4.1.2.3.1.1]
b. 1821 d. 1877
Eliza Welford
9
Jr. Lawrence Berry Rose
[1.1.4.1.2.3.1.1.1]
9
Susan Welford Rose
[1.1.4.1.2.3.1.1.2]
8
Edmund Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2]
b. 1817 d. 1893
Betty Maury
9
Alexander Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2.1]
9
John Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2.2]
9
Robert Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2.3]
9
Sarah Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.3.1.2.4]
8
Charles Alexander Rose
[1.1.4.1.2.3.1.3]
b. 1823 d. 1875
+
M. Rutherford
Logie Childs
9
Rutherford Rose
[1.1.4.1.2.3.1.3.1]
9
Hugh Rose
[1.1.4.1.2.3.1.3.2]
9
Charles Rose
[1.1.4.1.2.3.1.3.3]
8
Louisa Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.3.1.4]
b. 1819 d. 1891
John Potts
9
Rose Potts
[1.1.4.1.2.3.1.4.1]
9
Douglas Potts
[1.1.4.1.2.3.1.4.2]
9
Morris Templin Potts
[1.1.4.1.2.3.1.4.3]
9
Elizabeth Hawley Potts
[1.1.4.1.2.3.1.4.4]
7
Peter Rose
[1.1.4.1.2.3.2]
7
Sarah Elizabeth Rose
[1.1.4.1.2.3.3]
7
John Rose
[1.1.4.1.2.3.4]
6
Mary Ann Fontaine
[1.1.4.1.2.4]
b. Abt 1759 d. 5 Apr 1799
Bowles Armistead
b. 1752 d. Bef 21 Jun 1785
7
Peter Fontaine Armistead
[1.1.4.1.2.4.1]
b. 1778 d. 1866
Martha Fontaine Winston
b. 7 Jul 1784 d. 3 Aug 1870
8
Peter Fontaine Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.1]
8
Patrick Henry Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.2]
+
Clanton
8
Isaac Coles Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.3]
8
Eliza Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.4]
8
Virginia Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.5]
+
Lanier
8
George Washington Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.6]
8
Mary Anne Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.7]
8
Martha Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.8]
8
William Bowles Armistead
[1.1.4.1.2.4.1.9]
7
Elizabeth Armistead
[1.1.4.1.2.4.2]
b. 1780
Ludwell Lee
b. 1761 d. 1836
8
Eliza A. Lee
[1.1.4.1.2.4.2.1]
b. 1807
Jr. Wilson Cary Selden
9
Eleanor Love Selden
[1.1.4.1.2.4.2.1.1]
+
John Augustine Washington
b. 3 May 1821 d. 13 Sep 1861
8
Lightfoot Lee
[1.1.4.1.2.4.2.2]
8
Mary Lee
[1.1.4.1.2.4.2.3]
+
W. Selden
8
Lee
[1.1.4.1.2.4.2.4]
+
Knapp
7
Mary Bowles Armistead
[1.1.4.1.2.4.3]
b. 1783 d. 2 Mar 1864
Charles Alexander
8
Ellen Alexander
[1.1.4.1.2.4.3.1]
8
C. Armistead Alexander
[1.1.4.1.2.4.3.2]
Wilson Cary Selden
8
Jr. Wilson Cary Selden
[1.1.4.1.2.4.3.3]
Eliza A. Lee
b. 1807
9
Eleanor Love Selden
[1.1.4.1.2.4.3.3.1]
+
John Augustine Washington
b. 3 May 1821 d. 13 Sep 1861
7
Armistead
[1.1.4.1.2.4.4]
Terrill
8
Armistead Bowles Terrill
[1.1.4.1.2.4.4.1]
7
William Bowles Armistead
[1.1.4.1.2.4.5]
John Lewis
d. 1825
7
Frances Lewis
[1.1.4.1.2.4.6]
Keeling Terrell
8
John Terrell
[1.1.4.1.2.4.6.1]
7
Howell Lewis
[1.1.4.1.2.4.7]
7
Mary Ann Lewis
[1.1.4.1.2.4.8]
Charles Alexander
8
Armistead Alexander
[1.1.4.1.2.4.8.1]
8
Ellen Alexander
[1.1.4.1.2.4.8.2]
+
Selden
8
Mary Alexander
[1.1.4.1.2.4.8.3]
+
E. Lippit
8
Fontaine Alexander
[1.1.4.1.2.4.8.4]
+
L. Washington
6
James Fontaine
[1.1.4.1.2.5]
b. Abt 1761 d. 29 Oct 1790
6
Judith Fontaine
[1.1.4.1.2.6]
b. Abt 1763
6
Susanna Fontaine
[1.1.4.1.2.7]
b. Abt 1765
6
William Fontaine
[1.1.4.1.2.8]
b. 22 Jan 1751 d. 6 Oct 1810
Anne Morris
b. 14 Apr 1766 d. 21 Jul 1852
7
Sarah Rose Fontaine
[1.1.4.1.2.8.1]
b. 21 Sep 1796 d. 1863
Alexander Fontaine Rose
b. 1780 d. 1831
8
Lawrence Berry Rose
[1.1.4.1.2.8.1.1]
b. 1821 d. 1877
Eliza Welford
9
Jr. Lawrence Berry Rose
[1.1.4.1.2.8.1.1.1]
9
Susan Welford Rose
[1.1.4.1.2.8.1.1.2]
8
Edmund Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2]
b. 1817 d. 1893
Betty Maury
9
Alexander Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2.1]
9
John Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2.2]
9
Robert Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2.3]
9
Sarah Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.8.1.2.4]
8
Charles Alexander Rose
[1.1.4.1.2.8.1.3]
b. 1823 d. 1875
+
M. Rutherford
Logie Childs
9
Rutherford Rose
[1.1.4.1.2.8.1.3.1]
9
Hugh Rose
[1.1.4.1.2.8.1.3.2]
9
Charles Rose
[1.1.4.1.2.8.1.3.3]
8
Louisa Fontaine Rose
[1.1.4.1.2.8.1.4]
b. 1819 d. 1891
John Potts
9
Rose Potts
[1.1.4.1.2.8.1.4.1]
9
Douglas Potts
[1.1.4.1.2.8.1.4.2]
9
Morris Templin Potts
[1.1.4.1.2.8.1.4.3]
9
Elizabeth Hawley Potts
[1.1.4.1.2.8.1.4.4]
7
Peter Forreau Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2]
b. Abt 1793 d. 1815/1820
8
Charles Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.1]
8
Louisa Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.2]
8
John Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.3]
8
Alexander Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.4]
8
William Fontaine
[1.1.4.1.2.8.2.5]
7
Edmund Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3]
b. 29 Jan 1801 d. 26 Jun 1869
Maria Louisa Shackleford
b. 4 Feb 1807 d. 30 May 1876
8
Elizabeth "Betsey" Ann Betty Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.1]
b. Abt 1827 d. 1 May 1876
Thomas H. DeWitt
9
Mary Brown DeWitt
[1.1.4.1.2.8.3.1.1]
b. 9 Oct 1860
William H. Adams
b. Abt 1860
10
Helen Adams
[1.1.4.1.2.8.3.1.1.1]
b. May 1890
10
Anthony Crece Adams
[1.1.4.1.2.8.3.1.1.2]
b. Feb 1892
10
Fontaine DeWitt Adams
[1.1.4.1.2.8.3.1.1.3]
b. 25 Oct 1893 d. 30 Dec 1951
9
Edmund Fontaine DeWitt
[1.1.4.1.2.8.3.1.2]
b. Abt 1856
9
Louisa Fontaine DeWitt
[1.1.4.1.2.8.3.1.3]
d. CHILD
9
Nora Braxton DeWitt
[1.1.4.1.2.8.3.1.4]
d. CHILD
8
John Boursiquot Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.2]
b. 1 Apr 1840 d. 1 Oct 1864
Elizabeth Winston Price
9
Ellen Stuart Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.2.1]
Albert Sidney Morton
10
Stuart Fontaine Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.1]
10
Ellen Price Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.2]
10
D'Arcy Paul Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.3]
10
Jr. Albert Sidney Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.4]
10
Morton
[1.1.4.1.2.8.3.2.1.5]
d. INFANT
8
Mary Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.3]
b. 1835 d. 1910
Thomas L. Broun
b. 26 Dec 1823
9
Louisa Fontaine Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.1]
Malcolm Jackson
10
Thomas Broun Jackson
[1.1.4.1.2.8.3.3.1.1]
10
Anna Arbuthnot Jackson
[1.1.4.1.2.8.3.3.1.2]
9
Edmund Fontaine Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.2]
Sue Payton Kent
10
Jr. Edmund Fontaine Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.2.1]
10
Virginia Peyton Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.2.2]
9
Ann Conway Broun
[1.1.4.1.2.8.3.3.3]
Philip Sidney Powers
10
Thomas Broun Powers
[1.1.4.1.2.8.3.3.3.1]
10
Louisa Fontaine Powers
[1.1.4.1.2.8.3.3.3.2]
10
Ann Conway Powers
[1.1.4.1.2.8.3.3.3.3]
8
Edmund Fontaine Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.4]
b. 1837 d. 1 Jul 1861
8
Lucy Dabney Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.5]
b. 29 May 1844 d. 12 Mar 1917
Chiswell D. Dabney
b. 25 Jul 1844 d. 28 Apr 1923
9
John Charles Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.1]
b. Abt 1874 d. 1899
9
Jr. Chiswell Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.2]
b. Jul 1876 d. 1908
9
Louisa Fontaine Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.3]
b. Aug 1879
9
Lucy Fontaine Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.4]
b. Oct 1881
9
Elizabeth Towles Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.5]
b. Feb 1887 d. 1948
9
Edmund Fontaine Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.6]
b. Feb 1883 d. 1926
9
Louise Shackelford Dabney
[1.1.4.1.2.8.3.5.7]
b. Aug 1879 d. 1950
8
William Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.6]
b. 6 Jun 1828 d. 5 Aug 1842
8
Sarah Louisa Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.7]
b. 8 Nov 1831 d. CHILD
8
Jane Catherine Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.8]
b. 31 Mar 1833 d. 20 Oct 1909
Richard Hardway Meade
9
Edmonia Fontaine Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.1]
d. CHILD
9
Lila Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.2]
+
Benjamin B. Valentine
9
Jr. Richard Hardway Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.3]
Eleanor Prior Adkins
10
III Richard Hardway Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.3.1]
9
Louise Fontaine Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.4]
+
Clarence Cadot
9
Kate Fontaine Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.5]
9
Marianne Skelton Meade
[1.1.4.1.2.8.3.8.6]
8
Richard Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.9]
b. 5 Aug 1842 d. 15 Oct 1914
8
Rosalie Shackelford Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.10]
b. 12 Mar 1851 d. 5 Jan 1933
8
Rose Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.8.3.11]
b. 7 Mar 1848 d. 23 May 1848
7
Louise Elizabeth Fontaine
[1.1.4.1.2.8.4]
b. Abt 1791 d. 10 Nov 1806
7
Jr. William Fontaine
[1.1.4.1.2.8.5]
b. Abt 1797 d. 22 Jun 1824
7
Charles Fontaine
[1.1.4.1.2.8.6]
b. 25 May 1806 d. Jan 1827
7
Alexander Rose Fontaine
[1.1.4.1.2.8.7]
b. 1808 d. 1870
7
John Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.8]
b. 1803 d. 1827
7
James Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9]
b. 1799 d. 20 Jan 1875
Juliet C. Morris
b. Abt 1827 d. 1876
8
William Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.1]
b. 1 Dec 1835
8
Charles Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.2]
b. Abt 1851
8
Maury Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.3]
b. 1852 d. 1881
8
Joseph Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.4]
b. 1854 d. 1915
8
Sally Rose Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.5]
b. Abt 1855
8
John Dabney Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.6]
b. Abt 1850 d. CHILD
8
Susan Watson Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.7]
b. 16 May 1849
Carter Nelson Berkeley Minor
b. 6 Oct 1842
9
James Fontaine Minor
[1.1.4.1.2.8.9.7.1]
b. 24 Jul 1876
+
Lilian Forbes Lyman
b. Abt 1885
9
Berkeley Minor
[1.1.4.1.2.8.9.7.2]
b. 8 May 1879
9
Charles Landon Carter Minor
[1.1.4.1.2.8.9.7.3]
b. Abt 1881 d. Abt 1881
8
James Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.8]
d. CHILD
8
Peter Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.9]
Lydia Laidley
9
James Morris Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.9.1]
9
Betsy Ann Quarrier Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.9.2]
d. CHILD
9
Keith Niles Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.9.3]
8
Nancy Fontaine
[1.1.4.1.2.8.9.10]
d. CHILD
5
Edmund Winston
[1.1.4.1.3]
b. Abt 1745 d. 1818
Alice Winston
b. 20 Mar 1753 d. 1784
6
Jr. Edmund Winston
[1.1.4.1.3.1]
b. 1778 d. 1864
+
Carolyne Wyatt
6
Elizabeth Winston
[1.1.4.1.3.2]
b. 1783 d. 1856
+
Bennett W. Moseley
d. 1811
6
George Dabney Winston
[1.1.4.1.3.3]
b. 2 Aug 1771 d. 15 Jul 1831
Dorothea Spotswood Henry
b. 2 Aug 1778 d. 17 Jun 1854
7
James Winston
[1.1.4.1.3.3.1]
b. 1815 d. 1852
7
Edmund Dabney Winston
[1.1.4.1.3.3.2]
b. 17 Sep 1799 d. 21 Sep 1875
Elizabeth Louisa Fontaine
b. 17 Sep 1804 d. 1892
8
Nancy Miller Winston
[1.1.4.1.3.3.2.1]
b. 5 Mar 1825
+
Oliver H. Black
8
John Dabney Winston
[1.1.4.1.3.3.2.2]
b. 21 Feb 1822
8
William Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3]
b. 21 Jul 1828 d. 13 Aug 1878
Emma Eloise Furr
b. 1842 d. 9 Feb 1892
9
Edmund Tobias Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3.1]
b. 22 Jul 1871 d. 26 Dec 1944
Florence Theresa Seale
b. 9 Feb 1876 d. 28 Jun 1959
10
Eloise Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1]
b. 7 Mar 1899
Ozeph Chester Taylor
b. 1 Jul 1867
11
Edmund Warren Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.1]
Benna Dean
12
Edmund Warren Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.1.1]
12
Benna Jeanne Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.1.2]
12
Dorothy Frances Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.1.3]
11
Dorothy Eloise Taylor
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2]
Jr. William Leroy Evans
12
William Leroy Evans
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2.1]
12
John Scott Evans
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2.2]
12
James Randall Evans
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2.3]
12
Cynthia Ann Evans
[1.1.4.1.3.3.2.3.1.1.2.4]
9
Galen Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3.2]
b. 8 Feb 1873 d. 1928
+
Aurelia Odile Despommer
9
Masina Winston
[1.1.4.1.3.3.2.3.3]
b. 28 Aug 1875 d. 1928
+
Henry Henesler
8
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.4.1.3.3.2.4]
b. 8 Mar 1831 d. 1852
8
George Dabney Winston
[1.1.4.1.3.3.2.5]
b. 17 Sep 1833
+
Mrs. Iola Overton
8
Patrick Fontaine Winston
[1.1.4.1.3.3.2.6]
b. 5 Mar 1845 d. 1 Apr 1906
7
William Winston
[1.1.4.1.3.3.3]
b. 1809
7
Edward Henry Winston
[1.1.4.1.3.3.4]
b. 1811
Susan Moorehead Reynolds
8
Prior Winston
[1.1.4.1.3.3.4.1]
b. 1821/1860 d. 1830/1937
7
Sallie Butler Winston
[1.1.4.1.3.3.5]
b. 1807
+
Charles Dandridge
b. 1786/1818 d. 1812/1898
7
Fayette Henry Winston
[1.1.4.1.3.3.6]
b. 1813
Martha Dix
b. 1796/1827 d. 1821/1909
8
Lucy Winston
[1.1.4.1.3.3.6.1]
b. 1821/1860 d. 1839/1940
+
Hoffman
b. 1813/1858 d. 1839/1935
8
Elvira Winston
[1.1.4.1.3.3.6.2]
b. 1821/1860 d. 1839/1940
+
J. C. Granberry
b. 1813/1858 d. 1839/1935
7
Patrick Henry Winston
[1.1.4.1.3.3.7]
b. 28 Jan 1802
7
George Winston
[1.1.4.1.3.3.8]
b. 1804
7
Elvira Virginia Winston
[1.1.4.1.3.3.9]
d. 17 Jun 1854
James W. Crenshaw
b. 1786/1818 d. 1818/1898
8
Elvira Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.1]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
James C. Marvin
b. 1810/1851 d. 1836/1929
8
Sallie Winston Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.2]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
John Miller
b. 1810/1851 d. 1836/1929
8
Dorothea Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.3]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
David F. Smyer
b. 1810/1851 d. 1836/1929
8
Patrick Henry Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.4]
b. 1818/1853 d. 1839/1931
+
Lula Mack
b. 1818/1859 d. 1839/1939
8
Virginia Crenshaw
[1.1.4.1.3.3.9.5]
b. 3 Dec 1838
+
James W. Harper
b. 1810/1851 d. 1836/1929
6
Alice Winston
[1.1.4.1.3.4]
b. 1784
Frederic Cabell
b. 1775 d. 5 Mar 1841
7
Edmund Cabell
[1.1.4.1.3.4.1]
b. 12 Jul 1808
7
Lewis Carrington Cabell
[1.1.4.1.3.4.2]
b. 12 Jun 1814 d. 1896
7
Sarah Lynne Cabell
[1.1.4.1.3.4.3]
b. 27 Aug 1804 d. 16 Jul 1820
7
Mary Mildred Cabell
[1.1.4.1.3.4.4]
b. 15 Jan 1802 d. 3 Mar 1880
John Horsley
8
Edmond Winston Horsley
[1.1.4.1.3.4.4.1]
Lucy Wilhelmina Gwatkin
9
Edmonia Winston Horsley
[1.1.4.1.3.4.4.1.1]
+
P. L. Saunders
7
Alice Winston Cabell
[1.1.4.1.3.4.5]
b. Apr 1806 d. INFANT
7
Virginia Pauline Cabell
[1.1.4.1.3.4.6]
b. 15 Jul 1812 d. 23 May 1894
John Ware Mosby
b. 30 Jun 1804 d. 28 Dec 1875
8
Frederick Cabell Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.1]
b. 7 Jun 1840 d. 22 Nov 1841
8
Mary Winston Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.2]
b. 19 Feb 1843 d. 1 Jan 1847
8
Clifford C. Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.3]
b. 2 Jun 1834 d. 5 Sep 1834
8
Alice Jane Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.4]
b. 8 Jul 1836
John Churchill Garner
9
John Floyd Churchill Garner
[1.1.4.1.3.4.6.4.1]
Anne
10
Winston Churchill Garner
[1.1.4.1.3.4.6.4.1.1]
8
Carrington Winston Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.5]
b. 30 Sep 1849
+
Cora Cannon Clark
8
Ella Floy Mosby
[1.1.4.1.3.4.6.6]
b. 29 Aug 1846
7
Frederic Montimer Cabell
[1.1.4.1.3.4.7]
b. 15 Jan 1802 d. 1873
7
Clifford Cabell
[1.1.4.1.3.4.8]
b. 17 Aug 1810 d. 18 Sep 1871
6
Mary Winston
[1.1.4.1.3.5]
+
John Jones
Dorothea Spotswood Dandridge
b. 25 Sep 1755 d. 14 Feb 1831
6
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.4.1.3.6]
b. 1775/1798 d. 1780/1882
4
Jr. George Dabney
[1.1.4.2]
b. 2 Jan 1700 d. 18 Nov 1768
Ann Anderson
b. 14 Sep 1691 d. 17 May 1767
5
James Dabney
[1.1.4.2.1]
b. 6 Jan 1735/36 d. 13 Nov 1803
Judith Anderson
6
William S. Dabney
[1.1.4.2.1.1]
b. 1771 d. 1813
Sarah Watson
b. Abt 1775
7
Jr. William S. Dabney
[1.1.4.2.1.1.1]
b. Abt 1822 d. 1865
Susan FitzHugh Gordon
b. Abt 1822
8
William Cecil Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1]
b. 4 Jul 1869 d. 20 Aug 1894
Jane Bell Minor
b. 22 Sep 1847 d. 1914
9
Cecil Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.1]
b. 1884 d. 1913
+
Frances Cole
9
William Minor Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.2]
b. 21 Aug 1873
9
James Cabell Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.3]
b. 8 Oct 1875
Mary Beverley Whittle
10
Mary Beverley Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.3.1]
10
William Minor Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.3.2]
10
Elizabeth Calvert Page Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.3.3]
9
Susan FitzHugh Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.4]
St. George Tucker Grinnan
b. 6 Apr 1870
10
William C. Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.1]
10
David Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.2]
10
Jane Bell Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.3]
10
St. George Tucker Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.4]
10
Georgia Grinnan
[1.1.4.2.1.1.1.1.4.5]
9
Marian Gordon Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.5]
9
Jane Bell Dabney
[1.1.4.2.1.1.1.1.6]
+
E. Ruffln Jones
5
III George Dabney
[1.1.4.2.2]
Grace Smith
b. 1736
6
IV George Dabney
[1.1.4.2.2.1]
b. Abt 1760
+
Ann Nelson
6
Ann Dabney
[1.1.4.2.2.2]
b. 10 Feb 1759 d. 18 Jun 1831
+
Samuel Anderson
b. 25 Jun 1757 d. 4 Apr 1826
4
William Dabney
[1.1.4.3]
b. 1707 d. Aug 1773
Susannah Ann Barrett
b. 1714 d. 1753
5
George Francis Dabney
[1.1.4.3.1]
b. 17 Aug 1742 d. 1824
Elizabeth Randolph Price
b. 1740 d. 1819
6
John Dabney
[1.1.4.3.1.1]
b. 1770 d. 4 May 1816
Susannah Dabney Morris
b. 25 Dec 1773 d. 28 Feb 1850
7
John Blair Dabney
[1.1.4.3.1.1.1]
b. 15 Nov 1794 d. 23 Apr 1868
Elizabeth Lewis Towles
b. 25 Dec 1801 d. 22 Mar 1883
8
Maria Louisa Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.1]
b. 15 Jun 1825 d. 5 Aug 1902
William Cabell Carrington
b. 27 Aug 1821 d. 29 Dec 1851
9
Williamine "Willa" Cabell Carrington
[1.1.4.3.1.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1852 d. 16 Feb 1934
Robert Alexander Lancaster
b. 1829 d. 1902
10
Henry Carrington Lancaster
[1.1.4.3.1.1.1.1.1.1]
b. 12 Nov 1882
9
Louisa Edmonia Carrington
[1.1.4.3.1.1.1.1.2]
b. 1846 d. Abt 1847
9
Elizabeth Lewis Carrington
[1.1.4.3.1.1.1.1.3]
b. 14 Oct 1849
8
Belle Lewis Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.2]
b. 1829 d. 1887
8
William Oliver Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.3]
b. 1832 d. 1850
8
Susan Morris Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.4]
b. 4 Aug 1827 d. 27 Mar 1918
8
John Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.5]
b. 1822 d. 25 Nov 1887
8
Elizabeth Lewis Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.6]
b. May 1830 d. 1904
8
Catherine Morris Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.7]
b. 16 Dec 1837 d. 1881
8
Caroline Agatha Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.8]
b. 1842 d. 1865
8
Chiswell D. Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9]
b. 25 Jul 1844 d. 28 Apr 1923
Lucy Dabney Fontaine
b. 29 May 1844 d. 12 Mar 1917
9
John Charles Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.1]
b. Abt 1874 d. 1899
9
Jr. Chiswell Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.2]
b. Jul 1876 d. 1908
9
Louisa Fontaine Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.3]
b. Aug 1879
9
Lucy Fontaine Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.4]
b. Oct 1881
9
Elizabeth Towles Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.5]
b. Feb 1887 d. 1948
9
Edmund Fontaine Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.6]
b. Feb 1883 d. 1926
9
Louise Shackelford Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.7]
b. Aug 1879 d. 1950
Nell H
b. Abt 1884
9
Edmund Fontaine Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.9.8]
b. Feb 1883 d. 1926
8
Charles Edward Dabney
[1.1.4.3.1.1.1.10]
d. 1887
6
Anne Dabney
[1.1.4.3.1.2]
b. 1762 d. 1830
6
Catherine Dabney
[1.1.4.3.1.3]
b. 1768
6
Chiswell Dabney
[1.1.4.3.1.4]
b. 24 Jun 1791 d. 30 Mar 1865
Nancy Wiatt
b. 2 Feb 1796 d. 1 Aug 1834
7
Sarah Elizabeth Dabney
[1.1.4.3.1.4.1]
b. 14 Apr 1821 d. 26 Feb 1884
John Scarsbrook Langhorne
b. 1 Jun 1818 d. 29 Aug 1886
8
Chiswell Dabney "Chillie" Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1]
b. 4 Nov 1843 d. 14 Feb 1919
Nancy Witcher "Namie" Keene
b. 30 Aug 1848 d. 7 Oct 1903
9
Elizabeth "Lizzie" Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.1]
b. 1867 d. 9 Apr 1914
9
Elisha Keene Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.2]
b. Feb 1868 d. 28 Dec 1916
9
Irene Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.3]
b. 5 Jan 1874 d. 21 Apr 1956
9
Harry S. Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.4]
b. Oct 1874 d. Nov 1907
9
Nancy Witcher Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.5]
b. 19 May 1879 d. 18 Apr 1964
William Waldorf Astor
b. 19 May 1879 d. 30 Sep 1952
10
William Waldorf Astor, Jr.
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.1]
b. 13 Aug 1907 d. 7 Mar 1966
10
Nancy Phyllis Louise "Wisie" Astor
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.2]
10
Francis David Langhorne Astor
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.3]
10
Michael Langhorne Astor
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.4]
10
John Jacob "Jakie" Astor
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.5]
Robert Gould Shaw, II
b. 16 Jun 1872 d. 29 Mar 1930
10
Robert Gould Shaw, III
[1.1.4.3.1.4.1.1.5.6]
b. 18 Aug 1898 d. 10 Jul 1970
9
Nora Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.6]
b. 14 Sep 1887 d. 16 Jul 1955
Paul Phipps
b. 3 Mar 1883 d. 1953
10
Joyce Irene Phipps
[1.1.4.3.1.4.1.1.6.1]
9
Phillis Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.7]
b. 3 Nov 1881 d. 20 Jan 1937
9
William Henry Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.1.8]
b. 4 Nov 1882 d. 9 Jun 1938
8
John S Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.2]
b. 1868
8
Anne Frances Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.3]
b. 10 Apr 1842 d. 3 Jun 1907
8
Elizabeth Dabney Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.4]
b. 1845 d. 1918
8
Nannie S Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.5]
b. Abt 1842
8
Henry S Langhorne
[1.1.4.3.1.4.1.6]
b. Abt 1848
7
John Dabney
[1.1.4.3.1.4.2]
b. 1819 d. 2 Jul 1832
7
Lucy B Dabney
[1.1.4.3.1.4.3]
b. 1828
7
Catherine Maria Dabney
[1.1.4.3.1.4.4]
b. 1832 d. 1886
7
Ann C Dabney
[1.1.4.3.1.4.5]
d. 7 Dec 1839
7
George William Dabney
[1.1.4.3.1.4.6]
Martha Ann Norvell
b. 1797 d. 1 Oct 1815
7
George William Dabney
[1.1.4.3.1.4.7]
b. 1815
7
Sarah Elizabeth Dabney
[1.1.4.3.1.4.8]
b. 1775 d. 1808
7
Elizabeth Dabney
[1.1.4.3.1.4.9]
b. 1803 d. 26 Feb 1884
5
Samuel Dabney
[1.1.4.3.2]
b. 16 Apr 1752
Jane Meriwether
6
Charles Dabney
[1.1.4.3.2.1]
b. 1 Jul 1781 d. Sep 1833
Elizabeth Randolph Price
7
Robert Lewis Dabney
[1.1.4.3.2.1.1]
b. 5 Mar 1820 d. 3 Jan 1898
Margareta Lavinia Morrison
b. 1824 d. 1909
8
Charles William Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.1]
b. 19 Jun 1855
Mary Chilton Brent
b. 12 Apr 1861
9
Mary Moore Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.1.1]
b. 30 Aug 1886
+
Alexander Thomson
9
Katherine Brent Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.1.2]
b. 14 Feb 1893
+
Jr. John William Ingle
9
Marguerite Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.1.3]
8
Samuel Brown Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.2]
b. 1860
+
Annie Euginia Prescott
8
Lewis Meriwether Dabney
[1.1.4.3.2.1.1.3]
b. 1865 d. 1923
+
Stella Hutcheson
7
Anne Elizabeth Dabney
[1.1.4.3.2.1.2]
b. 23 Sep 1814 d. 1839/1908
+
George Woodson Payne
b. 29 Dec 1810 d. Jan 1870
7
Charles William Dabney
[1.1.4.3.2.1.3]
7
George Francis Dabney
[1.1.4.3.2.1.4]
6
Francis Dabney
[1.1.4.3.2.2]
b. 1 Jul 1781
5
Charles Dabney
[1.1.4.3.3]
b. Abt 1749
5
Mary Dabney
[1.1.4.3.4]
b. 1740 d. Oct 1835
+
Edmund Massie
b. Abt 1747
5
William Dabney
[1.1.4.3.5]
b. 3 Dec 1745
4
Judith Dabney
[1.1.4.4]
b. 17 May 1693 d. 16 Mar 1774
4
Susannah Dabney
[1.1.4.5]
b. 21 Mar 1691
4
Mary Dabney
[1.1.4.6]
b. 20 Mar 1696 d. 2 Sep 1763
Stephen Pettus
b. 1685
5
Dabney Pettus
[1.1.4.6.1]
4
Elizabeth Dabney
[1.1.4.7]
c. 11 Nov 1698 d. Bef 1729
Matthew Anderson
b. 21 Apr 1703 d. 22 May 1786
5
George Anderson
[1.1.4.7.1]
b. Abt 1725 d. 1808
Frances Woodson
b. 1730
6
George Dabney Anderson
[1.1.4.7.1.1]
b. Abt 1750 d. 1811
Susannah Mimms
b. 1736 d. 25 Feb 1824
7
Judith Anderson
[1.1.4.7.1.1.1]
b. Abt 1773 d. 18 Jun 1862
Richard Beckwith Payne
b. 9 Aug 1776 d. 8 Sep 1858
8
Elizabeth Beckwith Payne
[1.1.4.7.1.1.1.1]
b. 20 Aug 1815 d. 12 Oct 1815
8
Robert Burton Payne
[1.1.4.7.1.1.1.2]
b. 16 Aug 1795 d. 11 Mar 1875
+
Frances Gardner Anderson
b. 23 Nov 1810 d. 7 Aug 1881
+
Susannah ANDERSON
8
George Anderson Payne
[1.1.4.7.1.1.1.3]
b. 28 Mar 1797 d. 18 May 1839
8
Norella Burton Payne
[1.1.4.7.1.1.1.4]
b. 25 Dec 1801 d. 9 Feb 1889
Jesse Reese Hughes
d. 6 Jan 1880
9
Robert Burton Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.4.1]
b. 3 Nov 1820 d. 4 Dec 1900
Sarah Elizabeth Cleveland
b. 13 Jun 1824 d. 24 Aug 1864
10
Margaret Lelia Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1]
b. 12 Dec 1850 d. 18 Dec 1940
III Isaac Otey Perkins, Jr.
b. 20 Dec 1846 d. 18 Jan 1913
11
Edwin Judson Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.1]
b. Abt 1880
+
Henrietta Tapscott Snead
b. Abt 1880
11
Nathaniel James Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.2]
b. 31 May 1877 d. 20 Apr 1962
Ethel Vernon Beard
b. 25 Sep 1879 d. 19 Jan 1934
12
Ethel Goodwin Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.2.1]
[
=>
]
11
Lelia Cary Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.3]
11
Louise Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.4]
11
IV Isaac Otey Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.5]
11
Braxton Lee Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.6]
11
Jeter Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.7]
11
William Beckwith Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.8]
12
Jr. William Beckwith Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.8.1]
[
=>
]
11
Robert Cleveland Perkins
[1.1.4.7.1.1.1.4.1.1.9]
8
William Jordan Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5]
b. 23 Sep 1806 d. 24 Feb 1890
Sarah Elizabeth Herring
b. 1804 d. 1885
9
Sarah Judson Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.1]
b. 20 Sep 1847 d. 30 Jun 1890
John Hillery Morris
b. 9 Sep 1840 d. 25 Jan 1922
10
Alvin Ruffin Morris
[1.1.4.7.1.1.1.5.1.1]
b. 22 Aug 1876 d. 9 Oct 1967
Mertie Brent Gillespie
11
Alberta Morris
[1.1.4.7.1.1.1.5.1.1.1]
Raymond R. Quesenberry
b. 15 Jul 1911
12
Betty Jo Quesenberry
[1.1.4.7.1.1.1.5.1.1.1.1]
+
Theodore Currin
9
Alberta Jordan Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.2]
b. 15 Aug 1832 d. 6 Jun 1868
Walter Samuel Johnson
b. Abt 1812
10
Johnson
[1.1.4.7.1.1.1.5.2.1]
b. Yes, date unknown
9
Luther Rice Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.3]
b. 8 Nov 1834 d. 7 Sep 1885
Malvina Virginia Bowles
b. Abt 1839
10
Beckwith Benjamin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.3.1]
b. Yes, date unknown
9
Nancy B. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.4]
b. 15 Jul 1837 d. 14 Jun 1914
+
John Daniel Winn
9
Tucker W. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5]
b. 13 Feb 1840 d. 11 Nov 1921
Sarah F. Stines
b. 1842
10
William B. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5.1]
b. 1868
10
Rosa B. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5.2]
b. 1870
10
Alfred Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5.3]
b. 1871
10
Georgie T. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.5.4]
b. 1878
9
Fleming H. Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.6]
b. 1850 d. 27 Jun 1865
9
Mariah Agnes Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.7]
b. 10 Aug 1853 d. 24 Nov 1930
+
John Saunders
9
Hattie Evilene Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.8]
b. 26 May 1856 d. 19 May 1927
+
George Clements
b. 30 Jun 1855 d. 8 Oct 1936
9
George Anderson Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.9]
b. 20 Aug 1842 d. 20 Jan 1890
Mary M. Johns
b. Abt 1856
10
Magnus Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.9.1]
b. Between 15 Jun 1879 and 15 Jun 1880
10
Bernie Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.9.2]
b. Abt 1873
9
Thomas Gilman Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.10]
b. 19 Apr 1845 d. 27 Jan 1926
+
Mollie B Payne
b. Abt 1878
Eliza M Payne
b. Mar 1846 d. Abt 1905
10
Nannie Beckwith Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.10.1]
b. 26 Oct 1870 d. 24 Jun 1957
10
Oteria Virginia Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.10.2]
b. 14 Aug 1868 d. 10 Feb 1952
10
Oliver V Payne
[1.1.4.7.1.1.1.5.10.3]
b. Abt 1868
8
Mary Brockenbrough Payne
[1.1.4.7.1.1.1.6]
b. 15 Jul 1809 d. 3 Sep 1883
George Loving Seay
b. 15 Jul 1809 d. 3 Sep 1883
9
Norella Burton Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.1]
b. 19 Jan 1837 d. 2 Apr 1882
Benjamin Anderson SOWELL
b. 29 Feb 1832 d. 13 Jul 1912
10
Mary Paulina SOWELL
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1]
b. 12 Aug 1869 d. 25 Mar 1952
Russell Winston JENNINGS
b. 22 Feb 1870 d. 9 May 1941
11
Norella Burton JENNINGS
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1.1]
James Newton WOOD
b. Abt 1892 d. 19 Dec 1930
12
Mary Norella WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1.1.1]
12
WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1.1.2]
12
James WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.6.1.1.1.3]
9
Joseph Morton Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.2]
9
Robert Hasley Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3]
Lucy Oliver Cleveland
10
Chester Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.1]
10
Randolf Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.2]
10
Welford Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.3]
+
Clair Soule
10
Lorena Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.4]
10
Norella Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.5]
10
Sally Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.3.6]
9
Mary B. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.4]
9
Emily Judson Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.5]
9
Georgie A. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.6]
9
Judith Elizabeth Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.7]
9
Phillip G. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.8]
9
Sidney Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.9]
9
Richard B. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.10]
9
George P. Seay
[1.1.4.7.1.1.1.6.11]
8
Susan Mims Payne
[1.1.4.7.1.1.1.7]
b. 3 Feb 1812 d. 1886
Jeremiah Cleveland
b. 1786 d. Apr 1866
9
Mary Susan Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.1]
b. 23 Jan 1843 d. 22 Jul 1920
Williams Pitt JENNINGS
b. 2 Nov 1835 d. 27 Jul 1928
10
Russell Winston JENNINGS
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1]
b. 22 Feb 1870 d. 9 May 1941
Mary Paulina SOWELL
b. 12 Aug 1869 d. 25 Mar 1952
11
Norella Burton JENNINGS
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1.1]
James Newton WOOD
b. Abt 1892 d. 19 Dec 1930
12
Mary Norella WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1.1.1]
12
WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1.1.2]
12
James WOOD
[1.1.4.7.1.1.1.7.1.1.1.3]
9
John Poindexter Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.2]
b. 20 Aug 1846 d. 30 Jun 1924
9
James Fleming Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.3]
b. 1850 d. 7 Oct 1865
9
Judith Payne Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.4]
b. Mar 1854 d. 29 Sep 1923
9
George Beckwith Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.5]
b. 26 Jan 1842 d. 16 Feb 1932
9
Virginia Morton Cleveland
[1.1.4.7.1.1.1.7.6]
b. Sep 1845 d. 1916
8
Fleming S Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8]
b. 5 Aug 1799 d. 13 Jan 1857
Isabella Winn
b. 1805 d. 15 Jul 1882
9
James Franklin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1]
b. Nov 1837 d. Dec 1904
Angelina Ontario Keoka Chiles
b. 29 Apr 1849 d. 13 Mar 1933
10
Alice Clark Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1]
b. 20 Feb 1872 d. 20 Dec 1963
John E. Talley
b. 1876
11
Louise P Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.1]
b. Abt 1904
+
Smith
11
Maude A Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.2]
b. Abt 1909
11
Erma Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.3]
b. Abt 1911
+
Lacy Morris
11
Alice Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.4]
b. Abt 1902
+
Harold King
11
Cecil V Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.5]
+
Leo Isbell
11
Frank W Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.6]
b. Abt 1906
Betty
12
Marian Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.6.1]
12
Betsy Talley
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.1.6.2]
10
Georgia Magnolia Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.2]
b. 30 Mar 1869 d. 2 Dec 1935
+
Harry Masoncupp
10
Walter Daniel Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3]
b. 10 May 1875 d. 22 Jul 1970
Flora Lee Martin
11
Carroll Thomas Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.1]
Frances Tomlin
12
Jr. Carroll Thomas Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.1.1]
[
=>
]
12
Michael Scott Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.1.2]
11
Virginia Cameron Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.2]
John Marshall Ballard
12
David Lee Ballard
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.2.1]
[
=>
]
11
Elizabeth Rebecca Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.3]
Samuel Goodson
12
Sharon Goodson
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.3.1]
[
=>
]
+
Emerson Lewis
11
Wilbur Martin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.4]
b. 1912 d. 29 Feb 1932
11
Robert Lee Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.5]
b. 23 Sep 1914 d. 6 Mar 1932
11
Stuart Daniel Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.6]
+
Audrey Macirdo
+
Edna Luckard
11
James Franklin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7]
Elizabeth Rush
12
Dale Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.1]
12
Shawna Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.2]
12
Dawn Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.3]
12
Gwendolyn Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.4]
12
Jr. James Franklin Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.3.7.5]
+
Linda
10
Laura Belle Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4]
b. 19 Aug 1877 d. 1946
William G. Hughes
b. 1866
11
Mattie Payne Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.1]
+
Jr. Louis Saksen
b. 1866
11
Doris E. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.2]
+
Earl Carsell
11
Aubrey Scott Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.3]
11
Roy Linwood Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.4]
11
Charlie F. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.5]
11
William E. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.6]
11
James D. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.7]
11
Alfred G. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.8]
11
Jessie B. Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.9]
11
Ruth Hughes
[1.1.4.7.1.1.1.8.1.4.10]
+
William Marion
9
Richard Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.2]
b. Abt 1825 d. Between 1881 and 1900
9
Judith B Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.3]
b. Abt 1829
9
Eliza M Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.4]
b. Mar 1846 d. Abt 1905
Thomas Gilman Payne
b. 19 Apr 1845 d. 27 Jan 1926
10
Nannie Beckwith Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.4.1]
b. 26 Oct 1870 d. 24 Jun 1957
10
Oteria Virginia Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.4.2]
b. 14 Aug 1868 d. 10 Feb 1952
10
Oliver V Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.4.3]
b. Abt 1868
9
Flavius Josephus Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.5]
b. 7 Jul 1833 d. 20 Jan 1919
9
Barrett G Payne
[1.1.4.7.1.1.1.8.6]
b. 22 Mar 1827 d. 30 Apr 1904
8
Margaret Sydenham Payne
[1.1.4.7.1.1.1.9]
b. 23 Feb 1804 d. 19 May 1890