News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
William Branch
Abt 1531 - 1601 (70 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
William Branch
[1]
b. Abt 1531 d. Feb 1600/01
Katherine Jennings
b. Between 1520 and 1546 d. 25 Aug 1597
2
Lionel Branch
[1.1]
b. 18 Aug 1566 d. 1605
Valentia Sparke
b. Abt 1576 d. 1604/1610
3
Christopher Branch
[1.1.1]
b. 2 Sep 1602 d. Aft 20 Jun 1678
Mary Addie
b. 1600 d. 1629
4
Jr. Christopher Branch
[1.1.1.1]
b. Abt 1627 d. Abt 1665
Sarah Almond
b. 1629
5
Mary Branch
[1.1.1.1.1]
b. 1660 d. 1697
Thomas Jefferson
b. Abt 1653 d. Bef 7 Dec 1697
6
Jr. Thomas Jefferson
[1.1.1.1.1.1]
b. 20 Nov 1679 d. 15 Feb 1730/31
+
Alice
b. Abt 1679 d. Bef 1723
Mary Field
b. 3 Feb 1679/80 d. 13 Aug 1715
7
Peter Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 29 Feb 1707/08 d. 17 Aug 1757
Jane Randolph
b. 5 Feb 1719/20 d. 31 Mar 1776
8
Martha Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 29 May 1746 d. 3 Sep 1811
Dabney Carr
b. 26 Oct 1743 d. 16 May 1773
9
Peter Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 2 Jan 1770 d. 1815
+
Elizabeth Overton Carr
b. 27 Apr 1773 d. 1837
Hester Stevenson
b. 1767 d. 1834
10
Jane Margaret Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 15 Mar 1809 d. 22 Jan 1903
Wilson Jefferson Cary
b. 1806 d. 1877
11
Sarah Nicholas Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1832
James Howard McHenry
12
Juliana H. McHenry
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
d. 1901
12
Wilson Cary McHenry
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
[
=>
]
12
John McHenry
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
[
=>
]
12
Ellen McHenry
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
[
=>
]
12
Sophia McHenry
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
[
=>
]
11
Virginia Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1833 d. Abt 1833
11
Wilson Miles Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. Abt 1830
11
John Brune Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1840 d. 1917
Frances Eugenia Daniel
12
Hetty Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
[
=>
]
10
Dabney S. Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1802 d. 1854
10
Ellen Boucher Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 1806 d. 1876
9
Lucy Maria Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 7 Mar 1768 d. 1803
Richard M. Terrell
b. 1765 d. 3 Oct 1802
10
Virginia Terrell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 1798 d. 1860
Francis Carr
b. 4 Feb 1784 d. Abt 1843
11
Peter Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
d. 1859
+
Lydia Laura Lewis
d. 1864
10
Ann Overton Terrell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 1797
10
Mary Jane Terrell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 1803 d. 1879
John Andrew Gardiner Davis
b. 1802 d. 1840
11
John Staige Davis
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 1824 d. 1885
+
Lucy Landon Blackford
Caroline Kean Hill
b. 1833 d. 1912
12
John Staige Davis
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1.1]
b. 24 Jun 1866 [
=>
]
10
Dabney Carr Terrell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 1801 d. 1827
10
Martha Jefferson Terrell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 17 Jul 1793
10
Lucy Terrell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 1795
9
Samuel Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 9 Oct 1771 d. 25 Jul 1855
Maria Dabney
b. Abt 1801
10
George Watson Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 1823
Pinnie Laws
11
Sally Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1]
Emma Gilmer Watts
11
William Watts Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2]
11
Betty Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.3]
+
Donald McDonald
10
Sally Watson Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 12 Sep 1826 d. 1850
Francis Edward Garland Carr
b. Abt 1825 d. 1893
11
George Watson Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. Abt 1845
10
Maria Jefferson Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 1826
10
Sarah Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 1828 d. 1848
10
Lawrence Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5]
Eleanor Barbara Carr
b. Abt 1779 d. 1815
10
James Lawrence Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 1811 d. 1875
10
Martha Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 1808 d. 1816
10
Dabney Overton Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 1806 d. 1841
10
John Addison Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9]
b. 1801 d. 1839
9
Mary Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 7 Mar 1768
Daniel Sladding
b. 1760/1765 d. 1800/1810
10
Arthur Slaton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 1797
9
Jr. Dabney Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 27 Apr 1773 d. 8 Jan 1837
Elizabeth Overton Carr
b. 27 Apr 1773 d. 1837
10
Nancy Addison Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. Abt 1812
10
Dabney Jefferson Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 1817 d. 1826
10
Nancy Addison Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.3]
b. Abt 1801
10
Jane Cary Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4]
b. 3 Dec 1807 d. 21 Jul 1859
Peyton Randolph Harrison
b. 19 Nov 1800 d. 10 Sep 1887
11
Virginia Randolph Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1]
b. 31 Mar 1834 d. 9 Aug 1895
William James Hoge
b. 14 Aug 1825 d. 5 Jul 1864
12
Payton Harrison Hoge
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1.1]
b. 6 Jan 1858 d. 12 Oct 1940 [
=>
]
12
Mary Swift Hoge
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1.2]
b. 15 Oct 1855 d. 20 Apr 1934 [
=>
]
12
Dabney Carr Hoge
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1.3]
b. 24 Feb 1860 d. 11 Aug 1861
12
William Hoge
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1.4]
b. 1 Mar 1864 d. 13 Aug 1868
11
Dabney Carr Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.2]
b. 12 Sep 1830 d. 16 Feb 1862
Sallie Pendleton Buchanan
b. 1835 d. 1916
12
Jane Carr Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.2.1]
b. 1856 d. 1864
12
Dabney Carr Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.2.2]
b. 15 Oct 1858 [
=>
]
12
Ann Spottiswoode Dandridge Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.2.3]
b. 1860 d. 1898
11
Peyton Randolph Harrison, Jr
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.3]
b. 17 Jun 1832 d. 21 Jul 1861
Sarah Forrest Hunter
b. 7 Jul 1833 d. 11 Jan 1926
12
Peyton Randolph Harrison, III
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.3.1]
b. 21 Jul 1859 d. 25 Aug 1941 [
=>
]
12
Jane Cary Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.3.2]
b. 1856 d. 1928
12
Edmund Pendleton Hunter Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.3.3]
b. 27 Dec 1857 d. 25 Aug 1941 [
=>
]
11
Mary Clifton Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.4]
b. 21 Apr 1839 d. 14 Mar 1862
11
Nancy Addison "Nannie" Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.5]
b. 8 Aug 1841 d. 23 Feb 1862
11
Henry Tucker Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.6]
b. 12 Jun 1844 d. 4 Mar 1914
11
Randolph Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.7]
b. 16 Jan 1829 d. 22 Sep 1863
11
William Wirt Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.8]
b. 16 Feb 1837 d. 19 Jan 1880
11
Elizabeth Carr Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.9]
b. 3 Mar 1826 d. 27 Apr 1847
11
Williana Irving Harrison
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.10]
b. 27 Feb 1847
9
Martha Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. Abt 1775
9
Jane Barbara Carr
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1766 d. 1840
Jr. Wilson Miles Cary
b. 1760 d. 1793
10
Wilson Jefferson Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 1784 d. 1823
Virginia Randolph
b. 30 Jan 1786 d. 2 May 1852
11
Archibald Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1]
b. 1815 d. 1854
Mominia Fairfax
b. 1820 d. 1875
12
Constance Fairfax Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.1]
b. 1843 d. 1920 [
=>
]
11
Martha Jefferson Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.2]
b. 1820 d. 1873
Jr. Gouverneur Morris
b. 9 Feb 1813 d. 20 Aug 1888
12
III Gouverneur Morris
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.2.1]
b. 27 Dec 1844 d. 16 Feb 1897 [
=>
]
11
Mary Randolph Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3]
b. 1811 d. 1887
Orlando Fairfax
b. 1806 d. 1882
12
Ethelbert Fairfax
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.1]
b. 1845 d. 1865
12
Monimia Fairfax
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.2]
b. 27 Dec 1837
12
Randolph Fairfax
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.3]
b. 1842 d. 1862
12
Mary Edith Fairfax
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.4]
12
Virginia Fairfax
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.5]
d. 1832
12
Edith Fairfax
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.6]
d. 1839
12
Orlando Cary Fairfax
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.7]
d. 1836
12
Jane Cary Fairfax
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.8]
11
Anne Mantia Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.4]
b. 1813 d. 1822
11
Ellen Randolph Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.5]
b. 1817 d. 1901
11
Sally Newsum Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.6]
b. 1822 d. Abt 1823
11
Louisa Hartwell Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.7]
b. 1823 d. Abt 1823
11
Wilson Jefferson Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.8]
b. 1806 d. 1877
Jane Margaret Carr
b. 15 Mar 1809 d. 22 Jan 1903
12
Sarah Nicholas Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.8.1]
b. 1832 [
=>
]
12
Virginia Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.8.2]
b. 1833 d. Abt 1833
12
Wilson Miles Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.8.3]
b. Abt 1830
12
John Brune Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.8.4]
b. 1840 d. 1917 [
=>
]
11
Jane Blair Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.9]
b. 1808 d. 1888
Edward Dunlap Smith
12
Archibald Cary Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.9.1]
b. 1853 d. 1911
10
Sarah Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 1788
10
Miles Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1789 d. 1827
Elizabeth Scarsbrooke Wilson Curle
11
Lucius Falkland Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.1]
b. 1815 d. 1845
Lucy Anne Henley
12
Wilson Miles Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.1]
b. 1843 d. 1919 [
=>
]
12
Harriette Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.2]
b. 22 Mar 1838
11
Henry Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.2]
12
Jr. Henry Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.2.1]
10
Martha Carr Cary
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.4]
b. Abt 1791
8
President Thomas Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 2 Apr 1743 d. 4 Jul 1826
Martha Wayles
b. 30 Oct 1748 d. 6 Sep 1782
9
Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 28 May 1777
9
Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 3 Nov 1780
9
Mary Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 1 Aug 1778
9
Lucy Elizabeth Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 8 May 1782
9
Martha Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 27 Sep 1772 d. 10 Oct 1836
Jr. Thomas Mann Randolph
b. 17 May 1768 d. 20 Jun 1828
10
Anne Cary Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.1]
b. 23 Jan 1791 d. 11 Feb 1826
+
Charles Lewis Bankhead
b. 1788 d. 1835
10
Thomas Jefferson Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2]
b. 12 Sep 1792 d. 8 Oct 1875
Jane Hollins Nicholas
b. 1798 d. 1871
11
Margaret Smith Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.1]
b. 7 Mar 1816 d. 20 Dec 1842
William Mann Randolph
d. 1850
12
Jane Margaret Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.1.1]
b. 7 May 1840
12
William Lewis Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.1.2]
11
Mary Buchanan Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.2]
b. 17 Dec 1821 d. 23 Jun 1884
11
Eleonora Wayles Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.3]
b. 1 Dec 1823 d. 15 Aug 1896
+
William Byrd Harrison
b. 1800 d. 1870
11
Maria Jefferson Carr Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4]
b. 20 Jul 1817 d. 16 Jul 1857
John Charles Randolph Taylor
b. 30 May 1812 d. 6 Jan 1875
12
Bennett Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.1]
b. 15 Aug 1836 d. 9 Apr 1898
12
Susan Beverley Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.2]
b. 8 Feb 1840 d. 22 Sep 1890
12
Jefferson Randolph Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.3]
b. 27 Dec 1842 d. 15 Apr 1919
12
Margaret Randolph Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.4]
b. 14 Nov 1843 d. 12 Feb 1898
12
Charlotte Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.5]
b. 17 Dec 1845 d. 17 May 1846
12
Stevens Mason Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.6]
b. 16 Jul 1847 d. 10 Jan 1917
12
Cornelia Jefferson Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.7]
b. 29 Mar 1849 d. 3 Mar 1937
12
Moncure Robinson Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.8]
b. 23 Feb 1851 d. 7 Dec 1915
12
Edmund Randolph Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.4.9]
b. 12 Jul 1853 d. 16 Jun 1919
11
Mary Buchanan Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.5]
b. 23 Nov 1818 d. 24 Oct 1821
11
Caryanne Nicholas Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.6]
b. 22 Apr 1820 d. 24 Jul 1857
+
Francis Gildart Ruffin
b. 1816 d. 1892
11
Wilson Cary Nicholas Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.7]
b. 26 Oct 1834 d. 26 Apr 1907
+
Mary Holliday
11
Jane Nicholas Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.8]
b. 10 Dec 1831 d. 26 Aug 1868
+
Robert Garlick Hill Kean
b. 7 Oct 1828 d. 1898
11
Meriwether Lewis Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.9]
b. 17 Jul 1837 d. 1 Feb 1871
+
Anna T. Daniel
11
Sarah Nicholas Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.10]
b. 10 Oct 1839 d. 25 Apr 1892
+
Noah H. Haggard
11
Thomas Jefferson Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.11]
b. 29 Aug 1829 d. 8 Aug 1872
Mary Walker Meriwether
b. 29 Apr 1833 d. 4 Oct 1863
12
Francis Merriwether Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.11.1]
b. 22 Oct 1854 d. 8 Sep 1922 [
=>
]
12
George Geiger Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.11.2]
12
III Thomas Jefferson Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.11.3]
+
Charlotte N. Meriwether
d. 1876
11
Caroline Ramsay Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.12]
b. 15 Jan 1828 d. 28 Jun 1902
10
Ellen Wayles Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.3]
b. 30 Aug 1794 d. 26 Jul 1795
10
Ellen Wayles Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.4]
b. 13 Oct 1796 d. 21 Apr 1876
+
Joseph Coolidge
b. 1798 d. 1879
10
Cornelia Jefferson Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.5]
b. 26 Jul 1799 d. 24 Feb 1871
10
George Wythe Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.6]
b. 10 Mar 1818 d. 3 Apr 1867
+
Mary Elizabeth Adams
10
Virginia Jefferson Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.7]
b. 22 Aug 1801 d. 26 Apr 1882
+
Nicholas Philip Trist
b. 1800 d. 1874
10
Mary Jefferson Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.8]
b. 2 Nov 1803 d. 29 Mar 1876
10
James Madison Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.9]
b. 17 Jan 1806 d. 23 Jan 1834
10
Benjamin Franklin Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.10]
b. 14 Jul 1808 d. 18 Feb 1871
+
Sarah Champe Carter
b. 1810 d. 1896
10
Meriwether Lewis Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.11]
b. 31 Jan 1810 d. 24 Sep 1837
Elizabeth A. Martin
11
Lewis Jackson Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.11.1]
b. Mar 1836 d. 1840
10
Septimia Anne Randolph
[1.1.1.1.1.1.1.2.5.12]
b. 3 Jan 1814 d. 14 Sep 1887
+
David Scott Meikleham
b. 1804 d. 20 Nov 1849
9
Jane Randolph Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 3 Apr 1774
+
Sally Hemings
b. Abt 1769
8
Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 9 Mar 1749/50 d. 9 Mar 1749/50
8
Peter Field Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 16 Oct 1748 d. 29 Nov 1748
8
Randolph Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 1 Oct 1755 d. 15 Aug 1815
Anna Jefferson Lewis
b. Abt 1754 d. May 1808
9
James Lilburne Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 1784 d. 1874
+
Mitchie Pryor
d. Aft 1814
8
Elizabeth Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 4 Nov 1744 d. 24 Feb 1774
8
Anna Scott Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1 Oct 1755 d. 1805
+
Hastings Marks
d. Aft 1788
8
Jane Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 27 Jun 1740 d. 1 Oct 1765
8
Mary Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 1 Oct 1741 d. 1817
John William Bolling
b. 24 Jun 1737 d. 1797
9
Edward Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.1]
b. 17 Sep 1772 d. 1835
Dorothea Dandridge Payne
b. 10 Jul 1777 d. 1800/1871
10
Powhatan Polling Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.1.1]
b. Abt 1800 d. Aft 1840
Arminda R. Payne
b. 1790/1816 d. 1840/1904
11
Pocahontas J. Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.1.1.1]
b. 1830 d. 1831/1924
11
Elvira G. Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.1.1.2]
b. 1837 d. 1838/1931
9
Robert Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.2]
b. Abt 1771
+
Jane Spotswood Payne
b. 20 Oct 1780 d. 27 Feb 1807
9
Archibald Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3]
b. Abt 1770 d. 1829
Catherine Payne
b. Abt 1780
10
Edward Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.1]
b. Abt 1793 d. 1855
+
Anne Cralle
b. 1786/1829 d. 1807/1909
10
Alexander Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.2]
b. 1785/1824 d. 1878
+
Susan Gray
b. 1786/1830 d. 1807/1909
10
Jefferson Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.3]
b. 1785/1824 d. 1797/1902
10
Catherine Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.4]
b. 1785/1824 d. 1796/1905
10
Pocahontas R. Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.5]
b. Abt 1810
+
William G. White
b. Est 1778/1822 d. Est 1803/1900
+
Peter J. Hill
b. 1815/1847 d. 1872/1934
10
Jr. Archibald Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6]
b. 1806 d. 1860
Anne E. Wiggington
b. 1795/1818 d. 1840/1906
11
William Holcombe Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1]
b. 29 May 1837 d. 6 Jul 1899
Sallie Spiers White
b. 5 Jan 1843 d. 21 Nov 1925
12
Rolfe Emerson Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.1]
b. 22 Aug 1861 d. 3 Feb 1936 [
=>
]
12
William Archibald Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.2]
b. 11 Oct 1867 d. 1899/1958 [
=>
]
12
Bertha Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.3]
b. 11 Oct 1869 d. 1870/1963
12
Charles Rodefer Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.4]
b. 11 Jun 1871 d. 11 Jun 1871
12
Edith Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.5]
b. 15 Oct 1872 d. 28 Dec 1961
12
John Randolph Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.6]
b. 11 Apr 1876 d. 1877/1966
12
Richard Wilmer Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.7]
b. 6 Oct 1879 d. 1913/1970 [
=>
]
12
Julian Brandon Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.8]
b. 7 May 1882 d. 1912/1973
12
Geraldine Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.9]
b. 12 Aug 1885 d. 6 Jul 1887
12
Gertrude Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.10]
b. 16 May 1863 d. 1893/1957 [
=>
]
12
Anne Lee Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.1.11]
b. 15 Jun 1865 d. 26 Feb 1917 [
=>
]
11
Harriet W. Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.2]
+
Robert H. Waddell
11
Mary Jefferson Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.3]
+
Rudolph Tuesler
11
John Blair Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.3.6.4]
d. INFANT
9
Jane Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.4]
b. 17 Sep 1765
9
Ann Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.5]
b. 18 Jul 1767
9
Martha Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.6]
b. 1769
9
Thomas Bolling
[1.1.1.1.1.1.1.9.7]
b. 11 Feb 1764
8
Lucy Jefferson
[1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 10 Oct 1752 d. 1784
+
Charles Lilburn Lewis
b. Abt 1752 d. 1853
7
Thomas Jefferson
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 24 Sep 1700 d. 14 Feb 1722/23
7
Field Jefferson
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 6 Mar 1701/02 d. 16 Feb 1765
+
Mary Frances Robertson
b. Aft 1700 d. Bef 29 May 1762
+
Mary Hunt
d. Aft 1765
7
Mary Jefferson
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 1709 d. 13 Apr 1755
Jr. Thomas Turpin
b. 9 May 1708 d. 20 Jun 1790
8
Anne Obedience Turpin
[1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 17 Sep 1734 d. 8 Aug 1800
John Jordan Harris
b. 1732 d. Bef 19 Nov 1800
9
Mary Elizabeth Josepha Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 1767
9
Lucy Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 1756 d. 1832
Obadiah Smith
b. Abt 1756
10
Mary Burke Smith
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.1]
b. 9 Jun 1781
9
Judith Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 1760
+
John Crittenden
b. Abt 1759
9
Jordan Turpin Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.4]
b. 20 May 1763 d. 1826
Elizabeth Mosby Cannon
b. Abt 1763
10
James Madison Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.4.1]
b. 1776
Caroline John
b. Abt 1776
11
Md William Jordan Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.4.1.1]
b. Abt 1800
+
Mary Helen Epes
b. Abt 1800
10
Horatio Turpin Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.4.2]
b. 1799 d. 1855
+
Keturah
b. Abt 1799
10
John Francis Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.4.3]
b. 1808 d. 1880
+
Mary Duke Patten
b. Abt 1808
+
Ann Price
b. Abt 1763
9
John Turpin Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5]
b. 12 Oct 1758 d. 1815
Rebecca Britton
b. Abt 1770
10
Hiram Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1]
b. 15 Sep 1796 d. 3 Jun 1867
Margaret Christian Harris
b. Abt 1796 d. Mar 1825
11
Henry Benskin Christian Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1]
b. 3 Feb 1825
Elizabeth Ann Daniels
b. 17 Oct 1842
12
Pauline B. Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.1]
12
Robert D. Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.2]
b. 31 Mar 1875 d. 8 Oct 1875
12
Sallie Tilden Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.3]
b. 9 Sep 1877 d. 1952
12
Mary Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.4]
b. 15 Jun 1880 [
=>
]
12
Margaret Christian Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.5]
b. 10 Jan 1871
12
William Henry "Hiram" Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.6]
b. 7 May 1879 d. 1944 [
=>
]
12
Jesse B. Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.7]
b. Mar 1882
Sarah C. Calvert
b. 9 Mar 1834/1835 d. 18 Mar 1865
12
Hiram Henry Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.8]
b. 31 Jul 1855
12
Martha W. Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.9]
b. 7 Aug 1859
12
James Clay Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.10]
b. 16 Oct 1868
12
Catherine B. Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.11]
b. Aug 1861
12
Rebecca D Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.1.12]
b. 20 May 1852
11
Rebecca Ann Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.2]
b. 3 Mar 1823
+
John Wilson
b. Abt 1823
+
Alfred Douglas
b. Abt 1823
Margaret Wilson
b. Abt 1796 d. Abt 1827
11
Mary Eleanor Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.3]
b. 28 Sep 1827
Elizabeth George
b. Abt 1796
11
Jr. Hiram Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.4]
b. 1840
+
Frances Gordon
b. Abt 1840
11
Mary Eleanor Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.5]
b. Abt 1845
+
McRae
b. Abt 1845
11
Margaret Elizabeth Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.6]
b. 1847
John E. Benson
b. Abt 1847
12
Eleanor Harris Benson
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.6.1]
b. Abt 1870
11
John Wilson Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.5.1.7]
b. 1837 d. Aft 1867
+
Frances Gordon
b. Abt 1825
9
Polly Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.6]
b. 1774
9
Francis Turpin Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.7]
b. 7 May 1768 d. 5 Dec 1836
+
Sally Gaines
b. Abt 1768
9
Carolina Matilda Harris
[1.1.1.1.1.1.4.1.8]
b. 1 Dec 1756 d. 1815
+
Thomas Harris
b. Abt 1756
7
Martha Jefferson
[1.1.1.1.1.1.5]
b. Abt 1712 d. 20 Oct 1796
Bennett Goode
b. Abt 1710 d. 1771
8
Martha Goode
[1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 1760 d. 1810
Charles Povall
b. 1763 d. 1803
9
Martha Povall
[1.1.1.1.1.1.5.1.1]
b. 1 Nov 1784
William Carrington
b. 20 Aug 1774 d. 21 May 1825
10
Ellen Theodosia Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.1]
b. 1813 d. 1896
William Royal Bradley
b. 1804 d. 1889
11
Martha Carrington Bradley
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.1.1]
b. 1826/1847 d. 1862/1933
Thomas Pride Shields
b. 1808/1837 d. 1862/1922
12
Martha Tomasia Shields
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.1.1.1]
b. 21 Aug 1859 d. 15 Aug 1944 [
=>
]
10
Martha Ann Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2]
b. 26 Feb 1806 d. 29 Apr 1865
Codrington Carrington
b. 23 Oct 1801 d. 10 Sep 1859
11
Willie Ann Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.1]
b. 13 Jun 1833
11
Robert Codrington Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.2]
b. 6 Sep 1842
Hellen C. Walton
b. Cal 1846
12
Nathaniel W. Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.2.1]
b. Jul 1868 [
=>
]
12
Bernard Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.2.2]
b. Feb 1879
12
Rose Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.2.3]
b. Abt 1880
12
Collin Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.2.4]
b. Cal 1870
12
Lillian Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.2.5]
b. Cal 1874
12
Minnie M. Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.2.6]
b. Cal 1872
12
Martha Elvira Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.2.7]
b. 10 Sep 1867
11
Ellen Maria Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.3]
b. 22 Mar 1836 d. 14 Jul 1873
+
Fox
11
Cornelia Booker Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.4]
b. 1 Feb 1845
+
T. B. S. Walton
11
Martha Virginia Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.5]
b. 2 Apr 1839
+
E. C. Mayo
11
William A. Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1.2.6]
b. 22 Sep 1843 d. 25 Sep 1843
7
Alice Jefferson
[1.1.1.1.1.1.6]
b. 1704/1706
7
Judith Jefferson
[1.1.1.1.1.1.7]
b. 30 Aug 1698 d. 14 Feb 1723
+
George Farrar
b. 30 Aug 1698 d. 1772
6
Mary Jefferson
[1.1.1.1.1.2]
b. 1679 d. 1 Sep 1745
Thomas Harris
b. 1669 d. Bef 6 Jul 1730
7
John Harris
[1.1.1.1.1.2.1]
b. 28 Mar 1703 d. Aft 28 Mar 1749
Ursula Goode
b. 1707 d. Abt 1734
8
Elizabeth Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 31 Dec 1729 d. 19 May 1791
Samuel Flournoy
b. 4 Oct 1724 d. 12 Dec 1780
9
Silas F. Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
Martha Cannon
b. 1775 d. Oct 1817
10
Alfred Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
11
William Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
12
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1847
12
William Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2]
b. 12 May 1853
12
Alfred Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3]
b. 28 Aug 1854
12
Lucien Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4]
b. 22 Feb 1861
11
Alonzo Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
12
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1]
b. 11 Oct 1851 [
=>
]
12
James Patteson Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.2]
b. 25 Aug 1853
12
Belle Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.3]
12
Theodosia Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.4]
11
James Silas Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
11
Eliza Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4]
b. 29 May 1829 d. INFANT
11
Alfred F. Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.5]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
12
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.5.1]
b. 9 Mar 1868
12
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.5.2]
b. 21 Feb 1875
12
Mary Patteson Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.5.3]
b. 24 Apr 1866
12
Spencer Alston Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.5.4]
b. Aug 1879
11
Martha Moore Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.6]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
11
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
12
Alfred F. Wilson
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7.1]
b. 1847
12
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7.2]
12
Alice Wilson
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7.3]
12
Ruth Wilson
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7.4]
12
Pattie Wilson
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7.5]
[
=>
]
12
Laura Wilson
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7.6]
[
=>
]
12
Mary Wilson
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7.7]
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
11
Charles Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.8]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
11
David Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.9]
b. 1842 d. 1856
11
Maria Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.10]
b. 1837 d. 1841
11
Mary Camp Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
11
Martha Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.12]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
11
Indiana Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.13]
b. 1847
10
Eliza Susan Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
11
Alfred H. Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
11
Eliza Susan Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.2]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
11
Martha Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.3]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
10
William Cannon Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
11
Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.1]
b. 1833 d. 1833
11
Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.2]
b. 1829 d. 1829
11
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.3]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
12
Myra Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.3.1]
b. 19 Jun 1871
12
Julian Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.3.2]
b. 23 Dec 1868
12
William Cannon Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.3.3]
b. 11 Jan 1866
12
Tyree Rodes Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.3.4]
b. 10 May 1862
12
John Harper Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.3.5]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
12
Flournoy Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.3.6]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908 [
=>
]
11
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.4]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
12
Ezell Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.4.1]
b. 9 Dec 1878
12
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.4.2]
b. 13 Sep 1875
12
John Walker Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.4.3]
b. 24 Jan 1874
12
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.4.4]
b. 22 Oct 1870
12
III William Cannon Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.4.5]
b. 8 Apr 1872
11
John J. Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.5]
b. 1838
10
Mary Amanda Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
11
Mary Eliza Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.1]
b. 1 Jul 1825
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
12
Myra Flournoy Knapp
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.1.1]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
12
Maud Officer
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.1.2]
b. 9 May 1847
12
Eustis Field Officer
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.1.3]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
12
William P. Officer
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.1.4]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
11
James Alexander Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.2]
b. 30 May 1823
11
Jr. William Hume Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
11
Julian Clarence Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.4]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
11
Silas Flournoy Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
11
Margaret Julia Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.6]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
11
Henrietta Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.7]
b. 1833 d. 1833
11
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.8]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
11
Florence Huntley Field
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
10
Julia Ann Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.5]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
11
Hume Rigg Feild
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.5.1]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
11
Eliza Mildred Feild
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.5.2]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
12
Julia Batte
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.5.2.1]
12
Mildred Batte
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.5.2.2]
12
E. F. Batte
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.5.2.3]
10
Madison Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.6]
b. 1807
10
Martha C. Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.7]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
11
Silas Flournoy Trotter
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.7.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
10
Silas Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
11
Mary Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.1]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
12
Elizabeth Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.1.1]
b. Bef 1865
12
James P. Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.1.2]
b. Bef 1863
12
Mary Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.1.3]
b. Bef 1867
12
Silas Flournoy Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.1.4]
b. Bef 1871
12
William W. Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.1.5]
b. Bef 1869
12
Martha Rivers
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.1.6]
b. Bef 1873
11
Camp Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.2]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
12
Lucien Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.2.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918 [
=>
]
12
John Wise Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.2.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905 [
=>
]
12
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.2.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950 [
=>
]
12
Augusta Mary Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.2.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934 [
=>
]
12
Julia Rivers Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.2.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969 [
=>
]
12
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.2.6]
b. 23 Jan 1887 [
=>
]
11
Lucien Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.3]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
12
Caroline Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.3.1]
b. Bef 1863
11
Elizabeth Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.4]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
12
Duncan
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.4.1]
b. Bef 1870 d. 1876
12
Maude Eustace Duncan
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.4.2]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
11
III Silas Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.5]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
12
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.5.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
12
Silas Camp Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.8.5.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
10
Sarah Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.9]
b. 1816
10
Louisa Ann Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
11
Laura Ann Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.1]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
12
Leroy M. Black
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.1.1]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
12
Louisa Catherine Black
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.1.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895 [
=>
]
12
Laura Ann Black
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.1.3]
11
Flournoy Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.2]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
12
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.2.1]
b. Sep 1872 d. Dec 1942 [
=>
]
12
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.2.2]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905 [
=>
]
12
Cora Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.2.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
12
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.2.4]
b. Jul 1882
11
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.3]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
12
Lucy M. Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.3.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941 [
=>
]
12
Webber Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.3.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
12
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.3.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
11
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
12
Adella Frances Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4.1]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957 [
=>
]
12
Mamie J. Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4.2]
b. 8 Dec 1875 d. 18 Sep 1968 [
=>
]
12
Robert Lee Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4.3]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
12
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4.4]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
12
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4.5]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
12
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4.6]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970 [
=>
]
12
Edna Emma Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958 [
=>
]
12
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.4.8]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966 [
=>
]
11
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.5]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
11
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.6]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
12
Louisa Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.6.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942 [
=>
]
12
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.6.2]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
12
Nellie M Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.6.3]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
12
Edna L. Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.6.4]
b. Jan 1868 d. 1918
12
William P. Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.6.5]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
12
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.6.6]
b. 1867
11
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.7]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
11
Mary Julia Yancey
[1.1.1.1.1.2.1.1.1.10.8]
b. 1834
+
William D. Roberts
9
David Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 14 Apr 1761 d. 30 Jun 1831
+
Elizabeth Mills Britton
b. 17 Oct 1760 d. 30 Jun 1830
9
Gideon Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 20 Feb 1751 d. 15 Feb 1821
+
Jane F DeLisle
Grace B. Tarry
b. 1755 d. 20 Dec 1819
10
"Mattie" Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1]
b. 1795 d. 10 Oct 1855
Arthur Woodfin
b. 1790 d. 9 Oct 1855
11
William G. Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1]
b. 1817
11
Richard M. Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.2]
b. 1817
11
Thomas E Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.3]
b. 1818
11
John James Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.4]
b. 19 Mar 1820 d. 23 Sep 1860
11
Charles Newton Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.5]
b. 31 Jul 1824 d. 2 Jul 1912
11
Mary Elizabeth Susan Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.6]
b. 12 Jun 1829 d. 23 Nov 1890
11
Arthur Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.7]
b. 1832
11
Harriet Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.8]
b. 1836
11
Martha Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.9]
b. 1838
10
Martha Ann Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2]
b. Abt 1798 d. 1847
Thomas Woodfin
b. 1795 d. 1853
11
William Thomas Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1]
b. 16 Sep 1822 d. 3 Aug 1894
11
Samuel Flournoy Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2.2]
b. 4 Aug 1824 d. 14 Feb 1866
11
James Edward Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2.3]
b. 1826 d. 1889
11
Jane Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2.4]
b. 1828 d. 1892
11
Frances Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2.5]
b. 1830
11
George Washington Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2.6]
b. 15 Mar 1832 d. 3 Aug 1895
11
Martha Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2.7]
b. 1834
11
Rebecca Woodfin
[1.1.1.1.1.2.1.1.3.2.8]
b. 18 Dec 1836 d. 16 Aug 1860
9
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.4]
b. 25 Nov 1765
+
Isham Britton
b. Bef 1761
9
Julia Briton Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.5]
b. Abt 1770
9
John Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.6]
b. 29 Apr 1754
9
Thomas Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.7]
b. Bef 1767
9
Ursula Harris Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.8]
b. 15 May 1749
James Bailey Harris
b. 1749
10
III James Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.8.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
11
Alfred Turpin Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.8.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
12
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.8.1.1.1]
b. Abt 1820
10
Samuel Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.8.2]
b. Abt 1774
10
Elizabeth Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.8.3]
b. Abt 1776
10
Mary Harris
[1.1.1.1.1.2.1.1.8.4]
b. Abt 1778
9
Hannah Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.9]
b. Abt 1762
9
Jordan Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.10]
b. 20 Sep 1763 d. 21 Jun 1833
+
Judith Farrar
b. 21 Apr 1756 d. 1828
9
Samuel Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11]
b. 9 Dec 1758 d. 19 Aug 1818
Nancy Ann Martin
b. 1765
10
Samuel Martin Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.1]
b. 1799 d. 1878
+
Minerva Ann Wadlington
b. 1814 d. 1858
+
Harriett Elvira Fenley
b. 24 Jan 1820
10
Agnes Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.2]
b. 1799
10
Martha Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3]
b. 15 Aug 1813 d. 1891
Randolph Allen Hankla
b. 1 Feb 1803
11
Minerva Nancy Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.1]
b. 29 Mar 1837 d. 1 Apr 1898
11
Pendleton Flournoy Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.2]
b. 24 Mar 1831
11
James Marion F. Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.3]
b. 8 Feb 1833
11
John Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.4]
b. 21 Feb 1835
11
Mary Francis Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.5]
b. 29 Dec 1839
11
Martha Matilda Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.6]
b. 17 Jul 1844
11
Joseph Randolph Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.7]
b. 5 Nov 1847
11
William Harrison Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.8]
b. 17 Feb 1849
11
Ella Eugenia Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.9]
b. 24 Jul 1853
11
Eliza Hankla
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.3.10]
b. 2 Dec 1841 d. 7 Aug 1919
10
Matthews Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.4]
b. 1789 d. 1833
10
James Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.5]
b. 1 Jan 1791 d. 3 Mar 1855
+
Martha Halloway
b. 1790 d. 1871
10
Jack Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.6]
b. 1799 d. 1818
10
Nancy Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.7]
b. 1795
10
Rachel Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.8]
b. 1797
10
Amelia Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.9]
b. 1786
10
Emily Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.10]
b. 1801
10
Patsy Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.11]
b. 1793
10
Cassandra Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.11.12]
b. 1803
9
Martha Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.12]
b. Feb 1768
9
Mary Flournoy
[1.1.1.1.1.2.1.1.13]
b. Bef 1756
8
John Jordan Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 1732 d. Bef 19 Nov 1800
Anne Obedience Turpin
b. 17 Sep 1734 d. 8 Aug 1800
9
Mary Elizabeth Josepha Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 1767
9
Lucy Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.2]
b. 1756 d. 1832
Obadiah Smith
b. Abt 1756
10
Mary Burke Smith
[1.1.1.1.1.2.1.2.2.1]
b. 9 Jun 1781
9
Judith Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.3]
b. 1760
+
John Crittenden
b. Abt 1759
9
Jordan Turpin Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.4]
b. 20 May 1763 d. 1826
Elizabeth Mosby Cannon
b. Abt 1763
10
James Madison Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.4.1]
b. 1776
Caroline John
b. Abt 1776
11
Md William Jordan Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.4.1.1]
b. Abt 1800
+
Mary Helen Epes
b. Abt 1800
10
Horatio Turpin Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.4.2]
b. 1799 d. 1855
+
Keturah
b. Abt 1799
10
John Francis Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.4.3]
b. 1808 d. 1880
+
Mary Duke Patten
b. Abt 1808
+
Ann Price
b. Abt 1763
9
John Turpin Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5]
b. 12 Oct 1758 d. 1815
Rebecca Britton
b. Abt 1770
10
Hiram Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1]
b. 15 Sep 1796 d. 3 Jun 1867
Margaret Christian Harris
b. Abt 1796 d. Mar 1825
11
Henry Benskin Christian Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1]
b. 3 Feb 1825
Elizabeth Ann Daniels
b. 17 Oct 1842
12
Pauline B. Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.1]
12
Robert D. Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.2]
b. 31 Mar 1875 d. 8 Oct 1875
12
Sallie Tilden Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.3]
b. 9 Sep 1877 d. 1952
12
Mary Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.4]
b. 15 Jun 1880 [
=>
]
12
Margaret Christian Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.5]
b. 10 Jan 1871
12
William Henry "Hiram" Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.6]
b. 7 May 1879 d. 1944 [
=>
]
12
Jesse B. Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.7]
b. Mar 1882
Sarah C. Calvert
b. 9 Mar 1834/1835 d. 18 Mar 1865
12
Hiram Henry Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.8]
b. 31 Jul 1855
12
Martha W. Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.9]
b. 7 Aug 1859
12
James Clay Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.10]
b. 16 Oct 1868
12
Catherine B. Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.11]
b. Aug 1861
12
Rebecca D Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.1.12]
b. 20 May 1852
11
Rebecca Ann Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.2]
b. 3 Mar 1823
+
John Wilson
b. Abt 1823
+
Alfred Douglas
b. Abt 1823
Margaret Wilson
b. Abt 1796 d. Abt 1827
11
Mary Eleanor Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.3]
b. 28 Sep 1827
Elizabeth George
b. Abt 1796
11
Jr. Hiram Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.4]
b. 1840
+
Frances Gordon
b. Abt 1840
11
Mary Eleanor Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.5]
b. Abt 1845
+
McRae
b. Abt 1845
11
Margaret Elizabeth Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.6]
b. 1847
John E. Benson
b. Abt 1847
12
Eleanor Harris Benson
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.6.1]
b. Abt 1870
11
John Wilson Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.5.1.7]
b. 1837 d. Aft 1867
+
Frances Gordon
b. Abt 1825
9
Polly Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.6]
b. 1774
9
Francis Turpin Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.7]
b. 7 May 1768 d. 5 Dec 1836
+
Sally Gaines
b. Abt 1768
9
Carolina Matilda Harris
[1.1.1.1.1.2.1.2.8]
b. 1 Dec 1756 d. 1815
+
Thomas Harris
b. Abt 1756
8
Ursula Harris
[1.1.1.1.1.2.1.3]
b. Abt 1731
8
William Harris
[1.1.1.1.1.2.1.4]
b. Abt 1728
+
Osborne
b. Abt 1727
+
Elizabeth Evans
b. Abt 1745
Elizabeth Robards
b. Abt 1700
8
Jesse Harris
[1.1.1.1.1.2.1.5]
c. 14 Jun 1741
7
Mary Harris
[1.1.1.1.1.2.2]
b. Abt 1698 d. 17 Dec 1759
+
Francis James
b. Abt 1694
John Goode
b. Abt 1698
8
Bennett Goode
[1.1.1.1.1.2.2.1]
b. Abt 1710 d. 1771
Martha Jefferson
b. Abt 1712 d. 20 Oct 1796
9
Martha Goode
[1.1.1.1.1.2.2.1.1]
b. 1760 d. 1810
Charles Povall
b. 1763 d. 1803
10
Martha Povall
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1]
b. 1 Nov 1784
William Carrington
b. 20 Aug 1774 d. 21 May 1825
11
Ellen Theodosia Carrington
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1]
b. 1813 d. 1896
William Royal Bradley
b. 1804 d. 1889
12
Martha Carrington Bradley
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1.1]
b. 1826/1847 d. 1862/1933 [
=>
]
11
Martha Ann Carrington
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2]
b. 26 Feb 1806 d. 29 Apr 1865
Codrington Carrington
b. 23 Oct 1801 d. 10 Sep 1859
12
Willie Ann Carrington
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2.1]
b. 13 Jun 1833
12
Robert Codrington Carrington
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2.2]
b. 6 Sep 1842 [
=>
]
12
Ellen Maria Carrington
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2.3]
b. 22 Mar 1836 d. 14 Jul 1873
12
Cornelia Booker Carrington
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2.4]
b. 1 Feb 1845
12
Martha Virginia Carrington
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2.5]
b. 2 Apr 1839
12
William A. Carrington
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2.6]
b. 22 Sep 1843 d. 25 Sep 1843
7
Edith Harris
[1.1.1.1.1.2.3]
b. Abt 1700 d. Abt 1745
+
John Osborne
b. Abt 1684
+
Peter Fitzpatrick
b. Abt 1684
+
Henry Trent
b. 1676 d. 5 Sep 1726
7
Francis Harris
[1.1.1.1.1.2.4]
b. Abt 1692 d. Jul 1743
7
Jr. Thomas Harris, Jr
[1.1.1.1.1.2.5]
b. Abt 1690 d. Bef 1 Aug 1741
7
Sarah Harris
[1.1.1.1.1.2.6]
b. Abt 1696 d. Bef 24 Sep 1753
7
Ann Harris
[1.1.1.1.1.2.7]
b. 1708
Booth
b. Abt 1700
8
Anne Booth
[1.1.1.1.1.2.7.1]
b. Abt 1735 d. 1758
Samuel Yeargain
b. Abt 1735 d. Aft 24 Dec 1784
9
Sarah Ann Yeargain
[1.1.1.1.1.2.7.1.1]
b. 1752 d. 1786
William Alston
b. 1748 d. 1789
10
John Joseph Alston
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.1]
b. Abt 1775 d. 1 Apr 1831
Elizabeth Jones
b. Abt 1775
11
Mary Ann Alston
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.1.1]
b. Abt 1802
James Taylor
b. Abt 1802
12
Joe Taylor
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1]
b. Abt 1838
+
Thomas Degraaffenreidt
b. Abt 1802
11
Nancy Alston
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.1.2]
b. Abt 1800
+
John Degraaffenreidt
b. Abt 1800
10
William Chancy Alston
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.2]
b. Abt 1777 d. 1789
10
Samuel Yeargan Alston
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.3]
b. Abt 1779 d. Bef 1789
10
Oroondates Davis Alston
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.4]
b. Abt 1781 d. 15 May 1851
+
Medley Medley
b. Abt 1781
10
Nancy Ann Alston
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.5]
b. Abt 1783 d. 1860
+
Robert Palmer
b. Abt 1783
10
Mary Ann Alston
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6]
b. 9 Jun 1785 d. 8 Sep 1867
Edwards Rives
b. 19 Mar 1775 d. 2 Feb 1840
11
Anna Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.1]
b. 14 Feb 1810
+
William Goldson Harris
b. Abt 1810
11
Robert Edwards Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.2]
b. 24 May 1812 d. 1861
+
Mary Antoinette Brown
b. 16 Jun 1833
11
Thomas T. Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.3]
b. 28 Jul 1814
11
James Franklin Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.4]
b. 13 Jun 1820
11
Mary Edwards Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.5]
b. 27 Dec 1827 d. 13 Nov 1873
+
Aaron Gaston Headen
b. 21 Aug 1822 d. 1 Mar 1907
11
Sarah G. Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.6]
b. 11 Sep 1801 d. Bef 1830
11
William Alston Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.7]
b. 1 Nov 1803
11
Martha K. Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.8]
b. Oct 1806
+
John Jackson Goldston
b. Abt 1806
11
Oran D. Rives
[1.1.1.1.1.2.7.1.1.6.9]
b. 24 Sep 1808
+
Samuel Yeargain
b. 1707 d. 24 Dec 1784
7
Phoebe Harris
[1.1.1.1.1.2.8]
b. Abt 1689 d. Between 1697 and 1800
7
James Harris
[1.1.1.1.1.2.9]
b. Abt 1702 d. Bef 27 Jul 1767
Sarah Bailey
b. Abt 1704
8
James Bailey Harris
[1.1.1.1.1.2.9.1]
b. 1749
Ursula Harris Flournoy
b. 15 May 1749
9
III James Harris
[1.1.1.1.1.2.9.1.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
10
Alfred Turpin Harris
[1.1.1.1.1.2.9.1.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
11
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.1.1.1.2.9.1.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
9
Samuel Harris
[1.1.1.1.1.2.9.1.2]
b. Abt 1774
9
Elizabeth Harris
[1.1.1.1.1.2.9.1.3]
b. Abt 1776
9
Mary Harris
[1.1.1.1.1.2.9.1.4]
b. Abt 1778
8
John Bailey Harris
[1.1.1.1.1.2.9.2]
b. Abt 1732
8
Francis Bailey Harris
[1.1.1.1.1.2.9.3]
b. Abt 1758
+
Ann Diugud
b. Abt 1760
8
Mary Harris
[1.1.1.1.1.2.9.4]
b. Abt 1736
8
Phoebe Bailey Harris
[1.1.1.1.1.2.9.5]
b. Abt 1734
M.B.C.R. Joseph Royal Farrar
b. Abt 1734 d. 1796
9
Mary Farrar
[1.1.1.1.1.2.9.5.1]
b. Abt 1766
+
William Wager Harris
b. Abt 1766
8
Thomas Bailey Harris
[1.1.1.1.1.2.9.6]
b. Abt 1738 d. Bef 22 Nov 1810
+
Frances Moseley
b. Abt 1732
8
William Bailey Harris
[1.1.1.1.1.2.9.7]
b. 1757 d. Abt 1816
+
Mary Pollard
b. Abt 1760 d. Abt 1830
7
William Samuel Harris
[1.1.1.1.1.2.10]
b. Abt 1696 d. Bef 18 Dec 1794
Martha Osborne
b. Abt 1700
8
Mary Harris
[1.1.1.1.1.2.10.1]
b. Abt 1720
+
Bernard Markham
b. Abt 1720
8
Elizabeth Harris
[1.1.1.1.1.2.10.2]
b. Abt 1750
+
Vincent Markham
b. Abt 1750
+
Elizabeth Ward
b. Abt 1696
Martha Ward
b. Abt 1700
8
Thomas Harris
[1.1.1.1.1.2.10.3]
b. Abt 1756
+
Carolina Matilda Harris
b. 1 Dec 1756 d. 1815
7
Benjamin Harris
[1.1.1.1.1.2.11]
b. Abt 1710 d. Aft 24 Apr 1776
Priscilla Wager
b. Abt 1710
8
Phoebe Harris
[1.1.1.1.1.2.11.1]
b. 1755
Nathaniel Carrington
b. 28 Feb 1743/44 d. Nov 1803
9
Frances Ann Carrington
[1.1.1.1.1.2.11.1.1]
9
Henningham Carrington
[1.1.1.1.1.2.11.1.2]
8
Edith Harris
[1.1.1.1.1.2.11.2]
b. 1757 d. Aft 18 Nov 1779
8
Henson Wager Harris
[1.1.1.1.1.2.11.3]
b. 1753
+
Edward Moseley
b. Abt 1753
8
William Wager Harris
[1.1.1.1.1.2.11.4]
b. Abt 1766
+
Mary Farrar
b. Abt 1766
Frances Platt
b. Abt 1710
8
Mary Harris
[1.1.1.1.1.2.11.5]
b. Abt 1744
+
Sion Spencer
b. Abt 1744
8
Anne Harris
[1.1.1.1.1.2.11.6]
b. 1745
+
Joel Estes
b. 1741 d. 1825
7
Martha Harris
[1.1.1.1.1.2.12]
b. Abt 1706 d. 1743
+
William Pasture
b. Abt 1702
7
Timothy Harris
[1.1.1.1.1.2.13]
b. 1691 d. Jun 1743
6
Martha Jefferson
[1.1.1.1.1.3]
b. 23 Feb 1681/82 d. Bef 23 Jul 1754
Robert Wynne
b. 1685 d. 12 Jul 1754
7
Martha Wynne
[1.1.1.1.1.3.1]
b. 1715
Matthew Parham
b. Abt 1697
8
Angelica Parham
[1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 7 Jun 1745
8
Robert Parham
[1.1.1.1.1.3.1.2]
b. Jan 1747/48
8
Elizabeth Parham
[1.1.1.1.1.3.1.3]
b. Abt 1749
8
Jr. Matthew Parham
[1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 27 Feb 1750/51
7
Lucretia Wynne
[1.1.1.1.1.3.2]
b. 1712/13
Joseph Tudor Tucker
b. Abt 1710
8
Martha Tucker
[1.1.1.1.1.3.2.1]
b. Abt 1730
+
Benjamin Bell
b. Abt 1725 d. 1773
8
Robert Tucker
[1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 8 Sep 1739
8
Joel Tucker
[1.1.1.1.1.3.2.3]
b. Abt 1741
8
Lucretia Tucker
[1.1.1.1.1.3.2.4]
b. Abt 1743
7
Angelica Wynne
[1.1.1.1.1.3.3]
b. Abt 1710
William Raines
8
Robert Wynne Raines
[1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 25 Jun 1739
8
Jefferson Raines
[1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 10 Nov 1744
8
Anna Raines
[1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 22 Jul 1746
8
Nathaniel Raines
[1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 21 Mar 1747/48
8
Theodosia Raines
[1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 10 Dec 1749
7
Carnelia Wynne
[1.1.1.1.1.3.4]
b. Abt 1717
7
Anne Wynne
[1.1.1.1.1.3.5]
b. Abt 1719
Thomas Butler
b. Abt 1719
8
Martha Butler
[1.1.1.1.1.3.5.1]
b. 8 Nov 1741
8
Mary Butler
[1.1.1.1.1.3.5.2]
b. 21 Mar 1742/43
+
Joseph Mattox
b. Abt 1660
5
III Christopher Branch
[1.1.1.1.2]
b. 1658 d. Aft 11 Aug 1727
5
Samuel Branch
[1.1.1.1.3]
b. 1662
5
Benjamin Branch
[1.1.1.1.4]
b. 1665 d. 1706
Tabitha Osborne
b. 1677 d. 1756
6
Benjamin Branch
[1.1.1.1.4.1]
b. 1700 d. 1761
4
Thomas Branch
[1.1.1.2]
b. 1623 d. 25 Oct 1688
4
William Branch
[1.1.1.3]
b. 1625 d. 1670
Jane Hatcher
b. 1640 d. 1710
5
William Branch
[1.1.1.3.1]
b. Between 1646 and 1672 d. 1678
5
Sarah Branch
[1.1.1.3.2]
b. Between 1646 and 1672 d. Between 1651 and 1755
5
John Branch
[1.1.1.3.3]
b. 1658 d. 2 Apr 1688
2
Thomas Branch
[1.2]
b. 29 Jul 1557 d. Between 1589 and 1648
2
Richard Branch
[1.3]
b. 16 Sep 1560 d. Bef 1602
2
Mary Branch
[1.4]
b. 1561 d. Between 1562 and 1655
2
Ann Branch
[1.5]
b. 19 Sep 1562 d. Between 1563 and 1656
2
Eleanor Branch
[1.6]
b. 20 Oct 1564 d. Between 1565 and 1658
2
Elizabeth Brach
[1.7]
b. Abt 1558
2
Barbara Branch
[1.8]
b. 10 Jul 1569 d. Between 1570 and 1663
2
Martha Branch
[1.9]
b. 1 May 1578 d. Dec 1626
2
William Branch
[1.10]
b. 1579 d. Between 1580 and 1669
2
Katherine Branch
[1.11]
b. 21 Sep 1582
+
Elizabeth Waltham
d. Bef 1557