News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Joseph Croshaw
Abt 1610 - 1667 (57 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Joseph Croshaw
[1]
b. Abt 1610 d. 10 Apr 1667
Mary Broomfield
b. Abt 1610 d. Bef Jul 1661
2
Unity (Ursula) Croshaw
[1.1]
b. 1636 d. 20 Apr 1669
Jr. John West
b. 6 Jun 1632 d. 1689
3
Nathanial West
[1.1.1]
b. 1655 d. Abt 1724
Martha Woodward
b. Abt 1654 d. 1723
4
Unity West
[1.1.1.1]
b. 1696 d. Aft Jul 1753
William Dandridge
b. 29 Dec 1689 d. 25 Aug 1743
5
Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.1]
b. 7 Sep 1729 d. 16 Jan 1786
Dorothea Spotswood
b. 1733 d. 25 Sep 1778
6
Dorothea Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.1]
b. 25 Sep 1755 d. 14 Feb 1831
Patrick Henry
b. 29 May 1736 d. 6 Jun 1799
7
Sarah Butler Henry
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 4 Jan 1780 d. 10 Dec 1856
+
Robert Campbell
b. 1763/1783 d. 1797/1869
Alexander Scott
b. 1762 d. 29 Jun 1819
8
Catherine Henry Scott
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 18 Aug 1819
+
Robert Scott
b. 1788/1820 d. 1814/1900
8
Henrietta Dandridge Scott
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 24 Oct 1817
William H. Bailey
9
Elizabeth Ann Bailey
[1.1.1.1.1.1.1.2.1]
Eugene B. Pendleton
10
Allan Bowie Pendleton
[1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
d. 1900
10
Alice Pendleton
[1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
+
D. Frank Clarke
Epheshian Pickett
10
Katheryn Pickett
[1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
8
Patrick Henry Scott
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 4 Jun 1815 d. 9 Jan 1865
Mary Carrington Yancey
b. Abt 1831
9
Francis Alexander Scott
[1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 1 Nov 1855
+
Mary C. Pleasants
b. Abt 1852
9
Cabell Carrington Scott
[1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 24 Jul 1857
9
William Bailey Scott
[1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 27 Dec 1858
9
Charles Yancey Scott
[1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 9 May 1860
9
Sarah Butler Scott
[1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 12 Oct 1861
9
Harriet W. Scott
[1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 13 Aug 1863
7
Martha Catharine Henry
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 3 Nov 1781 d. 22 May 1801
Edward W. Henry
b. 1753/1781 d. 1803/1868
8
Dorothea Dandridge Henry
[1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 1797/1801 d. 1800/1894
7
Jr. Patrick Henry, Jr
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 15 Aug 1783 d. 22 Sep 1804
Elvira Ann Cabell
b. 10 Sep 1783 d. 22 Oct 1858
8
Elvira Ann Patrick Henry
[1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 27 Sep 1804 d. 24 Jun 1870
William Howson Clark
b. 23 Jan 1805 d. 20 Oct 1873
9
Patrick Clark
[1.1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 1826/1865 d. 1835/1942
9
Eliza Clark
[1.1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Alfred Shields
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Martha Clark
[1.1.1.1.1.1.3.1.3]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Lyle Clark
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Ellen Clark
[1.1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
George Lee
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Rosa Clark
[1.1.1.1.1.1.3.1.5]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Wilkins
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Elvira C. Clark
[1.1.1.1.1.1.3.1.6]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Augustine Claiborne
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Nannie Clark
[1.1.1.1.1.1.3.1.7]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Thomas Bruce
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
John Clark
[1.1.1.1.1.1.3.1.8]
b. 1826/1865 d. 1847/1942
+
Coleman
b. 1826/1871 d. 1847/1950
8
Nannie Henry
[1.1.1.1.1.1.3.2]
8
John Henry
[1.1.1.1.1.1.3.3]
8
Patrick Henry
[1.1.1.1.1.1.3.4]
8
Eliza Henry
[1.1.1.1.1.1.3.5]
8
Martha Henry
[1.1.1.1.1.1.3.6]
8
Ellen Henry
[1.1.1.1.1.1.3.7]
8
Rosa Henry
[1.1.1.1.1.1.3.8]
7
John Henry
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 16 Feb 1796 d. 7 Jan 1868
Elvira Bruce McClelland
b. 23 Apr 1808 d. 1871
8
William Wirt Henry
[1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 14 Feb 1831 d. 5 Dec 1900
Lucy Gray Marshall
b. 31 Jul 1832 d. 25 Jan 1922
9
Elizabeth Henry
[1.1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 22 Oct 1855 d. 1857/1954
+
Jr. James Lyons
b. 1831/1871 d. 28 Oct 1913
9
Lucy Gray Henry
[1.1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 1840/1873 d. 1857/1954
+
Mathew B. Harrison
b. 1831/1871 d. 1857/1949
9
Jr. William Wirt Henry, Jr
[1.1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 1860 d. 1941
+
Mary Bladen
b. 1860 d. 1934
9
James Marshall Henry
[1.1.1.1.1.1.4.1.4]
b. 1840/1873 d. 1848/1951
8
Laura Helen Henry
[1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 15 Mar 1836 d. 1831/1916
+
James Carter
b. 1804/1826 d. 1831/1911
8
Margaret Ann Henry
[1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 22 Jul 1833 d. 1881
William A. Miller
b. 1804/1826 d. 1837/1911
9
Ella Henry Miller
[1.1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 1837/1865 d. 1844/1948
9
Florence Henry Miller
[1.1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 1837/1865 d. 1854/1948
John Collins Dabney
b. 21 Feb 1793 d. 16 Apr 1875
10
Margaret Henry Dabney
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1]
+
S. Barksdale Penick
10
Miller Dabney
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.2]
10
Frederick Dabney
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.3]
9
John Henry Miller
[1.1.1.1.1.1.4.3.3]
b. 1837/1865 d. 1858/1945
+
Diana Hamilton
b. 1837/1872 d. 1858/1953
9
David Miller
[1.1.1.1.1.1.4.3.4]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
9
William Price Miller
[1.1.1.1.1.1.4.3.5]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
9
Rosa Cabell Miller
[1.1.1.1.1.1.4.3.6]
b. 1837/1865 d. 1844/1948
9
William Wirt Miller
[1.1.1.1.1.1.4.3.7]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
8
Emma Cabell Henry
[1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 14 Feb 1838 d. 1837/1916
III James Boswell Ferguson
b. 1823
9
Elvira Ferguson
[1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. Abt 1860
9
IV James Boswell Ferguson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 1861
Eudora Witt Horner
b. 1861
10
V James Boswell Ferguson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.1]
b. 1887
8
Thomas Stanhope McClelland Henry
[1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 22 Jul 1833
Mary E. Gaines
b. 1815/1838 d. 1835/1922
9
Robert Gaines Henry
[1.1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 4 Dec 1866
9
Jr. Thomas Stanhope Henry
[1.1.1.1.1.1.4.5.2]
b. 4 May 1863
9
Mary Ganes Henry
[1.1.1.1.1.1.4.5.3]
b. 29 May 1859
8
Elvira Henry
[1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 25 Jul 1828
+
Jesse A. Higginbotham
b. 1804/1826 d. 1831/1911
Alexander F. Taylor
b. 1804/1826 d. 1837/1911
9
Robert Taylor
[1.1.1.1.1.1.4.6.1]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
8
Margaret Ann Henry
[1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 4 May 1827
8
John Henry
[1.1.1.1.1.1.4.8]
b. Abt 1840
7
Alexander Spotswood Henry
[1.1.1.1.1.1.5]
b. 2 Jun 1788 d. 6 Jan 1854
Paulina Jordan Cabell
b. 1796 d. Dec 1833
8
Sarah Winston Henry
[1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 1822 d. 1906
George Cabell Carrington
b. 1819 d. 1880
9
John P. Merreaux Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.1]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Fanny Toot
b. 1829/1874 d. 1850/1953
9
Susan Love Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.2]
b. 1829/1868 d. 1847/1948
A. Y. Hundley
b. 1821/1866 d. 1847/1943
10
Alice C. Hundley
[1.1.1.1.1.1.5.1.2.1]
9
Charles Craddock Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.3]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Sally H. French
b. 1829/1874 d. 1850/1953
9
Sarah Cabell Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.4]
b. 1829/1868 d. 1847/1948
+
J. W. F. Bealle
b. 1821/1866 d. 1847/1943
9
Richard Bruce Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.5]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Ida Harrison
b. 1829/1874 d. 1850/1953
9
Walter Coles Carrington
[1.1.1.1.1.1.5.1.6]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Nettie Bauhan
b. 1829/1874 d. 1850/1953
8
Maria Antoinette Henry
[1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 1807/1836 d. 1823/1918
+
A. L. Hambrick
b. 1797/1834 d. 1823/1912
8
Marion F. Henry
[1.1.1.1.1.1.5.3]
b. 1807/1836 d. 1823/1918
+
Samuel Tyree
b. 1797/1834 d. 1823/1912
8
George Lafayette Henry
[1.1.1.1.1.1.5.4]
b. 29 Oct 1815 d. 16 May 1884
Margaretta Mason
b. May 1824
9
John Henry
[1.1.1.1.1.1.5.4.1]
b. 1832/1875 d. 1841/1951
9
Francis Marion Henry
[1.1.1.1.1.1.5.4.2]
b. 1832/1875 d. 1853/1951
+
Frances Cabell Henry
b. 19 Jun 1857 d. 19 Jan 1923
8
John Robert Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5]
b. 28 May 1823 d. 11 Nov 1903
Frances Elizabeth Edwards
b. 19 Apr 1829 d. 17 Feb 1904
9
William Keen Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.1]
b. 15 Mar 1852 d. 23 Apr 1919
+
Fanny Harper
b. 1832/1880 d. 1853/1958
9
Elizabeth E. Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.2]
b. 23 Oct 1853 d. 1883
+
Reuben Witcher
b. 1824/1873 d. 1850/1949
9
Daniel Edward Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.3]
b. 1862 d. Feb 1895
9
Patrick Mason Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.4]
b. 3 Dec 1863 d. 16 Feb 1902
+
Mary Anderson
b. 1832/1880 d. 1853/1958
9
Gillie Coleman Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.5]
b. 18 Mar 1867 d. 3 Jan 1938
9
Marie Antoinette Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.6]
b. 9 Apr 1872 d. Feb 1944
9
Frances Cabell Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.7]
b. 19 Jun 1857 d. 19 Jan 1923
+
Francis Marion Henry
b. 1832/1875 d. 1853/1951
9
Sarah S. Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.8]
b. 1851 d. Sep 1915
9
Cabell Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.9]
b. 1850 d. 1951
9
Eliza Garland Henry
[1.1.1.1.1.1.5.5.10]
b. 19 Aug 1859
8
Paulina Henry
[1.1.1.1.1.1.5.6]
b. 1807/1836 d. 1829/1918
Barlett Jones
b. 1797/1834 d. 1829/1912
9
Cabell H. Jones
[1.1.1.1.1.1.5.6.1]
b. 1829/1868 d. 1838/1945
8
Patrick Henry
[1.1.1.1.1.1.5.7]
b. Abt 1829
Clara F. Yancey
b. Abt 1833
9
George Henry
[1.1.1.1.1.1.5.7.1]
b. 1866
9
John Patrick Henry
[1.1.1.1.1.1.5.7.2]
b. 1852
9
William Henry
[1.1.1.1.1.1.5.7.3]
b. 1855
8
Lewis Cabell Henry
[1.1.1.1.1.1.5.8]
b. 1807/1836 d. 1813/1915
8
Laura S. Henry
[1.1.1.1.1.1.5.9]
b. 1807/1836 d. 1812/1918
7
Nathaniel West Henry
[1.1.1.1.1.1.6]
b. 7 Apr 1790 d. 6 Sep 1851
Virginia Ann Woodson
b. Abt 1796 d. 22 Oct 1838
8
Dorothea Virginia Henry
[1.1.1.1.1.1.6.1]
b. Abt 1823 d. 1905
+
Beasley
b. 1804/1841 d. 1830/1919
8
Mary B. Henry
[1.1.1.1.1.1.6.2]
b. Abt 1816 d. 1879
+
James Garrett
b. 1804/1841 d. 1830/1919
+
James Garrett
8
Martha Catherine Henry
[1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 15 Nov 1813 d. 10 May 1900
Charles Terrell Ward
b. Abt 1812 d. 27 Apr 1849
9
Robert Henry Ward
[1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 13 Mar 1834 d. 24 Oct 1884
9
Virginia Elizabeth Ward
[1.1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 23 Mar 1832 d. 25 Jan 1892
9
Anselm Ward
[1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. Sep 1846
9
Robert Henry Ward
[1.1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 13 Mar 1881 d. 21 Oct 1891
8
Patrick Miller Henry
[1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 1815 d. 4 May 1873
Susan Toby Robertson
b. 1820 d. 16 Aug 1880
9
Emma Henry
[1.1.1.1.1.1.6.4.1]
b. Abt 1854
9
Mary Virginia Henry
[1.1.1.1.1.1.6.4.2]
b. 16 Apr 1841 d. 21 Sep 1846
9
Sarah "Sallie" Catherine Henry
[1.1.1.1.1.1.6.4.3]
b. Nov 1845
Thomas Lawton Davis
b. 17 Oct 1844 d. 16 Mar 1899
10
Henry James Davis
[1.1.1.1.1.1.6.4.3.1]
b. Abt 1869
10
Ada Virginia Davis
[1.1.1.1.1.1.6.4.3.2]
b. Jul 1871
10
Leon B. Davis
[1.1.1.1.1.1.6.4.3.3]
b. Abt 1874
10
Thomas L Davis
[1.1.1.1.1.1.6.4.3.4]
b. Abt 1878
10
Davis
[1.1.1.1.1.1.6.4.3.5]
b. Sep 1879
10
Zelma Davis
[1.1.1.1.1.1.6.4.3.6]
b. Abt 1883
9
Elizabeth Ann Henry
[1.1.1.1.1.1.6.4.4]
b. 4 May 1843 d. 10 Oct 1846
9
Infant Son Henry
[1.1.1.1.1.1.6.4.5]
b. 10 May 1849
9
Victoria Henry
[1.1.1.1.1.1.6.4.6]
b. 1845
8
Lucy Ann Henry
[1.1.1.1.1.1.6.5]
b. 17 Mar 1817 d. 20 Jul 1888
John Cardwell
b. 1804/1841 d. 1836/1919
9
Wyatt Henry Cardwell
[1.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 1836/1875 d. 1845/1952
9
Mary Virginia Cardwell
[1.1.1.1.1.1.6.5.2]
b. 1836/1875 d. 1854/1955
+
P. Peak
b. 1828/1873 d. 1854/1950
9
Wiltshire Cardwell
[1.1.1.1.1.1.6.5.3]
b. 1836/1875 d. 1857/1952
+
Elizabeth Arney
b. 1836/1881 d. 1857/1960
9
Elvira Cardwell
[1.1.1.1.1.1.6.5.4]
b. 1836/1875 d. 1845/1955
9
Annotte Leslie Cardwell
[1.1.1.1.1.1.6.5.5]
b. Abt 1855 d. 1854/1955
+
Henry Curtis
b. 1828/1873 d. 1854/1950
9
Jr. John Cardwell, Jr
[1.1.1.1.1.1.6.5.6]
b. 1836/1875 d. 1857/1952
+
Ellen Esmack
b. 1836/1881 d. 1857/1960
9
William Wirt Henry Cardwell
[1.1.1.1.1.1.6.5.7]
+
Rachel Shriner
b. 1836/1881 d. 1857/1960
+
Charles Rosser
b. 1804/1841 d. 1830/1919
8
William Robertson Henry
[1.1.1.1.1.1.6.6]
b. Feb 1821 d. 15 Mar 1862
7
Dorothea Spotswood Henry
[1.1.1.1.1.1.7]
b. 2 Aug 1778 d. 17 Jun 1854
George Dabney Winston
b. 2 Aug 1771 d. 15 Jul 1831
8
James Winston
[1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 1815 d. 1852
8
Edmund Dabney Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 17 Sep 1799 d. 21 Sep 1875
Elizabeth Louisa Fontaine
b. 17 Sep 1804 d. 1892
9
Nancy Miller Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.1]
b. 5 Mar 1825
+
Oliver H. Black
9
John Dabney Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.2]
b. 21 Feb 1822
9
William Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.3]
b. 21 Jul 1828 d. 13 Aug 1878
Emma Eloise Furr
b. 1842 d. 9 Feb 1892
10
Edmund Tobias Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.3.1]
b. 22 Jul 1871 d. 26 Dec 1944
Florence Theresa Seale
b. 9 Feb 1876 d. 28 Jun 1959
11
Eloise Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.3.1.1]
b. 7 Mar 1899
Ozeph Chester Taylor
b. 1 Jul 1867
12
Edmund Warren Taylor
[1.1.1.1.1.1.7.2.3.1.1.1]
[
=>
]
12
Dorothy Eloise Taylor
[1.1.1.1.1.1.7.2.3.1.1.2]
[
=>
]
10
Galen Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.3.2]
b. 8 Feb 1873 d. 1928
+
Aurelia Odile Despommer
10
Masina Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.3.3]
b. 28 Aug 1875 d. 1928
+
Henry Henesler
9
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.4]
b. 8 Mar 1831 d. 1852
9
George Dabney Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.5]
b. 17 Sep 1833
+
Mrs. Iola Overton
9
Patrick Fontaine Winston
[1.1.1.1.1.1.7.2.6]
b. 5 Mar 1845 d. 1 Apr 1906
8
William Winston
[1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1809
8
Edward Henry Winston
[1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 1811
Susan Moorehead Reynolds
9
Prior Winston
[1.1.1.1.1.1.7.4.1]
b. 1821/1860 d. 1830/1937
8
Sallie Butler Winston
[1.1.1.1.1.1.7.5]
b. 1807
+
Charles Dandridge
b. 1786/1818 d. 1812/1898
8
Fayette Henry Winston
[1.1.1.1.1.1.7.6]
b. 1813
Martha Dix
b. 1796/1827 d. 1821/1909
9
Lucy Winston
[1.1.1.1.1.1.7.6.1]
b. 1821/1860 d. 1839/1940
+
Hoffman
b. 1813/1858 d. 1839/1935
9
Elvira Winston
[1.1.1.1.1.1.7.6.2]
b. 1821/1860 d. 1839/1940
+
J. C. Granberry
b. 1813/1858 d. 1839/1935
8
Patrick Henry Winston
[1.1.1.1.1.1.7.7]
b. 28 Jan 1802
8
George Winston
[1.1.1.1.1.1.7.8]
b. 1804
8
Elvira Virginia Winston
[1.1.1.1.1.1.7.9]
d. 17 Jun 1854
James W. Crenshaw
b. 1786/1818 d. 1818/1898
9
Elvira Crenshaw
[1.1.1.1.1.1.7.9.1]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
James C. Marvin
b. 1810/1851 d. 1836/1929
9
Sallie Winston Crenshaw
[1.1.1.1.1.1.7.9.2]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
John Miller
b. 1810/1851 d. 1836/1929
9
Dorothea Crenshaw
[1.1.1.1.1.1.7.9.3]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
David F. Smyer
b. 1810/1851 d. 1836/1929
9
Patrick Henry Crenshaw
[1.1.1.1.1.1.7.9.4]
b. 1818/1853 d. 1839/1931
+
Lula Mack
b. 1818/1859 d. 1839/1939
9
Virginia Crenshaw
[1.1.1.1.1.1.7.9.5]
b. 3 Dec 1838
+
James W. Harper
b. 1810/1851 d. 1836/1929
7
Jane Robertson Henry
[1.1.1.1.1.1.8]
b. 15 Jan 1798 d. 19 Jan 1798
7
George Lafayette Henry
[1.1.1.1.1.1.9]
b. 29 Oct 1785 d. 16 Mar 1813
+
Ann Elcan
b. 17 Feb 1788 d. 1 May 1808
7
Edward Winston Henry
[1.1.1.1.1.1.10]
b. 21 Jan 1794 d. 12 Oct 1872
Jane Randolph Yuille
b. 1790/1810 d. 1831/1894
8
Jr. Edward Winston Henry
[1.1.1.1.1.1.10.1]
b. 1815/1844 d. 1840/1923
Anne L. Ely
b. 1814/1850 d. 1840/1930
9
D. Yuille Henry
[1.1.1.1.1.1.10.1.1]
b. 1840/1883 d. 1849/1962
9
Fannie Henry
[1.1.1.1.1.1.10.1.2]
b. 1840/1883 d. Abt 1911
8
Maria Rosalie Henry
[1.1.1.1.1.1.10.2]
b. 27 Dec 1818 d. 1837/1926
William B. Lewis
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Louisa Lewis
[1.1.1.1.1.1.10.2.1]
b. 1837/1876 d. 1855/1956
+
Thomas W. Branch
b. 1829/1874 d. 1855/1951
9
William Lewis
[1.1.1.1.1.1.10.2.2]
b. 1837/1876 d. 1858/1953
+
Lucy Easly
b. 1837/1882 d. 1858/1961
9
E. W. Henry Lewis
[1.1.1.1.1.1.10.2.3]
b. 1837/1876 d. 1858/1953
+
Rosa D. Dickinson
b. 1837/1882 d. 1858/1961
9
Anne Page Lewis
[1.1.1.1.1.1.10.2.4]
b. 1837/1876 d. 1855/1956
+
John W. Collins
b. 1829/1874 d. 1855/1951
9
Alexander S. Lewis
[1.1.1.1.1.1.10.2.5]
b. 1837/1876 d. 1846/1953
8
Lucy Dorothea Henry
[1.1.1.1.1.1.10.3]
b. 1823 d. 1837/1926
Octave Leighton
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Fayetta Leighton
[1.1.1.1.1.1.10.3.1]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
9
Alberta Leighton
[1.1.1.1.1.1.10.3.2]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
8
Sarah Jane Henry
[1.1.1.1.1.1.10.4]
b. 1825 d. 1837/1926
William Armistead
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Adelia Armistead
[1.1.1.1.1.1.10.4.1]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
9
Edward Winston Armistead
[1.1.1.1.1.1.10.4.2]
b. 1837/1876 d. 1846/1953
8
Celine Henry
[1.1.1.1.1.1.10.5]
b. 25 Sep 1827 d. 1837/1926
Robert Catlett
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Winston Catlett
[1.1.1.1.1.1.10.5.1]
b. 1837/1876 d. 1846/1953
9
Jr. Robert Catlett
[1.1.1.1.1.1.10.5.2]
b. 1837/1876 d. 1858/1953
+
Jennie Daniel
b. 1837/1882 d. 1858/1961
8
Ada B. Henry
[1.1.1.1.1.1.10.6]
b. 1815/1844 d. 1837/1926
John G. Smith
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Lucy Smith
[1.1.1.1.1.1.10.6.1]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
9
Rosalie Smith
[1.1.1.1.1.1.10.6.2]
b. 1837/1876 d. 1855/1956
+
William Smith
b. 1829/1874 d. 1855/1951
9
Georgia Smith
[1.1.1.1.1.1.10.6.3]
b. 1837/1876 d. 1855/1956
+
Cobb
b. 1829/1874 d. 1855/1951
9
Sarah Smith
[1.1.1.1.1.1.10.6.4]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
8
Patrick Lafayette Henry
[1.1.1.1.1.1.10.7]
b. 1821 d. 1835/1923
+
Tillinghast
b. 1814/1850 d. 1835/1930
8
Thomas Yuille Henry
[1.1.1.1.1.1.10.8]
b. 1821 d. 1835/1923
+
Cunningham
b. 1814/1850 d. 1835/1930
8
Ella Henry
[1.1.1.1.1.1.10.9]
b. 1831
7
Richard Henry
[1.1.1.1.1.1.11]
b. 27 Mar 1792 d. 24 Aug 1793
Edmund Winston
b. Abt 1745 d. 1818
7
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.1.1.1.1.12]
b. 1775/1798 d. 1780/1882
6
Robert Ambler Dandridge
[1.1.1.1.1.2]
b. 21 Jun 1760 d. 20 Sep 1799
Mildred Aylett Allen
b. 7 Feb 1753 d. Aft May 1806
7
Allen Homes Dandridge
[1.1.1.1.1.2.1]
b. 22 Sep 1789 d. 29 Aug 1793
7
Richard Allen Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2]
b. 15 Jun 1784 d. 1825/1875
Fanny Anderson
b. 1766/1793 d. 1824/1882
8
Maria S. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 9 Jan 1804 d. 15 Sep 1804
8
Martha J. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 1805 d. 1806/1899
8
Spotswood Montgomery Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 19 Oct 1809 d. 1847/1900
Jane Frances Harding
b. 1795/1821 d. 1847/1909
9
William Archibald Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.3.1]
b. 5 Nov 1834 d. 1835/1924
9
Alfonso M. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.3.2]
b. 30 Nov 1835 d. 1836/1925
9
Marcella H. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.3.3]
b. 30 Nov 1839 d. 1840/1933
9
Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.3.4]
b. 7 Dec 1840 d. 1841/1930
9
Callimus G. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.3.5]
b. 3 Jun 1843 d. 1844/1933
9
William H. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.3.6]
b. 9 Jul 1844 d. 1845/1934
8
Archibald S. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 1816 d. 1817/1906
8
William G. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 1819 d. 1820/1909
8
Mary Frances Dandridge
[1.1.1.1.1.2.2.6]
b. 1822 d. 1823/1916
7
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.2.3]
b. 6 Apr 1786 d. 1813/1877
+
Jane Lewis
b. 1770/1794 d. 1813/1882
7
Jr. Robert Ambler Dandridge
[1.1.1.1.1.2.4]
b. 5 Feb 1788 d. 1824/1879
Ann Goodwin
b. 1780/1802 d. 1824/1889
8
Mildred Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.2.4.1]
b. 1821 d. 1844/1915
+
Benjamin Cash
b. 1793/1821 d. 1843/1908
7
Mildred Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.2.5]
b. 29 Sep 1795 d. 10 Oct 1819
+
Jr. Daniel Wade
b. 1770/1796 d. 1820/1883
7
Elizabeth Terrell Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6]
b. 7 May 1792 d. Abt 1846
Robert Honeyman Dandridge
b. 12 Oct 1784 d. Bef 3 Dec 1838
8
Mildred Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 1814 d. 1870
Robert H. Creilly
b. 1814 d. Feb 1856
9
Margaret J. B. Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.1]
b. 16 Mar 1845 d. 15 Feb 1905
William L. Barton
b. 10 Jul 1835 d. 18 Jul 1889
10
James Robert Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.1]
b. 9 Feb 1871 d. 1904/1962
Elizabeth Milner
b. 1861/1882 d. 1904/1971
11
Mildred Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.1.1]
b. 8 Nov 1901 d. 16 Oct 1905
11
Howard Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.1.2]
b. Abt 1907
10
Mary N. Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.2]
b. 31 Jan 1877 d. 1878/1971
Frank A. Walden
11
B. F. Walden
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.2.1]
b. 10 Aug 1911
Hazel Drake
12
James Franklin Walden
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.2.1.1]
[
=>
]
+
Freida Mohead
10
John Dandridge Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.3]
b. 2 Jul 1880 d. 31 May 1967
Inez Hightower
b. 11 Jan 1896 d. 14 Aug 1950
11
Thomas E. Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.3.1]
Juanita Crabtree
12
Mary J. Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.3.1.1]
[
=>
]
11
John Dandridge Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.3.2]
11
Mary Margaret Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.3.3]
11
Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.3.4]
11
A. L. Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.3.5]
10
Lelia Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4]
Jim Jordan
11
Robert Jordan
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4.1]
Dessie Roller
12
Dessie Jordan
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4.1.1]
11
Jimmie Jordan
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4.2]
11
Lelia Jordan
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4.3]
Allen
12
James Nolen Allen
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4.3.1]
12
Lee Olen Allen
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4.3.2]
12
Margaret Rynie Allen
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4.3.3]
12
Susan Lanell Allen
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.4.3.4]
10
Hance H. Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.5]
b. 23 Sep 1873 d. 1874/1963
Bulah Moore
d. 14 Jul 1909
11
Mildred Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.5.1]
+
Willey Shirley
10
Andrew Jackson Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.6]
b. 24 Sep 1875 d. 10 Sep 1903
+
Carrie Heart
10
Sarah Azile Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.7]
b. 28 Jan 1879
Sam Cline
11
Hazel Cline
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.7.1]
11
True Lynn Cline
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.7.2]
10
Troy Barton
[1.1.1.1.1.2.6.1.1.8]
b. 7 Jan 1884 d. 7 Feb 1884
9
Sarah C. Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.2]
b. 1856 d. Abt 1865
Dan Raines
10
John Bell Raines
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.1]
10
Babe Raines
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.2]
10
Dan Raines
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.3]
10
Boyd Raines
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.4]
10
Willie Raines
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.5]
10
Inez Raines
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.6]
+
Will Pierce
10
Minnie Raines
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.7]
Ed Motley
11
Bonner Motley
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.7.1]
11
Earl Raines Motley
[1.1.1.1.1.2.6.1.2.7.2]
9
George Washington Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3]
b. May 1847 d. 1848/1937
Georgia Ann Conant
b. May 1855
10
Thomas Jefferson Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1]
b. Jul 1877
Etoile Ophelia Lessell
11
Ola Mae Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.1]
b. 19 Dec 1904
Calvert Gault
12
Frances Etoile Gault
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.1.1]
[
=>
]
12
Evelyn Gault
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.1.2]
[
=>
]
12
Robert Ray Gault
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.1.3]
[
=>
]
11
Lucille Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.2]
b. 29 Jan 1907
Auzie Norris Myatt
12
Charleen Myatt
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.2.1]
[
=>
]
12
Jr. Auzie Norris Myatt
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.2.2]
[
=>
]
12
Creely Neal Myatt
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.2.3]
[
=>
]
12
Carl Preston Myatt
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.2.4]
[
=>
]
11
Bonnie Laverne Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.3]
Eugene V. Davis
12
Eugene V. Davis
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.3.1]
[
=>
]
12
James Milton Davis
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.3.2]
[
=>
]
11
Lurlyne Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.4]
Burnell Wade
12
Jr. Burnell Wade
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.4.1]
[
=>
]
12
Martha Ann Wade
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.4.2]
[
=>
]
12
Dorothy Jean Wade
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.4.3]
[
=>
]
12
Virginia Wade
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.4.4]
[
=>
]
11
Troy Edward Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.5]
Syble Partridge
12
Troy Edward Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.5.1]
[
=>
]
12
James Thomas Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.5.2]
[
=>
]
11
Preston Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.6]
Thelma Scott
12
George Thomas Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.6.1]
[
=>
]
12
Charles Preston Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.6.2]
[
=>
]
12
Martha Etoile Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.6.3]
12
Mary Nell Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.6.4]
[
=>
]
12
Jerald Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.6.5]
11
Carl Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.7]
Teddie Deaton
12
Carlene Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.7.1]
[
=>
]
11
Mildred Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.8]
Elmo Murff
12
Etiol Murff
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.8.1]
[
=>
]
12
Guy Thomas Murff
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.8.2]
[
=>
]
12
Betty Jane Murff
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.1.8.3]
[
=>
]
10
Homa Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.2]
b. Nov 1881
+
Joe Bennett
10
Alma Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.3]
b. Oct 1884
+
Jeff Crider
10
Daisy Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.4]
b. Feb 1888
+
Mitchell Ogilvee
10
Maude Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.5]
b. Mar 1890
+
Arthur Harrison
10
Lura Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.3.6]
+
J. H. Scruggs
9
Robert Gordon Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.4]
b. 17 May 1848 d. 1 Mar 1924
Jennie Lynn Brookshire
10
Electra Lynn Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1]
b. 2 Feb 1872 d. 30 Dec 1951
John Tillman Alexander
b. 2 Feb 1867 d. 12 Sep 1947
11
Ruth Electra Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.1]
+
Hannie Fortner
11
Ethel Donnon Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.2]
Bates
12
Betty Low Bates
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.2.1]
12
Jo Ann Bates
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.2.2]
11
Iska Lynn Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.3]
+
W. P. Inman
11
Otto Tillman Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.4]
b. 25 Oct 1899 d. 19 Mar 1967
+
Leona
11
Edna Bell Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.5]
b. 16 Oct 1905 d. 6 Sep 1943
Volly Booth Nelson
b. 24 Jul 1903 d. 19 Nov 1971
12
Jr. Volly Booth Nelson
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.5.1]
12
Yvonne Nelson
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.5.2]
11
Letha Aline Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.6]
+
Barbough
11
Joe Wheeler Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.7]
b. 7 Mar 1910 d. 24 Feb 1963
11
Frances Delores Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.8]
b. 16 Sep 1912 d. 18 Aug 1958
Jared Mann Wilcox
b. 7 Apr 1899 d. 17 Mar 1960
12
Virginia Lynn Wilcox
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.8.1]
[
=>
]
11
Paul Wilson Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.9]
11
John Gordon Alexander
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.1.10]
+
Edna
10
S. A. Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.2]
b. Abt 1874
10
Oscar T. Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.3]
b. Abt 1876
10
Lulla Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.4]
b. Abt 1878
10
Mahalia Delullah Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.5]
b. Abt 1881 d. Abt 1946
Gentry H. Shofner
b. Abt 1877 d. Abt 1937
11
Creilly Shofner
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.5.1]
11
Otto Shofner
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.5.2]
11
Ernestine Shofner
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.5.3]
+
Hendrix
11
Mary Shofner
[1.1.1.1.1.2.6.1.4.5.4]
+
Morgan
+
Honorra Sullivan
9
John Dandridge Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.5]
b. Abt 1852 d. 1853/1942
9
James Lewis Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.6]
b. 14 May 1854 d. 14 Oct 1941
Georgeanna Ford
b. 27 Jan 1863 d. 27 Jan 1943
10
Jennie Lee Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.1]
b. 12 Jul 1883 d. 20 Nov 1886
10
Alma Gertrude Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.2]
b. 9 Aug 1885
Gaston Allen
11
Jimmie Lee Allen
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.2.1]
Grace Malone
12
Brenda Allen
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.2.1.1]
11
Bernice Allen
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.2.2]
James McCarter
12
Freda McCarter
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.2.2.1]
12
Martha McCarter
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.2.2.2]
10
Andrew Jackson Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3]
b. 5 Feb 1888 d. Dec 1971
Ollie Mae Baldwin
11
Albert Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.1]
Henryetta Hodges
12
Gerald Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.1.1]
12
Earl Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.1.2]
11
Jimmie Lee Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.2]
+
Orin Hamner
11
Allen Jones Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.3]
11
Eunice Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.4]
Buford Brown
12
Wayne Brown
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.4.1]
12
Bobby Brown
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.4.2]
11
Katie Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.5]
+
Lynn Daugherty
11
Raymond Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.6]
Marietta Moffett
12
Georgia Ann Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.6.1]
12
Betty Ray Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.6.2]
12
Tommy Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.3.6.3]
10
Harvey Medford Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.4]
Bessie Poole
11
Mavis Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.4.1]
T. J. McCarter
12
Tommy McCarter
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.4.1.1]
10
Bessie Earl Watson Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.5]
Andy Hamilton
11
Oscar Hamilton
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.5.1]
11
James Hamilton
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.5.2]
11
Cleta Hamilton
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.5.3]
+
Woody Russell
11
Pat Hamilton
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.5.4]
11
Bilbo Hamilton
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.5.5]
11
Dallas Hamilton
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.5.6]
10
Eunice Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.6]
b. 11 Dec 1893 d. 17 Sep 1895
10
Allie Azalee Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.7]
b. 27 Sep 1898
Elzie Grady Armstrong
11
Lorraine Armstrong
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.7.1]
John Dillard Davis
12
John Armstrong Davis
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.7.1.1]
[
=>
]
12
Connie Linda Davis
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.7.1.2]
12
Sandra Elizabeth Davis
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.7.1.3]
[
=>
]
11
Mary Lou Armstrong
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.7.2]
Bobby Russell Parker
d. 29 Sep 1966
12
Nancy Angela Parker
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.7.2.1]
[
=>
]
12
Cynthia Marilyn Parker
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.7.2.2]
+
Harry L. O'Neal
10
Norman Jones Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.8]
Minnie Belle Lee
11
Leon Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.8.1]
Louise Curry
12
Lee Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.8.1.1]
12
Ronnie Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.8.1.2]
11
Jack Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.8.2]
Wilma Comer
12
Jackie Marie Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.8.2.1]
12
Natalie Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.8.2.2]
12
Chris Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.8.2.3]
10
Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.9]
b. Abt 1900 d. Abt 1900
10
Sam Barnes Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.10]
b. 13 Aug 1905
Birdie Mae Smith
11
Paul Barnes Creely
[1.1.1.1.1.2.6.1.6.10.1]
9
Mary C. Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.7]
b. Abt 1842 d. Abt 1869
9
Andrew Jackson Creilly
[1.1.1.1.1.2.6.1.8]
b. Abt 1844 d. Abt 1862
8
George Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2]
b. 1812 d. 26 Aug 1860
Elizabeth A Norwood
b. 1816 d. 1853
9
Esther F. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.1]
b. 1843
+
James B. Thompson
9
Joseph Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2]
b. 22 Dec 1845 d. 26 Nov 1917
Emma Freeman
b. Feb 1865 d. 26 Nov 1917
10
Lottie Louise Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.1]
b. 29 Dec 1899 d. 22 Jun 1955
10
Alva L Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.2]
Florence Elizabeth Henderson
b. Abt 1851 d. Abt 1876
10
Mary Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.3]
b. 10 Sep 1871 d. 16 Oct 1959
James William Minor
b. 30 Jun 1861 d. 5 Feb 1959
11
Fletcher Vinson Minor
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.3.1]
b. 14 Jul 1911 d. 27 Sep 1967
12
Margaret Minor
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.3.1.1]
10
Benjamin Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4]
b. 21 Dec 1872 d. 14 Jan 1968
Julia Ann Sprinkles
b. 2 Dec 1890 d. 15 Sep 1968
11
Ora Myrtle Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.1]
Samuel Lee Winkler, Jr
b. 23 Feb 1913 d. 3 Sep 1956
12
Ora Lee Winkler
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.1.1]
11
Joseph Samuel Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.2]
Ruby Robertson
12
Kathy Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.2.1]
[
=>
]
12
Kenneth Eugene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.2.2]
11
Jimmie Ben Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.3]
Lois Jean Waugh
12
James Calvin Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.3.1]
Alma Louise Betts
12
Charlene Louise Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.3.2]
11
Julia Florine Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.4]
Roy Millard Rodgers
12
Norma Jean Rodgers
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.4.1]
[
=>
]
12
Barbara Ann Rodgers
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.4.2]
[
=>
]
+
Marvin Mavie Thiessen
+
Frederick R. Boxberger
+
Robert D. Smith
+
James Keith Stull
11
Mitchell Dean Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.5]
b. 28 Aug 1910 d. 3 Aug 1971
Jennie Wildcat
b. 26 Jan 1921 d. 10 Aug 1951
12
Robert Lee Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.5.1]
b. 13 Oct 1943 d. 31 Oct 1969 [
=>
]
12
Mamie Darlene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.5.2]
[
=>
]
12
Lorene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.5.3]
[
=>
]
11
Willie Benjamin Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.6]
Susan Elizabeth McElhaney
12
Gerald Alan Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.6.1]
12
Willie Eugene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.6.2]
[
=>
]
12
Robert Edward Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.6.3]
[
=>
]
12
Harold Dean Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.6.4]
[
=>
]
11
Ramond E Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.7]
b. Abt 1907
Callie Donna Bryant
b. Dec 1861 d. 31 Dec 1904
11
Lilly Florence Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.8]
Granville McCoy
b. 21 Feb 1889 d. 4 Nov 1946
12
Fanny Vivian McCoy
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.8.1]
12
Johnnie Florine McCoy
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.8.2]
[
=>
]
12
Edna Jewel McCoy
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.8.3]
12
Bobby Eugene McCoy
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.8.4]
[
=>
]
11
James Ottie Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.9]
b. 30 Nov 1898 d. 21 Oct 1955
Martha Ofilda Winter
12
Naoma Joyce Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.9.1]
[
=>
]
12
Jerome Odell Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.9.2]
12
Dorcus E Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.9.3]
11
Ramond Eugene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.4.10]
b. 11 Jan 1907 d. 18 Jan 1945
10
Maude Irene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.5]
b. 2 Aug 1875 d. 22 Mar 1965
10
Earnest Claud Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6]
b. 9 Dec 1868 d. 14 Apr 1929
Pearl Lee Mayfield
11
Mary Esther Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6.1]
b. 11 Feb 1908
11
Joe Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6.2]
b. 12 Sep 1909
11
Maude Irene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6.3]
b. 17 Oct 1911 d. 8 Dec 1944
11
Katie Beatrice Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6.4]
11
Claude Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6.5]
b. 27 Sep 1917 d. 27 Sep 1917
11
Helen Lucile Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6.6]
11
Edna Ruth Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6.7]
11
Earnest Carl Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.2.6.8]
9
Liberty Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3]
b. 17 Jan 1849 d. 11 Dec 1933
Susan Antinethe Curtis
b. 29 Jan 1850 d. 27 Jul 1914
10
Isom Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1]
b. 15 Dec 1870 d. 27 Jul 1937
Frances Minerva Harvey
b. 3 Jan 1876 d. 12 Jun 1949
11
George Liberty Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.1]
b. 10 Sep 1893 d. 20 Jan 1939
Lillie Belle Denham
b. 1 Apr 1899
12
Edith Bernice Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.1.1]
[
=>
]
11
Willie Jasper Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.2]
b. 27 Apr 1897
Pearlie Lewis
b. 3 Jun 1897
12
Joe Edward Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.2.1]
[
=>
]
11
Allie Viola Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.3]
b. 9 Dec 1900
Vernon E. Faulkner
b. 6 Mar 1909
12
Delvin Raymond Faulkner
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Naomi Ruth Faulkner
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.3.2]
[
=>
]
11
Carl Curtis Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.4]
b. 10 Jan 1905
Mary Ann Sloma
12
Frances Carlene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.4.1]
12
Ruth Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.4.2]
12
Lillian Pearl Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.4.3]
11
Susan Maurine Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.5]
b. 29 Jan 1909
Jodie Clifford Hayes
b. 13 May 1904
12
Linda Nell Hayes
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.5.1]
11
Mary Mardene Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.6]
b. 2 Feb 1911
Clarence Lewis
12
Clarence George Lewis
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.6.1]
+
Hernandez
11
James Travis Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.3.1.7]
+
Ethel Virginia Patterson
9
Alfaretta Eoline Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.2.4]
b. 1851 d. 27 Sep 1894
+
Joseph Philip Cooper
8
Jane T. Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.3]
b. Abt 1820 d. 1843/1914
+
Ruben Allen
b. 1786/1818 d. 1843/1905
8
John Terrell Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.4]
b. Abt 1831 d. 5 Mar 1870
+
Octavia E. Banhook
b. 1824/1847 d. 1869/1935
8
Jr. Robert Honeyman Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.5]
b. 1832 d. CHILD
+
Margaret Ann Johnson
b. 1816/1840 d. 1859/1929
8
Adeline Dandridge
[1.1.1.1.1.2.6.6]
b. Abt 1822
+
William Wade Smith
6
Agnes Dandridge
[1.1.1.1.1.3]
b. 1769
6
William Alexander Dandridge
[1.1.1.1.1.4]
b. 6 Apr 1750 d. 1801
Anne Bolling
b. 7 Feb 1751/52 d. Aft Aug 1802
7
John Bolling Dandridge
[1.1.1.1.1.4.1]
b. 14 Nov 1780 d. 1843
Mary Underwood
b. 1770/1793 d. 1846
8
Bolling Starke Dandridge
[1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 1812 d. 1876
Elizabeth Ann Bowles
b. 1814 d. 1908
9
Sallie Dandridge
[1.1.1.1.1.4.1.1.1]
+
Briggs
+
Murray
9
Laura E. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.1.1.2]
+
Peter D. Woodson
+
Laura E. Dudley
b. 1797/1821 d. 1840/1909
7
Jane Butler Dandridge
[1.1.1.1.1.4.2]
b. Abt 1783 d. 1821
Joseph Davies Logan
b. 10 Jan 1781 d. 1820
8
James William Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 15 Jan 1815 d. 6 Mar 1903
Sarah Ann Woodville Strother
9
Jean Dandridge Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 24 Aug 1843 d. 9 Nov 1927
Samuel White
10
Erskine Lewis White
[1.1.1.1.1.4.2.1.1.1]
b. 13 Apr 1876
Olivia Whitess Sharpe
b. 10 Jan 1888
11
James Logan White
[1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1]
11
George Robert White
[1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.2]
11
Mary Erskine White
[1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.3]
11
Olivia Whitess White
[1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.4]
b. 31 Aug 1912
Martha Henderson Stackhouse
d. 7 Nov 1908
11
Jr. Erskine Lewis White
[1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.5]
b. 31 Jul 1908
+
Virginia Payson West
11
Jean Dandridge White
[1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.6]
b. 6 Jul 1905
Thomas Willoughby Potter
12
Virginia Ann Potter
[1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.6.1]
[
=>
]
9
II Joseph Davies Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1.2]
Georgine Willis
b. Abt 1861
10
Maud Matthews Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. Abt 1890
+
Garland J. Hopkins
10
Sally Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.2]
b. Abt 1887
10
Anna Clayton Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.3]
b. Abt 1888
10
John Lee Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.4]
b. Abt 1892
10
James Fielding Lewis Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.5]
Jean Markley
11
Jean Dandridge Logan
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.5.1]
8
Mary Woodville Logan
[1.1.1.1.1.4.2.2]
7
II Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3]
b. 14 Jan 1771 d. 26 Jul 1847
Martha Henry Fontaine
b. 4 Jul 1781 d. 12 Sep 1845
8
III Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 1824
Harriett A. Wylie
b. Abt 1828 d. 1815/1910
9
William B. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.1.1]
b. Abt 1853
9
Mary Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.1.2]
b. Abt 1849
8
William Fontaine Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 1804
Susan C. Stith
b. Abt 1809 d. 1830/1898
9
Catherine Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.2.1]
b. Abt 1826
9
John W. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.2.2]
b. Abt 1829
9
Mona H. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.2.3]
b. Abt 1835
9
Morrison Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.2.4]
b. Abt 1838
9
Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.2.5]
b. Abt 1841
8
Charles Fontaine Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.3]
b. 1806 d. 1866
Tabitha Ann McGee
b. 1794/1829 d. 1815/1910
9
McGee Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.3.1]
d. 7 Apr 1861
8
Henry Bolling Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4]
b. 1823 d. Aft 1885
Caroline Wylie
9
Mary Jane Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.1]
b. Abt 1829
9
Zelia Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.2]
b. Abt 1832
+
E. H. Lewis
9
Matilda Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.3]
b. Abt 1834
9
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.4]
b. Abt 1836
+
William P. Ome
9
Martha Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.5]
b. Abt 1838
9
Bolling Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.6]
b. Abt 1839
Adeline Kenon Wilbourn
b. 1818/1843 d. 1865/1931
9
Lightfoot Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.7]
b. 17 Apr 1874 d. 13 Dec 1928
Henry Woodson Baker
b. 26 Jan 1859 d. 24 Dec 1929
10
Katie Jenkins Baker
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1]
Marvin N. Fogleman
11
Mary Kate Fogleman
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.1]
Thomas Dove Copeland
12
Connie Sue Copeland
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.1.1]
[
=>
]
12
Sharon Diane Copeland
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.1.2]
[
=>
]
9
Nannie Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.8]
b. 1844/1872 d. 1849/1954
9
Jr. Henry Bolling Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.4.9]
b. 1844/1872 d. 1850/1951
8
Rosalie Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.5]
b. 1825 d. 1898
+
William Daugherty Bradford
b. 1785/1820 d. 1811/1900
8
Martha Lightfoot Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.6]
b. 1821 d. 3 Jun 1850
Richard Bolton
b. 1785/1820 d. 1811/1900
9
William Bolton
[1.1.1.1.1.4.3.6.1]
8
Eliza Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.4.3.7]
b. 1800 d. 1855
+
William Herford
b. 1765/1797 d. 1822/1884
7
Archibald Bolling Dandridge
[1.1.1.1.1.4.4]
b. 22 Dec 1776 d. 1815/1867
+
Elizabeth M. Underwood
b. 13 Sep 1798 d. 1814/1892
7
Robert Honeyman Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5]
b. 12 Oct 1784 d. Bef 3 Dec 1838
Elizabeth Terrell Dandridge
b. 7 May 1792 d. Abt 1846
8
Mildred Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 1814 d. 1870
Robert H. Creilly
b. 1814 d. Feb 1856
9
Margaret J. B. Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.1]
b. 16 Mar 1845 d. 15 Feb 1905
William L. Barton
b. 10 Jul 1835 d. 18 Jul 1889
10
James Robert Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.1]
b. 9 Feb 1871 d. 1904/1962
Elizabeth Milner
b. 1861/1882 d. 1904/1971
11
Mildred Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.1]
b. 8 Nov 1901 d. 16 Oct 1905
11
Howard Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2]
b. Abt 1907
10
Mary N. Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.2]
b. 31 Jan 1877 d. 1878/1971
Frank A. Walden
11
B. F. Walden
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.2.1]
b. 10 Aug 1911
Hazel Drake
12
James Franklin Walden
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.2.1.1]
[
=>
]
+
Freida Mohead
10
John Dandridge Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.3]
b. 2 Jul 1880 d. 31 May 1967
Inez Hightower
b. 11 Jan 1896 d. 14 Aug 1950
11
Thomas E. Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1]
Juanita Crabtree
12
Mary J. Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1]
[
=>
]
11
John Dandridge Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.2]
11
Mary Margaret Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.3]
11
Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.4]
11
A. L. Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.5]
10
Lelia Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4]
Jim Jordan
11
Robert Jordan
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.1]
Dessie Roller
12
Dessie Jordan
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.1.1]
11
Jimmie Jordan
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.2]
11
Lelia Jordan
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3]
Allen
12
James Nolen Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3.1]
12
Lee Olen Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3.2]
12
Margaret Rynie Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3.3]
12
Susan Lanell Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3.4]
10
Hance H. Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5]
b. 23 Sep 1873 d. 1874/1963
Bulah Moore
d. 14 Jul 1909
11
Mildred Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.1]
+
Willey Shirley
10
Andrew Jackson Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.6]
b. 24 Sep 1875 d. 10 Sep 1903
+
Carrie Heart
10
Sarah Azile Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7]
b. 28 Jan 1879
Sam Cline
11
Hazel Cline
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.1]
11
True Lynn Cline
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.2]
10
Troy Barton
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.8]
b. 7 Jan 1884 d. 7 Feb 1884
9
Sarah C. Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.2]
b. 1856 d. Abt 1865
Dan Raines
10
John Bell Raines
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.1]
10
Babe Raines
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.2]
10
Dan Raines
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.3]
10
Boyd Raines
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.4]
10
Willie Raines
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.5]
10
Inez Raines
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.6]
+
Will Pierce
10
Minnie Raines
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.7]
Ed Motley
11
Bonner Motley
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.7.1]
11
Earl Raines Motley
[1.1.1.1.1.4.5.1.2.7.2]
9
George Washington Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3]
b. May 1847 d. 1848/1937
Georgia Ann Conant
b. May 1855
10
Thomas Jefferson Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1]
b. Jul 1877
Etoile Ophelia Lessell
11
Ola Mae Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.1]
b. 19 Dec 1904
Calvert Gault
12
Frances Etoile Gault
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.1.1]
[
=>
]
12
Evelyn Gault
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.1.2]
[
=>
]
12
Robert Ray Gault
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.1.3]
[
=>
]
11
Lucille Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.2]
b. 29 Jan 1907
Auzie Norris Myatt
12
Charleen Myatt
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.2.1]
[
=>
]
12
Jr. Auzie Norris Myatt
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.2.2]
[
=>
]
12
Creely Neal Myatt
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.2.3]
[
=>
]
12
Carl Preston Myatt
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.2.4]
[
=>
]
11
Bonnie Laverne Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.3]
Eugene V. Davis
12
Eugene V. Davis
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.3.1]
[
=>
]
12
James Milton Davis
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.3.2]
[
=>
]
11
Lurlyne Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.4]
Burnell Wade
12
Jr. Burnell Wade
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.4.1]
[
=>
]
12
Martha Ann Wade
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.4.2]
[
=>
]
12
Dorothy Jean Wade
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.4.3]
[
=>
]
12
Virginia Wade
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.4.4]
[
=>
]
11
Troy Edward Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.5]
Syble Partridge
12
Troy Edward Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.5.1]
[
=>
]
12
James Thomas Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.5.2]
[
=>
]
11
Preston Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.6]
Thelma Scott
12
George Thomas Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.6.1]
[
=>
]
12
Charles Preston Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.6.2]
[
=>
]
12
Martha Etoile Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.6.3]
12
Mary Nell Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.6.4]
[
=>
]
12
Jerald Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.6.5]
11
Carl Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.7]
Teddie Deaton
12
Carlene Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.7.1]
[
=>
]
11
Mildred Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.8]
Elmo Murff
12
Etiol Murff
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.8.1]
[
=>
]
12
Guy Thomas Murff
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.8.2]
[
=>
]
12
Betty Jane Murff
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.1.8.3]
[
=>
]
10
Homa Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.2]
b. Nov 1881
+
Joe Bennett
10
Alma Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.3]
b. Oct 1884
+
Jeff Crider
10
Daisy Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.4]
b. Feb 1888
+
Mitchell Ogilvee
10
Maude Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.5]
b. Mar 1890
+
Arthur Harrison
10
Lura Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.3.6]
+
J. H. Scruggs
9
Robert Gordon Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.4]
b. 17 May 1848 d. 1 Mar 1924
Jennie Lynn Brookshire
10
Electra Lynn Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1]
b. 2 Feb 1872 d. 30 Dec 1951
John Tillman Alexander
b. 2 Feb 1867 d. 12 Sep 1947
11
Ruth Electra Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.1]
+
Hannie Fortner
11
Ethel Donnon Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.2]
Bates
12
Betty Low Bates
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.2.1]
12
Jo Ann Bates
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.2.2]
11
Iska Lynn Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.3]
+
W. P. Inman
11
Otto Tillman Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.4]
b. 25 Oct 1899 d. 19 Mar 1967
+
Leona
11
Edna Bell Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.5]
b. 16 Oct 1905 d. 6 Sep 1943
Volly Booth Nelson
b. 24 Jul 1903 d. 19 Nov 1971
12
Jr. Volly Booth Nelson
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.5.1]
12
Yvonne Nelson
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.5.2]
11
Letha Aline Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.6]
+
Barbough
11
Joe Wheeler Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.7]
b. 7 Mar 1910 d. 24 Feb 1963
11
Frances Delores Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.8]
b. 16 Sep 1912 d. 18 Aug 1958
Jared Mann Wilcox
b. 7 Apr 1899 d. 17 Mar 1960
12
Virginia Lynn Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.8.1]
[
=>
]
11
Paul Wilson Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.9]
11
John Gordon Alexander
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.1.10]
+
Edna
10
S. A. Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.2]
b. Abt 1874
10
Oscar T. Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.3]
b. Abt 1876
10
Lulla Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.4]
b. Abt 1878
10
Mahalia Delullah Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.5]
b. Abt 1881 d. Abt 1946
Gentry H. Shofner
b. Abt 1877 d. Abt 1937
11
Creilly Shofner
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.5.1]
11
Otto Shofner
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.5.2]
11
Ernestine Shofner
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.5.3]
+
Hendrix
11
Mary Shofner
[1.1.1.1.1.4.5.1.4.5.4]
+
Morgan
+
Honorra Sullivan
9
John Dandridge Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.5]
b. Abt 1852 d. 1853/1942
9
James Lewis Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.6]
b. 14 May 1854 d. 14 Oct 1941
Georgeanna Ford
b. 27 Jan 1863 d. 27 Jan 1943
10
Jennie Lee Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.1]
b. 12 Jul 1883 d. 20 Nov 1886
10
Alma Gertrude Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.2]
b. 9 Aug 1885
Gaston Allen
11
Jimmie Lee Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.2.1]
Grace Malone
12
Brenda Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.2.1.1]
11
Bernice Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.2.2]
James McCarter
12
Freda McCarter
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.2.2.1]
12
Martha McCarter
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.2.2.2]
10
Andrew Jackson Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3]
b. 5 Feb 1888 d. Dec 1971
Ollie Mae Baldwin
11
Albert Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.1]
Henryetta Hodges
12
Gerald Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.1.1]
12
Earl Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.1.2]
11
Jimmie Lee Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.2]
+
Orin Hamner
11
Allen Jones Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.3]
11
Eunice Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.4]
Buford Brown
12
Wayne Brown
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.4.1]
12
Bobby Brown
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.4.2]
11
Katie Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.5]
+
Lynn Daugherty
11
Raymond Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.6]
Marietta Moffett
12
Georgia Ann Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.6.1]
12
Betty Ray Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.6.2]
12
Tommy Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.3.6.3]
10
Harvey Medford Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.4]
Bessie Poole
11
Mavis Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.4.1]
T. J. McCarter
12
Tommy McCarter
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.4.1.1]
10
Bessie Earl Watson Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.5]
Andy Hamilton
11
Oscar Hamilton
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.5.1]
11
James Hamilton
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.5.2]
11
Cleta Hamilton
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.5.3]
+
Woody Russell
11
Pat Hamilton
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.5.4]
11
Bilbo Hamilton
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.5.5]
11
Dallas Hamilton
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.5.6]
10
Eunice Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.6]
b. 11 Dec 1893 d. 17 Sep 1895
10
Allie Azalee Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.7]
b. 27 Sep 1898
Elzie Grady Armstrong
11
Lorraine Armstrong
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.7.1]
John Dillard Davis
12
John Armstrong Davis
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.7.1.1]
[
=>
]
12
Connie Linda Davis
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.7.1.2]
12
Sandra Elizabeth Davis
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.7.1.3]
[
=>
]
11
Mary Lou Armstrong
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.7.2]
Bobby Russell Parker
d. 29 Sep 1966
12
Nancy Angela Parker
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.7.2.1]
[
=>
]
12
Cynthia Marilyn Parker
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.7.2.2]
+
Harry L. O'Neal
10
Norman Jones Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.8]
Minnie Belle Lee
11
Leon Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.8.1]
Louise Curry
12
Lee Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.8.1.1]
12
Ronnie Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.8.1.2]
11
Jack Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.8.2]
Wilma Comer
12
Jackie Marie Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.8.2.1]
12
Natalie Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.8.2.2]
12
Chris Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.8.2.3]
10
Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.9]
b. Abt 1900 d. Abt 1900
10
Sam Barnes Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.10]
b. 13 Aug 1905
Birdie Mae Smith
11
Paul Barnes Creely
[1.1.1.1.1.4.5.1.6.10.1]
9
Mary C. Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.7]
b. Abt 1842 d. Abt 1869
9
Andrew Jackson Creilly
[1.1.1.1.1.4.5.1.8]
b. Abt 1844 d. Abt 1862
8
George Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2]
b. 1812 d. 26 Aug 1860
Elizabeth A Norwood
b. 1816 d. 1853
9
Esther F. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.1]
b. 1843
+
James B. Thompson
9
Joseph Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2]
b. 22 Dec 1845 d. 26 Nov 1917
Emma Freeman
b. Feb 1865 d. 26 Nov 1917
10
Lottie Louise Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.1]
b. 29 Dec 1899 d. 22 Jun 1955
10
Alva L Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.2]
Florence Elizabeth Henderson
b. Abt 1851 d. Abt 1876
10
Mary Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.3]
b. 10 Sep 1871 d. 16 Oct 1959
James William Minor
b. 30 Jun 1861 d. 5 Feb 1959
11
Fletcher Vinson Minor
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.3.1]
b. 14 Jul 1911 d. 27 Sep 1967
12
Margaret Minor
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.3.1.1]
10
Benjamin Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4]
b. 21 Dec 1872 d. 14 Jan 1968
Julia Ann Sprinkles
b. 2 Dec 1890 d. 15 Sep 1968
11
Ora Myrtle Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.1]
Samuel Lee Winkler, Jr
b. 23 Feb 1913 d. 3 Sep 1956
12
Ora Lee Winkler
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.1.1]
11
Joseph Samuel Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.2]
Ruby Robertson
12
Kathy Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.2.1]
[
=>
]
12
Kenneth Eugene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.2.2]
11
Jimmie Ben Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.3]
Lois Jean Waugh
12
James Calvin Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.3.1]
Alma Louise Betts
12
Charlene Louise Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.3.2]
11
Julia Florine Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.4]
Roy Millard Rodgers
12
Norma Jean Rodgers
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.4.1]
[
=>
]
12
Barbara Ann Rodgers
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.4.2]
[
=>
]
+
Marvin Mavie Thiessen
+
Frederick R. Boxberger
+
Robert D. Smith
+
James Keith Stull
11
Mitchell Dean Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.5]
b. 28 Aug 1910 d. 3 Aug 1971
Jennie Wildcat
b. 26 Jan 1921 d. 10 Aug 1951
12
Robert Lee Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.5.1]
b. 13 Oct 1943 d. 31 Oct 1969 [
=>
]
12
Mamie Darlene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.5.2]
[
=>
]
12
Lorene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.5.3]
[
=>
]
11
Willie Benjamin Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.6]
Susan Elizabeth McElhaney
12
Gerald Alan Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.6.1]
12
Willie Eugene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.6.2]
[
=>
]
12
Robert Edward Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.6.3]
[
=>
]
12
Harold Dean Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.6.4]
[
=>
]
11
Ramond E Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.7]
b. Abt 1907
Callie Donna Bryant
b. Dec 1861 d. 31 Dec 1904
11
Lilly Florence Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.8]
Granville McCoy
b. 21 Feb 1889 d. 4 Nov 1946
12
Fanny Vivian McCoy
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.8.1]
12
Johnnie Florine McCoy
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.8.2]
[
=>
]
12
Edna Jewel McCoy
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.8.3]
12
Bobby Eugene McCoy
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.8.4]
[
=>
]
11
James Ottie Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.9]
b. 30 Nov 1898 d. 21 Oct 1955
Martha Ofilda Winter
12
Naoma Joyce Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.9.1]
[
=>
]
12
Jerome Odell Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.9.2]
12
Dorcus E Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.9.3]
11
Ramond Eugene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.4.10]
b. 11 Jan 1907 d. 18 Jan 1945
10
Maude Irene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.5]
b. 2 Aug 1875 d. 22 Mar 1965
10
Earnest Claud Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6]
b. 9 Dec 1868 d. 14 Apr 1929
Pearl Lee Mayfield
11
Mary Esther Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6.1]
b. 11 Feb 1908
11
Joe Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6.2]
b. 12 Sep 1909
11
Maude Irene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6.3]
b. 17 Oct 1911 d. 8 Dec 1944
11
Katie Beatrice Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6.4]
11
Claude Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6.5]
b. 27 Sep 1917 d. 27 Sep 1917
11
Helen Lucile Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6.6]
11
Edna Ruth Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6.7]
11
Earnest Carl Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.2.6.8]
9
Liberty Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3]
b. 17 Jan 1849 d. 11 Dec 1933
Susan Antinethe Curtis
b. 29 Jan 1850 d. 27 Jul 1914
10
Isom Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1]
b. 15 Dec 1870 d. 27 Jul 1937
Frances Minerva Harvey
b. 3 Jan 1876 d. 12 Jun 1949
11
George Liberty Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.1]
b. 10 Sep 1893 d. 20 Jan 1939
Lillie Belle Denham
b. 1 Apr 1899
12
Edith Bernice Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.1.1]
[
=>
]
11
Willie Jasper Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.2]
b. 27 Apr 1897
Pearlie Lewis
b. 3 Jun 1897
12
Joe Edward Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.2.1]
[
=>
]
11
Allie Viola Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.3]
b. 9 Dec 1900
Vernon E. Faulkner
b. 6 Mar 1909
12
Delvin Raymond Faulkner
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Naomi Ruth Faulkner
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.3.2]
[
=>
]
11
Carl Curtis Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.4]
b. 10 Jan 1905
Mary Ann Sloma
12
Frances Carlene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.4.1]
12
Ruth Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.4.2]
12
Lillian Pearl Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.4.3]
11
Susan Maurine Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.5]
b. 29 Jan 1909
Jodie Clifford Hayes
b. 13 May 1904
12
Linda Nell Hayes
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.5.1]
11
Mary Mardene Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.6]
b. 2 Feb 1911
Clarence Lewis
12
Clarence George Lewis
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.6.1]
+
Hernandez
11
James Travis Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.3.1.7]
+
Ethel Virginia Patterson
9
Alfaretta Eoline Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.2.4]
b. 1851 d. 27 Sep 1894
+
Joseph Philip Cooper
8
Jane T. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.3]
b. Abt 1820 d. 1843/1914
+
Ruben Allen
b. 1786/1818 d. 1843/1905
8
John Terrell Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.4]
b. Abt 1831 d. 5 Mar 1870
+
Octavia E. Banhook
b. 1824/1847 d. 1869/1935
8
Jr. Robert Honeyman Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.5]
b. 1832 d. CHILD
+
Margaret Ann Johnson
b. 1816/1840 d. 1859/1929
8
Adeline Dandridge
[1.1.1.1.1.4.5.6]
b. Abt 1822
+
William Wade Smith
7
George Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.6]
b. 3 Feb 1787 d. 27 Sep 1794
7
Dorothea Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.4.7]
b. 5 Jan 1779 d. 10 Feb 1821
Frederick William James
b. 1781 d. Feb 1825
8
Elizabeth Goode James
[1.1.1.1.1.4.7.1]
b. 7 Jan 1815 d. 15 Jun 1840
+
Samuel Martin
b. 1790/1816 d. 1840/1903
8
Martha Ann James
[1.1.1.1.1.4.7.2]
b. 9 Feb 1805 d. 1830/1899
William B. Johnson
b. 1779/1805 d. 1829/1893
9
Elizabeth Ann Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.1]
b. 5 Nov 1828 d. 22 May 1861
9
Isabella Marion Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.2]
b. 25 Aug 1830 d. 25 Sep 1849
9
Henrietta Snow Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.3]
b. 2 Jun 1832 d. 23 Aug 1854
9
Helen St. Mawr Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.4]
b. 22 Jan 1835 d. 29 Aug 1835
9
William Bennett Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.5]
b. 14 Feb 1838
9
Martin Van Buren Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.6]
b. 18 Oct 1840 d. 25 Jan 1858
9
James Oscgood Andrew Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.7]
b. 15 Nov 1844 d. 17 Jan 1852
9
Frederick Valentine Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8]
b. 28 Nov 1825
Cornelia Ann Harris
10
Isabella May Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.1]
b. 10 May 1850
+
W. N. Cowan
10
Ann Letitia Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.2]
b. 6 Apr 1852 d. 20 Oct 1917
+
Charles Askin
10
Eliza Jane Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.3]
b. 26 Jul 1854 d. 28 Mar 1875
10
Sue Emma Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.4]
b. 15 Dec 1857 d. 18 Feb 1932
+
James M. Irvin
10
George Robinson Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.5]
b. 17 Jan 1860
+
Corrine Lewis
10
Frederick Harris Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.6]
b. 23 Oct 1862
10
Mary Cornelia Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.7]
b. 11 Oct 1866 d. 25 Sep 1885
10
Jessie Lee Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.8]
b. 15 Nov 1869 d. 24 Apr 1902
+
Charles Albert Nye
b. 5 Mar 1855 d. 24 Aug 1921
10
William Richard Johnson
[1.1.1.1.1.4.7.2.8.9]
b. 5 Sep 1848
8
William Dandridge James
[1.1.1.1.1.4.7.3]
b. 20 Jun 1803 d. 28 Aug 1804
8
Mary Lavinia James
[1.1.1.1.1.4.7.4]
b. 1 Jan 1808 d. 28 Jun 1856
+
Morgan Utz
b. 1791/1811 d. 1825/1897
8
Richard Henry James
[1.1.1.1.1.4.7.5]
b. 15 Sep 1806 d. 15 Sep 1806
8
Alfred Turpin James
[1.1.1.1.1.4.7.6]
b. 19 Nov 1802 d. 1803/1892
8
Archibald Bolling James
[1.1.1.1.1.4.7.7]
b. 7 Sep 1813 d. 1830/1903
+
Ann Eliza Harris
b. 1809/1829 d. 1830/1913
8
Marion James
[1.1.1.1.1.4.7.8]
b. 1798/1820 d. 1804/1902
8
Jane Catherine James
[1.1.1.1.1.4.7.9]
b. 11 Aug 1817 d. 6 Jun 1840
+
Larkin Bradford
b. 1800/1819 d. 1834/1906
8
Isabella Marion James
[1.1.1.1.1.4.7.10]
b. 16 Oct 1811 d. 23 Feb 1830
+
Lawrence S. Banks
b. 1783/1811 d. 1833/1898
8
Lucy Ambler James
[1.1.1.1.1.4.7.11]
b. 1816 d. 1816
8
Richard Bland James
[1.1.1.1.1.4.7.12]
b. 29 May 1820 d. 11 Dec 1885
Sarah Woodson Bransford
b. 5 Jul 1796 d. 20 May 1862
9
Mary Catherine James
[1.1.1.1.1.4.7.12.1]
b. 27 Dec 1840 d. 28 Jun 1910
9
Marion Isabella James
[1.1.1.1.1.4.7.12.2]
b. 30 Aug 1842 d. 5 May 1903
+
N. W. Hawkins
+
Henry J. Ford
9
John Henry James
[1.1.1.1.1.4.7.12.3]
b. 31 Jul 1844 d. 30 Jun 1885
Alice Cook Connally
10
Thomas Brewster James
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1]
b. 5 Apr 1872 d. 12 Dec 1926
Laura Octavia Branum
b. 29 Nov 1880 d. 13 Aug 1971
11
Bertha Mildred James
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.1]
b. 29 Jul 1905
Albert Cotton Jordan
12
Carolyn Fay Jordan
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.1.1]
[
=>
]
12
Mary Joyce Jordan
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.1.2]
[
=>
]
11
Ruth Lawler James
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.2]
b. 1 Jan 1903
Earl Clarence Worley
12
Laura Jacqueline Worley
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.2.1]
[
=>
]
12
Jr. Earl Clarence Worley
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.2.2]
[
=>
]
12
James Bruce Worley
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.2.3]
[
=>
]
12
Ruth Geraldine Worley
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.2.4]
[
=>
]
11
Alice Edna James
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.3]
b. 9 Oct 1910
Thomas Pickens
12
Edna Doris Pickens
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Virginia Lorene Pickens
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.3.2]
[
=>
]
12
Sandra Gale Pickens
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.3.3]
11
Virgil Connally James
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.4]
b. 27 Feb 1913 d. Abt 1931
11
Thomas Brewster James
[1.1.1.1.1.4.7.12.3.1.5]
Sarah Ann Howard
b. 1816/1835 d. 1 Jul 1861
9
Alfred Bolling James
[1.1.1.1.1.4.7.12.4]
b. 21 Sep 1852 d. 2 Apr 1906
Mary Jackson Curry
10
Blanche B. James
[1.1.1.1.1.4.7.12.4.1]
b. 30 Aug 1875
10
Walter Bland James
[1.1.1.1.1.4.7.12.4.2]
b. 15 Aug 1880
9
Arabella Elizabeth "Betty" James
[1.1.1.1.1.4.7.12.5]
b. 1 Jul 1854 d. 11 May 1898
9
Frances Ann James
[1.1.1.1.1.4.7.12.6]
b. 15 Mar 1859 d. 15 Aug 1915
Roland Alexander Gooch
d. 16 Mar 1883
10
Howard Bland Gooch
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.1]
b. 1 Nov 1881
+
Augusta Ernestine Albies
10
Roland Alexander Gooch
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.2]
b. 9 Sep 1883 d. Abt 1966
+
August H. Longmoor
d. 29 Apr 1908
John W. O'Neill
11
James Leo O'Neill
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.2.1]
Eloise Skipper
12
Margaret Skipper O'Neill
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.2.1.1]
[
=>
]
12
Eleanor Patricia O'Neill
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.2.1.2]
[
=>
]
12
John Alexander O'Neill
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.2.1.3]
[
=>
]
11
John William O'Neill
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.2.2]
b. 10 Apr 1917 d. Abt 1950
Cola Allen
12
Sarah Ann O'Neill
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.2.2.1]
[
=>
]
James Monroe Kerr
10
William Appleman Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.3]
b. 30 Aug 1897 d. 20 Mar 1908
10
Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.4]
b. 30 Aug 1897 d. 30 Aug 1897
10
Alfred Thomas Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5]
b. 10 Jan 1889 d. Abt 1950
Kate French Stewart
b. 29 Jan 1888 d. 10 Jul 1954
11
Howard James Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.1]
b. 28 Nov 1925 d. 4 Mar 1945
11
Jane Snow Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.2]
b. 10 Nov 1918 d. 1 Nov 1929
11
Alfred Thomas Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.3]
Lillian Bernice Hester
12
Howard James Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.3.1]
[
=>
]
12
Jane Hester Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.3.2]
[
=>
]
12
Robert William Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.3.3]
[
=>
]
11
Kathryn Ann Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.4]
Howard Morgan Keen
12
James Howard Keen
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.4.1]
12
Stewart Hamilton Keen
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.4.2]
12
Rebecca Jane Keen
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.5.4.3]
10
Julian Hawke Kerr
[1.1.1.1.1.4.7.12.6.6]
7
Thomas Bolling Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8]
b. 3 Feb 1789 d. 10 May 1842
Caroline Matilda Nichols
b. 1803 d. 1825/1897
8
Sarah Ann "Sally" Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.1]
b. 1823 d. Aft 1880
Charles de la Boulay Fontaine
b. 28 Dec 1817 d. 20 Aug 1871
9
Charles Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.1]
b. 1846
9
John Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.2]
b. 14 Aug 1841 d. 3 Sep 1925
Sarah Amanda "Dallie" Duncan
b. Jul 1849 d. Nov 1940
10
John Brooks "Little Jack" Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.2.1]
b. 14 Oct 1871 d. 13 Aug 1967
Catherine English Crawford
11
Charles English Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.2.1.1]
Grace May Fleming
12
Charles English Fontaine, Jr.
[1.1.1.1.1.4.8.1.2.1.1.1]
12
Margaret Crawford Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.2.1.1.2]
11
Jack Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.2.1.2]
10
Charles De La Bouley Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.2.2]
b. 26 Oct 1873 d. 20 Oct 1916
10
Andrew Duncan Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.2.3]
b. 21 Oct 1875 d. 5 May 1954
10
Maury Blackwell Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.2.4]
b. Jun 1879 d. 1946
9
Mary Chaillon Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.3]
b. 1852 d. 1933
9
Bettie Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.4]
b. 1854
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.5]
b. 1855 d. 1896
9
Sarah M "Sally" Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.6]
b. 1857 d. 1943
9
Francis Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.7]
b. 14 Feb 1843 d. 8 Aug 1844
9
Frances Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.8]
b. 14 Mar 1845 d. 29 Oct 1845
9
Ann Maury Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.9]
b. 27 Feb 1848 d. 19 May 1849
9
Benjamin Lamar Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.10]
b. Abt 1849 d. 15 Jun 1931
9
Edward Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.11]
b. 26 Oct 1858 d. 9 Apr 1859
9
Martha "Patty" S Fontaine
[1.1.1.1.1.4.8.1.12]
b. 1862
8
Caroline M. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.2]
b. Abt 1836
8
Elizabeth B. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.3]
b. Abt 1838
8
Marsha F. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.4]
b. Abt 1840
8
Powhatan B. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.5]
b. Abt 1839
8
Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.6]
b. Abt 1824
8
Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.7]
b. Abt 1826
8
Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.8]
b. Abt 1828
8
Dandridge
[1.1.1.1.1.4.8.9]
b. Abt 1830
7
Martha A. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.9]
b. 21 Jan 1790 d. 22 Jan 1790
7
John Marshall Dandridge
[1.1.1.1.1.4.10]
b. 8 May 1799 d. 1800/1889
7
William Alexander Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11]
b. 30 Aug 1772 d. 10 Sep 1842
+
Joanna Stith
b. 1778 d. Bef Jun 1800
Nancy Harris Pullium
b. 23 Mar 1782 d. 9 May 1835
8
Jr. William Alexander Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1]
b. 12 May 1807 d. 27 Oct 1865
Sarah Virginia Nicholds
b. 1796/1820 d. Aft 20 Aug 1845
9
Sarah Virginia Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.1]
b. 20 Aug 1845 d. 7 Dec 1908
Samuel Wall
b. 28 Jun 1847 d. 14 Nov 1900
10
Thomas Wall
[1.1.1.1.1.4.11.1.1.1]
b. 1864/1892 d. 1871/1972
10
Elizabeth Roseboro Wall
[1.1.1.1.1.4.11.1.1.2]
10
Jr. Samuel S. Wall
[1.1.1.1.1.4.11.1.1.3]
b. 1864/1892 d. 1871/1972
10
Robert Edward Wall
[1.1.1.1.1.4.11.1.1.4]
b. 1864/1892 d. 1871/1972
10
Nannie Spotswood Wall
[1.1.1.1.1.4.11.1.1.5]
9
Robert Bolling Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2]
b. 6 Aug 1838 d. 13 Feb 1907
Susan Webster Rangeley
b. 30 Nov 1843 d. 26 Sep 1936
10
William Rangeley Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.1]
b. 10 Sep 1867 d. 13 Feb 1948
Grace Overton
11
Lucy Virginia Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.1.1]
Edward Henry Watkins
12
Thomas Edward Watkins
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.1.1.1]
11
Mary Susan Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.1.2]
+
Clinton Eugene Main
b. 22 Aug 1910 d. 7 May 1970
11
William Frank Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.1.3]
Mary Ann Shelton
12
Carolyn Faye Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.1.3.1]
[
=>
]
12
Robert Edward Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.1.3.2]
[
=>
]
12
Charles Wayne Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.1.3.3]
[
=>
]
+
Nell Horton
10
John Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2]
b. 14 Jul 1870 d. 15 Feb 1946
Annie Delma Lovell
b. 10 May 1886 d. 24 May 1955
11
Mary Alice Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.1]
Walter Krawczel
12
Richard Steven Krawczel
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.1.1]
[
=>
]
11
Essie Mae (Elaine) Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.2]
Eugene Gregory Cehan
12
Jr. Eugene Gregory Cehan
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.2.1]
12
Francis Elizabeth Cehan
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.2.2]
12
Barbara Jean Cehan
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.2.3]
[
=>
]
11
Robert Jackson Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.3]
Sarah Ruth Anthony
12
William Rangeley Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.3.1]
[
=>
]
12
Jr. Robert Jackson Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.3.2]
[
=>
]
12
Martha Ann Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.3.3]
[
=>
]
12
Susan Ruth Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.3.4]
[
=>
]
11
Harry Neal Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.4]
Helen Louise Harmon
12
Cathy Jeanine Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.4.1]
[
=>
]
11
Lucille Rangeley Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.5]
11
Thomas Hugh Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.6]
+
Sallie Ruth Ross
11
Iris Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.7]
Chesley Randolph Yates
12
Iris Jean Yates
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.7.1]
[
=>
]
12
Carolyn Fay Yates
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.7.2]
12
Jr. Chesley Randolph Yates
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.2.7.3]
[
=>
]
10
Thomas Nichols Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.3]
b. 18 Oct 1883 d. 29 Feb 1964
10
Una Denzil Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.4]
b. 31 Mar 1876 d. 18 Dec 1959
Kelsey Puckett
b. 16 Feb 1869 d. Apr 1924
11
Virginia Rangeley Puckett
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.4.1]
James Fontaine Hodnett
b. Cal 1912
12
Carolyn Rangeley Hodnett
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.4.1.1]
[
=>
]
12
Jr. James Fontaine Hodnett
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.4.1.2]
[
=>
]
11
Evelyn Spottswood Puckett
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.4.2]
b. 24 Apr 1910 d. 16 Jul 1911
10
Annie Dell Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.5]
b. 15 Jan 1881 d. 5 Apr 1964
10
Harry Clay Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6]
b. 23 Jan 1887 d. 29 May 1947
Grace Mildred Barr
b. 27 Apr 1894 d. 29 May 1964
11
William Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.1]
Hetty Wray Hurd
12
Jr. William Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.1.1]
12
James Hurd Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.1.2]
[
=>
]
12
Thomas Clay Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.1.3]
12
Anne Wray Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.1.4]
[
=>
]
11
Jr. Harry Clay Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.2]
+
Mary Belle Preece
11
Thomas Rangeley Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.3]
b. 25 Oct 1918 d. Jul 1938
11
Ellen Katherine Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.4]
11
Anna Pearl Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.5]
Harold T. Eastwood
12
Gary Dandridge Eastwood
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.5.1]
12
Dean Raymond Eastwood
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.5.2]
12
Beverly Barr Eastwood
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.5.3]
[
=>
]
11
Janet Lee Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.6]
Thomas Edward Miller
12
Jr. Thomas Edward Miller
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.6.1]
12
Katherine Galt Miller
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.6.2]
[
=>
]
12
Susan Dandridge Miller
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.6.6.3]
10
John Thomas Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.7]
b. Abt 1870
10
Annie Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.2.8]
9
Harry Clay Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.3]
b. 5 Aug 1840 d. 1872/1931
Maria Dodd
b. 1827/1850 d. 3 Jul 1869
10
Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.3.1]
b. Abt May 1869 d. 1890/1959
Watson
b. 1865/1885 d. 1890/1969
11
Nell Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.3.1.1]
9
John M. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.4]
b. Abt 1843 d. Abt 1862
9
Thomas West Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.5]
b. Abt 1836 d. Abt 1880
Mary Jane Hamner
b. 15 Jan 1817 d. Apr 1879
9
Martha Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.6]
b. 2 Jan 1859 d. 31 Jan 1918
J. W. Thornton
b. 1839/1868 d. 1893/1953
10
Dandridge Thornton
[1.1.1.1.1.4.11.1.6.1]
10
Margaret Thornton
[1.1.1.1.1.4.11.1.6.2]
10
Mary Thornton
[1.1.1.1.1.4.11.1.6.3]
9
James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7]
b. 27 Jan 1851 d. Bef 1900
Mary Eliza Cathey
b. 1846/1869 d. 1896/1958
10
Cathey Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1]
b. 15 Feb 1891 d. 25 Jul 1970
Ollie May Dupuy
11
James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1.1]
b. Dec 1920 d. 7 Jul 1948
Dorothy Hyde
12
James Haley Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1.1.1]
b. Abt 1941 d. Abt 1963
12
Edith Gwendolyn Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1.1.2]
11
Edward Roy Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1.2]
Grace Griffin
12
Edward Cathey Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1.2.1]
12
Ralph Marlin Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1.2.2]
11
Hayley Cathey Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1.3]
Marjorie Latham
12
Nancy Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.1.3.1]
10
Jimmie Ophelia Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.2]
+
Marvin A. Ingram
b. 1876/1896 d. Abt 1940
10
Jr. James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.3]
b. 1871/1892 d. 31 Jan 1894
10
Jimmie Lou Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.4]
10
Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.5]
10
Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.6]
10
Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.7]
10
Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.7.8]
9
Samuel Hamner Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8]
b. 1 Jan 1855 d. Apr 1927
Nannie Cathey
b. Oct 1865 d. Abt 1929
10
Mildred Hamner Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.1]
b. 11 Oct 1891 d. 23 Mar 1957
Perrin Holmes Lowery
11
Gloria Lowery
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.1.1]
+
John Kelly
10
William Cathey Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.2]
b. 31 Jul 1893 d. 11 Jun 1971
Velma Dickerson
11
Jr. William Cathey Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.2.1]
+
Joann Hawkins
11
Anne Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.2.2]
George Hugh Freeman
b. 1898/1929 d. 6 Dec 1952
12
Carol Diane Freeman
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.2.2.1]
12
Patricia Freeman
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.2.2.2]
+
Jr. Leon Lucien Parks
11
Lightie Rivers Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.2.3]
+
William Maurice Durley
10
Lightie Louise Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.3]
10
George Samuel Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.4]
+
Jean Feathersone
10
James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.8.5]
b. Abt 1902 d. 1903
9
George Gilmer Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9]
b. 29 Jan 1853 d. Abt 1946
Mattie Sue Norfleet
b. Abt 1861 d. Abt 1934
10
Merle Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.1]
10
Jessie Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.2]
10
Edward Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.3]
10
Martha Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.4]
10
Zelia Lightfoot Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.5]
+
M. Thompson
10
Beatrice Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.6]
+
Marcus Samuel Wilborn
b. 8 Jun 1883 d. 12 Feb 1966
10
George Gilmer Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.7]
b. 17 Jul 1890 d. 4 Jul 1947
10
Samuel Clark Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.8]
b. 7 Apr 1892 d. 29 Jul 1949
10
Mattie Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.9]
+
Robert Smith
10
James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.10]
b. 17 Sep 1900 d. 22 Jan 1960
10
Mary Merle Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.11]
+
E. A. Billingsly
10
W. Edward Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.12]
10
Pattie Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.13]
+
M. B. Hardwicke
10
Lucile Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.14]
10
Jessie Lee Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.15]
Thomas H. Rogers
11
Laura Rogers
[1.1.1.1.1.4.11.1.9.15.1]
+
Hixson
9
Mary Pocahontas Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.10]
b. 24 Jul 1849 d. 29 Oct 1915
James Thomas Wilborn
b. 15 Jun 1849 d. 24 Jan 1940
10
William Clark Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.1]
b. 26 Feb 1875 d. Aft 1963
Anna Davis
11
Marjorie Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.1.1]
11
Willodean Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.1.2]
10
James Durwood Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.2]
b. 8 Dec 1877 d. 14 Apr 1936
Mamie Allen
b. 17 Dec 1882 d. 2 May 1960
11
William Allen Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.2.1]
b. 24 May 1911 d. 9 Feb 1969
+
Ruth Hyde
11
Thomas Henry Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.2.2]
+
Connie Roe
+
Anita Stratten
11
James Harris Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.2.3]
+
Jewel Lipsey
11
Marcus Eugene Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.2.4]
Mary Louise Triplett
12
Sandra Ann Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.2.4.1]
[
=>
]
12
Diana Sue Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.2.4.2]
[
=>
]
11
Mabel Elizabeth Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.2.5]
+
Michael E. Shaleen
10
Marcus Samuel Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.3]
b. 8 Jun 1883 d. 12 Feb 1966
+
Beatrice Dandridge
+
Eva Smart Powell
10
Mabel Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.4]
b. 8 Jun 1883 d. Abt 1886
10
Ora Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.5]
b. Abt 1882 d. 6 Feb 1888
10
Bessie V. Wilborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.6]
b. 19 Mar 1891 d. Aft 1963
Locke Lafon Welborn
11
Clary H. Welborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.6.1]
11
Mary Nell Welborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.6.2]
11
Durwood Lafon Welborn
[1.1.1.1.1.4.11.1.10.6.3]
+
Bessie Louise Bacon
9
Emma Louise Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.11]
b. 19 Nov 1857 d. 22 Apr 1930
9
Elizabeth Lee Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.12]
b. 8 Sep 1865 d. 1887/1959
Emmett T. Gumpton
b. 14 May 1865
10
Dandridge Perry Gumpton
[1.1.1.1.1.4.11.1.12.1]
10
Mary Caroline Gumpton
[1.1.1.1.1.4.11.1.12.2]
10
Anna Louise Gumpton
[1.1.1.1.1.4.11.1.12.3]
10
Walter George Gumpton
[1.1.1.1.1.4.11.1.12.4]
d. Abt 1906
9
Walter Alexander Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.13]
b. 24 Jul 1862 d. 5 Sep 1932
+
Lucy Cathey
b. 1860/1913 d. 23 Dec 1953
+
Elizabeth B. Davis
9
Nannie Anderson Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.1.14]
b. 15 Apr 1848 d. 4 Jun 1922
Peter Washington Dalton
10
Edgar Elliot Dalton
[1.1.1.1.1.4.11.1.14.1]
b. 1866/1889 d. 1871/1970
10
Harry Lee Dalton
[1.1.1.1.1.4.11.1.14.2]
b. 1866/1889 d. 1871/1970
10
Charles Dalton
[1.1.1.1.1.4.11.1.14.3]
b. 1866/1889 d. 1871/1970
10
Ada Nannie Anderson Dalton
[1.1.1.1.1.4.11.1.14.4]
b. 1866/1889 d. 1871/1973
10
Nannie Anderson Dalton
[1.1.1.1.1.4.11.1.14.5]
b. 1866/1889 d. 1871/1973
10
Hunter Dalton
[1.1.1.1.1.4.11.1.14.6]
b. 1866/1889 d. 1871/1970
10
Irene Dalton
[1.1.1.1.1.4.11.1.14.7]
b. 1866/1889 d. 1871/1973
10
Elliott Dalton
[1.1.1.1.1.4.11.1.14.8]
8
Sarah T. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.2]
b. 30 May 1809 d. May 1841
+
William H. Starling
b. 1785/1811 d. 1836/1898
8
Robert T. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.3]
b. 22 Apr 1811 d. 28 Apr 1843
+
Sarah S. Pulliam
b. Abt 1816 d. 1853/1911
8
Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.4]
b. 30 Apr 1813 d. 5 May 1813
8
John Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5]
b. 26 May 1814 d. 1877/1907
Louisa Virginia Perkins
b. 1814/1845 d. 1879/1935
9
Rosa Lee Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.1]
b. 28 Jan 1873 d. 23 Nov 1876
9
Lucy Anderson Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.2]
b. 17 Mar 1875 d. 1876
9
Eunice Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.3]
b. 24 Aug 1877 d. 11 Oct 1931
+
Benjamin Franklin Amos
b. 1852/1878 d. 1902/1965
Martha Washington Pulliam
b. 1822 d. 9 Apr 1875
9
James T. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.4]
b. Abt 1837 d. 1838/1927
9
Anne Catherine Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.5]
b. Abt 1841 d. 1842/1935
9
Henry Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.6]
b. 15 Jul 1842 d. 23 Apr 1915
Sarah Frances Armstrong
b. 20 Aug 1844 d. 5 Mar 1921
10
Martha Roberta Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1]
b. 16 Aug 1882 d. 7 Oct 1940
Horace Greeley Culpepper
b. 16 Jun 1872 d. 25 Dec 1958
11
Lillian Aline Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.1]
b. 2 Aug 1904 d. 18 Jan 1966
+
Swift McAulay
11
Mary Frances Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.2]
+
Jack Hayne
+
Harold Samuel Levi
11
Horace Cohn Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.3]
+
Bobbie Ridgeway
11
Bessie Lee Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.4]
b. 3 Jun 1911 d. INFANT
11
Virginia Pearl Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.5]
+
J. W. Montgomery
+
John Douglas Askew
11
Mabel Elizabeth Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.6]
+
Reece L. Lewing
11
Joseph Henry Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.7]
+
Elizabeth Munson
+
Madeline Gomes
11
Thomas Webber Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.8]
+
Marilyn M. Mayer
11
Bobbie Louise Culpepper
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.1.9]
+
Franklin L. Young
10
Stephen Price Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.2]
b. Nov 1875 d. 1947
+
Martha Ann Leggett
10
James Guy Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.3]
b. 11 Mar 1873 d. 11 Nov 1945
+
Ada Arringron
b. 1875 d. 1905
10
Charles L. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.4]
b. 1871 d. 1872/1961
10
Leonard Joseph Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.5]
b. 1865 d. 1866/1955
10
Henry Armstrong Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.6.6]
b. 9 Apr 1886 d. 27 Mar 1953
+
Della Lee Davis
b. 18 Dec 1886 d. 18 Feb 1960
9
John Dallas Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7]
b. 27 Mar 1846 d. 1893/1938
Elizabeth Jane Atkisson
b. 1829/1856 d. 1887
10
Clay Arlington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.1]
b. 20 Jun 1871 d. 27 Nov 1947
Nancy Caroline Brooks
11
Flora Jane Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.1.1]
+
Joel Lester Powers
11
Marian Arlington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.1.2]
11
James Dallas Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.1.3]
+
Virginia Payne
11
Hazel Bernice Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.1.4]
+
Bryan Branson Wilson
11
Eleanor Myrtle Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.1.5]
+
Emory Alvis
10
Lelia Celestial Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.2]
b. 6 Oct 1879 d. 11 Mar 1966
+
Landon Cutler Singleton
b. 1856/1883 d. 1908/1969
10
Martha Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3]
b. 6 Dec 1869 d. 7 Mar 1955
Morgan Jackson Toler
b. 1867 d. 1943
11
Betty Jane Toler
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3.1]
b. 18 Jun 1890 d. 9 Mar 1972
+
Andrew Jackson Atkinson
11
Bernice Lee Toler
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3.2]
b. 21 Nov 1891 d. 15 Feb 1912
+
George Washington Brooks
11
Ray Davis Toler
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3.3]
Allenia Elizabeth Powers
12
Myrle Jewel Toler
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3.3.1]
12
Eugene Brady Toler
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3.3.2]
11
Roy Jackson Toler
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3.4]
+
Gracie Lillian Long
11
Charles Clay Toler
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3.5]
b. 18 Sep 1898 d. 9 Dec 1970
+
Daisy Estelle Gammon
11
Annie Lelia Toler
[1.1.1.1.1.4.11.5.7.3.6]
+
Frank Elery Willis
+
Susan Catherine Ragland
b. 1843/1872 d. 1894/1959
9
Robert Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.8]
b. 10 May 1854 d. 1855/1944
9
Charles C. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.9]
b. Abt 1856 d. 1890/1947
+
Elizabeth Carter
b. 1847/1868 d. 1890/1957
9
William Bolling Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.10]
b. Abt 1838
Mary Susan Vaughan
10
Laura Washington Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.5.10.1]
b. 4 Jun 1881
8
Mary Jane Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.6]
b. 7 Dec 1816 d. 5 Sep 1820
8
Spottswood B. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.7]
b. 7 Feb 1820 d. 25 Jul 1828
8
Elizabeth B. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.8]
b. 11 Aug 1801 d. 22 Sep 1804
8
William P. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.9]
b. 7 Dec 1803 d. 22 Dec 1803
8
Ann L. Dandridge
[1.1.1.1.1.4.11.10]
b. 1 Mar 1805 d. 11 May 1818
7
Elizabeth Blair Dandridge
[1.1.1.1.1.4.12]
b. 21 Apr 1774 d. 1 Apr 1796
6
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.5]
b. 1 Aug 1753 d. Apr 1785
Anne Stephen
b. "The Bower", Leetown, Jefferson Co., WV d. 1834
7
Adam Stephen Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1]
b. 5 Dec 1782 d. 20 Nov 1821
Sarah Pendleton
b. 18 Jun 1785 d. 13 Mar 1855
8
Jr. Adam Stephen Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1]
b. 13 Dec 1814 d. Jan 1890
Serena Catherine Pendleton
b. 9 Jun 1816 d. 2 Sep 1889
9
III Adam Stephen Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.1]
b. 30 Sep 1844
+
Carolyn Dane Bedinger
b. 19 Nov 1854 d. 3 Jun 1914
9
Serena Catherine Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.2]
b. 1835/1864 d. 1840/1946
9
Sarah Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.3]
b. 1835/1864 d. 1851/1946
+
Blackburn Hughes
b. 1825/1862 d. 1851/1940
9
Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.4]
b. 28 Jan 1841 d. 29 Sep 1884
Elizabeth Pitts
b. 1834/1870 d. 1860/1950
10
Serena Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.4.1]
b. Oct 1876
Hugh Nelson Pendleton
b. 11 Jan 1875
11
Serena Dandridge Pendleton
[1.1.1.1.1.5.1.1.4.1.1]
b. 31 Jul 1902
11
Jr. Hugh Nelson Pendleton
[1.1.1.1.1.5.1.1.4.1.2]
b. 30 Aug 1906
11
Helen Boteler Pendleton
[1.1.1.1.1.5.1.1.4.1.3]
b. 2 Aug 1909
11
Isabella Lawrence Pendleton
[1.1.1.1.1.5.1.1.4.1.4]
b. 18 May 1911
10
Helen Nicholson Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.4.2]
b. Oct 1878
10
Jr. Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.4.3]
b. Nov 1882
9
Lemuel Purnell Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5]
b. Nov 1842 d. 1919
Isabelle L.
b. Oct 1845
10
Florence Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.1]
b. Nov 1880
10
Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.2]
b. Sep 1881 d. 1961
Mary R. Lloyd
b. Cal 1885
11
Jr. Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.2.1]
Anne Davis
12
Anne Davis Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.2.1.1]
12
Sally Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.2.1.2]
12
III Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.2.1.3]
11
Elizabeth Lloyd Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.2.2]
+
Angus McDonald
10
Lawrence Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.3]
b. Jan 1889
10
Martha Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.5.4]
b. Jul 1885
9
Mary Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.6]
9
Nannie Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.7]
9
Philip Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.8]
d. CHILD
9
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.1.9]
d. 1869/1971
8
Philip Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2]
b. 2 Oct 1817 d. 28 Oct 1881
+
Mary Elizabeth Taylor
b. 20 Apr 1824 d. 25 Jul 1909
Caroline FitzHugh Goldsborough
b. 1820 d. 1854
9
Mary FitzHugh Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.1]
b. 1838 d. May 1893
9
Ann Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.2]
b. Jan 1840 d. Apr 1840
9
Jr. Philip Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.3]
b. 4 Nov 1843 d. 1844
9
Sarah Goldsborough Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.4]
b. 1846 d. 1871
E. Holmes Boyd
b. Apr 1840 d. 1871/1933
10
Eleanor Boyd
[1.1.1.1.1.5.1.2.4.1]
b. 1870 d. 1870
10
Holmes Boyd
[1.1.1.1.1.5.1.2.4.2]
b. 1869 d. 1 Apr 1905
10
Nannie Spotswood Boyd
[1.1.1.1.1.5.1.2.4.3]
b. 22 Nov 1873 d. 26 May 1937
Peyton Randolph Harrison, III
b. 21 Jul 1859 d. 25 Aug 1941
11
Holmes Boyd Harrison
[1.1.1.1.1.5.1.2.4.3.1]
b. 22 Oct 1899 d. 22 May 1911
11
Peyton Randolph Harrison, IV
[1.1.1.1.1.5.1.2.4.3.2]
b. 2 Sep 1905 d. 16 Feb 1938
11
Anne "Nana" Spottswood Harrison
[1.1.1.1.1.5.1.2.4.3.3]
+
Bennett Taylor
10
Philip Pendleton Boyd
[1.1.1.1.1.5.1.2.4.4]
b. 1870
10
Lily Dandridge Boyd
[1.1.1.1.1.5.1.2.4.5]
b. 22 Nov 1871 d. 18 Jun 1940
9
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.5]
b. 19 Nov 1819 d. 29 Apr 1889
9
William FitzHugh Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.6]
b. 1838/1866 d. 1863/1945
Mary Brassfield Winn
b. 1837/1873 d. 1863/1953
10
Elsie Winn Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.6.1]
10
Jr. William FitzHugh Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.6.2]
b. 1863/1905 d. CHILD
9
Carolyn Goldsborough Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.7]
b. 1840 d. 1860
9
Mary Evelina Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.8]
b. 1838/1866 d. May 1893
Robert Mercer Taliaferro Hunter
b. 21 Apr 1809 d. 18 Jul 1887
10
James Dandridge Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.1]
b. 3 Mar 1841
Emma Lee Parker
11
Mary Evelina Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.1.1]
b. 14 May 1886 d. 26 Jan 1905
11
III Robert Mercer Taliaferro Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.1.2]
b. 12 Oct 1888
11
Stephen Spotswood Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.1.3]
b. 17 Oct 1890
10
Sarah Stephena Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.2]
b. 24 Apr 1846 d. 14 Apr 1865
10
Annie Buchanan Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.3]
b. 23 May 1852
10
Mary Evelina Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.4]
b. 12 Sep 1854 d. 11 Jun 1881
10
Muscoe Russell Garnett Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.5]
b. 18 Feb 1850 d. 28 Jul 1865
10
Jr. Robert Mercer Taliaferro Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.6]
b. 1 Apr 1839 d. 28 Nov 1861
10
Philip Stephen Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.7]
b. 17 Jul 1848
10
Martha "Pink" Taliaferro Hunter
[1.1.1.1.1.5.1.2.8.8]
b. 1 Apr 1844 d. 9 Feb 1909
9
Charles Goldsborough Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.2.9]
b. 1848 d. 1864
8
Ann Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.3]
b. 19 Oct 1806 d. INFANT
8
Ann Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.4]
b. 18 Jun 1813 d. 1827/1907
Thomas Elie Buchanan
b. 18 Jun 1813 d. 1889
9
Sallie Pendleton Buchanan
[1.1.1.1.1.5.1.4.1]
b. 1835 d. 1916
Dabney Carr Harrison
b. 12 Sep 1830 d. 16 Feb 1862
10
Jane Carr Harrison
[1.1.1.1.1.5.1.4.1.1]
b. 1856 d. 1864
10
Dabney Carr Harrison
[1.1.1.1.1.5.1.4.1.2]
b. 15 Oct 1858
Ellen Robinson Riley
b. 13 May 1876
11
William Riley Harrison
[1.1.1.1.1.5.1.4.1.2.1]
b. 25 Nov 1900
11
Dabney Carr Harrison
[1.1.1.1.1.5.1.4.1.2.2]
10
Ann Spottiswoode Dandridge Harrison
[1.1.1.1.1.5.1.4.1.3]
b. 1860 d. 1898
8
Sarah Stephena Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.5]
b. 7 Nov 1811 d. 25 Oct 1846
+
Anthony (Arthur) Kennedy
b. 1786/1813 d. 1837/1900
8
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6]
b. 19 Nov 1819 d. 29 Apr 1889
Martha Elizabeth Pendleton
b. 30 Dec 1823 d. 24 Feb 1882
9
Jane Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6.1]
b. 1840/1869 d. 1856/1950
+
William Dalton Warren
b. 1830/1867 d. 1856/1945
9
Nathaniel Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6.2]
b. 1840/1869 d. 1846/1948
9
Sarah Kennedy Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6.3]
b. 1840/1869 d. CHILD
9
Susan Bowler Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6.4]
b. 1840/1869 d. 1856/1950
John M. Bowers
b. 1830/1867 d. 1856/1945
10
Spotswood Boyd Bowers
[1.1.1.1.1.5.1.6.4.1]
+
Martha Bryte Lane
10
Mary Stewart f Bowers
[1.1.1.1.1.5.1.6.4.2]
10
Martha Dandridge Bowers
[1.1.1.1.1.5.1.6.4.3]
10
Henry M. Bowers
[1.1.1.1.1.5.1.6.4.4]
10
William Bowers
[1.1.1.1.1.5.1.6.4.5]
9
Alice Key Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6.5]
b. 1840/1869 d. 1856/1950
+
Lewis N. Irving
b. 1830/1867 d. 1856/1945
9
Jr. Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6.6]
b. 1840/1869 d. 15 Apr 1889
9
Mary Evelina Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6.7]
b. 1840/1869
9
Martha Dandridge
[1.1.1.1.1.5.1.6.8]
b. 1840/1869 d. 1845/1950
6
John Dandridge
[1.1.1.1.1.6]
b. 15 Apr 1756 d. 20 Jul 1804
Elizabeth Booth
b. Abt 1764 d. Aft 12 Jun 1857
7
Dolly Dandridge
[1.1.1.1.1.6.1]
b. 1778/1803 d. 1784/1887
7
Jr. John W. Dandridge
[1.1.1.1.1.6.2]
b. 1778/1799 d. 1818/1883
+
Lucy M. H. Sharp
b. 1768/1795 d. 1817/1885
7
Susanna Dandridge
[1.1.1.1.1.6.3]
b. 1777/1793 d. 1819/1883
+
Lewis Davis
b. 1762/1794 d. 1819/1881
+
David Darrington
b. 1752/1784 d. 1809/1871
7
Alexander Dandridge
[1.1.1.1.1.6.4]
b. 1778/1803 d. 1785/1884
7
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.1.6.5]
b. 1778/1800 d. 1818/1887
+
Samuel Hawkins
b. 1761/1793 d. 1818/1880
7
William H. Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6]
b. Abt 1802 d. Bef 16 Mar 1868
Santa Maria
b. Abt 1800 d. 18 Jul 1824
8
Santa Maria Elizabeth Booth Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.1]
b. 15 Jul 1824 d. 5 Feb 1853
James Gaston Robinson
b. 1793/1823 d. 1850/1909
9
Ann Katherine Robinson
[1.1.1.1.1.6.6.1.1]
b. 19 Apr 1842 d. 15 Nov 1875
Joseph V.A. Tucker
b. 1817/1844 d. 1868/1931
10
Kate Goodwin Tucker
[1.1.1.1.1.6.6.1.1.1]
b. 1855/1874 d. 1890/1962
Samuel Robert Gresham
b. 1836/1865 d. 1890/1950
11
Joseph Samuel Gresham
[1.1.1.1.1.6.6.1.1.1.1]
Mary Tatum Friend
12
Martha Dandridge Gresham
[1.1.1.1.1.6.6.1.1.1.1.1]
10
Florence Dandridge Tucker
[1.1.1.1.1.6.6.1.1.2]
b. 1860/1875 d. 1865/1963
9
Virginia Robinson
[1.1.1.1.1.6.6.1.2]
b. 14 Oct 1843 d. 16 Jul 1844
9
William Francis Robinson
[1.1.1.1.1.6.6.1.3]
b. 4 May 1845 d. 3 May 1846
9
Maria Elizabeth Robinson
[1.1.1.1.1.6.6.1.4]
b. 20 Feb 1847 d. Apr 1872
Charles William Barnett
b. 1817/1847 d. 1871/1934
10
Rennie Goolsby Barnett
[1.1.1.1.1.6.6.1.4.1]
b. 27 Oct 1866 d. 27 Oct 1940
+
Reuben Mosley Buckley
b. 1841/1867 d. 1891/1954
Elizabeth Bullock Mosley
b. 1821 d. 1862/1916
8
Mary E. Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.2]
b. Abt 1844 d. 1845/1938
8
John S. Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.3]
b. Abt 1846 d. 1847/1936
8
Fanny R. Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.4]
b. Abt 1850 d. 1851/1944
8
William West Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.5]
b. Abt 1851 d. 1852/1941
8
Lucy B. Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.6]
b. Abt 1855 d. 1856/1949
8
Julian N. Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.7]
b. 7 Aug 1856 d. 17 Apr 1914
8
Lee Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.8]
b. Abt 1860 d. 1861/1950
Maria L. Jones
b. 1784/1810 d. Bef 1842
8
Ella H. Dandridge
[1.1.1.1.1.6.6.9]
b. 1825 d. 1849/1919
+
Frederick D. Bullock
b. 1798/1825 d. 1848/1912
7
Fanny Richards Dandridge
[1.1.1.1.1.6.7]
b. 1777/1792 d. 1809/1881
+
Basil Brown
b. 1751/1783 d. 1808/1870
+
Goode
b. 1752/1771 d. 1773/1856
6
Jr. Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.1.7]
b. 26 Oct 1762
Sarah Watson
b. 1758 d. 1814
7
Martha Hale Dandridge
[1.1.1.1.1.7.1]
b. 23 Sep 1795 d. 7 Apr 1875
William Winston Fontaine
b. 25 Nov 1786 d. 1816
8
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1]
b. 18 May 1813 d. 3 Nov 1845
Sarah Miller Cole
b. 14 Feb 1815 d. 2 Mar 1892
9
Samuel Cole Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.1]
b. 1 May 1835 d. 3 Jun 1891
Mary Morton Anderson
b. 16 Apr 1852 d. 9 Jan 1904
10
Robert Anderson Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.1]
b. 7 Mar 1879 d. 1955
Genevieve Kearfott
11
Nancy Herr Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.1.1]
b. 13 Aug 1916 d. 30 Jun 1947
10
William Hale Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.2]
b. 7 Mar 1882 d. 1883/1972
10
Jr. Samuel Cole Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.3]
b. 1883 d. 1884/1973
10
Justina Cole Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4]
b. 1887 d. 1969
+
Arthur B. Richardson
b. 1882 d. 1903/1973
9
Watson Hale Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.2]
9
Nathaniel Cole Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.3]
9
Katherine Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.4]
Overton Redd Wootton
b. 1837
10
Eva Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.1]
10
Nora Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.2]
10
Lucy Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.3]
10
Sallie Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.4]
10
Maude Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.5]
10
Nathaniel Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.6]
10
William Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.7]
10
John Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.8]
10
Hale Wootton
[1.1.1.1.1.7.1.1.4.9]
9
Unity Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.1.5]
+
Edward Estes
8
Anne Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.2]
b. 1810/1838 d. 1807/1918
8
William Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3]
b. 7 Nov 1810 d. 1882
Sarah Shelton Aylett
b. 24 Jun 1811 d. 5 Mar 1875
9
Sarah Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.1]
b. 18 Jan 1848
Henry Sampson
b. 10 Mar 1847 d. 18 Sep 1915
10
Cornelia Dandridge Sampson
[1.1.1.1.1.7.1.3.1.1]
b. 1 Apr 1874 d. 13 Sep 1903
Malcolm Graham
b. Feb 1865
11
Sarah Aylett Graham
[1.1.1.1.1.7.1.3.1.1.1]
Frank W. Simpson
12
Jr. Frank W. Simpson
[1.1.1.1.1.7.1.3.1.1.1.1]
12
Geary Graham Simpson
[1.1.1.1.1.7.1.3.1.1.1.2]
[
=>
]
12
William A. Simpson
[1.1.1.1.1.7.1.3.1.1.1.3]
+
Powell
11
Malcolm Montrose Graham
[1.1.1.1.1.7.1.3.1.1.2]
b. 16 Sep 1898
9
William Winston Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2]
b. 27 Nov 1834 d. 2 Nov 1917
Mary Adelaide Burrows
b. 4 Jan 1838 d. 28 Mar 1887
10
Elizabeth Adelaide Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.1]
b. 6 Jan 1873 d. 19 Nov 1916
10
John Lansing Burrows Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.2]
b. 18 Jun 1868 d. 11 May 1913
+
Elizabeth Rose Waggener
b. 12 Apr 1870 d. 9 Oct 1925
10
William Winston Spottswood Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.3]
b. 16 Mar 1870 d. 19 Aug 1939
Florence West Evans
b. Mar 1877 d. 21 Jan 1928
11
Evan-Burrows Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.3.1]
Cornelius Vanderbilt Whitney
12
Neil “Sonny” Winston Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.3.1.1]
[
=>
]
+
Sterling Lawrence Adair
b. 18 Dec 1894 d. 14 Jan 1921
Harold “Stubby” Herman Kruger
b. 23 Sep 1898 d. 7 Oct 1965
12
Robert "Bobby" Kruger
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.3.1.2]
+
Jack Lynch
+
Mabel Kathleen Lawrence
b. Abt 1890
10
William Spottswood Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.4]
b. 27 Feb 1862 d. 28 Jul 1863
10
Mary Aylett Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.5]
b. 13 May 1866 d. 8 Aug 1933
10
Marion Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.2.6]
b. 10 Jan 1880 d. 10 Jan 1880
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3]
b. 1841 d. 1915
Annie Elizabeth Redd
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.1]
10
James Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.2]
b. 1888
10
John Winston Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.3]
b. 1887
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.1]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.1.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.1.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.1.3]
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.2]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.3]
b. 3 Dec 1897
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.4]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.4.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.4.2]
11
John Winston Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.5]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.5.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.6]
11
William Fontaine Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.7]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.4.8]
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.5]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.6]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.7]
b. 1879
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.8]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.3.9]
b. 1877
9
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.4]
b. 1838 d. 1856
9
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.5]
b. 1845 d. 1862
9
Marian Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.6]
b. 19 May 1840 d. 1913
+
John Hairston Redd
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
9
Alexander Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.7]
b. Abt 1836 d. CHILD
9
Elizabeth Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.3.8]
b. 28 Jun 1833
+
Elizabeth Henry Aylett
b. Nov 1798 d. 14 Nov 1818
8
Sarah Ann Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4]
b. 5 Nov 1815 d. 9 Feb 1909
Edmund Burwell Redd
b. 4 Jun 1808 d. 10 Aug 1850
9
James Smith Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.1]
b. Abt 1841
Sarah Hairston
10
Annie Spotswood Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.1.1]
+
John G. Hulsbush
10
Pocahontas Cabel Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.1.2]
+
Norman Thomas Mallonee
9
Celeste Tunstall Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.2]
b. Abt 1843
Samuel Pickney Caldwell
10
Alice Brandon Caldwell
[1.1.1.1.1.7.1.4.2.1]
9
Annie Elizabeth Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.3]
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
Patrick Henry Fontaine
b. 1841 d. 1915
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.1]
10
James Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.2]
b. 1888
10
John Winston Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.3]
b. 1887
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.1]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.1.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.1.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.1.3]
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.2]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.3]
b. 3 Dec 1897
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.4]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.4.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.4.2]
11
John Winston Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.5]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.5.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.6]
11
William Fontaine Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.7]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.4.8]
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.5]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.6]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.7]
b. 1879
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.8]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.7.1.4.3.9]
b. 1877
9
William Spotswood Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.4]
b. 1 Mar 1839 d. 1 Nov 1909
Mary Taylor Wootton
b. 27 Aug 1844 d. 26 Apr 1918
10
Ella Spotswood Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1]
b. 5 Oct 1872 d. 25 Mar 1932
Richard Wordsworth Fischer
11
Grace Brown Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.1]
Frank Beauregard Jenkins
b. Abt 1906 d. Abt 1950
12
Grace Jenkins
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.1.1]
11
Spotswood Redd Gill Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.2]
b. 5 Apr 1896 d. Abt Jun 1923
11
Jr. Richard Wordsworth Fischer, Jr
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.3]
b. 7 Sep 1897 d. 24 Mar 1937
11
Caroline Dorothea Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.4]
IV Jesse Marden
b. 18 Jan 1906 d. 4 Jul 1962
12
Ann Marden
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.4.1]
11
John Gill Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.5]
b. 3 Feb 1901 d. 2 Jan 1950
+
Grace Elizabeth Shelfer
b. 2 Feb 1908 d. 8 Apr 1961
11
Mary Elizabeth Redd Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.6]
+
James Everett Sanner
b. 15 Jul 1896 d. Oct 1968
11
Ann Franklin Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.7]
b. 8 Sep 1905 d. Abt 1909
11
Martha Redd Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.8]
+
Frank Lewis
11
Lucinda Reamey Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.9]
b. 1 Jan 1907 d. 4 Nov 1960
+
Carl Hubbard
+
Ralph Ray Jack Williams
11
Louis Christian Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.10]
11
Matthew Redd Fischer
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.1.11]
b. Abt 1911 d. Bef 1920
10
Lucinda Dabney Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.2]
b. 1 Sep 1866 d. 9 Nov 1912
10
II Edmund Burwell Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.3]
b. 23 Feb 1868 d. CHILD
10
Martha Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.4]
b. 19 Sep 1870 d. 9 Nov 1933
+
Overton Reamey
d. Abt 1898
+
Jack B. Walker
b. 1 Jun 1859
10
Sarah Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.4.5]
b. 5 Oct 1872 d. 20 Jul 1873
9
John Hairston Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.5]
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
+
Marian Dandridge Fontaine
b. 19 May 1840 d. 1913
9
Mary Dandridge Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.6]
b. 8 Jan 1837 d. 10 Sep 1888
John Wayt
b. Abt 1831
10
Martha "Mattie" Frances Wayt
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1]
b. Jun 1874 d. Feb 1926
William Augustus Osborne
b. 15 Dec 1869 d. Jul 1942
11
Frances West Osborne
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.1]
Hiram Oscar Kerns, Jr
b. 24 May 1893 d. 5 Oct 1964
12
Elizabeth Osborne Kerns
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.1.1]
12
Hiram Oscar Kerns, III
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.1.2]
[
=>
]
12
Edward Johnson Kerns
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.1.3]
[
=>
]
11
William Osborne
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.2]
b. Abt 1908
11
Marion Osborne
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.3]
b. Abt 1908
11
Dorothy Osborne
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.4]
b. Abt 1910
11
Elizabeth Osborne
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.5]
b. Abt 1904
11
Mary Osborne
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.6]
b. Abt 1898
11
Kate Osborne
[1.1.1.1.1.7.1.4.6.1.7]
b. Abt 1901
9
Edmund Madison Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.7]
b. 18 Dec 1844 d. 2 Oct 1928
+
Anna Richardson
b. Abt 1859 d. Abt 1929
9
Martha Catherine Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.8]
b. 3 Apr 1833 d. 15 Sep 1913
+
John Francis Wootton
b. Abt 1827 d. Abt 1888
9
Ella E. Redd
[1.1.1.1.1.7.1.4.9]
b. Abt 1849 d. Abt 1919
+
Francis Watlington
b. Abt 1847 d. Abt 1917
+
William Perkins
b. 21 Jul 1785 d. 8 Nov 1849
7
Watson N. Dandridge
[1.1.1.1.1.7.2]
b. 1778/1798 d. 1816/1882
+
Sarah Elizabeth Moore
b. 1773/1856 d. 1830/1937
7
Mary Dandridge
[1.1.1.1.1.7.3]
b. 1783/1808 d. 1799/1891
+
Ellis
b. 1773/1806 d. 1799/1886
7
Unity Dandridge
[1.1.1.1.1.7.4]
b. Abt 1799 d. 24 Oct 1823
Jesse Winston Garth
b. 17 Oct 1788 d. 8 Sep 1867
8
Sarah Dandridge Garth
[1.1.1.1.1.7.4.1]
b. 20 May 1825 d. 9 Feb 1908
+
Charles F. M. Dancy
b. 1808/1828 d. 1842/1914
6
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.1.8]
b. 12 Sep 1764 d. 26 Apr 1833
Philip Payne
b. 29 Mar 1760 d. 7 Jul 1840
7
Jane Smith Payne
[1.1.1.1.1.8.1]
b. 1784 d. 1798/1878
+
Tamerlain W. Davies
b. 1767/1787 d. 1801/1873
7
John Smith Payne
[1.1.1.1.1.8.2]
b. 26 Jun 1786 d. 1839/1878
Susan Elwood Scott
b. 21 Mar 1794 d. 27 May 1862
8
Walter Tazewell Payne
[1.1.1.1.1.8.2.1]
b. 14 Nov 1826 d. 1 Jun 1923
+
Elizabeth Kimbrough Ligon
b. 6 Jun 1827 d. 14 Mar 1893
8
Elizabeth S. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.2]
b. 3 May 1829 d. 1843/1923
+
Robert W. Nowlin
b. 1812/1832 d. 1846/1918
+
Creed Clark
b. 1812/1832 d. 1846/1918
8
Edward S. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.3]
b. 11 Jun 1831 d. 1832/1921
8
Martha Harriette Payne
[1.1.1.1.1.8.2.4]
b. 2 Apr 1836 d. 1850/1930
+
Marco B. Carter
b. 1819/1839 d. 1853/1925
8
Blanche T. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.5]
b. 1809/1837 d. 1860/1925
+
Robert W. Withers
b. 1803/1835 d. 1860/1922
8
Robert G. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.6]
b. 21 Aug 1810 d. 1844/1901
+
Sarah P. Miller
b. 1801/1822 d. 1844/1911
8
Mary Clementine Payne
[1.1.1.1.1.8.2.7]
b. 23 Dec 1812 d. 1826/1906
+
Francis W. Scott
b. 1795/1815 d. 1829/1901
8
John W. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.8]
b. 30 Nov 1814 d. 1841/1905
+
Sarah Ann Poindexter
b. 1798/1822 d. 1841/1910
8
Amanda V. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.9]
b. 14 Nov 1815 d. 1839/1909
+
George Yuille
b. 1788/1815 d. 1838/1902
8
Ann M. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.10]
b. 28 Feb 1818 d. 1832/1912
+
John C. Elliott
b. 1812
8
Philip W. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.11]
b. 11 Dec 1821 d. 1856/1912
+
Julia A. Ogden
b. 1812/1834 d. 1856/1923
8
Susan E. Payne
[1.1.1.1.1.8.2.12]
b. 12 Apr 1824 d. 1838/1918
+
Jessee Hargrave
b. 1807/1827 d. 1841/1913
+
Susan E. N. Clark
b. Abt Mar 1812 d. 12 Sep 1889
7
Elizabeth S. Payne
[1.1.1.1.1.8.3]
b. 1788 d. 1802/1882
+
William Syme Cabell
b. 1771/1791 d. 1805/1877
7
Nathaniel West Payne
[1.1.1.1.1.8.4]
b. 1790 d. 1818/1881
+
Catherine W. Alexander
b. 1774/1798 d. 1817/1887
7
Mary C. Payne
[1.1.1.1.1.8.5]
b. 1792 d. 1808
7
Philip Matthews Payne
[1.1.1.1.1.8.6]
b. 1794 d. 1837/1886
+
Elizabeth Cobbs
b. 1790/1810 d. 1811/1894
Mary E. Mitchell
b. 1789/1815 d. 1837/1903
8
Catherine Mitchell Payne
[1.1.1.1.1.8.6.1]
b. 1815/1840 d. 1861/1928
Ferdinan Perrow
b. 1804/1836 d. 1861/1923
9
Charles Mathew Perrow
[1.1.1.1.1.8.6.1.1]
b. 1855/1885 d. 1910/1971
Mary S. Holman
10
Catherine Mitchell Perrow
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1]
Paul Campbell Bowles
11
Paula Catherine Bowles
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1.1]
James Garland Watkins
12
Jr. James Garland Watkins, Jr
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1.1.1]
12
Mary Jane Watkins
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1.1.2]
[
=>
]
11
Elizabeth Perrow Bowles
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1.2]
Jr. Charles Henry Robertson
12
Paul Stuart Roberton
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1.2.1]
12
Catherine Watt Robertson
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1.2.2]
12
III Charles Henry Robertson
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1.2.3]
12
Elizabeth Perrow Robertson
[1.1.1.1.1.8.6.1.1.1.2.4]
7
Baldwin Matthews Payne
[1.1.1.1.1.8.7]
b. 11 Dec 1796 d. 1832/1887
+
Catherine Thompson Coles
b. 10 Feb 1795
7
Ann T. Payne
[1.1.1.1.1.8.8]
b. 1799 d. 1813/1893
+
Jeremiah Pannill
b. 1782/1802 d. 1816/1888
7
Eveline Washington Payne
[1.1.1.1.1.8.9]
b. 1801 d. 1815/1895
+
Edward Ball Withers
b. 1784/1804 d. 1818/1890
7
Camilla West Payne
[1.1.1.1.1.8.10]
b. 1803 d. 1817/1897
+
Samuel Scott
b. 1786/1806 d. 1820/1892
7
Elvira Henry Payne
[1.1.1.1.1.8.11]
b. 1805 d. 1806
7
Louisa Woodson Payne
[1.1.1.1.1.8.12]
b. 11 Oct 1807 d. 1821/1901
+
John Coles
b. 26 Apr 1799
7
Clarissa Aylette Payne
[1.1.1.1.1.8.13]
b. 1809 d. 1823/1903
+
Robert Wyatt
b. 1792/1812 d. 1826/1898
6
Anna Catharina Dandridge
[1.1.1.1.1.9]
b. 27 Jul 1767
John Spotswood Moore
b. Abt 1752 d. Abt 1810
7
Jr. John Spotswood Moore
[1.1.1.1.1.9.1]
b. Bef 1810 d. 1827/1900
Mary Virginia Murray
b. 1806/1826 d. 1827/1910
8
Sarah Elizabeth Moore
[1.1.1.1.1.9.1.1]
b. 1773/1856 d. 1830/1937
Albert M. Gurley
b. 1766/1854 d. 1798/1931
9
Francis Asbury Gurley
[1.1.1.1.1.9.1.1.1]
b. 1798/1888 d. 1826/1963
Mary Frances Haynes
b. 1799/1893 d. 1826/1970
10
Julia Claire Gurley
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1]
Roy Simmons
11
Jr. Roy Simmons
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1]
Helen Foster Cobb
12
III Roy Simmons
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.1]
12
William Frederick Simmons
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.2]
12
David Chester Simmons
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.3]
12
Anna Clare Simmons
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.4]
+
Watson N. Dandridge
b. 1778/1798 d. 1816/1882
7
Anne Catherine Moore
[1.1.1.1.1.9.2]
+
Thompson (Thomas) W. Pulliam
6
Mary Claiborne Dandridge
[1.1.1.1.1.10]
b. 14 Jan 1772 d. 26 Jul 1847
+
George Woodson Payne
b. 9 Oct 1767 d. 1788/1858
6
Martha Dandridge
[1.1.1.1.1.11]
b. 20 Sep 1748 d. 28 Sep 1791
Archibald Payne
b. 1748
7
Anne Spotswood "Nancy" Payne
[1.1.1.1.1.11.1]
b. 19 Apr 1772 d. 23 May 1813
Thomas Mann Randolph Fleming
b. 12 Feb 1767 d. 21 Feb 1801
8
II Tarleton Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1]
b. 12 Aug 1795 d. 27 Jul 1859
Rebecca Elizabeth Coles
b. 23 Apr 1802 d. 21 May 1872
9
Thomas Mann Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.1]
b. 22 Jan 1830 d. 21 Nov 1872
Virginia K. Pemberton
b. 1834 d. 1860
10
Rebecca Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.1.1]
b. 1857 d. 1903
George J. Anderson
11
Mary Anderson
[1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1]
+
James F. Howison
10
Cannon Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.1.2]
b. 1839/1887 d. 1852/1963
10
Virginia Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.1.3]
b. 1839/1887 d. 1851/1966
+
Virginia Morrison
b. 1813/1855 d. 1834/1935
9
Elizabeth Anne Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.2]
b. 15 Dec 1828 d. 7 Apr 1893
+
William Webb
b. 1805/1847 d. 1830/1925
9
Sarah Eleanor Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.3]
b. Abt 1833 d. 1830/1930
Jesse Hartwell Heath
b. 1805/1847 d. 1830/1925
10
Tarleton Fleming Heath
[1.1.1.1.1.11.1.1.3.1]
b. 30 Nov 1860 d. 25 Jul 1924
9
William Randolph Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.4]
b. 7 Jan 1832 d. 9 Nov 1892
Lelia Anna Shield
b. 18 Nov 1832 d. 24 Apr 1878
10
Jr. William Randolph Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.4.1]
b. 4 Mar 1859 d. 8 May 1898
10
Henry Corbin Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.4.2]
b. 11 Nov 1860 d. 6 May 1931
+
Lottie Webster
b. 1856/1875 d. 1877/1960
10
Orland Fairfax Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.4.3]
b. 9 Dec 1861 d. 1 Mar 1934
+
Belle Henley Harbold
b. 25 Jun 1867 d. 1891/1961
10
Tarleton Beverley Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.4.4]
b. 3 Oct 1866 d. 10 May 1898
10
Charles Spotswood Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.4.5]
b. 19 Sep 1871 d. 1912/1962
+
Rosa Lee Carpenter
10
Thomas Mann Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.4.6]
b. 2 Sep 1862 d. 10 Sep 1863
10
Samuel Shield Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.4.7]
b. 6 Oct 1873 d. 27 Oct 1943
9
Sarah Elenor "Sallie" Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.1.5]
b. 28 Feb 1834 d. 8 Feb 1916
8
Martha Dandridge Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.2]
b. 5 Oct 1793 d. 1823
+
Peter Cotton
b. 1765/1797 d. 1822/1884
8
Mary Page Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.3]
b. 23 Nov 1797 d. 1894
8
Ann Spotswood Fleming
[1.1.1.1.1.11.1.4]
b. 1790 d. 1794
7
Jr. Archer Payne
[1.1.1.1.1.11.2]
b. 29 Nov 1775 d. 1776/1865
7
Martha Payne
[1.1.1.1.1.11.3]
b. 6 Nov 1773 d. 1787/1867
Jeremiah Strother
b. 1750/1776 d. 1801/1863
8
Archer Strother
[1.1.1.1.1.11.3.1]
b. 1791/1814 d. 1811/1895
+
Fay
b. 1791/1822 d. 1811/1904
8
Martha Strother
[1.1.1.1.1.11.3.2]
b. 1791/1814 d. 1796/1898
7
Dorothea Dandridge Payne
[1.1.1.1.1.11.4]
b. 10 Jul 1777 d. 1800/1871
Edward Bolling
b. 17 Sep 1772 d. 1835
8
Powhatan Polling Bolling
[1.1.1.1.1.11.4.1]
b. Abt 1800 d. Aft 1840
Arminda R. Payne
b. 1790/1816 d. 1840/1904
9
Pocahontas J. Bolling
[1.1.1.1.1.11.4.1.1]
b. 1830 d. 1831/1924
9
Elvira G. Bolling
[1.1.1.1.1.11.4.1.2]
b. 1837 d. 1838/1931
7
Jane Spotswood Payne
[1.1.1.1.1.11.5]
b. 20 Oct 1780 d. 27 Feb 1807
+
Robert Bolling
b. Abt 1771
Jr. James Boswell Ferguson
b. 1781 d. 3 Sep 1858
8
Jane Elvira Ferguson
[1.1.1.1.1.11.5.1]
b. 6 Apr 1806 d. 8 Sep 1888
Peachy R. Grattan
b. 7 Nov 1801 d. 8 Sep 1881
9
Elizabeth Gilmer Grattan
[1.1.1.1.1.11.5.1.1]
b. 1837 d. 1838/1931
9
Sally Gray Grattan
[1.1.1.1.1.11.5.1.2]
b. 10 Aug 1838 d. 1852/1932
+
Otho G. Kean
b. 1821/1841 d. 1855/1927
9
Lucy Gilmer Grattan
[1.1.1.1.1.11.5.1.3]
b. 10 Aug 1838 d. 14 Oct 1890
William Felix Alexander
b. 7 May 1832 d. 16 Aug 1907
10
Elvira B. Alexander
[1.1.1.1.1.11.5.1.3.1]
b. 4 Jan 1869
Edgeworth Bird Baxter
b. 18 Jul 1868 d. 7 Oct 1910
11
Lucy Alexander Baxter
[1.1.1.1.1.11.5.1.3.1.1]
11
Elvira Grattan Baxter
[1.1.1.1.1.11.5.1.3.1.2]
9
James Ferguson Grattan
[1.1.1.1.1.11.5.1.4]
b. 11 Jul 1840 d. 1879
+
Morris
b. 1836/1856 d. 1857/1940
9
George Gilmer Grattan
[1.1.1.1.1.11.5.1.5]
b. 12 Oct 1844 d. 1845/1934
8
Robert Bolling Ferguson
[1.1.1.1.1.11.5.2]
7
Alexander Spotswood Payne
[1.1.1.1.1.11.6]
b. 20 Oct 1780 d. 1859
Charlotte Bryce
b. 15 Jun 1796 d. 1870
8
Charlotte Bryce Payne
[1.1.1.1.1.11.6.1]
b. 9 Jan 1829 d. 27 Oct 1915
John Hastings Winston
b. 1803/1829 d. 1853/1917
9
Charlotte P. Winston
[1.1.1.1.1.11.6.1.1]
b. 1847/1870 d. 1863/1954
+
Samuel Read
b. 1837/1869 d. 1863/1949
+
Alexander West
b. 1837/1869 d. 1863/1949
9
Sarah Althea Winston
[1.1.1.1.1.11.6.1.2]
b. 1847/1870 d. 1863/1954
+
John Brown
b. 1837/1869 d. 1863/1949
9
Harriett Winston
[1.1.1.1.1.11.6.1.3]
b. 1847/1870 d. 1863/1954
+
Gwathmey
b. 1837/1869 d. 1863/1949
9
Frank Winston
[1.1.1.1.1.11.6.1.4]
b. 1847/1870 d. 1852/1951
9
Mary Lee Winston
[1.1.1.1.1.11.6.1.5]
b. 1847/1870 d. 1852/1954
9
John Winston
[1.1.1.1.1.11.6.1.6]
b. 1847/1870 d. 1867/1951
+
Taylor
b. 1847/1878 d. 1867/1960
8
Harriett Jane Payne
[1.1.1.1.1.11.6.2]
b. 11 Feb 1831 d. 1876
+
William Steptoe
b. 1815/1847 d. 1872/1931
8
Lilias James Payne
[1.1.1.1.1.11.6.3]
b. 6 Dec 1824 d. 1825/1918
8
William Michel Payne
[1.1.1.1.1.11.6.4]
b. 15 Feb 1828 d. 31 Oct 1898
Frances A. Mitchell
b. 1817/1841 d. 1873/1930
9
Frances Dandridge Payne
[1.1.1.1.1.11.6.4.1]
b. 14 Sep 1871 d. 1885/1965
+
E. D. Brown
b. 1854/1874 d. 1888/1960
9
James Mitchell Payne
[1.1.1.1.1.11.6.4.2]
b. 8 Sep 1855 d. 19 Aug 1913
+
Margaret Belville
b. 1851/1870 d. 1872/1955
9
William Spotswood Payne
[1.1.1.1.1.11.6.4.3]
b. 16 May 1858 d. 9 Jul 1907
+
Mary Norvell
b. 1854/1873 d. 1875/1958
9
Ida Payne
[1.1.1.1.1.11.6.4.4]
b. 30 Apr 1860 d. 26 Mar 1880
9
Josephine Payne
[1.1.1.1.1.11.6.4.5]
b. 20 Nov 1861 d. 1875/1955
+
R. W. Wooten
b. 1844/1864 d. 1878/1950
9
J. Duche Payne
[1.1.1.1.1.11.6.4.6]
b. 7 Jul 1867 d. 1884/1957
+
Minnie Kohe
b. 1863/1883 d. 1884/1967
9
Alexander S. Payne
[1.1.1.1.1.11.6.4.7]
b. 31 Jul 1869 d. 1886/1959
+
Nora Van Lear Huddleson
b. 1865/1885 d. 1886/1969
8
James Ferguson Payne
[1.1.1.1.1.11.6.5]
b. 10 Sep 1814 d. 1831/1904
+
Frances Dudley
b. 1810/1830 d. 1831/1914
8
Martha Dandridge Payne
[1.1.1.1.1.11.6.6]
b. 20 Apr 1820 d. 1838/1914
Isaac Vandeventer
b. 1803/1823 d. 1838/1909
9
Robert Vandeventer
[1.1.1.1.1.11.6.6.1]
b. 1838/1861 d. 1843/1942
9
Helen Vandeventer
[1.1.1.1.1.11.6.6.2]
b. 1838/1861 d. 1854/1945
+
N. S. Purcell
b. 1828/1860 d. 1854/1940
8
Ann Bryce Payne
[1.1.1.1.1.11.6.7]
b. 3 May 1822 d. 12 Dec 1907
Henry Russell Smith
b. 1803/1834 d. 1862/1918
9
Lillias Smith
[1.1.1.1.1.11.6.7.1]
b. 17 Sep 1852 d. 1866/1946
+
Salmon M. Withers
b. 1835/1855 d. 1869/1941
9
Eliza Bell Smith
[1.1.1.1.1.11.6.7.2]
b. 18 Sep 1853 d. 1867/1947
+
James Isaac Hutton
b. 1836/1856 d. 1870/1942
9
Nansie Bryce Smith
[1.1.1.1.1.11.6.7.3]
b. 14 Jan 1857 d. 1871/1951
+
John Emil Roberts
b. 1840/1860 d. 1874/1946
9
Addison Melvin Smith
[1.1.1.1.1.11.6.7.4]
b. 3 Jul 1859 d. 1860/1949
8
Robert Spotswood Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8]
b. 15 Jan 1809 d. 28 Sep 1884
Frances Ann Russell Meem
b. 2 Apr 1819 d. 17 May 1870
9
John Meem Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1]
b. 11 Nov 1840 d. 16 May 1934
Elizabeth Allen Langhorne
b. 20 Dec 1842 d. 17 Jan 1936
10
Eliza Meem Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1.1]
b. 25 Oct 1877 d. 16 Jun 1957
10
Archer Langhorne Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1.2]
b. 24 Sep 1864 d. 1901
10
Robert Spotswood Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1.3]
b. 21 Jun 1866 d. 1920
10
John Meem Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1.4]
b. 30 Apr 1868 d. 1897
10
Margaret Kent Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1.5]
b. 12 Jan 1872 d. 17 Jan 1967
10
Daniel Allen Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1.6]
b. 5 Jan 1874 d. 19 Jan 1938
10
Francis Russell Meem Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1.7]
b. 9 Mar 1870
10
Andrew Russell Payne
[1.1.1.1.1.11.6.8.1.8]
b. 3 Mar 1876
8
George Woodson Payne
[1.1.1.1.1.11.6.9]
b. 29 Dec 1810 d. Jan 1870
+
Anne Elizabeth Dabney
b. 23 Sep 1814 d. 1839/1908
8
David Bryce Payne
[1.1.1.1.1.11.6.10]
b. 10 Aug 1812 d. 1888
Helen James
b. 1808/1828 d. 1833/1912
9
Ella Grattan Payne
[1.1.1.1.1.11.6.10.1]
b. 1833/1862 d. 1849/1944
+
George K. Turner
b. 1823/1860 d. 1849/1938
9
Robert Spotswood Payne
[1.1.1.1.1.11.6.10.2]
b. 1833/1862 d. 1853/1941
+
Meta Eskridge
b. 1832/1868 d. 1853/1948
9
David B. Payne
[1.1.1.1.1.11.6.10.3]
b. 1833/1862 d. 1853/1941
+
Ellen Scott
b. 1832/1868 d. 1853/1948
9
Richard J. Payne
[1.1.1.1.1.11.6.10.4]
b. 1833/1862 d. 1839/1941
9
Mary C. Payne
[1.1.1.1.1.11.6.10.5]
b. 1833/1862 d. 1838/1944
9
George A. W. Payne
[1.1.1.1.1.11.6.10.6]
b. 1833/1862 d. 1853/1941
+
Louise B. Mitchell
b. 1832/1868 d. 1853/1948
9
Helen Stockton Payne
[1.1.1.1.1.11.6.10.7]
b. 1833/1862 d. 1849/1944
+
Edward T. Page
b. 1823/1860 d. 1849/1938
8
Archer Alexander Payne
[1.1.1.1.1.11.6.11]
b. 28 Jul 1805 d. 20 Jul 1826
7
John Robert Dandridge Payne
[1.1.1.1.1.11.7]
b. 20 Nov 1770
Susan Bryce
8
Mary Jane Payne
[1.1.1.1.1.11.7.1]
James Alexander Turner
b. 15 Aug 1807 d. 19 Sep 1872
9
William Spotswood Turner
[1.1.1.1.1.11.7.1.1]
+
Juliet Holt
7
Catherine Payne
[1.1.1.1.1.11.8]
b. Abt 1780
Archibald Bolling
b. Abt 1770 d. 1829
8
Edward Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.1]
b. Abt 1793 d. 1855
+
Anne Cralle
b. 1786/1829 d. 1807/1909
8
Alexander Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.2]
b. 1785/1824 d. 1878
+
Susan Gray
b. 1786/1830 d. 1807/1909
8
Jefferson Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.3]
b. 1785/1824 d. 1797/1902
8
Catherine Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.4]
b. 1785/1824 d. 1796/1905
8
Pocahontas R. Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.5]
b. Abt 1810
+
William G. White
b. Est 1778/1822 d. Est 1803/1900
+
Peter J. Hill
b. 1815/1847 d. 1872/1934
8
Jr. Archibald Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6]
b. 1806 d. 1860
Anne E. Wiggington
b. 1795/1818 d. 1840/1906
9
William Holcombe Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1]
b. 29 May 1837 d. 6 Jul 1899
Sallie Spiers White
b. 5 Jan 1843 d. 21 Nov 1925
10
Rolfe Emerson Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.1]
b. 22 Aug 1861 d. 3 Feb 1936
Annie Stuart Litchfield
b. 19 Feb 1869 d. 12 Apr 1944
11
Elizabeth Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.1.1]
Jorge Eduardo Boyd
12
Lola Elizabeth Boyd
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.1.1.1]
12
Mildred Stuart Boyd
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.1.1.2]
12
Edith Bolling Boyd
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.1.1.3]
12
Elena Rolfe Boyd
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.1.1.4]
10
William Archibald Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.2]
b. 11 Oct 1867 d. 1899/1958
Mary Johnson Keller
b. 31 Mar 1870 d. 1899/1964
11
John Esten Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.2.1]
+
Edith Marion Bourne
11
William Holcombe Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.2.2]
+
Virginia Gaither
10
Bertha Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.3]
b. 11 Oct 1869 d. 1870/1963
10
Charles Rodefer Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.4]
b. 11 Jun 1871 d. 11 Jun 1871
10
Edith Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.5]
b. 15 Oct 1872 d. 28 Dec 1961
+
Norman Galt
b. 30 Apr 1866 d. 28 Jan 1908
+
Thomas Woodrow Wilson
b. 28 Dec 1856 d. 3 Feb 1924
10
John Randolph Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.6]
b. 11 Apr 1876 d. 1877/1966
10
Richard Wilmer Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.7]
b. 6 Oct 1879 d. 1913/1970
Elianor Hunter Lutz
11
Clara Lutz Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.7.1]
11
Jr. Richard Wilmer Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.7.2]
11
Sterling Ruffin Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.7.3]
11
Barbara Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.7.4]
10
Julian Brandon Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.8]
b. 7 May 1882 d. 1912/1973
+
Viola Roosevelt Belden
10
Geraldine Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.9]
b. 12 Aug 1885 d. 6 Jul 1887
10
Gertrude Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.10]
b. 16 May 1863 d. 1893/1957
Alexander Hunter Galt
b. 5 Dec 1860 d. 1893/1951
11
Alexander Bolling Galt
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.10.1]
10
Anne Lee Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11]
b. 15 Jun 1865 d. 26 Feb 1917
Matthew Hawes Maury
b. 9 Jun 1860 d. 10 Oct 1930
11
Anne Bolling Maury
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11.1]
John A. Goodloe
12
Jr. John A. Goodloe
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11.1.1]
12
Ann L. Goodloe
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11.1.2]
12
Matthew Maury Goodloe
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11.1.3]
12
Elizabeth Goodloe
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11.1.4]
11
Lucy Logwood Maury
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11.2]
John Edward Moeling
12
Sally Green Moeling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11.2.1]
b. 10 Aug 1937 d. 28 May 1965
12
Moeling
[1.1.1.1.1.11.8.6.1.11.2.2]
9
Harriet W. Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.2]
+
Robert H. Waddell
9
Mary Jefferson Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.3]
+
Rudolph Tuesler
9
John Blair Bolling
[1.1.1.1.1.11.8.6.4]
d. INFANT
7
America Payne
[1.1.1.1.1.11.9]
b. 5 Nov 1786 d. 1787/1880
7
Elizabeth Payne
[1.1.1.1.1.11.10]
b. 29 Oct 1782 d. 1783/1876
+
Jane Pollard
b. 25 May 1744 d. 13 Apr 1821
5
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.2]
b. Abt 1722 d. 1740/1816
Philip Whitehead Claiborne
b. 1705/1725 d. 5 Dec 1771
6
Philip Claiborne
[1.1.1.1.2.1]
b. 1740/1763 d. 1745/1844
6
Betty Claiborne
[1.1.1.1.2.2]
b. 1740/1763 d. 1762/1847
Esq. John Watkins
b. Abt 1732 d. 10 Mar 1785
7
John Dandridge Watkins
[1.1.1.1.2.2.1]
b. 1762/1797 d. 1771/1875
7
Elizabeth Watkins
[1.1.1.1.2.2.2]
b. 1762/1797 d. 1770/1878
7
Ann Dandridge Watkins
[1.1.1.1.2.2.3]
b. 1762/1797 d. 1770/1878
6
William Dandridge Claiborne
[1.1.1.1.2.3]
b. 1740/1763 d. 1763/1844
Anne Dandridge
b. 1759/1783 d. 1775/1867
7
Elizabeth Dandridge Claiborne
[1.1.1.1.2.3.1]
b. 1685/1800 d. 1802
Jr. William Langborne
b. 1622/1764 d. 1814
8
III William Langborne
[1.1.1.1.2.3.1.1]
b. 1651/1798 d. 1669/1876
8
Langborne
[1.1.1.1.2.3.1.2]
b. 1651/1798 d. 1668/1879
6
Philadelphia Claiborne
[1.1.1.1.2.4]
b. 1739/1758 d. 1776/1846
+
John Carter
b. 1719/1751 d. 1776/1838
+
Jr. Thomas Fox
b. 1729/1757 d. 1755/1839
5
Anna Dandridge
[1.1.1.1.3]
b. Abt 1723 d. 15 Dec 1781
+
Thomas Dansie
b. 1706/1726 d. 1740/1812
+
Davey
b. 1706/1726 d. 1740/1812
5
Martha Dandridge
[1.1.1.1.4]
b. Abt 1721 d. 25 Apr 1747
Philip Aylett
b. 1720 d. 1790
6
William Aylett
[1.1.1.1.4.1]
b. 1742 d. 12 Apr 1781
Mary Macon
b. Aft 1742 d. 1781/1837
7
Philip Aylett
[1.1.1.1.4.1.1]
b. 12 Mar 1767 d. 11 Sep 1831
Elizabeth Henry
b. 23 Apr 1769 d. 24 Sep 1842
8
Sarah Shelton Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.1]
b. 24 Jun 1811 d. 5 Mar 1875
William Spotswood Fontaine
b. 7 Nov 1810 d. 1882
9
Sarah Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.1]
b. 18 Jan 1848
Henry Sampson
b. 10 Mar 1847 d. 18 Sep 1915
10
Cornelia Dandridge Sampson
[1.1.1.1.4.1.1.1.1.1]
b. 1 Apr 1874 d. 13 Sep 1903
Malcolm Graham
b. Feb 1865
11
Sarah Aylett Graham
[1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1]
Frank W. Simpson
12
Jr. Frank W. Simpson
[1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1]
12
Geary Graham Simpson
[1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.2]
[
=>
]
12
William A. Simpson
[1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.3]
+
Powell
11
Malcolm Montrose Graham
[1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.2]
b. 16 Sep 1898
9
William Winston Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2]
b. 27 Nov 1834 d. 2 Nov 1917
Mary Adelaide Burrows
b. 4 Jan 1838 d. 28 Mar 1887
10
Elizabeth Adelaide Henry Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.1]
b. 6 Jan 1873 d. 19 Nov 1916
10
John Lansing Burrows Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.2]
b. 18 Jun 1868 d. 11 May 1913
+
Elizabeth Rose Waggener
b. 12 Apr 1870 d. 9 Oct 1925
10
William Winston Spottswood Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.3]
b. 16 Mar 1870 d. 19 Aug 1939
Florence West Evans
b. Mar 1877 d. 21 Jan 1928
11
Evan-Burrows Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.3.1]
Cornelius Vanderbilt Whitney
12
Neil “Sonny” Winston Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.3.1.1]
[
=>
]
+
Sterling Lawrence Adair
b. 18 Dec 1894 d. 14 Jan 1921
Harold “Stubby” Herman Kruger
b. 23 Sep 1898 d. 7 Oct 1965
12
Robert "Bobby" Kruger
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.3.1.2]
+
Jack Lynch
+
Mabel Kathleen Lawrence
b. Abt 1890
10
William Spottswood Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.4]
b. 27 Feb 1862 d. 28 Jul 1863
10
Mary Aylett Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.5]
b. 13 May 1866 d. 8 Aug 1933
10
Marion Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.2.6]
b. 10 Jan 1880 d. 10 Jan 1880
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3]
b. 1841 d. 1915
Annie Elizabeth Redd
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.1]
10
James Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.2]
b. 1888
10
John Winston Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.3]
b. 1887
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.1]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.1.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.1.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.1.3]
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.2]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.3]
b. 3 Dec 1897
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.4]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.4.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.4.2]
11
John Winston Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.5]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.5.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.6]
11
William Fontaine Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.7]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.4.8]
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.5]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.6]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.7]
b. 1879
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.8]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.3.9]
b. 1877
9
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.4]
b. 1838 d. 1856
9
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.5]
b. 1845 d. 1862
9
Marian Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.6]
b. 19 May 1840 d. 1913
+
John Hairston Redd
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
9
Alexander Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.7]
b. Abt 1836 d. CHILD
9
Elizabeth Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.4.1.1.1.8]
b. 28 Jun 1833
8
Mary Macon Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.2]
b. 5 Dec 1793 d. 6 Oct 1836
Philip FitzHugh
b. 1790 d. 21 Dec 1836
9
Patrick Henry FitzHugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.1]
b. 2 Dec 1818 d. 18 Jun 1864
+
Mary Christian
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Elizabeth Henry Fitzhugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.2]
b. 12 May 1816 d. 1827
+
Robert Curtis
b. 1801/1842 d. 1827/1920
9
Lucy FitzHugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.3]
b. 8 Oct 1819 d. 1827
+
Samuel C. Redd
b. 1801/1842 d. 1827/1920
9
John Henry Fitzhugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.4]
b. 20 Dec 1821 d. 9 May 1894
+
Hattie Bullitt
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Philip Aylett Fitzhugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.5]
b. 14 Jun 1824 d. 7 Jun 1908
+
Georgia Tankard
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Edwin FitzHugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.6]
b. 1809/1844 d. 1818/1922
9
LaFayette Henry Fitzhugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.7]
b. 9 May 1829 d. 1 Aug 1905
+
E. Semple
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Thaddeus FitzHugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.8]
b. 1809/1844 d. 1830/1922
+
Julia Horsey
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Mary FitzHugh
[1.1.1.1.4.1.1.2.9]
b. 26 Jan 1826 d. 18 Feb 1826
8
Jr. Philip Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3]
b. 7 Dec 1791 d. 1835/1883
Judith Page Waller
b. 1786/1811 d. 1836/1898
9
William Roane Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.1]
b. 1833 d. 1878/1925
Alice R. Brockenbrough
b. 1823/1849 d. 1878/1937
10
Sarah Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.1.1]
b. 1861 d. 1862/1955
10
Pattie Waller Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.1.2]
b. 1862 d. 1863/1956
10
Philip Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.1.3]
b. 1867 d. 1868/1957
10
Alice Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.1.4]
b. 1868 d. 1869/1962
10
William R. Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.1.5]
b. 1872 d. 1873/1962
10
Bessie Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.1.6]
b. 1873 d. 1874/1967
10
Patrick Henry Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.1.7]
b. 1876 d. Sep 1943
9
Rosalie Page Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.2]
b. 1812/1841 d. 1828/1923
+
Norman D. Sampson
b. 1802/1839 d. 1828/1917
9
Patrick Henry Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.3]
b. 19 May 1825 d. 27 Apr 1870
Emily Ann Coles Rutherfoord
b. Abt 1830
10
Sarah Bennett Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.3.1]
b. 1855
+
Jr. Thomas Randolph Bolling
10
Judith Page Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.3.2]
b. 1860 d. 1942
+
William Laurence Royall
b. 15 Nov 1844
10
Emily Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.3.3]
b. 1853 d. 1911
+
Jr. John Enders
9
Anne Henry Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.4]
b. 1812/1851 d. 1821/1931
9
Benjamin W. Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.5]
b. 1812/1851 d. 1821/1928
9
Cora Dandridge Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.6]
b. 1812/1851 d. 1821/1931
9
Pattie Waller Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.3.7]
b. 1812/1841 d. 1828/1923
+
Patrick Henry Cabell
b. 10 May 1827 d. 19 Oct 1865
+
Henry A. Ware
b. 1802/1839 d. 1828/1917
+
James Bliss
b. 1802/1839 d. 1828/1917
8
William Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.4]
b. 1807 d. 11 Feb 1829
8
Patrick Henry Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.5]
b. Jun 1808 d. 28 Jan 1829
8
Martha Dandridge Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.6]
b. 5 Apr 1801 d. 1833
+
Silas M. Duncan
b. 1788 d. 14 Sep 1834
8
Anna Henry Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.7]
b. 1803 d. 2 Jan 1828
Thomas Moore
b. 1777/1809 d. 1809/1889
9
Anna H. Moore
[1.1.1.1.4.1.1.7.1]
b. 1809/1844 d. 1827/1925
+
W. G. Gwathmey
b. 1801/1842 d. 1827/1920
9
Elizabeth Moore
[1.1.1.1.4.1.1.7.2]
b. 1809/1844 d. 1827/1925
John Milton Dabney
b. 1801/1842 d. 1827/1920
10
Lucie Dabney
[1.1.1.1.4.1.1.7.2.1]
+
James W. Powell
8
Elizabeth Henry Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.8]
b. Nov 1798 d. 14 Nov 1818
+
William Spotswood Fontaine
b. 7 Nov 1810 d. 1882
8
Louisa Fontaine Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.9]
b. Mar 1805 d. 19 Aug 1822
8
Patrick Henry Aylett
[1.1.1.1.4.1.1.10]
b. 7 Dec 1789 d. 18 Nov 1799
7
William Aylett
[1.1.1.1.4.1.2]
b. 1761/1781 d. 1767/1864
7
Ann Dandridge Aylett
[1.1.1.1.4.1.3]
b. 1778 d. 1818
+
Andrew Alexander
b. 1768 d. 1844
7
Elizabeth Aylett
[1.1.1.1.4.1.4]
b. Abt 1769 d. 1793/1863
Alexander Spotswood Moore
b. 1763 d. 1793/1854
8
Mildred Walker Moore
[1.1.1.1.4.1.4.1]
b. 1785/1811 d. 1791/1894
6
John Aylett
[1.1.1.1.4.2]
b. 1748 d. 7 Feb 1776
Elizabeth Dandridge
b. 25 May 1749 d. 1776
7
William Aylett
[1.1.1.1.4.2.1]
b. 15 Jun 1774 d. 29 Aug 1777
7
John Aylett
[1.1.1.1.4.2.2]
b. 17 Feb 1776 d. 24 Aug 1777
6
Unity Aylett
[1.1.1.1.4.3]
b. 1740
6
Anne Aylett
[1.1.1.1.4.4]
b. 1744
5
Mary Dandridge
[1.1.1.1.5]
b. 1725 d. 1798
+
John Campbell
b. 1708/1738 d. 1763/1823
John M. Spotswood
d. 6 May 1756
6
Alexander Spotswood
[1.1.1.1.5.1]
b. 16 Oct 1746 d. 20 Dec 1818
Elizabeth Washington
b. 15 Nov 1749 d. 20 Oct 1814
7
Elizabeth Jane Spotswood
[1.1.1.1.5.1.1]
b. 16 May 1777 d. 20 Oct 1777
7
Elizabeth Butler Spotswood
[1.1.1.1.5.1.2]
b. 12 Sep 1781 d. 27 Jun 1805
+
Mann Page
b. 1777 d. 1810
7
Mary Randolph Spotswood
[1.1.1.1.5.1.3]
b. 29 Jun 1775 d. 16 Jan 1803
+
Francis Taliaferro Brooke
b. 1739/1771 d. 1796/1858
7
Anne Washington Burwell Spotswood
[1.1.1.1.5.1.4]
b. 18 Sep 1779 d. Dec 1822
+
Baldwin Taliaferro
b. 27 Apr 1776 d. Aft 1840
7
Henrietta Brayne Spotswood
[1.1.1.1.5.1.5]
b. 29 Aug 1786 d. 10 Aug 1860
+
Taliaferro
b. 1758/1778 d. 1792/1864
+
Bushrod Washington
b. 4 Apr 1785 d. 1830
7
Martha Ann Maria Spotswood
[1.1.1.1.5.1.6]
b. 29 Sep 1790 d. 21 Sep 1826
7
John Augustine Spotswood
[1.1.1.1.5.1.7]
b. 7 Jun 1771 d. 16 Apr 1806
7
George Augustine Washington Spotswood
[1.1.1.1.5.1.8]
b. 5 Jan 1783 d. 24 Nov 1844
Lucy Spotswood
b. 21 Jul 1783 d. 1866
8
William Augustine Washington Spotswood
[1.1.1.1.5.1.8.1]
b. 2 Oct 1806 d. 7 Sep 1891
8
Charles Fenton Mercer Spotswood
[1.1.1.1.5.1.8.2]
b. 22 Feb 1813 d. 6 Aug 1892
7
William Lawrence McCarty Spotswood
[1.1.1.1.5.1.9]
b. 7 Oct 1791 d. 1871
+
Catherine Ann Jones
b. Bef 1800 d. Abt 1835
7
Alexander Eilliott Spotswood
[1.1.1.1.5.1.10]
b. 1 Dec 1769 d. 1842
7
William Lafayette Spotswood
[1.1.1.1.5.1.11]
b. 29 Aug 1786 d. 30 Aug 1786
7
Ann Spotswood
[1.1.1.1.5.1.12]
b. 15 Jul 1773 d. 16 Aug 1774
7
Robert Spotswood
[1.1.1.1.5.1.13]
b. 15 Jul 1772 d. 24 Jul 1772
6
Jr. John Spotswood
[1.1.1.1.5.2]
b. 1748 d. 1795/1840
Sarah Rowzie
b. 1735/1760 d. 1795/1850
7
Mary Spotswood
[1.1.1.1.5.2.1]
b. 1772 d. 1786/1866
+
Nicholas Voss
b. 1755/1775 d. 1789/1861
7
John Spotswood
[1.1.1.1.5.2.2]
b. 1774 d. 1791/1864
+
Mary Goode
b. 1770/1790 d. 1791/1874
7
Susan Spotswood
[1.1.1.1.5.2.3]
b. 1776 d. 1790/1870
+
John Bott
b. 1759/1779 d. 1793/1865
7
Robert Spotswood
[1.1.1.1.5.2.4]
b. 1780 d. 1801/1870
Louisa Bott
b. 1776/1796 d. 1801/1880
8
John Bott Spotswood
[1.1.1.1.5.2.4.1]
b. 1801/1830 d. 1807/1909
7
Dandridge Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5]
b. 1789 d. 1841/1881
Catherine Brooke Francisco
b. 1801 d. 1842/1896
8
William Francisco Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.1]
b. 16 Feb 1824 d. 13 Apr 1895
+
Isabella Matoaca Dunlop
b. 1820/1839 d. 1841/1924
8
Joseph Edwin Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.2]
b. 1829 d. 1846/1919
+
Lucy Starke Cooper
b. 1825/1845 d. 1846/1929
8
Catherine Dandridge Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.3]
b. 31 Aug 1831 d. INFANT
8
Benjamin Henry Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.4]
b. 16 Jun 1833 d. 22 Apr 1843
8
Rosa Brooke Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.5]
b. 1836 d. 1850/1930
+
F. N. Strudwick
b. 1819/1839 d. 1853/1925
8
Alexander Dandridge Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.6]
b. 1838 d. 9 Jul 1840
8
Elizabeth Robinson Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.7]
b. 2 Aug 1840 d. 1841/1934
8
Alexander Elliott Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.8]
b. 2 Jun 1821 d. 21 Nov 1834
8
Dandridge Rowzie Spotswood
[1.1.1.1.5.2.5.9]
b. 12 Oct 1823 d. 1 Sep 1830
7
Norborne Berkeley Spotswood
[1.1.1.1.5.2.6]
b. 1790 d. 1807/1880
+
Sallie Markham
b. 1786/1806 d. 1807/1890
7
Elliott Spotswood
[1.1.1.1.5.2.7]
b. 1782 d. 1799/1872
+
Sallie Littlepage
b. 1778/1798 d. 1799/1882
7
Lucy Spotswood
[1.1.1.1.5.2.8]
b. 21 Jul 1783 d. 1866
George Augustine Washington Spotswood
b. 5 Jan 1783 d. 24 Nov 1844
8
William Augustine Washington Spotswood
[1.1.1.1.5.2.8.1]
b. 2 Oct 1806 d. 7 Sep 1891
8
Charles Fenton Mercer Spotswood
[1.1.1.1.5.2.8.2]
b. 22 Feb 1813 d. 6 Aug 1892
7
Annie Spotswood
[1.1.1.1.5.2.9]
b. 1793 d. 1807/1887
+
William Robertson
b. 1776/1796 d. 1810/1882
7
Sarah Spotswood
[1.1.1.1.5.2.10]
b. 1785 d. 1799/1879
+
Roger Atkinson
b. 1768/1788 d. 1802/1874
+
George Whitlock
b. 1768/1788 d. 1802/1874
6
Mary Spotswood
[1.1.1.1.5.3]
b. 1752 d. 1766/1846
+
Peter Randolph
b. 1735/1755 d. 1769/1841
6
Anne Spotswood
[1.1.1.1.5.4]
b. 1748 d. 14 Feb 1789
V Lewis Armistead Burwell
b. 26 Sep 1745 d. 2 Jul 1800
7
Ann Spotswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.1]
b. 14 Feb 1773 d. 1814
+
John "Mad Jack" Ravenscroft
b. 17 Apr 1772 d. 5 Mar 1830
7
Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.2]
b. 26 Jun 1770 d. 28 Nov 1820
Lucy Crawley
b. 30 Dec 1775 d. 14 Nov 1825
8
Sally T. Burwell
[1.1.1.1.5.4.2.1]
b. Abt 1792 d. 1793/1886
8
Matilda Boyd Burwell
[1.1.1.1.5.4.2.2]
b. 3 Aug 1805 d. 11 Apr 1876
+
Lewis Dandridge Burwell
b. 13 Jul 1813 d. 19 Jan 1874
8
Harriet Dandridge Burwell
[1.1.1.1.5.4.2.3]
b. 5 Oct 1811 d. 18 May 1896
+
William Duke Jones
b. 28 May 1801 d. 14 Dec 1876
8
John Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.2.4]
b. 6 Apr 1813 d. 18 Aug 1857
+
Lucy Penn Guy
b. 29 May 1814 d. 13 Jul 1859
8
Lucy Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.2.5]
b. 25 Dec 1801 d. 17 Feb 1860
7
Elizabeth Blair Burwell
[1.1.1.1.5.4.3]
b. 19 Jun 1774 d. 27 Aug 1833
+
Edward Lowry Tabb
b. 6 Jan 1769 d. 1797
7
Mary Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.4]
b. 30 Dec 1768 d. 20 Mar 1829
Samuel Goode
b. 21 Mar 1756 d. 14 Jan 1822
8
Thomas Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1]
b. 31 Oct 1787 d. 2 Apr 1858
Mary Ann Knox
b. 17 Dec 1797 d. 1 May 1871
9
Thomas Francis Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1]
b. 29 Jun 1825 d. 6 Jan 1905
Rosa Cowles Chambers
b. 6 Feb 1842 d. 20 Jan 1921
10
Jr. Thomas Francis Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.1]
b. 27 May 1869 d. Jan 1941
10
St. John Chambers Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.2]
b. 27 Jul 1879
Lucille Randolph Pleasants
11
Virginia Chambers Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.2.1]
11
William Sterling Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.2.2]
11
Mary Louise Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.2.3]
11
Katherine Randolph Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.2.4]
11
John Chambers Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.2.5]
10
Edward Chambers Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.3]
b. 1 Mar 1862 d. 25 Jun 1933
Maria Belle Morton
b. Mar 1861 d. 22 Jan 1901
11
Marguerite Keen Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.3.1]
b. 30 Oct 1888 d. 10 Jul 1930
11
Benjamin Douglas Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.3.2]
b. 24 Dec 1889 d. 18 May 1928
11
Gordon Murray Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.3.3]
b. 28 Jun 1893 d. 25 Jul 1962
11
Rose Chambers Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.3.4]
11
Mable Laird Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.3.5]
11
Virginia Morton Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.3.6]
+
Alice M.
10
Kate Tucker Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.4]
b. 22 Nov 1863 d. 19 Nov 1917
10
Marion Knox Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.5]
b. 24 May 1865 d. 30 Sep 1954
Phillip Jackson Briscoe, Jr
b. 15 Dec 1855 d. 20 Jan 1940
11
Rose Chambers Briscoe
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.5.1]
11
Thomas Goode Briscoe
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.5.2]
b. 1886 d. 28 Jun 1887
11
Charlotte James Briscoe
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.5.3]
b. Apr 1888
11
Marion Knox Briscoe
[1.1.1.1.5.4.4.1.1.5.4]
9
Samuel Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.2]
b. 20 Oct 1823 d. 29 Jan 1908
Mary Gatewood Massie
10
Mary Eugenia Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.2.1]
10
Nellie Pleasants Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.2.2]
10
William Alfred Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.2.3]
10
Aurelia Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.2.4]
10
Florine Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.2.5]
9
Martha Ward Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.3]
b. 12 Jan 1821 d. 2 Aug 1861
Samuel Goode Jones
b. 20 Sep 1815
10
Thomas Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.1]
b. 26 Nov 1844 d. 28 Apr 1914
Gena C. Bird
11
Marshall Bird Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.1.1]
b. 3 Nov 1869
11
Gena Moore Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.1.2]
b. 26 Nov 1871
11
Martha Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.1.3]
b. 10 Aug 1874
11
Carrie Bird Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.1.4]
b. 25 Aug 1876
11
Gordon Houston Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.1.5]
b. 15 Jun 1880
11
Thomas Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.1.6]
b. 9 Jun 1885
10
Charles Pollard Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.2]
b. 13 Jun 1858
10
Mary Virginia Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.3]
b. 6 Apr 1847
+
William Gesner
10
Jr. Samuel Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.4]
b. 2 Dec 1849 d. 16 May 1854
10
Lucy Spotswood Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.5]
b. 3 Aug 1851 d. 1 Feb 1879
+
F. H. Armstrong
10
Edwin Francis Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.6]
b. 21 Dec 1853
Bertha Stubbs
11
Samuel Baytop Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.6.1]
10
Carter Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.7]
b. 19 Sep 1855
10
Martha Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.1.3.8]
b. 13 Nov 1856 d. 8 Feb 1859
9
Ellen Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.4]
b. 3 Aug 1838 d. 20 Jan 1920
+
William G. Friend
9
Sophia Louisa Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.5]
b. 7 Apr 1822 d. 19 Jan 1904
9
Isabella Scott Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.6]
b. 15 Mar 1841 d. 26 Apr 1914
9
Lucy Knox Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.7]
b. 1830 d. 22 Feb 1881
George William Brent
b. Aug 1821 d. 2 Jan 1872
10
Jessie Innis Brent
[1.1.1.1.5.4.4.1.7.1]
b. 15 Jan 1870
10
Thomas Goode Brent
[1.1.1.1.5.4.4.1.7.2]
b. 3 Feb 1852
10
Lucy Brent
[1.1.1.1.5.4.4.1.7.3]
b. 11 Jul 1853
+
William G. Howard
+
Robert T. Thorp
10
Samuel Gordon Brent
[1.1.1.1.5.4.4.1.7.4]
b. 28 Jun 1855 d. 6 May 1928
10
Mary E. Brent
[1.1.1.1.5.4.4.1.7.5]
b. 2 Sep 1857 d. 27 Dec 1950
+
Charles A. Read
10
George G. Brent
[1.1.1.1.5.4.4.1.7.6]
b. 3 Jan 1860
10
Alice Virginia Brent
[1.1.1.1.5.4.4.1.7.7]
b. 8 Nov 1863 d. 20 Jun 1927
10
Cornelia W. Brent
[1.1.1.1.5.4.4.1.7.8]
b. 8 Nov 1863 d. 6 Jan 1946
9
Alice Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.8]
b. 18 Mar 1831 d. 12 Jun 1903
William Crump
d. Abt 1869
10
Sallie Crump
[1.1.1.1.5.4.4.1.8.1]
+
Goodwin
10
Alice Crump
[1.1.1.1.5.4.4.1.8.2]
10
William Crump
[1.1.1.1.5.4.4.1.8.3]
10
Ellen Crump
[1.1.1.1.5.4.4.1.8.4]
10
Mary Crump
[1.1.1.1.5.4.4.1.8.5]
9
Margaret Knox Goode
[1.1.1.1.5.4.4.1.9]
d. 1868
William Phillips Garland
b. 27 Sep 1833 d. 14 Apr 1863
10
Willie Phillips Garland
[1.1.1.1.5.4.4.1.9.1]
b. Mar 1863
8
Mary Armistead Goode
[1.1.1.1.5.4.4.2]
Thomas Williamson Jones
9
Samuel Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1]
b. 20 Sep 1815
Martha Ward Goode
b. 12 Jan 1821 d. 2 Aug 1861
10
Thomas Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.1]
b. 26 Nov 1844 d. 28 Apr 1914
Gena C. Bird
11
Marshall Bird Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.1.1]
b. 3 Nov 1869
11
Gena Moore Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.1.2]
b. 26 Nov 1871
11
Martha Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.1.3]
b. 10 Aug 1874
11
Carrie Bird Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.1.4]
b. 25 Aug 1876
11
Gordon Houston Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.1.5]
b. 15 Jun 1880
11
Thomas Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.1.6]
b. 9 Jun 1885
10
Charles Pollard Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.2]
b. 13 Jun 1858
10
Mary Virginia Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.3]
b. 6 Apr 1847
+
William Gesner
10
Jr. Samuel Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.4]
b. 2 Dec 1849 d. 16 May 1854
10
Lucy Spotswood Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.5]
b. 3 Aug 1851 d. 1 Feb 1879
+
F. H. Armstrong
10
Edwin Francis Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.6]
b. 21 Dec 1853
Bertha Stubbs
11
Samuel Baytop Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.6.1]
10
Carter Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.7]
b. 19 Sep 1855
10
Martha Goode Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.1.8]
b. 13 Nov 1856 d. 8 Feb 1859
+
Aurie Elmore
9
Edwin Burwell Jones
[1.1.1.1.5.4.4.2.2]
7
John Spotswood Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.5.4.5]
b. 15 May 1776 d. 25 Apr 1854
Elizabeth Middleton Woods
b. 8 Mar 1790 d. 20 Nov 1863
8
Armistead Lewis Burwell
[1.1.1.1.5.4.5.1]
b. 1812 d. 1883
7
Lewis Burwell
[1.1.1.1.5.4.6]
b. 14 Dec 1779 d. 15 Apr 1847
Sally Edwards Green
b. 1784 d. 1880
8
Abram Lewis Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1]
b. 11 Apr 1805 d. 1887
Elizabeth Bloombury Peterson Wathall
b. 1818 d. 1884
9
Lewis Moton Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.1]
b. 1843 d. 1844
9
Sally Lewis Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.2]
b. 7 Feb 1845 d. 17 Dec 1891
+
Joseph Randolph Mitchell
b. 4 Jul 1836 d. 18 Nov 1902
9
Virginia A. Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.3]
b. 1848 d. 1849/1942
9
Charles Blair Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.4]
b. 1850 d. 1925
9
William Lewis Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.5]
b. 1852 d. 1923
+
Margaret Virginia Hall
b. 1875 d. 1952
9
Betty Brown Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.6]
b. 1854 d. 1929
+
Milton Walter Wagner
b. 6 Sep 1859 d. 19 Sep 1915
9
Henry Bascom Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7]
b. 1858 d. 1927
Mamie Jane Swett
b. 1867 d. 1933
10
Harriet Harris Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1]
Ansley Powell Carney
b. 7 May 1890 d. 11 Oct 1968
11
Carolyn Carney
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1.1]
James Newton Holland
12
Volna Harriet Holland
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1.1.1]
[
=>
]
12
Carrol Lynn Holland
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1.1.2]
12
Jr. James Newton Holland
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1.1.3]
12
Susan Holland
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1.1.4]
11
Jr. Ansley Powell Carney
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1.2]
11
Nell Harris Carney
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1.3]
11
Harry David Ben Carney
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.1.4]
10
Celest Lousia Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.2]
b. 1897 d. 1953
10
Annie Lewis Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.3]
10
Vernice Grace Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.4]
b. 1894 d. 1894
10
Russel Gladwin Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.5]
10
Jakie Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.6]
b. 1903 d. 1903
10
Henry Wadsworth Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.7]
b. 1906 d. 1972
10
Marrie Ray Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.1.7.8]
b. 1908 d. 1908
8
Allen Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.2]
b. 6 Jun 1808 d. 1885
8
Jr. Lewis Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.3]
b. 5 Aug 1811 d. 1898
8
John Spotswood Randolph Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.4]
b. 2 Feb 1813 d. 1877
+
Panthea Eliza Boyd
b. 28 Aug 1821 d. 14 Aug 1851
8
William Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.5]
b. 27 Jun 1827 d. 29 Dec 1866
8
Ann Elizabeth Burwell
[1.1.1.1.5.4.6.6]
b. 4 Nov 1806 d. 1884
+
Thedrick M. Roberts
b. 1789/1809 d. 1823/1895
7
Panthea Burwell
[1.1.1.1.5.4.7]
b. 13 Nov 1781 d. 13 Nov 1848
John Richard Boyd
b. 16 Oct 1771 d. 13 Oct 1860
8
Panthea Eliza Boyd
[1.1.1.1.5.4.7.1]
b. 28 Aug 1821 d. 14 Aug 1851
+
John Spotswood Randolph Burwell
b. 2 Feb 1813 d. 1877
7
John Spotswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8]
b. 15 Jan 1785 d. 1 Jan 1855
Mary Green Marshall
b. 13 Dec 1792 d. 12 Jan 1856
8
Mary Ann Spottswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.1]
b. 25 Nov 1825 d. 1854
+
Otis F. Manson
b. 1798/1825 d. 1848/1912
8
Robert Randolph Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.2]
b. 16 Jan 1829 d. 9 Dec 1892
Jessie Atherton Dawson
b. 17 Feb 1841 d. 14 Feb 1899
9
Temperance Williams Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.2.1]
b. 1854/1881 d. 1860/1964
8
William Marshall Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.3]
b. 4 Sep 1809 d. 15 May 1887
+
Mary Graves Williams
b. 15 Jul 1810 d. 1 Oct 1896
8
John Spotswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.4]
b. 18 Aug 1811 d. 31 May 1889
Sarah Elizabeth Hayes
b. 10 Sep 1814 d. 22 Sep 1865
9
Spotswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.4.1]
b. 7 Jan 1847 d. 23 Jan 1913
9
Martha Harrison Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.4.2]
b. Abt 1849 d. 1850/1943
9
Mary Lewis Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.4.3]
b. Abt 1851 d. 1852/1945
8
Lewis Dandridge Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.5]
b. 13 Jul 1813 d. 19 Jan 1874
+
Matilda Boyd Burwell
b. 3 Aug 1805 d. 11 Apr 1876
8
Blair Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.6]
b. 5 Oct 1815 d. 30 Mar 1848
Mary S. Davis
b. 1805/1826 d. 1848/1915
9
Laura Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.6.1]
+
Laura Blair
b. 1811/1828 d. 1832/1914
8
Henry Harrison Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.7]
b. 5 Mar 1818 d. 12 Aug 1884
Susan Caroline Hargrove
b. 20 Sep 1820 d. 25 May 1897
9
Jr. Henry Harrison Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.7.1]
b. Abt 1852 d. 8 Mar 1919
9
John Spotswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.7.2]
b. 19 Feb 1857 d. 9 Sep 1926
9
Susan Caroline Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.7.3]
b. 15 Oct 1858 d. 30 Jun 1934
9
Nannie Hargrove Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.7.4]
b. 18 Sep 1854 d. 1855/1948
9
Samuel Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.7.5]
b. 1864 d. 1938
8
George Washington Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.8]
b. 12 Mar 1823 d. 16 Jun 1873
+
Elizabeth F. Gayle
b. 27 Oct 1827 d. 2 Aug 1872
8
Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9]
b. 30 Oct 1820 d. 8 Aug 1889
Elizabeth Kyle Norman
b. 5 Mar 1832 d. 28 Aug 1889
9
Thomas Norman Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.1]
b. Abt 1853
+
Mary Alice Travis
b. 1849/1869 d. 1870/1953
9
Elizabeth Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.2]
b. 2 Aug 1862 d. 14 Nov 1944
+
John J. Parris
b. 1845/1865 d. 1879/1951
9
Sallie B. Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.3]
b. Abt 1859
+
Lycurgus L. Thomas
b. 1859
9
Isaac Norman Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.4]
b. Abt 1861 d. 1862/1951
9
Jr. Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.5]
b. Abt 1863
9
William Spottswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6]
b. 20 Jan 1855 d. 8 Nov 1943
Alice Josephine Morton
b. 1 Feb 1863 d. 20 Sep 1947
10
Annie Rochette Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1]
Jr. Andrew Bascom Spencer
b. 21 Jun 1884 d. 8 Nov 1956
11
Edward William Wright Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.1]
b. 1924 d. 1953
11
Sallie Spottswood Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.2]
11
III Andrew Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.3]
b. 1919 d. 1919
11
Willie Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.4]
b. 1919 d. 1919
11
Annie Venable Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.5]
11
Alice Dugger Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.6]
11
Mary Elizabeth Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.7]
11
Frank Charles Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.8]
11
Helen Jean Spencer
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.1.9]
10
Isaac Norman Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.2]
10
Margaret Venable Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3]
Howard Badgett Hester
b. 12 Aug 1892 d. 7 Aug 1971
11
Mary Hamilton Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.1]
11
Howard June Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.2]
b. 1920 d. 9 Nov 1925
11
Benjamin Spottswood Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.3]
11
Jeanette Burwell Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.4]
11
Margaret Parish Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.5]
b. 1929 d. 16 Nov 1932
11
Alice Armistead Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.6]
11
Alice Thomas Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.7]
11
Lois Howard Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.8]
11
Anne Morton Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.9]
11
Margaret Hester
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.3.10]
10
Sallie Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.4]
10
Nathaniel Daniel Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.5]
b. Mar 1896 d. Bef May 1900
10
Joseph William Thomas Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6]
b. 26 May 1898 d. 1 Jul 1970
Annie Hamilton Lee
11
Jr. Joseph William Thomas Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.1]
b. 1922 d. 1965
11
Bettie Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.2]
b. 1930 d. 1930
11
Margaret Lee Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.3]
11
Henrietta Drake Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.4]
11
William Lee Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.5]
11
Annie Hamilton Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.6]
11
Ruth Howard Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.7]
11
Nathaniel Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.8]
11
John Spottswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.9]
11
Jean Adams Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.6.10]
10
Nathaniel Daniel Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.7]
Josephine Babcock
11
Venable Babcock Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.7.1]
11
Augusta Jo Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.7.2]
11
Virginia Leach Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.7.3]
11
Jr. Nathaniel Daniel "Nat" Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.7.4]
11
Joy Kyle Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.7.5]
10
Jr. William Spottswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8]
b. 4 Aug 1884 d. 29 Oct 1940
Alexine Gregory Knott
b. 27 Dec 1888 d. 24 Sep 1972
11
John Buxton Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.1]
Annie Doris Riggan
12
Brenda Joyce Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.1.1]
11
Richard Taylor Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.2]
b. 12 Nov 1926 d. 6 Dec 1963
11
Josephine Jackson Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.3]
11
James Morton Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.4]
11
III William Spottswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.5]
11
Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.6]
11
Edna Mae Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.7]
11
Samuel Watkins Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.8]
11
Frances Iola Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.9]
11
Sallie Alexine Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.10]
11
Samuel Watkins Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.11]
11
Sallie Alexine Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.12]
11
Iola Frances Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.13]
11
Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.14]
11
Edna Mae Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.8.15]
10
Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.9]
b. 21 Apr 1886 d. 7 Jun 1956
10
James Morton Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.10]
b. 10 Aug 1888 d. 3 Sep 1954
Percye Carrington Rudd
11
Taylor Spottswood Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.10.1]
11
Nancy Meade Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.10.2]
b. 31 Jul 1917 d. 1918
11
Percye Venable Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.10.3]
11
James Sidney Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.10.4]
10
Bettie Armistead Burwell
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11]
b. 7 Apr 1883 d. 23 Nov 1959
William Henry Wilson
b. 12 Aug 1876 d. 16 Oct 1957
11
Margaret Elizabeth Wilson
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.1]
Joseph Kenneth Dean
12
Jerry Kenneth Dean
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.1.1]
11
Alice Morton Wilson
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2]
Roy Allen Cates
b. 20 Sep 1909 d. 8 Jun 1958
12
Jr. Roy Allen Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.1]
[
=>
]
12
George Henry Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.2]
[
=>
]
12
David Clifford Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.3]
12
William Wilson Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.4]
[
=>
]
12
John Douglas Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.5]
[
=>
]
12
Brenda Anne Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.6]
[
=>
]
12
Betty Morton Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.7]
[
=>
]
12
Alice Marie Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.8]
[
=>
]
12
Jean Phyllis Cates
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.2.9]
[
=>
]
11
Jr. William Henry Wilson
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.3]
Hazel Iris Oliver
12
Joan Carol Wilson
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.3.1]
12
Judy Elaine Wilson
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.3.2]
12
Iris Jean Wilson
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.3.3]
12
Donald King Wilson
[1.1.1.1.5.4.8.9.6.11.3.4]
7
Matilda Boyd Burwell
[1.1.1.1.5.4.9]
b. 10 Jan 1787 d. 9 May 1867
+
Alexander Boyd
b. Abt 1783 d. 1804/1876
7
Christian Burwell
[1.1.1.1.5.4.10]
b. 8 Dec 1774
+
William Hamblin
b. Abt 1770
7
Blair Burwell
[1.1.1.1.5.4.11]
b. 29 May 1783 d. 8 Aug 1871
+
Sally Edwards Green
b. 1784 d. 1880
+
Delia Hatcher Harris
b. Abt 1806 d. 1833/1900
+
Elizabeth Hatcher
b. Abt 1786 d. 1813/1880
7
Harriett Burwell
[1.1.1.1.5.4.12]
b. 14 Feb 1789 d. 14 Feb 1789
7
Richard Boyd Burwell
[1.1.1.1.5.4.13]
b. 20 Oct 1771 d. 13 Oct 1860
5
Jr. William Dandridge
[1.1.1.1.6]
b. 1727 d. Abt 1784
Agnes West
b. Abt 1740 d. Abt 1800
6
Francis Dandridge
[1.1.1.1.6.1]
b. 1749/1768 d. 1785/1852
Lucy Webb
b. 1735/1762 d. 1784/1852
7
IV William Dandridge
[1.1.1.1.6.1.1]
b. 1770/1808 d. 1792/1886
+
Sally Webb
b. 1770/1814 d. 1792/1894
7
John Dandridge
[1.1.1.1.6.1.2]
b. 1770/1808 d. 1781/1886
7
Nancy Dandridge
[1.1.1.1.6.1.3]
b. 1758/1785 d. 1807/1875
Jr. Bowler Cocke
b. 1750/1782 d. 1807/1869
8
Elizabeth Cocke
[1.1.1.1.6.1.3.1]
d. 1764/1847
Thomas Massie
b. 1747 d. 1834
9
David Massie
[1.1.1.1.6.1.3.1.1]
b. 17 May 1777
9
Elizabeth Watkins Massie
[1.1.1.1.6.1.3.1.2]
b. 29 Mar 1781
6
Agnes Dandridge
[1.1.1.1.6.2]
b. 1753/1772 d. 1790/1859
Edward Pye Chamberlayne
b. 1758 d. 1806
7
Robert Chamberlayne
[1.1.1.1.6.2.1]
b. Abt 1790
7
Jr. Edward Pye Chamberlayne
[1.1.1.1.6.2.2]
b. Abt 1787
7
William Byrd Chamberlayne
[1.1.1.1.6.2.3]
b. 1789 d. 1858
Ann Williamson Mosby
b. Abt 1792
8
Lucy W. Chamberlayne
[1.1.1.1.6.2.3.1]
+
Efford Bentley
8
Edwin Harvey Chamberlayne
[1.1.1.1.6.2.3.2]
+
Sarah Madison Scott
7
Thomas Chamberlayne
[1.1.1.1.6.2.4]
b. Abt 1791 d. CHILD
6
III William Dandridge
[1.1.1.1.6.3]
b. 1755/1781 d. 1798
6
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.6.4]
b. 1751/1776 d. 1793/1862
Byrd Chamberlayne
b. Abt 1754 d. 1793/1853
7
Evelyn Byrd Chamberlayne
[1.1.1.1.6.4.1]
b. 1790 d. 1863
Jr. Robert Pollard
b. 1 Jan 1783 d. 18 Jun 1856
8
Edward Spotswood Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.1]
b. 7 Jul 1832
Mary Douglas
9
Evelyn Byrd Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.1.1]
+
Jr. Albert H. Stoddard
9
John Beverly Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.1.2]
9
Walter Weir Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.1.3]
9
James Hankins Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.1.4]
9
Henry Douglas Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.1.5]
9
William George Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.1.6]
9
Robert Spotswood Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.1.7]
8
Eliza Dandridge Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.2]
b. 7 Aug 1822 d. 7 Nov 1866
Beverly Browne Douglas
9
Evelyn Spotswood Douglas
[1.1.1.1.6.4.1.2.1]
b. 24 Feb 1841
James Colvin Causey
d. 6 Dec 1908
10
Mary Douglas Causey
[1.1.1.1.6.4.1.2.1.1]
b. 16 Sep 1881
Marion Kelly Kendrick
b. Abt 1882
11
Evelyn Douglas Kendrick
[1.1.1.1.6.4.1.2.1.1.1]
11
James Causey Kendrick
[1.1.1.1.6.4.1.2.1.1.2]
11
Elizabeth Dandridge Kendrick
[1.1.1.1.6.4.1.2.1.1.3]
10
Beverly Douglas Causey
[1.1.1.1.6.4.1.2.1.2]
+
Mary Katherine Paul
9
Elizabeth Dandridge Douglas
[1.1.1.1.6.4.1.2.2]
+
Travers Daniel Moncure
9
Mary Ellen Douglas
[1.1.1.1.6.4.1.2.3]
William T. Weathers
10
Willie True Weathers
[1.1.1.1.6.4.1.2.3.1]
10
Elizabeth Weathers
[1.1.1.1.6.4.1.2.3.2]
+
Tom Peet Cross
8
James Otway Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.3]
b. 6 May 1820
+
George Anna Smith
8
William George Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.4]
b. 2 Apr 1818 d. Sep 1862
Sarah Adams Smith
b. Abt 1825
9
Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.4.1]
+
John Gascoine Moncure
8
Robert Byrd Pollard
[1.1.1.1.6.4.1.5]
b. 3 Jan 1810
7
Eleanor "Ellen" Chamberlayne
[1.1.1.1.6.4.2]
John Camm Pollard
8
Chamberlayne Pollard
[1.1.1.1.6.4.2.1]
3
III John West
[1.1.2]
b. Abt 1666 d. 1700/1760
Judith Armistead
b. 1651/1678 d. 1700/1768
4
Charles West
[1.1.2.1]
b. 1677/1717 d. Abt 1734
3
Thomas West
[1.1.3]
b. Abt 1670 d. Aft 1714
Agnes
b. 1663/1685 d. 1707/1772
4
Thomas West
[1.1.3.1]
b. 1691/1720 d. 1743
Mary Martha Cole
b. 1671/1720 d. 1715/1800
5
John West
[1.1.3.1.1]
b. 1700/1729 d. Bef 8 Feb 1787
Elizabeth Seaton
b. 1709/1732 d. 8 May 1812
6
Thomas West
[1.1.3.1.1.1]
b. 1751 d. 1829
Elizabeth Blair Bolling
b. 1768
7
Elizabeth Bolling West
[1.1.3.1.1.1.1]
b. 1798 d. 10 Apr 1864
Joel Walker Flood
b. 11 Jul 1789 d. 1858
8
Henry de La Warr Flood
[1.1.3.1.1.1.1.1]
b. 14 Aug 1816 d. 21 Apr 1892
Mary Elizabeth Trent
b. 1821 d. 26 Jan 1839
9
Joel Walker Flood
[1.1.3.1.1.1.1.1.1]
b. 9 Jan 1839 d. 1916
Ella Faulkner
b. 1844 d. 1885
10
Eleanor Bolling Flood
[1.1.3.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1868 d. 17 Sep 1957
Richard Evelyn Byrd
b. 13 Aug 1860 d. 23 Oct 1925
11
Harry Flood Byrd
[1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 8 Jun 1887 d. 20 Oct 1966
Anne Douglas Beverley
12
Jr. Harry Flood Byrd
[1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
[
=>
]
11
Richard Evelyn Byrd, Jr
[1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 25 Oct 1888 d. 11 Mar 1957
Marie Donaldson Ames
12
Richard Evelyn Byrd, III
[1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
11
Thomas Bolling Byrd
[1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 4 Sep 1890 d. Feb 1968
8
Eliza Bolling Flood
[1.1.3.1.1.1.1.2]
b. 1820
7
Martha West
[1.1.3.1.1.1.2]
b. 1796 d. 1828
+
James Saunders Jones
b. 1786 d. 1846
6
John West
[1.1.3.1.1.2]
b. 1730/1770 d. 16 Apr 1818
+
Anne Cornick
b. 1731/1776 d. 1752/1856
6
Delaware West
[1.1.3.1.1.3]
b. 1730/1770 d. 1810
6
Lucy West
[1.1.3.1.1.4]
b. 1730/1770 d. 1742/1851
6
Martha West
[1.1.3.1.1.5]
b. 1739/1766 d. 1788/1856
+
George Gilbert
b. 1731/1763 d. 1788/1850
5
Thomas West
[1.1.3.1.2]
b. 1715/1743 d. Abt 28 Feb 1810
4
Nathaniel West
[1.1.3.2]
b. 1691/1718 d. 1727
4
Francis West
[1.1.3.3]
b. 1702 d. 28 Jun 1796
+
Jane Cole
b. 1719
Susannah Littlepage
b. 22 Jan 1718
5
Agnes West
[1.1.3.3.1]
b. Abt 1740 d. Abt 1800
Jr. William Dandridge
b. 1727 d. Abt 1784
6
Francis Dandridge
[1.1.3.3.1.1]
b. 1749/1768 d. 1785/1852
Lucy Webb
b. 1735/1762 d. 1784/1852
7
IV William Dandridge
[1.1.3.3.1.1.1]
b. 1770/1808 d. 1792/1886
+
Sally Webb
b. 1770/1814 d. 1792/1894
7
John Dandridge
[1.1.3.3.1.1.2]
b. 1770/1808 d. 1781/1886
7
Nancy Dandridge
[1.1.3.3.1.1.3]
b. 1758/1785 d. 1807/1875
Jr. Bowler Cocke
b. 1750/1782 d. 1807/1869
8
Elizabeth Cocke
[1.1.3.3.1.1.3.1]
d. 1764/1847
Thomas Massie
b. 1747 d. 1834
9
David Massie
[1.1.3.3.1.1.3.1.1]
b. 17 May 1777
9
Elizabeth Watkins Massie
[1.1.3.3.1.1.3.1.2]
b. 29 Mar 1781
6
Agnes Dandridge
[1.1.3.3.1.2]
b. 1753/1772 d. 1790/1859
Edward Pye Chamberlayne
b. 1758 d. 1806
7
Robert Chamberlayne
[1.1.3.3.1.2.1]
b. Abt 1790
7
Jr. Edward Pye Chamberlayne
[1.1.3.3.1.2.2]
b. Abt 1787
7
William Byrd Chamberlayne
[1.1.3.3.1.2.3]
b. 1789 d. 1858
Ann Williamson Mosby
b. Abt 1792
8
Lucy W. Chamberlayne
[1.1.3.3.1.2.3.1]
+
Efford Bentley
8
Edwin Harvey Chamberlayne
[1.1.3.3.1.2.3.2]
+
Sarah Madison Scott
7
Thomas Chamberlayne
[1.1.3.3.1.2.4]
b. Abt 1791 d. CHILD
6
III William Dandridge
[1.1.3.3.1.3]
b. 1755/1781 d. 1798
6
Elizabeth Dandridge
[1.1.3.3.1.4]
b. 1751/1776 d. 1793/1862
Byrd Chamberlayne
b. Abt 1754 d. 1793/1853
7
Evelyn Byrd Chamberlayne
[1.1.3.3.1.4.1]
b. 1790 d. 1863
Jr. Robert Pollard
b. 1 Jan 1783 d. 18 Jun 1856
8
Edward Spotswood Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.1]
b. 7 Jul 1832
Mary Douglas
9
Evelyn Byrd Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.1.1]
+
Jr. Albert H. Stoddard
9
John Beverly Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.1.2]
9
Walter Weir Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.1.3]
9
James Hankins Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.1.4]
9
Henry Douglas Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.1.5]
9
William George Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.1.6]
9
Robert Spotswood Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.1.7]
8
Eliza Dandridge Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.2]
b. 7 Aug 1822 d. 7 Nov 1866
Beverly Browne Douglas
9
Evelyn Spotswood Douglas
[1.1.3.3.1.4.1.2.1]
b. 24 Feb 1841
James Colvin Causey
d. 6 Dec 1908
10
Mary Douglas Causey
[1.1.3.3.1.4.1.2.1.1]
b. 16 Sep 1881
Marion Kelly Kendrick
b. Abt 1882
11
Evelyn Douglas Kendrick
[1.1.3.3.1.4.1.2.1.1.1]
11
James Causey Kendrick
[1.1.3.3.1.4.1.2.1.1.2]
11
Elizabeth Dandridge Kendrick
[1.1.3.3.1.4.1.2.1.1.3]
10
Beverly Douglas Causey
[1.1.3.3.1.4.1.2.1.2]
+
Mary Katherine Paul
9
Elizabeth Dandridge Douglas
[1.1.3.3.1.4.1.2.2]
+
Travers Daniel Moncure
9
Mary Ellen Douglas
[1.1.3.3.1.4.1.2.3]
William T. Weathers
10
Willie True Weathers
[1.1.3.3.1.4.1.2.3.1]
10
Elizabeth Weathers
[1.1.3.3.1.4.1.2.3.2]
+
Tom Peet Cross
8
James Otway Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.3]
b. 6 May 1820
+
George Anna Smith
8
William George Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.4]
b. 2 Apr 1818 d. Sep 1862
Sarah Adams Smith
b. Abt 1825
9
Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.4.1]
+
John Gascoine Moncure
8
Robert Byrd Pollard
[1.1.3.3.1.4.1.5]
b. 3 Jan 1810
7
Eleanor "Ellen" Chamberlayne
[1.1.3.3.1.4.2]
John Camm Pollard
8
Chamberlayne Pollard
[1.1.3.3.1.4.2.1]
5
Susanna West
[1.1.3.3.2]
b. 15 Mar 1743/44 d. 5 Dec 1780
+
West Gregory
b. 1727/1747 d. 1761/1833
+
Holt Richerson
b. 1740 d. 1800
5
William West
[1.1.3.3.3]
b. Abt 1735
Letitia Martin
6
Robert West
[1.1.3.3.3.1]
Mary Beverly Grymes
b. 12 Jul 1782 d. 8 May 1859
7
John W. West
[1.1.3.3.3.1.1]
b. Abt 1805
Maria F. Scott
8
Caroline Willis West
[1.1.3.3.3.1.1.1]
Thomas Yeatman Mosby, Jr
b. 24 Aug 1867 d. 2 Aug 1920
9
Jr. Thomas Talford Mosby
[1.1.3.3.3.1.1.1.1]
b. Oct 1891 d. May 1962
Marguarite Hill
b. Dec 1893
10
Margaret Mosby
[1.1.3.3.3.1.1.1.1.1]
10
Barbara R. Mosby
[1.1.3.3.3.1.1.1.1.2]
11
Frederica Barbara Mosby
[1.1.3.3.3.1.1.1.1.2.1]
10
III Thomas Talford Mosby
[1.1.3.3.3.1.1.1.1.3]
b. Cal 1922 d. Yes, date unknown
10
Ada Winston Mosby
[1.1.3.3.3.1.1.1.1.4]
+
Caroline D.
b. Cal 1881
4
Agnes West
[1.1.3.4]
b. 1691/1720 d. 1707/1802
Richard T. Gregory
b. 1681/1718 d. 1707/1796
5
Richard W. Gregory
[1.1.3.4.1]
b. 1730 d. 17 May 1817
Nancy Ann Vaughan
d. 21 Oct 1821
6
Smith Gregory
[1.1.3.4.1.1]
b. 1760 d. 8 Mar 1832
Martha
b. Abt 1766 d. Aft 1813
7
Nancy Vaughn Gregory
[1.1.3.4.1.1.1]
b. 1797 d. 13 Dec 1895
Wiley C. Hatton
b. Abt 1797 d. 11 Sep 1872
8
Rose Elizabeth Hatton
[1.1.3.4.1.1.1.1]
b. 1821 d. 1852
Thomas M. Hendrickson
b. Abt 1815 d. Aft 1865
9
Susan Hendrickson
[1.1.3.4.1.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1843 d. 1919
Isaac Newton Petty
b. 4 Dec 1841 d. 18 Nov 1875
10
Delilia May Petty
[1.1.3.4.1.1.1.1.1.1]
b. 21 Feb 1875 d. Aug 1944
Daniel Willard Spaulding
b. 1868 d. 1941
11
Marion Virginia Spaulding
[1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.1]
Robert Fraser Reynolds
12
Ada Mae Reynolds
[1.1.3.4.1.1.1.1.1.1.1.1]
[
=>
]
3
Anne West
[1.1.4]
b. Abt 1660 d. Aft 1708
Henry Fox
b. 1633/1662 d. 1687/1747
4
Ann Fox
[1.1.4.1]
b. 20 Jun 1684 d. 8 May 1733
Jr. Thomas Claiborne
b. 16 Dec 1680 d. 16 Aug 1732
5
Daniel Parke Claiborne
[1.1.4.1.1]
b. Abt 1725 d. Sep 1790
Mary Anne Maury
b. 1728 d. 10 Apr 1797
6
Mary Anne Claiborne
[1.1.4.1.1.1]
b. 1750
6
Dorothea Claiborne
[1.1.4.1.1.2]
b. 18 May 1765
+
Henry Tatum
6
Hannah Claiborne
[1.1.4.1.1.3]
6
Matthew Claiborne
[1.1.4.1.1.4]
5
Elizabeth Claiborne
[1.1.4.1.2]
b. 1701/1726 d. 1718/1810
+
Benjamin Hoomes
b. 1691/1725 d. 1718/1805
5
Martha Claiborne
[1.1.4.1.3]
b. 17 Nov 1721 d. 23 Aug 1784
+
Patrick Napier
b. 1 Feb 1713 d. 23 Aug 1774
5
Sarah Claiborne
[1.1.4.1.4]
b. 1701/1726 d. 1718/1810
+
Joseph Thompson
b. 1691/1725 d. 1718/1805
5
Augustine Claiborne
[1.1.4.1.5]
b. 1721 d. 3 May 1789
Mary Herbert
b. 25 Aug 1728
6
Herbert Claiborne
[1.1.4.1.5.1]
b. 1746 d. 1763/1836
+
Ruffin
+
Mary Burnet Browne
b. 1742/1762 d. 1763/1846
6
Mary Herbert Claiborne
[1.1.4.1.5.2]
b. 1744 d. 25 Jul 1775
+
Charles Harrison
b. 30 Sep 1742 d. 1794
6
Anne Claiborne
[1.1.4.1.5.3]
b. 30 Dec 1749 d. Est 1774/1843
V Richard Cocke
b. 20 Jun 1748 d. 24 Jan 1816
7
Buller Cocke
[1.1.4.1.5.3.1]
b. Abt 1773 d. 1787/1871
Elizabeth Barron
b. 1767/1798 d. 1787/1880
8
Elizabeth Marion Cocke
[1.1.4.1.5.3.1.1]
Louis Cruger Trezevant
9
Edward Buller Trezevant
[1.1.4.1.5.3.1.1.1]
7
Richard Herbert Cocke
[1.1.4.1.5.3.2]
b. 1769 d. 1833
+
Ann Hunt Cocke
Markie
8
Martha Ann Cocke
[1.1.4.1.5.3.2.1]
Batt Henley
9
Indiana Henley
[1.1.4.1.5.3.2.1.1]
+
Emmett Robinson
+
John Peter
7
Augustine Cocke
[1.1.4.1.5.3.3]
b. 1771
7
Lucy Herbert Cocke
[1.1.4.1.5.3.4]
b. Abt 1772
+
William Ruffin
6
Thomas B. Claiborne
[1.1.4.1.5.4]
b. 1 Jan 1746/47 d. 1812
+
Scott
Mary Clayton
b. 11 Nov 1755 d. 1833
7
Esq. Philip Claiborne
[1.1.4.1.5.4.1]
b. 18 Jul 1773 d. 27 Oct 1827
Sally Sims
d. Bef 1817
8
Mary Elizabeth Claiborne
[1.1.4.1.5.4.1.1]
b. Abt 1808
8
John C. Claiborne
[1.1.4.1.5.4.1.2]
b. Abt 1804
8
Lucy S. Claiborne
[1.1.4.1.5.4.1.3]
b. 1806
8
Martha J. Claiborne
[1.1.4.1.5.4.1.4]
b. Abt 1800
6
Buller Claiborne
[1.1.4.1.5.5]
b. 1755
Patsy Ruffin
7
Sterling Claiborne
[1.1.4.1.5.5.1]
6
Lucy Herbert Claiborne
[1.1.4.1.5.6]
b. 1769
John Cocke
b. Abt 1745 d. 22 Aug 1798
7
John Ruffin Cocke
[1.1.4.1.5.6.1]
b. 15 Jul 1783 d. 1827
+
Mary Coleman Scott
b. Abt 1787 d. 30 Sep 1857
7
Herbert Cocke
[1.1.4.1.5.6.2]
5
Nathaniel Claiborne
[1.1.4.1.6]
b. 1701/1726 d. 1722/1807
Jane Cole
b. 1701/1733 d. 1722/1815
6
Thomas Claiborne
[1.1.4.1.6.1]
5
III Thomas Claiborne
[1.1.4.1.7]
b. 9 Jan 1703/04 d. 1 Dec 1735
4
Thomas Fox
[1.1.4.2]
b. 1668/1705 d. 1729/1784
Mary Tunstall
b. 1670/1729 d. 1729/1809
5
Jr. Thomas Fox
[1.1.4.2.1]
b. 1729/1757 d. 1755/1839
+
Philadelphia Claiborne
b. 1739/1758 d. 1776/1846
3
Unity West
[1.1.5]
b. Abt 1657