News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Register for a User Account
Home
Search
Login
Find
Surnames
What's New
Most Wanted
Reports
Cemeteries
Media
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
•
First Name:
Last Name:
ID:
Joseph Croshaw
Abt 1610 - 1667 (57 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Joseph Croshaw
[1]
b. Abt 1610 d. 10 Apr 1667
Mary Broomfield
b. Abt 1610 d. Bef Jul 1661
2
Unity (Ursula) Croshaw
[1.1]
b. 1636 d. 20 Apr 1669
Jr. John West
b. 6 Jun 1632 d. 1689
3
Nathanial West
[1.1.1]
b. 1655 d. Abt 1724
Martha Woodward
b. Abt 1654 d. 1723
4
Unity West
[1.1.1.1]
b. 1696 d. Aft Jul 1753
William Dandridge
b. 29 Dec 1689 d. 25 Aug 1743
5
Martha Dandridge
[1.1.1.1.1]
b. Abt 1721 d. 25 Apr 1747
Philip Aylett
b. 1720 d. 1790
6
Unity Aylett
[1.1.1.1.1.1]
b. 1740
6
William Aylett
[1.1.1.1.1.2]
b. 1742 d. 12 Apr 1781
Mary Macon
b. Aft 1742 d. 1781/1837
7
Philip Aylett
[1.1.1.1.1.2.1]
b. 12 Mar 1767 d. 11 Sep 1831
Elizabeth Henry
b. 23 Apr 1769 d. 24 Sep 1842
8
Patrick Henry Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 7 Dec 1789 d. 18 Nov 1799
8
Jr. Philip Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 7 Dec 1791 d. 1835/1883
Judith Page Waller
b. 1786/1811 d. 1836/1898
9
Patrick Henry Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 19 May 1825 d. 27 Apr 1870
Emily Ann Coles Rutherfoord
b. Abt 1830
10
Emily Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.1.1]
b. 1853 d. 1911
+
Jr. John Enders
10
Sarah Bennett Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.1.2]
b. 1855
+
Jr. Thomas Randolph Bolling
10
Judith Page Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.1.3]
b. 1860 d. 1942
+
William Laurence Royall
b. 15 Nov 1844
9
William Roane Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.2]
b. 1833 d. 1878/1925
Alice R. Brockenbrough
b. 1823/1849 d. 1878/1937
10
Sarah Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.2.1]
b. 1861 d. 1862/1955
10
Pattie Waller Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
b. 1862 d. 1863/1956
10
Philip Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.2.3]
b. 1867 d. 1868/1957
10
Alice Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.2.4]
b. 1868 d. 1869/1962
10
William R. Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.2.5]
b. 1872 d. 1873/1962
10
Bessie Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.2.6]
b. 1873 d. 1874/1967
10
Patrick Henry Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.2.7]
b. 1876 d. Sep 1943
9
Rosalie Page Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.3]
b. 1812/1841 d. 1828/1923
+
Norman D. Sampson
b. 1802/1839 d. 1828/1917
9
Pattie Waller Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.4]
b. 1812/1841 d. 1828/1923
+
Patrick Henry Cabell
b. 10 May 1827 d. 19 Oct 1865
+
Henry A. Ware
b. 1802/1839 d. 1828/1917
+
James Bliss
b. 1802/1839 d. 1828/1917
9
Anne Henry Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.5]
b. 1812/1851 d. 1821/1931
9
Benjamin W. Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.6]
b. 1812/1851 d. 1821/1928
9
Cora Dandridge Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.2.7]
b. 1812/1851 d. 1821/1931
8
Mary Macon Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 5 Dec 1793 d. 6 Oct 1836
Philip FitzHugh
b. 1790 d. 21 Dec 1836
9
Elizabeth Henry Fitzhugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.1]
b. 12 May 1816 d. 1827
+
Robert Curtis
b. 1801/1842 d. 1827/1920
9
Patrick Henry FitzHugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.2]
b. 2 Dec 1818 d. 18 Jun 1864
+
Mary Christian
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Lucy FitzHugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.3]
b. 8 Oct 1819 d. 1827
+
Samuel C. Redd
b. 1801/1842 d. 1827/1920
9
John Henry Fitzhugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.4]
b. 20 Dec 1821 d. 9 May 1894
+
Hattie Bullitt
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Philip Aylett Fitzhugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.5]
b. 14 Jun 1824 d. 7 Jun 1908
+
Georgia Tankard
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Mary FitzHugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.6]
b. 26 Jan 1826 d. 18 Feb 1826
9
LaFayette Henry Fitzhugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.7]
b. 9 May 1829 d. 1 Aug 1905
+
E. Semple
b. 1809/1850 d. 1830/1930
9
Edwin FitzHugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.8]
b. 1809/1844 d. 1818/1922
9
Thaddeus FitzHugh
[1.1.1.1.1.2.1.3.9]
b. 1809/1844 d. 1830/1922
+
Julia Horsey
b. 1809/1850 d. 1830/1930
8
Elizabeth Henry Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.4]
b. Nov 1798 d. 14 Nov 1818
+
William Spotswood Fontaine
b. 7 Nov 1810 d. 1882
8
Martha Dandridge Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 5 Apr 1801 d. 1833
+
Silas M. Duncan
b. 1788 d. 14 Sep 1834
8
Anna Henry Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 1803 d. 2 Jan 1828
Thomas Moore
b. 1777/1809 d. 1809/1889
9
Anna H. Moore
[1.1.1.1.1.2.1.6.1]
b. 1809/1844 d. 1827/1925
+
W. G. Gwathmey
b. 1801/1842 d. 1827/1920
9
Elizabeth Moore
[1.1.1.1.1.2.1.6.2]
b. 1809/1844 d. 1827/1925
John Milton Dabney
b. 1801/1842 d. 1827/1920
10
Lucie Dabney
[1.1.1.1.1.2.1.6.2.1]
+
James W. Powell
8
Louisa Fontaine Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.7]
b. Mar 1805 d. 19 Aug 1822
8
William Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.8]
b. 1807 d. 11 Feb 1829
8
Patrick Henry Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.9]
b. Jun 1808 d. 28 Jan 1829
8
Sarah Shelton Aylett
[1.1.1.1.1.2.1.10]
b. 24 Jun 1811 d. 5 Mar 1875
William Spotswood Fontaine
b. 7 Nov 1810 d. 1882
9
Elizabeth Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.1]
b. 28 Jun 1833
9
William Winston Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2]
b. 27 Nov 1834 d. 2 Nov 1917
Mary Adelaide Burrows
b. 4 Jan 1838 d. 28 Mar 1887
10
William Spottswood Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.1]
b. 27 Feb 1862 d. 28 Jul 1863
10
Mary Aylett Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.2]
b. 13 May 1866 d. 8 Aug 1933
10
John Lansing Burrows Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.3]
b. 18 Jun 1868 d. 11 May 1913
+
Elizabeth Rose Waggener
b. 12 Apr 1870 d. 9 Oct 1925
10
William Winston Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.4]
b. 16 Mar 1870 d. 19 Aug 1939
Florence West Evans
b. Mar 1877 d. 21 Jan 1928
11
Evan-Burrows Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.4.1]
Cornelius Vanderbilt Whitney
12
Neil “Sonny” Winston Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.4.1.1]
[
=>
]
Harold “Stubby” Herman Kruger
b. 23 Sep 1898 d. 7 Oct 1965
12
Robert "Bobby" Kruger
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.4.1.2]
+
Jack Lynch
+
Sterling Lawrence Adair
b. 18 Dec 1894 d. 14 Jan 1921
+
Mabel Kathleen Lawrence
b. Abt 1890
10
Elizabeth Adelaide Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.5]
b. 6 Jan 1873 d. 19 Nov 1916
10
Marion Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.2.6]
b. 10 Jan 1880 d. 10 Jan 1880
9
Alexander Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.3]
b. Abt 1836 d. CHILD
9
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.4]
b. 1838 d. 1856
9
Marian Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.5]
b. 19 May 1840 d. 11 Feb 1913
+
John Hairston Redd
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6]
b. 1841 d. 1915
Annie Elizabeth Redd
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.1]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.2]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.3]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
John Winston Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.1]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.1.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.2]
11
William Fontaine Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.3]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.4]
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.5]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.5.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.5.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.5.3]
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.6]
b. 3 Dec 1897
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.7]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.8]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.8.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.4.8.2]
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.5]
b. 1877
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.6]
b. 1879
10
John Winston Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.7]
b. 1887
10
James Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.8]
b. 1888
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.6.9]
9
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.7]
b. 1845 d. 1862
9
Sarah Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.1.2.1.10.8]
b. 18 Jan 1848
Henry Sampson
b. 10 Mar 1847 d. 18 Sep 1915
10
Cornelia Dandridge Sampson
[1.1.1.1.1.2.1.10.8.1]
b. 1 Apr 1874 d. 13 Sep 1903
Malcolm Graham
b. Feb 1865
11
Malcolm Montrose Graham
[1.1.1.1.1.2.1.10.8.1.1]
b. 16 Sep 1898
11
Sarah Aylett Graham
[1.1.1.1.1.2.1.10.8.1.2]
+
Powell
Frank W. Simpson
12
Jr. Frank W. Simpson
[1.1.1.1.1.2.1.10.8.1.2.1]
12
Geary Graham Simpson
[1.1.1.1.1.2.1.10.8.1.2.2]
[
=>
]
12
William A. Simpson
[1.1.1.1.1.2.1.10.8.1.2.3]
7
Elizabeth Aylett
[1.1.1.1.1.2.2]
b. Abt 1769 d. 1793/1863
Alexander Spotswood Moore
b. 1763 d. 1793/1854
8
Mildred Walker Moore
[1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 1785/1811 d. 1791/1894
7
Ann Dandridge Aylett
[1.1.1.1.1.2.3]
b. 1778 d. 1818
+
Andrew Alexander
b. 1768 d. 1844
7
William Aylett
[1.1.1.1.1.2.4]
b. 1761/1781 d. 1767/1864
6
Anne Aylett
[1.1.1.1.1.3]
b. 1744
6
John Aylett
[1.1.1.1.1.4]
b. 1748 d. 7 Feb 1776
Elizabeth Dandridge
b. 25 May 1749 d. 1776
7
William Aylett
[1.1.1.1.1.4.1]
b. 15 Jun 1774 d. 29 Aug 1777
7
John Aylett
[1.1.1.1.1.4.2]
b. 17 Feb 1776 d. 24 Aug 1777
5
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.2]
b. Abt 1722 d. 1740/1816
Philip Whitehead Claiborne
b. 1705/1725 d. 5 Dec 1771
6
Philadelphia Claiborne
[1.1.1.1.2.1]
b. 1739/1758 d. 1776/1846
+
John Carter
b. 1719/1751 d. 1776/1838
+
Jr. Thomas Fox
b. 1729/1757 d. 1755/1839
6
Philip Claiborne
[1.1.1.1.2.2]
b. 1740/1763 d. 1745/1844
6
Betty Claiborne
[1.1.1.1.2.3]
b. 1740/1763 d. 1762/1847
Esq. John Watkins
b. Abt 1732 d. 10 Mar 1785
7
John Dandridge Watkins
[1.1.1.1.2.3.1]
b. 1762/1797 d. 1771/1875
7
Elizabeth Watkins
[1.1.1.1.2.3.2]
b. 1762/1797 d. 1770/1878
7
Ann Dandridge Watkins
[1.1.1.1.2.3.3]
b. 1762/1797 d. 1770/1878
6
William Dandridge Claiborne
[1.1.1.1.2.4]
b. 1740/1763 d. 1763/1844
Anne Dandridge
b. 1759/1783 d. 1775/1867
7
Elizabeth Dandridge Claiborne
[1.1.1.1.2.4.1]
b. 1685/1800 d. 1802
Jr. William Langborne
b. 1622/1764 d. 1814
8
III William Langborne
[1.1.1.1.2.4.1.1]
b. 1651/1798 d. 1669/1876
8
Langborne
[1.1.1.1.2.4.1.2]
b. 1651/1798 d. 1668/1879
5
Anna Dandridge
[1.1.1.1.3]
b. Abt 1723 d. 15 Dec 1781
+
Thomas Dansie
b. 1706/1726 d. 1740/1812
+
Davey
b. 1706/1726 d. 1740/1812
5
Mary Dandridge
[1.1.1.1.4]
b. 1725 d. 1798
John M. Spotswood
d. 6 May 1756
6
Alexander Spotswood
[1.1.1.1.4.1]
b. 16 Oct 1746 d. 20 Dec 1818
Elizabeth Washington
b. 15 Nov 1749 d. 20 Oct 1814
7
Alexander Eilliott Spotswood
[1.1.1.1.4.1.1]
b. 1 Dec 1769 d. 1842
7
John Augustine Spotswood
[1.1.1.1.4.1.2]
b. 7 Jun 1771 d. 16 Apr 1806
7
Robert Spotswood
[1.1.1.1.4.1.3]
b. 15 Jul 1772 d. 24 Jul 1772
7
Ann Spotswood
[1.1.1.1.4.1.4]
b. 15 Jul 1773 d. 16 Aug 1774
7
Mary Randolph Spotswood
[1.1.1.1.4.1.5]
b. 29 Jun 1775 d. 16 Jan 1803
+
Francis Taliaferro Brooke
b. 1739/1771 d. 1796/1858
7
Elizabeth Jane Spotswood
[1.1.1.1.4.1.6]
b. 16 May 1777 d. 20 Oct 1777
7
Anne Washington Burwell Spotswood
[1.1.1.1.4.1.7]
b. 18 Sep 1779 d. Dec 1822
+
Baldwin Taliaferro
b. 27 Apr 1776 d. Aft 1840
7
Elizabeth Butler Spotswood
[1.1.1.1.4.1.8]
b. 12 Sep 1781 d. 27 Jun 1805
+
Mann Page
b. 1777 d. 1810
7
George Augustine Washington Spotswood
[1.1.1.1.4.1.9]
b. 5 Jan 1783 d. 24 Nov 1844
Lucy Spotswood
b. 21 Jul 1783 d. 1866
8
William Augustine Washington Spotswood
[1.1.1.1.4.1.9.1]
b. 2 Oct 1806 d. 7 Sep 1891
8
Charles Fenton Mercer Spotswood
[1.1.1.1.4.1.9.2]
b. 22 Feb 1813 d. 6 Aug 1892
7
Henrietta Brayne Spotswood
[1.1.1.1.4.1.10]
b. 29 Aug 1786 d. 10 Aug 1860
+
Bushrod Washington
b. 4 Apr 1785 d. 1830
+
Taliaferro
b. 1758/1778 d. 1792/1864
7
William Lafayette Spotswood
[1.1.1.1.4.1.11]
b. 29 Aug 1786 d. 30 Aug 1786
7
Martha Ann Maria Spotswood
[1.1.1.1.4.1.12]
b. 29 Sep 1790 d. 21 Sep 1826
7
William Lawrence McCarty Spotswood
[1.1.1.1.4.1.13]
b. 7 Oct 1791 d. 1871
+
Catherine Ann Jones
b. Bef 1800 d. Abt 1835
6
Jr. John Spotswood
[1.1.1.1.4.2]
b. 1748 d. 1795/1840
Sarah Rowzie
b. 1735/1760 d. 1795/1850
7
Mary Spotswood
[1.1.1.1.4.2.1]
b. 1772 d. 1786/1866
+
Nicholas Voss
b. 1755/1775 d. 1789/1861
7
John Spotswood
[1.1.1.1.4.2.2]
b. 1774 d. 1791/1864
+
Mary Goode
b. 1770/1790 d. 1791/1874
7
Susan Spotswood
[1.1.1.1.4.2.3]
b. 1776 d. 1790/1870
+
John Bott
b. 1759/1779 d. 1793/1865
7
Robert Spotswood
[1.1.1.1.4.2.4]
b. 1780 d. 1801/1870
Louisa Bott
b. 1776/1796 d. 1801/1880
8
John Bott Spotswood
[1.1.1.1.4.2.4.1]
b. 1801/1830 d. 1807/1909
7
Elliott Spotswood
[1.1.1.1.4.2.5]
b. 1782 d. 1799/1872
+
Sallie Littlepage
b. 1778/1798 d. 1799/1882
7
Lucy Spotswood
[1.1.1.1.4.2.6]
b. 21 Jul 1783 d. 1866
George Augustine Washington Spotswood
b. 5 Jan 1783 d. 24 Nov 1844
8
William Augustine Washington Spotswood
[1.1.1.1.4.2.6.1]
b. 2 Oct 1806 d. 7 Sep 1891
8
Charles Fenton Mercer Spotswood
[1.1.1.1.4.2.6.2]
b. 22 Feb 1813 d. 6 Aug 1892
7
Sarah Spotswood
[1.1.1.1.4.2.7]
b. 1785 d. 1799/1879
+
Roger Atkinson
b. 1768/1788 d. 1802/1874
+
George Whitlock
b. 1768/1788 d. 1802/1874
7
Dandridge Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8]
b. 1789 d. 1841/1881
Catherine Brooke Francisco
b. 1801 d. 1842/1896
8
Alexander Elliott Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.1]
b. 2 Jun 1821 d. 21 Nov 1834
8
Dandridge Rowzie Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.2]
b. 12 Oct 1823 d. 1 Sep 1830
8
William Francisco Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.3]
b. 16 Feb 1824 d. 13 Apr 1895
+
Isabella Matoaca Dunlop
b. 1820/1839 d. 1841/1924
8
Joseph Edwin Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.4]
b. 1829 d. 1846/1919
+
Lucy Starke Cooper
b. 1825/1845 d. 1846/1929
8
Catherine Dandridge Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.5]
b. 31 Aug 1831 d. INFANT
8
Benjamin Henry Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.6]
b. 16 Jun 1833 d. 22 Apr 1843
8
Rosa Brooke Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.7]
b. 1836 d. 1850/1930
+
F. N. Strudwick
b. 1819/1839 d. 1853/1925
8
Alexander Dandridge Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.8]
b. 1838 d. 9 Jul 1840
8
Elizabeth Robinson Spotswood
[1.1.1.1.4.2.8.9]
b. 2 Aug 1840 d. 1841/1934
7
Norborne Berkeley Spotswood
[1.1.1.1.4.2.9]
b. 1790 d. 1807/1880
+
Sallie Markham
b. 1786/1806 d. 1807/1890
7
Annie Spotswood
[1.1.1.1.4.2.10]
b. 1793 d. 1807/1887
+
William Robertson
b. 1776/1796 d. 1810/1882
6
Anne Spotswood
[1.1.1.1.4.3]
b. 1748 d. 14 Feb 1789
V Lewis Armistead Burwell
b. 26 Sep 1745 d. 2 Jul 1800
7
Mary Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.1]
b. 30 Dec 1768 d. 20 Mar 1829
Samuel Goode
b. 21 Mar 1756 d. 14 Jan 1822
8
Mary Armistead Goode
[1.1.1.1.4.3.1.1]
Thomas Williamson Jones
9
Edwin Burwell Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.1]
9
Samuel Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2]
b. 20 Sep 1815
+
Aurie Elmore
Martha Ward Goode
b. 12 Jan 1821 d. 2 Aug 1861
10
Thomas Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1]
b. 26 Nov 1844 d. 28 Apr 1914
Gena C. Bird
11
Marshall Bird Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.1]
b. 3 Nov 1869
11
Gena Moore Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.2]
b. 26 Nov 1871
11
Martha Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.3]
b. 10 Aug 1874
11
Carrie Bird Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.4]
b. 25 Aug 1876
11
Gordon Houston Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.5]
b. 15 Jun 1880
11
Thomas Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.6]
b. 9 Jun 1885
10
Mary Virginia Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2]
b. 6 Apr 1847
+
William Gesner
10
Jr. Samuel Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3]
b. 2 Dec 1849 d. 16 May 1854
10
Lucy Spotswood Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.4]
b. 3 Aug 1851 d. 1 Feb 1879
+
F. H. Armstrong
10
Edwin Francis Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.5]
b. 21 Dec 1853
Bertha Stubbs
11
Samuel Baytop Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.5.1]
10
Carter Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.6]
b. 19 Sep 1855
10
Martha Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.7]
b. 13 Nov 1856 d. 8 Feb 1859
10
Charles Pollard Jones
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.8]
b. 13 Jun 1858
8
Thomas Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2]
b. 31 Oct 1787 d. 2 Apr 1858
Mary Ann Knox
b. 17 Dec 1797 d. 1 May 1871
9
Margaret Knox Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.1]
d. 1868
William Phillips Garland
b. 27 Sep 1833 d. 14 Apr 1863
10
Willie Phillips Garland
[1.1.1.1.4.3.1.2.1.1]
b. Mar 1863
9
Martha Ward Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.2]
b. 12 Jan 1821 d. 2 Aug 1861
Samuel Goode Jones
b. 20 Sep 1815
10
Thomas Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.1]
b. 26 Nov 1844 d. 28 Apr 1914
Gena C. Bird
11
Marshall Bird Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.1.1]
b. 3 Nov 1869
11
Gena Moore Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.1.2]
b. 26 Nov 1871
11
Martha Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.1.3]
b. 10 Aug 1874
11
Carrie Bird Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.1.4]
b. 25 Aug 1876
11
Gordon Houston Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.1.5]
b. 15 Jun 1880
11
Thomas Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.1.6]
b. 9 Jun 1885
10
Mary Virginia Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.2]
b. 6 Apr 1847
+
William Gesner
10
Jr. Samuel Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.3]
b. 2 Dec 1849 d. 16 May 1854
10
Lucy Spotswood Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.4]
b. 3 Aug 1851 d. 1 Feb 1879
+
F. H. Armstrong
10
Edwin Francis Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.5]
b. 21 Dec 1853
Bertha Stubbs
11
Samuel Baytop Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.5.1]
10
Carter Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.6]
b. 19 Sep 1855
10
Martha Goode Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.7]
b. 13 Nov 1856 d. 8 Feb 1859
10
Charles Pollard Jones
[1.1.1.1.4.3.1.2.2.8]
b. 13 Jun 1858
9
Sophia Louisa Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.3]
b. 7 Apr 1822 d. 19 Jan 1904
9
Samuel Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.4]
b. 20 Oct 1823 d. 29 Jan 1908
Mary Gatewood Massie
10
Mary Eugenia Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.4.1]
10
Nellie Pleasants Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.4.2]
10
William Alfred Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.4.3]
10
Aurelia Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.4.4]
10
Florine Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.4.5]
9
Thomas Francis Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5]
b. 29 Jun 1825 d. 6 Jan 1905
Rosa Cowles Chambers
b. 6 Feb 1842 d. 20 Jan 1921
10
Edward Chambers Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.1]
b. 1 Mar 1862 d. 25 Jun 1933
+
Alice M.
Maria Belle Morton
b. Mar 1861 d. 22 Jan 1901
11
Rose Chambers Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.1.1]
11
Mable Laird Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.1.2]
11
Virginia Morton Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.1.3]
11
Marguerite Keen Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.1.4]
b. 30 Oct 1888 d. 10 Jul 1930
11
Benjamin Douglas Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.1.5]
b. 24 Dec 1889 d. 18 May 1928
11
Gordon Murray Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.1.6]
b. 28 Jun 1893 d. 25 Jul 1962
10
Kate Tucker Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.2]
b. 22 Nov 1863 d. 19 Nov 1917
10
Marion Knox Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.3]
b. 24 May 1865 d. 30 Sep 1954
Phillip Jackson Briscoe, Jr
b. 15 Dec 1855 d. 20 Jan 1940
11
Marion Knox Briscoe
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.3.1]
11
Thomas Goode Briscoe
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.3.2]
b. 1886 d. 28 Jun 1887
11
Charlotte James Briscoe
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.3.3]
b. Apr 1888
11
Rose Chambers Briscoe
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.3.4]
10
Jr. Thomas Francis Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.4]
b. 27 May 1869 d. Jan 1941
10
St. John Chambers Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.5]
b. 27 Jul 1879
Lucille Randolph Pleasants
11
Virginia Chambers Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.5.1]
11
William Sterling Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.5.2]
11
Mary Louise Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.5.3]
11
Katherine Randolph Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.5.4]
11
John Chambers Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.5.5.5]
9
Lucy Knox Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.6]
b. 1830 d. 22 Feb 1881
George William Brent
b. Aug 1821 d. 2 Jan 1872
10
Thomas Goode Brent
[1.1.1.1.4.3.1.2.6.1]
b. 3 Feb 1852
10
Lucy Brent
[1.1.1.1.4.3.1.2.6.2]
b. 11 Jul 1853
+
William G. Howard
+
Robert T. Thorp
10
Samuel Gordon Brent
[1.1.1.1.4.3.1.2.6.3]
b. 28 Jun 1855 d. 6 May 1928
10
Mary E. Brent
[1.1.1.1.4.3.1.2.6.4]
b. 2 Sep 1857 d. 27 Dec 1950
+
Charles A. Read
10
George G. Brent
[1.1.1.1.4.3.1.2.6.5]
b. 3 Jan 1860
10
Alice Virginia Brent
[1.1.1.1.4.3.1.2.6.6]
b. 8 Nov 1863 d. 20 Jun 1927
10
Cornelia W. Brent
[1.1.1.1.4.3.1.2.6.7]
b. 8 Nov 1863 d. 6 Jan 1946
10
Jessie Innis Brent
[1.1.1.1.4.3.1.2.6.8]
b. 15 Jan 1870
9
Alice Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.7]
b. 18 Mar 1831 d. 12 Jun 1903
William Crump
d. Abt 1869
10
Sallie Crump
[1.1.1.1.4.3.1.2.7.1]
+
Goodwin
10
Alice Crump
[1.1.1.1.4.3.1.2.7.2]
10
William Crump
[1.1.1.1.4.3.1.2.7.3]
10
Ellen Crump
[1.1.1.1.4.3.1.2.7.4]
10
Mary Crump
[1.1.1.1.4.3.1.2.7.5]
9
Ellen Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.8]
b. 3 Aug 1838 d. 20 Jan 1920
+
William G. Friend
9
Isabella Scott Goode
[1.1.1.1.4.3.1.2.9]
b. 15 Mar 1841 d. 26 Apr 1914
7
Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.2]
b. 26 Jun 1770 d. 28 Nov 1820
Lucy Crawley
b. 30 Dec 1775 d. 14 Nov 1825
8
Sally T. Burwell
[1.1.1.1.4.3.2.1]
b. Abt 1792 d. 1793/1886
8
Lucy Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.2.2]
b. 25 Dec 1801 d. 17 Feb 1860
8
Matilda Boyd Burwell
[1.1.1.1.4.3.2.3]
b. 3 Aug 1805 d. 11 Apr 1876
+
Lewis Dandridge Burwell
b. 13 Jul 1813 d. 19 Jan 1874
8
Harriet Dandridge Burwell
[1.1.1.1.4.3.2.4]
b. 5 Oct 1811 d. 18 May 1896
+
William Duke Jones
b. 28 May 1801 d. 14 Dec 1876
8
John Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.2.5]
b. 6 Apr 1813 d. 18 Aug 1857
+
Lucy Penn Guy
b. 29 May 1814 d. 13 Jul 1859
7
Richard Boyd Burwell
[1.1.1.1.4.3.3]
b. 20 Oct 1771 d. 13 Oct 1860
7
Ann Spotswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.4]
b. 14 Feb 1773 d. 1814
+
John "Mad Jack" Ravenscroft
b. 17 Apr 1772 d. 5 Mar 1830
7
Elizabeth Blair Burwell
[1.1.1.1.4.3.5]
b. 19 Jun 1774 d. 27 Aug 1833
+
Edward Lowry Tabb
b. 6 Jan 1769 d. 1797
7
Christian Burwell
[1.1.1.1.4.3.6]
b. 8 Dec 1774
+
William Hamblin
b. Abt 1770
7
John Spotswood Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.4.3.7]
b. 15 May 1776 d. 25 Apr 1854
Elizabeth Middleton Woods
b. 8 Mar 1790 d. 20 Nov 1863
8
Armistead Lewis Burwell
[1.1.1.1.4.3.7.1]
b. 1812 d. 1883
7
Lewis Burwell
[1.1.1.1.4.3.8]
b. 14 Dec 1779 d. 15 Apr 1847
Sally Edwards Green
b. 1784 d. 1880
8
Abram Lewis Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1]
b. 11 Apr 1805 d. 1887
Elizabeth Bloombury Peterson Wathall
b. 1818 d. 1884
9
Lewis Moton Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.1]
b. 1843 d. 1844
9
Sally Lewis Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.2]
b. 7 Feb 1845 d. 17 Dec 1891
+
Joseph Randolph Mitchell
b. 4 Jul 1836 d. 18 Nov 1902
9
Virginia A. Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.3]
b. 1848 d. 1849/1942
9
Charles Blair Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.4]
b. 1850 d. 1925
9
William Lewis Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.5]
b. 1852 d. 1923
+
Margaret Virginia Hall
b. 1875 d. 1952
9
Betty Brown Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.6]
b. 1854 d. 1929
+
Milton Walter Wagner
b. 6 Sep 1859 d. 19 Sep 1915
9
Henry Bascom Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7]
b. 1858 d. 1927
Mamie Jane Swett
b. 1867 d. 1933
10
Vernice Grace Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.1]
b. 1894 d. 1894
10
Annie Lewis Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.2]
b. 1895 d. 1975
10
Celest Lousia Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.3]
b. 1897 d. 1953
10
Harriet Harris Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4]
Ansley Powell Carney
b. 7 May 1890 d. 11 Oct 1968
11
Nell Harris Carney
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4.1]
11
Harry David Ben Carney
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4.2]
11
Jr. Ansley Powell Carney
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4.3]
11
Carolyn Carney
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4.4]
James Newton Holland
12
Volna Harriet Holland
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4.4.1]
[
=>
]
12
Carrol Lynn Holland
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4.4.2]
12
Jr. James Newton Holland
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4.4.3]
12
Susan Holland
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.4.4.4]
10
Russel Gladwin Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.5]
10
Jakie Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.6]
b. 1903 d. 1903
10
Henry Wadsworth Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.7]
b. 1906 d. 1972
10
Marrie Ray Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.1.7.8]
b. 1908 d. 1908
8
Ann Elizabeth Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.2]
b. 4 Nov 1806 d. 1884
+
Thedrick M. Roberts
b. 1789/1809 d. 1823/1895
8
Allen Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.3]
b. 6 Jun 1808 d. 1885
8
Jr. Lewis Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.4]
b. 5 Aug 1811 d. 1898
8
John Spotswood Randolph Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.5]
b. 2 Feb 1813 d. 1877
+
Panthea Eliza Boyd
b. 28 Aug 1821 d. 14 Aug 1851
8
William Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.8.6]
b. 27 Jun 1827 d. 29 Dec 1866
7
Panthea Burwell
[1.1.1.1.4.3.9]
b. 13 Nov 1781 d. 13 Nov 1848
John Richard Boyd
b. 16 Oct 1771 d. 13 Oct 1860
8
Panthea Eliza Boyd
[1.1.1.1.4.3.9.1]
b. 28 Aug 1821 d. 14 Aug 1851
+
John Spotswood Randolph Burwell
b. 2 Feb 1813 d. 1877
7
Blair Burwell
[1.1.1.1.4.3.10]
b. 29 May 1783 d. 8 Aug 1871
+
Sally Edwards Green
b. 1784 d. 1880
+
Delia Hatcher Harris
b. Abt 1806 d. 1833/1900
+
Elizabeth Hatcher
b. Abt 1786 d. 1813/1880
7
John Spotswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11]
b. 15 Jan 1785 d. 1 Jan 1855
Mary Green Marshall
b. 13 Dec 1792 d. 12 Jan 1856
8
William Marshall Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.1]
b. 4 Sep 1809 d. 15 May 1887
+
Mary Graves Williams
b. 15 Jul 1810 d. 1 Oct 1896
8
John Spotswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.2]
b. 18 Aug 1811 d. 31 May 1889
Sarah Elizabeth Hayes
b. 10 Sep 1814 d. 22 Sep 1865
9
Spotswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.2.1]
b. 7 Jan 1847 d. 23 Jan 1913
9
Martha Harrison Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.2.2]
b. Abt 1849 d. 1850/1943
9
Mary Lewis Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.2.3]
b. Abt 1851 d. 1852/1945
8
Lewis Dandridge Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.3]
b. 13 Jul 1813 d. 19 Jan 1874
+
Matilda Boyd Burwell
b. 3 Aug 1805 d. 11 Apr 1876
8
Blair Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.4]
b. 5 Oct 1815 d. 30 Mar 1848
Mary S. Davis
b. 1805/1826 d. 1848/1915
9
Laura Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.4.1]
+
Laura Blair
b. 1811/1828 d. 1832/1914
8
Henry Harrison Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.5]
b. 5 Mar 1818 d. 12 Aug 1884
Susan Caroline Hargrove
b. 20 Sep 1820 d. 25 May 1897
9
Jr. Henry Harrison Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.5.1]
b. Abt 1852 d. 8 Mar 1919
9
Nannie Hargrove Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.5.2]
b. 18 Sep 1854 d. 1855/1948
9
John Spotswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.5.3]
b. 19 Feb 1857 d. 9 Sep 1926
9
Susan Caroline Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.5.4]
b. 15 Oct 1858 d. 30 Jun 1934
9
Samuel Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.5.5]
b. 1864 d. 1938
8
Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6]
b. 30 Oct 1820 d. 8 Aug 1889
Elizabeth Kyle Norman
b. 5 Mar 1832 d. 28 Aug 1889
9
Thomas Norman Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.1]
b. Abt 1853
+
Mary Alice Travis
b. 1849/1869 d. 1870/1953
9
William Spottswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2]
b. 20 Jan 1855 d. 8 Nov 1943
Alice Josephine Morton
b. 1 Feb 1863 d. 20 Sep 1947
10
Bettie Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1]
b. 7 Apr 1883 d. 23 Nov 1959
William Henry Wilson
b. 12 Aug 1876 d. 16 Oct 1957
11
Jr. William Henry Wilson
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.1]
Hazel Iris Oliver
12
Joan Carol Wilson
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.1.1]
12
Judy Elaine Wilson
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.1.2]
12
Iris Jean Wilson
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.1.3]
12
Donald King Wilson
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.1.4]
11
Alice Morton Wilson
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2]
Roy Allen Cates
b. 20 Sep 1909 d. 8 Jun 1958
12
George Henry Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.1]
[
=>
]
12
David Clifford Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.2]
12
William Wilson Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.3]
[
=>
]
12
John Douglas Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.4]
[
=>
]
12
Brenda Anne Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.5]
[
=>
]
12
Betty Morton Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.6]
[
=>
]
12
Alice Marie Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.7]
[
=>
]
12
Jean Phyllis Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.8]
[
=>
]
12
Jr. Roy Allen Cates
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.2.9]
[
=>
]
11
Margaret Elizabeth Wilson
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.3]
Joseph Kenneth Dean
12
Jerry Kenneth Dean
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.1.3.1]
10
Jr. William Spottswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2]
b. 4 Aug 1884 d. 29 Oct 1940
Alexine Gregory Knott
b. 27 Dec 1888 d. 24 Sep 1972
11
Samuel Watkins Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.1]
11
Sallie Alexine Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.2]
11
Iola Frances Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.3]
11
Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.4]
11
Edna Mae Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.5]
11
Josephine Jackson Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.6]
11
Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.7]
11
James Morton Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.8]
11
Edna Mae Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.9]
11
III William Spottswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.10]
11
Samuel Watkins Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.11]
11
Sallie Alexine Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.12]
11
John Buxton Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.13]
Annie Doris Riggan
12
Brenda Joyce Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.13.1]
11
Frances Iola Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.14]
11
Richard Taylor Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.2.15]
b. 12 Nov 1926 d. 6 Dec 1963
10
Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.3]
b. 21 Apr 1886 d. 7 Jun 1956
10
James Morton Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.4]
b. 10 Aug 1888 d. 3 Sep 1954
Percye Carrington Rudd
b. 24 Jun 1888 d. 28 Jun 1973
11
Percye Venable Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.4.1]
11
James Sidney Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.4.2]
11
Taylor Spottswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.4.3]
11
Nancy Meade Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.4.4]
b. 31 Jul 1917 d. 1918
10
Annie Rochette Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5]
b. 13 Mar 1890 d. 13 Aug 1973
Jr. Andrew Bascom Spencer
b. 21 Jun 1884 d. 8 Nov 1956
11
Annie Venable Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.1]
11
Alice Dugger Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.2]
11
Mary Elizabeth Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.3]
11
Frank Charles Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.4]
11
Helen Jean Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.5]
11
III Andrew Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.6]
b. 1919 d. 1919
11
Willie Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.7]
b. 1919 d. 1919
11
Edward William Wright Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.8]
b. 1924 d. 1953
11
Sallie Spottswood Spencer
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.5.9]
10
Isaac Norman Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.6]
10
Margaret Venable Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7]
Howard Badgett Hester
b. 12 Aug 1892 d. 7 Aug 1971
11
Alice Thomas Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.1]
11
Lois Howard Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.2]
11
Anne Morton Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.3]
11
Margaret Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.4]
11
Mary Hamilton Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.5]
11
Howard June Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.6]
b. 1920 d. 9 Nov 1925
11
Alice Armistead Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.7]
11
Benjamin Spottswood Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.8]
b. 22 May 1924 d. 28 Jan 1974
11
Margaret Parish Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.9]
b. 1929 d. 16 Nov 1932
11
Jeanette Burwell Hester
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.7.10]
10
Sallie Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.8]
10
Nathaniel Daniel Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.9]
b. Mar 1896 d. Bef May 1900
10
Joseph William Thomas Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10]
b. 26 May 1898 d. 1 Jul 1970
Annie Hamilton Lee
11
Margaret Lee Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.1]
11
Henrietta Drake Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.2]
11
William Lee Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.3]
11
Annie Hamilton Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.4]
11
Ruth Howard Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.5]
11
Nathaniel Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.6]
11
John Spottswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.7]
11
Jean Adams Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.8]
11
Jr. Joseph William Thomas Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.9]
b. 1922 d. 1965
11
Bettie Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.10.10]
b. 1930 d. 1930
10
Nathaniel Daniel Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.11]
Josephine Babcock
11
Venable Babcock Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.11.1]
11
Augusta Jo Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.11.2]
11
Virginia Leach Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.11.3]
11
Jr. Nathaniel Daniel "Nat" Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.11.4]
11
Joy Kyle Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.2.11.5]
9
Sallie B. Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.3]
b. Abt 1859
+
Lycurgus L. Thomas
b. 1859
9
Isaac Norman Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.4]
b. Abt 1861 d. 1862/1951
9
Elizabeth Armistead Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.5]
b. 2 Aug 1862 d. 14 Nov 1944
+
John J. Parris
b. 1845/1865 d. 1879/1951
9
Jr. Armistead Ravenscroft Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.6.6]
b. Abt 1863
8
George Washington Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.7]
b. 12 Mar 1823 d. 16 Jun 1873
+
Elizabeth F. Gayle
b. 27 Oct 1827 d. 2 Aug 1872
8
Mary Ann Spottswood Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.8]
b. 25 Nov 1825 d. 1854
+
Otis F. Manson
b. 1798/1825 d. 1848/1912
8
Robert Randolph Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.9]
b. 16 Jan 1829 d. 9 Dec 1892
Jessie Atherton Dawson
b. 17 Feb 1841 d. 14 Feb 1899
9
Temperance Williams Burwell
[1.1.1.1.4.3.11.9.1]
b. 1854/1881 d. 1860/1964
7
Matilda Boyd Burwell
[1.1.1.1.4.3.12]
b. 10 Jan 1787 d. 9 May 1867
+
Alexander Boyd
b. Abt 1783 d. 1804/1876
7
Harriett Burwell
[1.1.1.1.4.3.13]
b. 14 Feb 1789 d. 14 Feb 1789
6
Mary Spotswood
[1.1.1.1.4.4]
b. 1752 d. 1766/1846
+
Peter Randolph
b. 1735/1755 d. 1769/1841
+
John Campbell
b. 1708/1738 d. 1763/1823
5
Jr. William Dandridge
[1.1.1.1.5]
b. 1727 d. Abt 1784
Agnes West
b. Abt 1740 d. Abt 1800
6
Francis Dandridge
[1.1.1.1.5.1]
b. 1749/1768 d. 1785/1852
Lucy Webb
b. 1735/1762 d. 1784/1852
7
Nancy Dandridge
[1.1.1.1.5.1.1]
b. 1758/1785 d. 1807/1875
Jr. Bowler Cocke
b. 1750/1782 d. 1807/1869
8
Elizabeth Cocke
[1.1.1.1.5.1.1.1]
d. 1764/1847
Thomas Massie
b. 1747 d. 1834
9
David Massie
[1.1.1.1.5.1.1.1.1]
b. 17 May 1777
9
Elizabeth Watkins Massie
[1.1.1.1.5.1.1.1.2]
b. 29 Mar 1781
7
IV William Dandridge
[1.1.1.1.5.1.2]
b. 1770/1808 d. 1792/1886
+
Sally Webb
b. 1770/1814 d. 1792/1894
7
John Dandridge
[1.1.1.1.5.1.3]
b. 1770/1808 d. 1781/1886
6
Agnes Dandridge
[1.1.1.1.5.2]
b. 1753/1772 d. 1790/1859
Edward Pye Chamberlayne
b. 1758 d. 1806
7
Jr. Edward Pye Chamberlayne
[1.1.1.1.5.2.1]
b. Abt 1787
7
William Byrd Chamberlayne
[1.1.1.1.5.2.2]
b. 1789 d. 1858
Ann Williamson Mosby
b. Abt 1792
8
Lucy W. Chamberlayne
[1.1.1.1.5.2.2.1]
+
Efford Bentley
8
Edwin Harvey Chamberlayne
[1.1.1.1.5.2.2.2]
+
Sarah Madison Scott
7
Robert Chamberlayne
[1.1.1.1.5.2.3]
b. Abt 1790
7
Thomas Chamberlayne
[1.1.1.1.5.2.4]
b. Abt 1791 d. CHILD
6
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.5.3]
b. 1751/1776 d. 1793/1862
Byrd Chamberlayne
b. Abt 1754 d. 1793/1853
7
Eleanor "Ellen" Chamberlayne
[1.1.1.1.5.3.1]
John Camm Pollard
8
Chamberlayne Pollard
[1.1.1.1.5.3.1.1]
7
Evelyn Byrd Chamberlayne
[1.1.1.1.5.3.2]
b. 1790 d. 1863
Jr. Robert Pollard
b. 1 Jan 1783 d. 18 Jun 1856
8
Robert Byrd Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.1]
b. 3 Jan 1810
8
William George Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.2]
b. 2 Apr 1818 d. Sep 1862
Sarah Adams Smith
b. Abt 1825
9
Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.2.1]
+
John Gascoine Moncure
8
James Otway Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.3]
b. 6 May 1820
+
George Anna Smith
8
Eliza Dandridge Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.4]
b. 7 Aug 1822 d. 7 Nov 1866
Beverly Browne Douglas
9
Elizabeth Dandridge Douglas
[1.1.1.1.5.3.2.4.1]
+
Travers Daniel Moncure
9
Mary Ellen Douglas
[1.1.1.1.5.3.2.4.2]
William T. Weathers
10
Willie True Weathers
[1.1.1.1.5.3.2.4.2.1]
10
Elizabeth Weathers
[1.1.1.1.5.3.2.4.2.2]
+
Tom Peet Cross
9
Evelyn Spotswood Douglas
[1.1.1.1.5.3.2.4.3]
b. 24 Feb 1841
James Colvin Causey
d. 6 Dec 1908
10
Beverly Douglas Causey
[1.1.1.1.5.3.2.4.3.1]
+
Mary Katherine Paul
10
Mary Douglas Causey
[1.1.1.1.5.3.2.4.3.2]
b. 16 Sep 1881
Marion Kelly Kendrick
b. Abt 1882
11
James Causey Kendrick
[1.1.1.1.5.3.2.4.3.2.1]
11
Elizabeth Dandridge Kendrick
[1.1.1.1.5.3.2.4.3.2.2]
11
Evelyn Douglas Kendrick
[1.1.1.1.5.3.2.4.3.2.3]
8
Edward Spotswood Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.5]
b. 7 Jul 1832
Mary Douglas
9
Evelyn Byrd Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.5.1]
+
Jr. Albert H. Stoddard
9
John Beverly Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.5.2]
9
Walter Weir Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.5.3]
9
James Hankins Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.5.4]
9
Henry Douglas Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.5.5]
9
William George Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.5.6]
9
Robert Spotswood Pollard
[1.1.1.1.5.3.2.5.7]
6
III William Dandridge
[1.1.1.1.5.4]
b. 1755/1781 d. 1798
5
Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.6]
b. 7 Sep 1729 d. 16 Jan 1786
Dorothea Spotswood
b. 1733 d. 25 Sep 1778
6
Martha Dandridge
[1.1.1.1.6.1]
b. 20 Sep 1748 d. 28 Sep 1791
Archibald "Archer" Payne
b. 12 Sep 1748 d. 1831
7
John Robert Dandridge Payne
[1.1.1.1.6.1.1]
b. 20 Nov 1770
Susan Bryce
8
Mary Jane Payne
[1.1.1.1.6.1.1.1]
James Alexander Turner
b. 15 Aug 1807 d. 19 Sep 1872
9
William Spotswood Turner
[1.1.1.1.6.1.1.1.1]
+
Juliet Holt
7
Anne Spotswood "Nancy" Payne
[1.1.1.1.6.1.2]
b. 19 Apr 1772 d. 23 May 1813
Thomas Mann Randolph Fleming
b. 12 Feb 1767 d. 21 Feb 1801
8
Ann Spotswood Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.1]
b. 1790 d. 1794
8
Martha Dandridge Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.2]
b. 5 Oct 1793 d. 1823
+
Peter Cotton
b. 1765/1797 d. 1822/1884
8
II Tarleton Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3]
b. 12 Aug 1795 d. 27 Jul 1859
Rebecca Elizabeth Coles
b. 23 Apr 1802 d. 21 May 1872
9
Elizabeth Anne Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.1]
b. 15 Dec 1828 d. 7 Apr 1893
+
William Webb
b. 1805/1847 d. 1830/1925
9
Thomas Mann Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.2]
b. 22 Jan 1830 d. 21 Nov 1872
Virginia K. Pemberton
b. 1834 d. 1860
10
Rebecca Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.2.1]
b. 1857 d. 1903
George J. Anderson
11
Mary Anderson
[1.1.1.1.6.1.2.3.2.1.1]
+
James F. Howison
10
Cannon Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.2.2]
b. 1839/1887 d. 1852/1963
10
Virginia Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.2.3]
b. 1839/1887 d. 1851/1966
+
Virginia Morrison
b. 1813/1855 d. 1834/1935
9
William Randolph Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.3]
b. 7 Jan 1832 d. 9 Nov 1892
Lelia Anna Shield
b. 18 Nov 1832 d. 24 Apr 1878
10
Jr. William Randolph Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.3.1]
b. 4 Mar 1859 d. 8 May 1898
10
Henry Corbin Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.3.2]
b. 11 Nov 1860 d. 6 May 1931
+
Lottie Webster
b. 1856/1875 d. 1877/1960
10
Orland Fairfax Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.3.3]
b. 9 Dec 1861 d. 1 Mar 1934
+
Belle Henley Harbold
b. 25 Jun 1867 d. 1891/1961
10
Thomas Mann Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.3.4]
b. 2 Sep 1862 d. 10 Sep 1863
10
Tarleton Beverley Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.3.5]
b. 3 Oct 1866 d. 10 May 1898
10
Charles Spotswood Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.3.6]
b. 19 Sep 1871 d. 1912/1962
+
Rosa Lee Carpenter
10
Samuel Shield Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.3.7]
b. 6 Oct 1873 d. 27 Oct 1943
9
Sarah Eleanor Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.4]
b. Abt 1833 d. 1830/1930
Jesse Hartwell Heath
b. 1805/1847 d. 1830/1925
10
Tarleton Fleming Heath
[1.1.1.1.6.1.2.3.4.1]
b. 30 Nov 1860 d. 25 Jul 1924
9
Sarah Elenor "Sallie" Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.3.5]
b. 28 Feb 1834 d. 8 Feb 1916
8
Mary Page Fleming
[1.1.1.1.6.1.2.4]
b. 23 Nov 1797 d. 1894
7
Martha Payne
[1.1.1.1.6.1.3]
b. 6 Nov 1773 d. 1787/1867
Jeremiah Strother
b. 1750/1776 d. 1801/1863
8
Archer Strother
[1.1.1.1.6.1.3.1]
b. 1791/1814 d. 1811/1895
+
Fay
b. 1791/1822 d. 1811/1904
8
Martha Strother
[1.1.1.1.6.1.3.2]
b. 1791/1814 d. 1796/1898
7
Jr. Archer Payne
[1.1.1.1.6.1.4]
b. 29 Nov 1775 d. 1776/1865
7
Dorothea Dandridge Payne
[1.1.1.1.6.1.5]
b. 10 Jul 1777 d. 1800/1871
Edward Bolling
b. 17 Sep 1772 d. 1835
8
Powhatan Polling Bolling
[1.1.1.1.6.1.5.1]
b. Abt 1800 d. Aft 1840
Arminda R. Payne
b. 1790/1816 d. 1840/1904
9
Pocahontas J. Bolling
[1.1.1.1.6.1.5.1.1]
b. 1830 d. 1831/1924
9
Elvira G. Bolling
[1.1.1.1.6.1.5.1.2]
b. 1837 d. 1838/1931
7
Catherine Payne
[1.1.1.1.6.1.6]
b. Abt 1780
Archibald Bolling
b. Abt 1770 d. 1829
8
Edward Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.1]
b. Abt 1793 d. 1855
+
Anne Cralle
b. 1786/1829 d. 1807/1909
8
Jr. Archibald Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2]
b. 1806 d. 1860
Anne E. Wiggington
b. 1795/1818 d. 1840/1906
9
Harriet W. Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.1]
+
Robert H. Waddell
9
Mary Jefferson Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.2]
+
Rudolph Tuesler
9
John Blair Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.3]
d. INFANT
9
William Holcombe Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4]
b. 29 May 1837 d. 6 Jul 1899
Sallie Spiers White
b. 5 Jan 1843 d. 21 Nov 1925
10
Rolfe Emerson Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.1]
b. 22 Aug 1861 d. 3 Feb 1936
Annie Stuart Litchfield
b. 19 Feb 1869 d. 12 Apr 1944
11
Elizabeth Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.1.1]
Jorge Eduardo Boyd
12
Lola Elizabeth Boyd
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.1.1.1]
12
Mildred Stuart Boyd
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.1.1.2]
12
Edith Bolling Boyd
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.1.1.3]
12
Elena Rolfe Boyd
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.1.1.4]
10
Gertrude Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.2]
b. 16 May 1863 d. 1893/1957
Alexander Hunter Galt
b. 5 Dec 1860 d. 1893/1951
11
Alexander Bolling Galt
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.2.1]
10
Anne Lee Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3]
b. 15 Jun 1865 d. 26 Feb 1917
Matthew Hawes Maury
b. 9 Jun 1860 d. 10 Oct 1930
11
Anne Bolling Maury
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3.1]
John A. Goodloe
12
Jr. John A. Goodloe
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3.1.1]
12
Ann L. Goodloe
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3.1.2]
12
Matthew Maury Goodloe
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3.1.3]
12
Elizabeth Goodloe
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3.1.4]
11
Lucy Logwood Maury
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3.2]
John Edward Moeling
12
Moeling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3.2.1]
12
Sally Green Moeling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.3.2.2]
b. 10 Aug 1937 d. 28 May 1965
10
William Archibald Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.4]
b. 11 Oct 1867 d. 1899/1958
Mary Johnson Keller
b. 31 Mar 1870 d. 1899/1964
11
John Esten Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.4.1]
+
Edith Marion Bourne
11
William Holcombe Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.4.2]
+
Virginia Gaither
10
Bertha Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.5]
b. 11 Oct 1869 d. 1870/1963
10
Charles Rodefer Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.6]
b. 11 Jun 1871 d. 11 Jun 1871
10
Edith Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.7]
b. 15 Oct 1872 d. 28 Dec 1961
+
Norman Galt
b. 30 Apr 1866 d. 28 Jan 1908
+
Thomas Woodrow Wilson
b. 28 Dec 1856 d. 3 Feb 1924
10
John Randolph Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.8]
b. 11 Apr 1876 d. 1877/1966
10
Richard Wilmer Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.9]
b. 6 Oct 1879 d. 1913/1970
Elianor Hunter Lutz
11
Clara Lutz Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.9.1]
11
Jr. Richard Wilmer Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.9.2]
11
Sterling Ruffin Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.9.3]
11
Barbara Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.9.4]
10
Julian Brandon Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.10]
b. 7 May 1882 d. 1912/1973
+
Viola Roosevelt Belden
10
Geraldine Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.2.4.11]
b. 12 Aug 1885 d. 6 Jul 1887
8
Pocahontas R. Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.3]
b. Abt 1810
+
William G. White
b. Est 1778/1822 d. Est 1803/1900
+
Peter J. Hill
b. 1815/1847 d. 1872/1934
8
Alexander Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.4]
b. 1785/1824 d. 1878
+
Susan Gray
b. 1786/1830 d. 1807/1909
8
Jefferson Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.5]
b. 1785/1824 d. 1797/1902
8
Catherine Bolling
[1.1.1.1.6.1.6.6]
b. 1785/1824 d. 1796/1905
7
Jane Spotswood Payne
[1.1.1.1.6.1.7]
b. 20 Oct 1780 d. 27 Feb 1807
+
Robert Bolling
b. Abt 1771
Jr. James Boswell Ferguson
b. 1781 d. 3 Sep 1858
8
Robert Bolling Ferguson
[1.1.1.1.6.1.7.1]
8
Jane Elvira Ferguson
[1.1.1.1.6.1.7.2]
b. 6 Apr 1806 d. 8 Sep 1888
Peachy R. Grattan
b. 7 Nov 1801 d. 8 Sep 1881
9
Elizabeth Gilmer Grattan
[1.1.1.1.6.1.7.2.1]
b. 1837 d. 1838/1931
9
Sally Gray Grattan
[1.1.1.1.6.1.7.2.2]
b. 10 Aug 1838 d. 1852/1932
+
Otho G. Kean
b. 1821/1841 d. 1855/1927
9
Lucy Gilmer Grattan
[1.1.1.1.6.1.7.2.3]
b. 10 Aug 1838 d. 14 Oct 1890
William Felix Alexander
b. 7 May 1832 d. 16 Aug 1907
10
Elvira B. Alexander
[1.1.1.1.6.1.7.2.3.1]
b. 4 Jan 1869
Edgeworth Bird Baxter
b. 18 Jul 1868 d. 7 Oct 1910
11
Lucy Alexander Baxter
[1.1.1.1.6.1.7.2.3.1.1]
11
Elvira Grattan Baxter
[1.1.1.1.6.1.7.2.3.1.2]
9
James Ferguson Grattan
[1.1.1.1.6.1.7.2.4]
b. 11 Jul 1840 d. 1879
+
Morris
b. 1836/1856 d. 1857/1940
9
George Gilmer Grattan
[1.1.1.1.6.1.7.2.5]
b. 12 Oct 1844 d. 1845/1934
7
Alexander Spotswood Payne
[1.1.1.1.6.1.8]
b. 20 Oct 1780 d. 1859
Charlotte Bryce
b. 15 Jun 1796 d. 1870
8
Archer Alexander Payne
[1.1.1.1.6.1.8.1]
b. 28 Jul 1805 d. 20 Jul 1826
8
Robert Spotswood Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2]
b. 15 Jan 1809 d. 28 Sep 1884
Frances Ann Russell Meem
b. 2 Apr 1819 d. 17 May 1870
9
John Meem Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1]
b. 11 Nov 1840 d. 16 May 1934
Elizabeth Allen Langhorne
b. 20 Dec 1842 d. 17 Jan 1936
10
Archer Langhorne Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1.1]
b. 24 Sep 1864 d. 1901
10
Robert Spotswood Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1.2]
b. 21 Jun 1866 d. 1920
10
John Meem Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1.3]
b. 30 Apr 1868 d. 1897
10
Francis Russell Meem Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1.4]
b. 9 Mar 1870
10
Margaret Kent Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1.5]
b. 12 Jan 1872 d. 17 Jan 1967
10
Daniel Allen Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1.6]
b. 5 Jan 1874 d. 19 Jan 1938
10
Andrew Russell Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1.7]
b. 3 Mar 1876
10
Eliza Meem Payne
[1.1.1.1.6.1.8.2.1.8]
b. 25 Oct 1877 d. 16 Jun 1957
8
George Woodson Payne
[1.1.1.1.6.1.8.3]
b. 29 Dec 1810 d. Jan 1870
+
Anne Elizabeth Dabney
b. 23 Sep 1814 d. 1839/1908
8
David Bryce Payne
[1.1.1.1.6.1.8.4]
b. 10 Aug 1812 d. 1888
Helen James
b. 1808/1828 d. 1833/1912
9
Ella Grattan Payne
[1.1.1.1.6.1.8.4.1]
b. 1833/1862 d. 1849/1944
+
George K. Turner
b. 1823/1860 d. 1849/1938
9
Robert Spotswood Payne
[1.1.1.1.6.1.8.4.2]
b. 1833/1862 d. 1853/1941
+
Meta Eskridge
b. 1832/1868 d. 1853/1948
9
David B. Payne
[1.1.1.1.6.1.8.4.3]
b. 1833/1862 d. 1853/1941
+
Ellen Scott
b. 1832/1868 d. 1853/1948
9
Richard J. Payne
[1.1.1.1.6.1.8.4.4]
b. 1833/1862 d. 1839/1941
9
Mary C. Payne
[1.1.1.1.6.1.8.4.5]
b. 1833/1862 d. 1838/1944
9
George A. W. Payne
[1.1.1.1.6.1.8.4.6]
b. 1833/1862 d. 1853/1941
+
Louise B. Mitchell
b. 1832/1868 d. 1853/1948
9
Helen Stockton Payne
[1.1.1.1.6.1.8.4.7]
b. 1833/1862 d. 1849/1944
+
Edward T. Page
b. 1823/1860 d. 1849/1938
8
James Ferguson Payne
[1.1.1.1.6.1.8.5]
b. 10 Sep 1814 d. 1831/1904
+
Frances Dudley
b. 1810/1830 d. 1831/1914
8
Martha Dandridge Payne
[1.1.1.1.6.1.8.6]
b. 20 Apr 1820 d. 1838/1914
Isaac Vandeventer
b. 1803/1823 d. 1838/1909
9
Robert Vandeventer
[1.1.1.1.6.1.8.6.1]
b. 1838/1861 d. 1843/1942
9
Helen Vandeventer
[1.1.1.1.6.1.8.6.2]
b. 1838/1861 d. 1854/1945
+
N. S. Purcell
b. 1828/1860 d. 1854/1940
8
Ann Bryce Payne
[1.1.1.1.6.1.8.7]
b. 3 May 1822 d. 12 Dec 1907
Henry Russell Smith
b. 1803/1834 d. 1862/1918
9
Lillias Smith
[1.1.1.1.6.1.8.7.1]
b. 17 Sep 1852 d. 1866/1946
+
Salmon M. Withers
b. 1835/1855 d. 1869/1941
9
Eliza Bell Smith
[1.1.1.1.6.1.8.7.2]
b. 18 Sep 1853 d. 1867/1947
+
James Isaac Hutton
b. 1836/1856 d. 1870/1942
9
Nansie Bryce Smith
[1.1.1.1.6.1.8.7.3]
b. 14 Jan 1857 d. 1871/1951
+
John Emil Roberts
b. 1840/1860 d. 1874/1946
9
Addison Melvin Smith
[1.1.1.1.6.1.8.7.4]
b. 3 Jul 1859 d. 1860/1949
8
Lilias James Payne
[1.1.1.1.6.1.8.8]
b. 6 Dec 1824 d. 1825/1918
8
William Michel Payne
[1.1.1.1.6.1.8.9]
b. 15 Feb 1828 d. 31 Oct 1898
Frances A. Mitchell
b. 1817/1841 d. 1873/1930
9
James Mitchell Payne
[1.1.1.1.6.1.8.9.1]
b. 8 Sep 1855 d. 19 Aug 1913
+
Margaret Belville
b. 1851/1870 d. 1872/1955
9
William Spotswood Payne
[1.1.1.1.6.1.8.9.2]
b. 16 May 1858 d. 9 Jul 1907
+
Mary Norvell
b. 1854/1873 d. 1875/1958
9
Ida Payne
[1.1.1.1.6.1.8.9.3]
b. 30 Apr 1860 d. 26 Mar 1880
9
Josephine Payne
[1.1.1.1.6.1.8.9.4]
b. 20 Nov 1861 d. 1875/1955
+
R. W. Wooten
b. 1844/1864 d. 1878/1950
9
J. Duche Payne
[1.1.1.1.6.1.8.9.5]
b. 7 Jul 1867 d. 1884/1957
+
Minnie Kohe
b. 1863/1883 d. 1884/1967
9
Alexander S. Payne
[1.1.1.1.6.1.8.9.6]
b. 31 Jul 1869 d. 1886/1959
+
Nora Van Lear Huddleson
b. 1865/1885 d. 1886/1969
9
Frances Dandridge Payne
[1.1.1.1.6.1.8.9.7]
b. 14 Sep 1871 d. 1885/1965
+
E. D. Brown
b. 1854/1874 d. 1888/1960
8
Charlotte Bryce Payne
[1.1.1.1.6.1.8.10]
b. 9 Jan 1829 d. 27 Oct 1915
John Hastings Winston
b. 1803/1829 d. 1853/1917
9
Charlotte P. Winston
[1.1.1.1.6.1.8.10.1]
b. 1847/1870 d. 1863/1954
+
Samuel Read
b. 1837/1869 d. 1863/1949
+
Alexander West
b. 1837/1869 d. 1863/1949
9
Sarah Althea Winston
[1.1.1.1.6.1.8.10.2]
b. 1847/1870 d. 1863/1954
+
John Brown
b. 1837/1869 d. 1863/1949
9
Harriett Winston
[1.1.1.1.6.1.8.10.3]
b. 1847/1870 d. 1863/1954
+
Gwathmey
b. 1837/1869 d. 1863/1949
9
Frank Winston
[1.1.1.1.6.1.8.10.4]
b. 1847/1870 d. 1852/1951
9
Mary Lee Winston
[1.1.1.1.6.1.8.10.5]
b. 1847/1870 d. 1852/1954
9
John Winston
[1.1.1.1.6.1.8.10.6]
b. 1847/1870 d. 1867/1951
+
Taylor
b. 1847/1878 d. 1867/1960
8
Harriett Jane Payne
[1.1.1.1.6.1.8.11]
b. 11 Feb 1831 d. 1876
+
William Steptoe
b. 1815/1847 d. 1872/1931
7
Elizabeth Payne
[1.1.1.1.6.1.9]
b. 29 Oct 1782 d. 1783/1876
7
America Payne
[1.1.1.1.6.1.10]
b. 5 Nov 1786 d. 1787/1880
6
William Alexander Dandridge
[1.1.1.1.6.2]
b. 6 Apr 1750 d. 1801
Anne Bolling
b. 7 Feb 1751/52 d. Aft Aug 1802
7
II Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1]
b. 14 Jan 1771 d. 26 Jul 1847
Martha Henry Fontaine
b. 4 Jul 1781 d. 12 Sep 1845
8
Eliza Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.1]
b. 1800 d. 1855
+
William Herford
b. 1765/1797 d. 1822/1884
8
William Fontaine Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.2]
b. 1804
Susan C. Stith
b. Abt 1809 d. 1830/1898
9
Catherine Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.2.1]
b. Abt 1826
9
John W. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.2.2]
b. Abt 1829
9
Mona H. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.2.3]
b. Abt 1835
9
Morrison Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.2.4]
b. Abt 1838
9
Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.2.5]
b. Abt 1841
8
Charles Fontaine Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.3]
b. 1806 d. 1866
Tabitha Ann McGee
b. 1794/1829 d. 1815/1910
9
McGee Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.3.1]
d. 7 Apr 1861
8
Martha Lightfoot Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.4]
b. 1821 d. 3 Jun 1850
Richard Bolton
b. 1785/1820 d. 1811/1900
9
William Bolton
[1.1.1.1.6.2.1.4.1]
8
Henry Bolling Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5]
b. 1823 d. Aft 1885
Caroline Wylie
9
Mary Jane Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.1]
b. Abt 1829
9
Zelia Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.2]
b. Abt 1832
+
E. H. Lewis
9
Matilda Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.3]
b. Abt 1834
9
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.4]
b. Abt 1836
+
William P. Ome
9
Martha Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.5]
b. Abt 1838
9
Bolling Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.6]
b. Abt 1839
Adeline Kenon Wilbourn
b. 1818/1843 d. 1865/1931
9
Nannie Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.7]
b. 1844/1872 d. 1849/1954
9
Jr. Henry Bolling Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.8]
b. 1844/1872 d. 1850/1951
9
Lightfoot Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.5.9]
b. 17 Apr 1874 d. 13 Dec 1928
Henry Woodson Baker
b. 26 Jan 1859 d. 24 Dec 1929
10
Katie Jenkins Baker
[1.1.1.1.6.2.1.5.9.1]
Marvin N. Fogleman
11
Mary Kate Fogleman
[1.1.1.1.6.2.1.5.9.1.1]
Thomas Dove Copeland
12
Connie Sue Copeland
[1.1.1.1.6.2.1.5.9.1.1.1]
[
=>
]
12
Sharon Diane Copeland
[1.1.1.1.6.2.1.5.9.1.1.2]
[
=>
]
8
III Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.6]
b. 1824
Harriett A. Wylie
b. Abt 1828 d. 1815/1910
9
Mary Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.6.1]
b. Abt 1849
9
William B. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.6.2]
b. Abt 1853
8
Rosalie Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.1.7]
b. 1825 d. 1898
+
William Daugherty Bradford
b. 1785/1820 d. 1811/1900
7
William Alexander Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2]
b. 30 Aug 1772 d. 10 Sep 1842
+
Joanna Stith
b. 1778 d. Bef Jun 1800
Nancy Harris Pullium
b. 23 Mar 1782 d. 9 May 1835
8
Elizabeth B. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.1]
b. 11 Aug 1801 d. 22 Sep 1804
8
William P. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.2]
b. 7 Dec 1803 d. 22 Dec 1803
8
Ann L. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.3]
b. 1 Mar 1805 d. 11 May 1818
8
Jr. William Alexander Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4]
b. 12 May 1807 d. 27 Oct 1865
Sarah Virginia Nicholds
b. 1796/1820 d. Aft 20 Aug 1845
9
Thomas West Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.1]
b. Abt 1836 d. Abt 1880
9
Robert Bolling Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2]
b. 6 Aug 1838 d. 13 Feb 1907
Susan Webster Rangeley
b. 30 Nov 1843 d. 26 Sep 1936
10
Annie Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.1]
10
William Rangeley Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.2]
b. 10 Sep 1867 d. 13 Feb 1948
Grace Overton
11
Mary Susan Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.2.1]
+
Clinton Eugene Main
b. 22 Aug 1910 d. 7 May 1970
11
William Frank Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.2.2]
Mary Ann Shelton
12
Carolyn Faye Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.2.2.1]
[
=>
]
12
Robert Edward Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.2.2.2]
[
=>
]
12
Charles Wayne Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.2.2.3]
[
=>
]
+
Nell Horton
11
Lucy Virginia Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.2.3]
Edward Henry Watkins
12
Thomas Edward Watkins
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.2.3.1]
10
John Thomas Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.3]
b. Abt 1870
10
John Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4]
b. 14 Jul 1870 d. 15 Feb 1946
Annie Delma Lovell
b. 10 May 1886 d. 24 May 1955
11
Harry Neal Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.1]
Helen Louise Harmon
12
Cathy Jeanine Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.1.1]
[
=>
]
11
Lucille Rangeley Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.2]
11
Thomas Hugh Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.3]
+
Sallie Ruth Ross
11
Iris Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.4]
Chesley Randolph Yates
12
Iris Jean Yates
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.4.1]
[
=>
]
12
Carolyn Fay Yates
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.4.2]
12
Jr. Chesley Randolph Yates
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.4.3]
[
=>
]
11
Robert Jackson Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.5]
Sarah Ruth Anthony
12
William Rangeley Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.5.1]
[
=>
]
12
Jr. Robert Jackson Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.5.2]
[
=>
]
12
Martha Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.5.3]
[
=>
]
12
Susan Ruth Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.5.4]
[
=>
]
11
Essie Mae (Elaine) Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.6]
Eugene Gregory Cehan
12
Francis Elizabeth Cehan
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.6.1]
12
Barbara Jean Cehan
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.6.2]
[
=>
]
12
Jr. Eugene Gregory Cehan
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.6.3]
11
Mary Alice Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.7]
Walter Krawczel
12
Richard Steven Krawczel
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.4.7.1]
[
=>
]
10
Una Denzil Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.5]
b. 31 Mar 1876 d. 18 Dec 1959
Kelsey Puckett
b. 16 Feb 1869 d. Apr 1924
11
Evelyn Spottswood Puckett
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.5.1]
b. 24 Apr 1910 d. 16 Jul 1911
11
Virginia Rangeley Puckett
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.5.2]
b. 20 Aug 1913
James Fontaine Hodnett
b. Cal 1912
12
Jr. James Fontaine Hodnett
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.5.2.1]
[
=>
]
12
Carolyn Rangeley Hodnett
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.5.2.2]
[
=>
]
10
Annie Dell Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.6]
b. 15 Jan 1881 d. 5 Apr 1964
10
Thomas Nichols Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.7]
b. 18 Oct 1883 d. 29 Feb 1964
10
Harry Clay Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8]
b. 23 Jan 1887 d. 29 May 1947
Grace Mildred Barr
b. 27 Apr 1894 d. 29 May 1964
11
Ellen Katherine Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.1]
11
Anna Pearl Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.2]
Harold T. Eastwood
12
Gary Dandridge Eastwood
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.2.1]
12
Dean Raymond Eastwood
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.2.2]
12
Beverly Barr Eastwood
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.2.3]
[
=>
]
11
Janet Lee Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.3]
Thomas Edward Miller
12
Jr. Thomas Edward Miller
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.3.1]
12
Katherine Galt Miller
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.3.2]
[
=>
]
12
Susan Dandridge Miller
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.3.3]
11
Jr. Harry Clay Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.4]
+
Mary Belle Preece
11
William Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.5]
Hetty Wray Hurd
12
Jr. William Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.5.1]
12
James Hurd Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.5.2]
[
=>
]
12
Thomas Clay Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.5.3]
12
Anne Wray Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.5.4]
[
=>
]
11
Thomas Rangeley Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.2.8.6]
b. 25 Oct 1918 d. Jul 1938
9
Harry Clay Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.3]
b. 5 Aug 1840 d. 1872/1931
Maria Dodd
b. 1827/1850 d. 3 Jul 1869
10
Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.3.1]
b. Abt May 1869 d. 1890/1959
Watson
b. 1865/1885 d. 1890/1969
11
Nell Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.3.1.1]
9
John M. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.4]
b. Abt 1843 d. Abt 1862
9
Sarah Virginia Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.5]
b. 20 Aug 1845 d. 7 Dec 1908
Samuel Wall
b. 28 Jun 1847 d. 14 Nov 1900
10
Thomas Wall
[1.1.1.1.6.2.2.4.5.1]
b. 1864/1892 d. 1871/1972
10
Elizabeth Roseboro Wall
[1.1.1.1.6.2.2.4.5.2]
b. 1864/1892 d. 1870/1975
10
Jr. Samuel S. Wall
[1.1.1.1.6.2.2.4.5.3]
b. 1864/1892 d. 1871/1972
10
Robert Edward Wall
[1.1.1.1.6.2.2.4.5.4]
b. 1864/1892 d. 1871/1972
10
Nannie Spotswood Wall
[1.1.1.1.6.2.2.4.5.5]
b. 1864/1892 d. 1870/1975
Mary Jane Hamner
b. 15 Jan 1817 d. Apr 1879
9
Nannie Anderson Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.6]
b. 15 Apr 1848 d. 4 Jun 1922
Peter Washington Dalton
10
Elliott Dalton
[1.1.1.1.6.2.2.4.6.1]
10
Edgar Elliot Dalton
[1.1.1.1.6.2.2.4.6.2]
b. 1866/1889 d. 1871/1970
10
Harry Lee Dalton
[1.1.1.1.6.2.2.4.6.3]
b. 1866/1889 d. 1871/1970
10
Charles Dalton
[1.1.1.1.6.2.2.4.6.4]
b. 1866/1889 d. 1871/1970
10
Ada Nannie Anderson Dalton
[1.1.1.1.6.2.2.4.6.5]
b. 1866/1889 d. 1871/1973
10
Nannie Anderson Dalton
[1.1.1.1.6.2.2.4.6.6]
b. 1866/1889 d. 1871/1973
10
Hunter Dalton
[1.1.1.1.6.2.2.4.6.7]
b. 1866/1889 d. 1871/1970
10
Irene Dalton
[1.1.1.1.6.2.2.4.6.8]
b. 1866/1889 d. 1871/1973
9
Mary Pocahontas Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.7]
b. 24 Jul 1849 d. 29 Oct 1915
James Thomas Wilborn
b. 15 Jun 1849 d. 24 Jan 1940
10
William Clark Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.1]
b. 26 Feb 1875 d. Aft 1963
Anna Davis
11
Marjorie Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.1.1]
11
Willodean Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.1.2]
10
James Durwood Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.2]
b. 8 Dec 1877 d. 14 Apr 1936
Mamie Allen
b. 17 Dec 1882 d. 2 May 1960
11
James Harris Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.2.1]
b. 24 Aug 1909 d. 12 Oct 1974
+
Jewel Lipsey
11
William Allen Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.2.2]
b. 24 May 1911 d. 9 Feb 1969
+
Ruth Hyde
11
Marcus Eugene Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.2.3]
Mary Louise Triplett
12
Diana Sue Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.2.3.1]
[
=>
]
12
Sandra Ann Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.2.3.2]
[
=>
]
11
Mabel Elizabeth Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.2.4]
+
Michael E. Shaleen
11
Thomas Henry Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.2.5]
+
Connie Roe
+
Anita Stratten
10
Ora Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.3]
b. Abt 1882 d. 6 Feb 1888
10
Marcus Samuel Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.4]
b. 8 Jun 1883 d. 12 Feb 1966
+
Eva Smart Powell
+
Beatrice Dandridge
10
Mabel Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.5]
b. 8 Jun 1883 d. Abt 1886
10
Bessie V. Wilborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.6]
b. 19 Mar 1891 d. Aft 1963
Locke Lafon Welborn
11
Clary H. Welborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.6.1]
11
Mary Nell Welborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.6.2]
11
Durwood Lafon Welborn
[1.1.1.1.6.2.2.4.7.6.3]
+
Bessie Louise Bacon
9
James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8]
b. 27 Jan 1851 d. Bef 1900
Mary Eliza Cathey
b. 1846/1869 d. 1896/1958
10
Jimmie Lou Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.1]
10
Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.2]
10
Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.3]
10
Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.4]
10
Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.5]
10
Cathey Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6]
b. 15 Feb 1891 d. 25 Jul 1970
Ollie May Dupuy
11
Edward Roy Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6.1]
Grace Griffin
12
Edward Cathey Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6.1.1]
12
Ralph Marlin Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6.1.2]
11
Hayley Cathey Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6.2]
Marjorie Latham
12
Nancy Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6.2.1]
11
James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6.3]
b. Dec 1920 d. 7 Jul 1948
Dorothy Hyde
12
Edith Gwendolyn Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6.3.1]
12
James Haley Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.6.3.2]
b. Abt 1941 d. Abt 1963
10
Jr. James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.7]
b. 1871/1892 d. 31 Jan 1894
10
Jimmie Ophelia Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.8.8]
+
Marvin A. Ingram
b. 1876/1896 d. Abt 1940
9
George Gilmer Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9]
b. 29 Jan 1853 d. Abt 1946
Mattie Sue Norfleet
b. Abt 1861 d. Abt 1934
10
Mary Merle Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.1]
+
E. A. Billingsly
10
W. Edward Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.2]
10
Pattie Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.3]
+
M. B. Hardwicke
10
Lucile Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.4]
10
Jessie Lee Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.5]
Thomas H. Rogers
11
Laura Rogers
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.5.1]
+
Hixson
10
George Gilmer Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.6]
b. 17 Jul 1890 d. 4 Jul 1947
10
Beatrice Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.7]
+
Marcus Samuel Wilborn
b. 8 Jun 1883 d. 12 Feb 1966
10
Samuel Clark Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.8]
b. 7 Apr 1892 d. 29 Jul 1949
10
James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.9]
b. 17 Sep 1900 d. 22 Jan 1960
10
Merle Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.10]
10
Jessie Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.11]
10
Edward Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.12]
10
Martha Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.13]
10
Zelia Lightfoot Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.14]
+
M. Thompson
10
Mattie Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.9.15]
+
Robert Smith
9
Samuel Hamner Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10]
b. 1 Jan 1855 d. Apr 1927
Nannie Cathey
b. Oct 1865 d. Abt 1929
10
Mildred Hamner Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.1]
b. 11 Oct 1891 d. 23 Mar 1957
Perrin Holmes Lowery
11
Gloria Lowery
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.1.1]
+
John Kelly
10
William Cathey Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.2]
b. 31 Jul 1893 d. 11 Jun 1971
Velma Dickerson
11
Jr. William Cathey Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.2.1]
+
Joann Hawkins
11
Anne Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.2.2]
George Hugh Freeman
b. 1898/1929 d. 6 Dec 1952
12
Carol Diane Freeman
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.2.2.1]
12
Patricia Freeman
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.2.2.2]
+
Jr. Leon Lucien Parks
11
Lightie Rivers Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.2.3]
+
William Maurice Durley
10
Lightie Louise Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.3]
b. 12 Feb 1896 d. Abt 1975
10
George Samuel Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.4]
+
Jean Feathersone
10
James Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.10.5]
b. Abt 1902 d. 1903
9
Emma Louise Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.11]
b. 19 Nov 1857 d. 22 Apr 1930
9
Martha Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.12]
b. 2 Jan 1859 d. 31 Jan 1918
J. W. Thornton
b. 1839/1868 d. 1893/1953
10
Dandridge Thornton
[1.1.1.1.6.2.2.4.12.1]
10
Margaret Thornton
[1.1.1.1.6.2.2.4.12.2]
10
Mary Thornton
[1.1.1.1.6.2.2.4.12.3]
9
Walter Alexander Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.13]
b. 24 Jul 1862 d. 5 Sep 1932
+
Elizabeth B. Davis
+
Lucy Cathey
b. 1860/1913 d. 23 Dec 1953
9
Elizabeth Lee Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.4.14]
b. 8 Sep 1865 d. 1887/1959
Emmett T. Gumpton
b. 14 May 1865
10
Dandridge Perry Gumpton
[1.1.1.1.6.2.2.4.14.1]
10
Mary Caroline Gumpton
[1.1.1.1.6.2.2.4.14.2]
10
Anna Louise Gumpton
[1.1.1.1.6.2.2.4.14.3]
10
Walter George Gumpton
[1.1.1.1.6.2.2.4.14.4]
d. Abt 1906
8
Sarah T. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.5]
b. 30 May 1809 d. May 1841
+
William H. Starling
b. 1785/1811 d. 1836/1898
8
Robert T. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.6]
b. 22 Apr 1811 d. 28 Apr 1843
+
Sarah S. Pulliam
b. Abt 1816 d. 1853/1911
8
Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.7]
b. 30 Apr 1813 d. 5 May 1813
8
John Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8]
b. 26 May 1814 d. 1877/1907
Martha Washington Pulliam
b. 1822 d. 9 Apr 1875
9
James T. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.1]
b. Abt 1837 d. 1838/1927
9
William Bolling Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.2]
b. Abt 1838
Mary Susan Vaughan
10
Laura Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.2.1]
b. 4 Jun 1881
9
Anne Catherine Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.3]
b. Abt 1841 d. 1842/1935
9
Henry Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.4]
b. 15 Jul 1842 d. 23 Apr 1915
Sarah Frances Armstrong
b. 20 Aug 1844 d. 5 Mar 1921
10
Leonard Joseph Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.1]
b. 1865 d. 1866/1955
10
Charles L. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.2]
b. 1871 d. 1872/1961
10
James Guy Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.3]
b. 11 Mar 1873 d. 11 Nov 1945
+
Ada Arringron
b. 1875 d. 1905
10
Stephen Price Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.4]
b. Nov 1875 d. 1947
+
Martha Ann Leggett
b. 1871/1891 d. 1892/1975
10
Martha Roberta Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5]
b. 16 Aug 1882 d. 7 Oct 1940
Horace Greeley Culpepper
b. 16 Jun 1872 d. 25 Dec 1958
11
Thomas Webber Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.1]
+
Marilyn M. Mayer
11
Bobbie Louise Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.2]
+
Franklin L. Young
11
Lillian Aline Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.3]
b. 2 Aug 1904 d. 18 Jan 1966
+
Swift McAulay
11
Mary Frances Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.4]
+
Jack Hayne
+
Harold Samuel Levi
11
Horace Cohn Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.5]
+
Bobbie Ridgeway
11
Bessie Lee Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.6]
b. 3 Jun 1911 d. INFANT
11
Virginia Pearl Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.7]
+
J. W. Montgomery
+
John Douglas Askew
11
Mabel Elizabeth Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.8]
+
Reece L. Lewing
11
Joseph Henry Culpepper
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.5.9]
+
Elizabeth Munson
+
Madeline Gomes
10
Henry Armstrong Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.4.6]
b. 9 Apr 1886 d. 27 Mar 1953
+
Della Lee Davis
b. 18 Dec 1886 d. 18 Feb 1960
9
John Dallas Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5]
b. 27 Mar 1846 d. 1893/1938
Elizabeth Jane Atkisson
b. 1829/1856 d. 1887
10
Martha Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1]
b. 6 Dec 1869 d. 7 Mar 1955
Morgan Jackson Toler
b. 1867 d. 1943
11
Betty Jane Toler
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1.1]
b. 18 Jun 1890 d. 9 Mar 1972
+
Andrew Jackson Atkinson
11
Bernice Lee Toler
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1.2]
b. 21 Nov 1891 d. 15 Feb 1912
+
George Washington Brooks
11
Ray Davis Toler
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1.3]
Allenia Elizabeth Powers
12
Myrle Jewel Toler
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1.3.1]
12
Eugene Brady Toler
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1.3.2]
11
Roy Jackson Toler
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1.4]
b. 23 Jun 1894 d. 15 Dec 1973
+
Gracie Lillian Long
11
Charles Clay Toler
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1.5]
b. 18 Sep 1898 d. 9 Dec 1970
+
Daisy Estelle Gammon
11
Annie Lelia Toler
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.1.6]
+
Frank Elery Willis
10
Clay Arlington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.2]
b. 20 Jun 1871 d. 27 Nov 1947
Nancy Caroline Brooks
11
James Dallas Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.2.1]
+
Virginia Payne
11
Hazel Bernice Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.2.2]
+
Bryan Branson Wilson
11
Eleanor Myrtle Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.2.3]
+
Emory Alvis
11
Flora Jane Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.2.4]
+
Joel Lester Powers
11
Marian Arlington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.2.5]
10
Lelia Celestial Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.5.3]
b. 6 Oct 1879 d. 11 Mar 1966
+
Landon Cutler Singleton
b. 1856/1883 d. 1908/1969
+
Susan Catherine Ragland
b. 1843/1872 d. 1894/1959
9
Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.6]
b. 10 May 1854 d. 1855/1944
9
Charles C. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.7]
b. Abt 1856 d. 1890/1947
+
Elizabeth Carter
b. 1847/1868 d. 1890/1957
Louisa Virginia Perkins
b. 1814/1845 d. 1879/1935
9
Rosa Lee Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.8]
b. 28 Jan 1873 d. 23 Nov 1876
9
Lucy Anderson Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.9]
b. 17 Mar 1875 d. 1876
9
Eunice Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.8.10]
b. 24 Aug 1877 d. 11 Oct 1931
+
Benjamin Franklin Amos
b. 1852/1878 d. 1902/1965
8
Mary Jane Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.9]
b. 7 Dec 1816 d. 5 Sep 1820
8
Spottswood B. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.2.10]
b. 7 Feb 1820 d. 25 Jul 1828
7
Elizabeth Blair Dandridge
[1.1.1.1.6.2.3]
b. 21 Apr 1774 d. 1 Apr 1796
7
Archibald Bolling Dandridge
[1.1.1.1.6.2.4]
b. 22 Dec 1776 d. 1815/1867
+
Elizabeth M. Underwood
b. 13 Sep 1798 d. 1814/1892
7
Dorothea Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.2.5]
b. 5 Jan 1779 d. 10 Feb 1821
Frederick William James
b. 1781 d. Feb 1825
8
Alfred Turpin James
[1.1.1.1.6.2.5.1]
b. 19 Nov 1802 d. 1803/1892
8
William Dandridge James
[1.1.1.1.6.2.5.2]
b. 20 Jun 1803 d. 28 Aug 1804
8
Martha Ann James
[1.1.1.1.6.2.5.3]
b. 9 Feb 1805 d. 1830/1899
William B. Johnson
b. 1779/1805 d. 1829/1893
9
Frederick Valentine Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1]
b. 28 Nov 1825
Cornelia Ann Harris
10
William Richard Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.1]
b. 5 Sep 1848
10
Isabella May Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.2]
b. 10 May 1850
+
W. N. Cowan
10
Ann Letitia Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.3]
b. 6 Apr 1852 d. 20 Oct 1917
+
Charles Askin
10
Eliza Jane Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.4]
b. 26 Jul 1854 d. 28 Mar 1875
10
Sue Emma Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.5]
b. 15 Dec 1857 d. 18 Feb 1932
+
James M. Irvin
10
George Robinson Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.6]
b. 17 Jan 1860
+
Corrine Lewis
10
Frederick Harris Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.7]
b. 23 Oct 1862
10
Mary Cornelia Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.8]
b. 11 Oct 1866 d. 25 Sep 1885
10
Jessie Lee Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.1.9]
b. 15 Nov 1869 d. 24 Apr 1902
+
Charles Albert Nye
b. 5 Mar 1855 d. 24 Aug 1921
9
Elizabeth Ann Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.2]
b. 5 Nov 1828 d. 22 May 1861
9
Isabella Marion Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.3]
b. 25 Aug 1830 d. 25 Sep 1849
9
Henrietta Snow Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.4]
b. 2 Jun 1832 d. 23 Aug 1854
9
Helen St. Mawr Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.5]
b. 22 Jan 1835 d. 29 Aug 1835
9
William Bennett Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.6]
b. 14 Feb 1838
9
Martin Van Buren Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.7]
b. 18 Oct 1840 d. 25 Jan 1858
9
James Oscgood Andrew Johnson
[1.1.1.1.6.2.5.3.8]
b. 15 Nov 1844 d. 17 Jan 1852
8
Richard Henry James
[1.1.1.1.6.2.5.4]
b. 15 Sep 1806 d. 15 Sep 1806
8
Mary Lavinia James
[1.1.1.1.6.2.5.5]
b. 1 Jan 1808 d. 28 Jun 1856
+
Morgan Utz
b. 1791/1811 d. 1825/1897
8
Isabella Marion James
[1.1.1.1.6.2.5.6]
b. 16 Oct 1811 d. 23 Feb 1830
+
Lawrence S. Banks
b. 1783/1811 d. 1833/1898
8
Archibald Bolling James
[1.1.1.1.6.2.5.7]
b. 7 Sep 1813 d. 1830/1903
+
Ann Eliza Harris
b. 1809/1829 d. 1830/1913
8
Elizabeth Goode James
[1.1.1.1.6.2.5.8]
b. 7 Jan 1815 d. 15 Jun 1840
+
Samuel Martin
b. 1790/1816 d. 1840/1903
8
Lucy Ambler James
[1.1.1.1.6.2.5.9]
b. 1816 d. 1816
8
Jane Catherine James
[1.1.1.1.6.2.5.10]
b. 11 Aug 1817 d. 6 Jun 1840
+
Larkin Bradford
b. 1800/1819 d. 1834/1906
8
Marion James
[1.1.1.1.6.2.5.11]
b. 1798/1820 d. 1804/1902
8
Richard Bland James
[1.1.1.1.6.2.5.12]
b. 29 May 1820 d. 11 Dec 1885
Sarah Woodson Bransford
b. 5 Jul 1796 d. 20 May 1862
9
Mary Catherine James
[1.1.1.1.6.2.5.12.1]
b. 27 Dec 1840 d. 28 Jun 1910
9
Marion Isabella James
[1.1.1.1.6.2.5.12.2]
b. 30 Aug 1842 d. 5 May 1903
+
Henry J. Ford
+
N. W. Hawkins
9
John Henry James
[1.1.1.1.6.2.5.12.3]
b. 31 Jul 1844 d. 30 Jun 1885
Alice Cook Connally
10
Thomas Brewster James
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1]
b. 5 Apr 1872 d. 12 Dec 1926
Laura Octavia Branum
b. 29 Nov 1880 d. 13 Aug 1971
11
Ruth Lawler James
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.1]
b. 1 Jan 1903
Earl Clarence Worley
12
Laura Jacqueline Worley
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.1.1]
[
=>
]
12
Jr. Earl Clarence Worley
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.1.2]
[
=>
]
12
James Bruce Worley
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.1.3]
[
=>
]
12
Ruth Geraldine Worley
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.1.4]
[
=>
]
11
Bertha Mildred James
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.2]
b. 29 Jul 1905
Albert Cotton Jordan
12
Carolyn Fay Jordan
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.2.1]
[
=>
]
12
Mary Joyce Jordan
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.2.2]
[
=>
]
11
Alice Edna James
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.3]
b. 9 Oct 1910
Thomas Pickens
12
Edna Doris Pickens
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Virginia Lorene Pickens
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.3.2]
[
=>
]
12
Sandra Gale Pickens
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.3.3]
11
Virgil Connally James
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.4]
b. 27 Feb 1913 d. Abt 1931
11
Thomas Brewster James
[1.1.1.1.6.2.5.12.3.1.5]
Sarah Ann Howard
b. 1816/1835 d. 1 Jul 1861
9
Alfred Bolling James
[1.1.1.1.6.2.5.12.4]
b. 21 Sep 1852 d. 2 Apr 1906
Mary Jackson Curry
10
Blanche B. James
[1.1.1.1.6.2.5.12.4.1]
b. 30 Aug 1875
10
Walter Bland James
[1.1.1.1.6.2.5.12.4.2]
b. 15 Aug 1880
9
Arabella Elizabeth "Betty" James
[1.1.1.1.6.2.5.12.5]
b. 1 Jul 1854 d. 11 May 1898
9
Frances Ann James
[1.1.1.1.6.2.5.12.6]
b. 15 Mar 1859 d. 15 Aug 1915
Roland Alexander Gooch
d. 16 Mar 1883
10
Howard Bland Gooch
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.1]
b. 1 Nov 1881
+
Augusta Ernestine Albies
10
Roland Alexander Gooch
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.2]
b. 9 Sep 1883 d. Abt 1966
+
August H. Longmoor
d. 29 Apr 1908
John W. O'Neill
11
James Leo O'Neill
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.2.1]
Eloise Skipper
12
Margaret Skipper O'Neill
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.2.1.1]
[
=>
]
12
Eleanor Patricia O'Neill
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.2.1.2]
[
=>
]
12
John Alexander O'Neill
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.2.1.3]
[
=>
]
11
John William O'Neill
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.2.2]
b. 10 Apr 1917 d. Abt 1950
Cola Allen
12
Sarah Ann O'Neill
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.2.2.1]
[
=>
]
James Monroe Kerr
10
Julian Hawke Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.3]
10
Alfred Thomas Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4]
b. 10 Jan 1889 d. Abt 1950
Kate French Stewart
b. 29 Jan 1888 d. 10 Jul 1954
11
Kathryn Ann Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.1]
Howard Morgan Keen
12
James Howard Keen
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.1.1]
12
Stewart Hamilton Keen
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.1.2]
12
Rebecca Jane Keen
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.1.3]
11
Jane Snow Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.2]
b. 10 Nov 1918 d. 1 Nov 1929
11
Alfred Thomas Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.3]
Lillian Bernice Hester
12
Howard James Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.3.1]
[
=>
]
12
Jane Hester Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.3.2]
[
=>
]
12
Robert William Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.3.3]
[
=>
]
11
Howard James Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.4.4]
b. 28 Nov 1925 d. 4 Mar 1945
10
William Appleman Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.5]
b. 30 Aug 1897 d. 20 Mar 1908
10
Kerr
[1.1.1.1.6.2.5.12.6.6]
b. 30 Aug 1897 d. 30 Aug 1897
7
John Bolling Dandridge
[1.1.1.1.6.2.6]
b. 14 Nov 1780 d. 1843
Mary Underwood
b. 1770/1793 d. 1846
8
Bolling Starke Dandridge
[1.1.1.1.6.2.6.1]
b. 1812 d. 1876
+
Laura E. Dudley
b. 1797/1821 d. 1840/1909
Elizabeth Ann Bowles
b. 1814 d. 1908
9
Sallie Dandridge
[1.1.1.1.6.2.6.1.1]
+
Briggs
+
Murray
9
Laura E. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.6.1.2]
+
Peter D. Woodson
7
Jane Butler Dandridge
[1.1.1.1.6.2.7]
b. Abt 1783 d. 1821
Joseph Davies Logan
b. 10 Jan 1781 d. 1820
8
Mary Woodville Logan
[1.1.1.1.6.2.7.1]
8
James William Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2]
b. 15 Jan 1815 d. 6 Mar 1903
Sarah Ann Woodville Strother
9
II Joseph Davies Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2.1]
Georgine Willis
b. Abt 1861
10
James Fielding Lewis Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2.1.1]
Jean Markley
11
Jean Dandridge Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2.1.1.1]
10
Sally Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2.1.2]
b. Abt 1887
10
Anna Clayton Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2.1.3]
b. Abt 1888
10
Maud Matthews Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2.1.4]
b. Abt 1890
+
Garland J. Hopkins
10
John Lee Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2.1.5]
b. Abt 1892
9
Jean Dandridge Logan
[1.1.1.1.6.2.7.2.2]
b. 24 Aug 1843 d. 9 Nov 1927
Samuel White
10
Erskine Lewis White
[1.1.1.1.6.2.7.2.2.1]
b. 13 Apr 1876
Martha Henderson Stackhouse
d. 7 Nov 1908
11
Jean Dandridge White
[1.1.1.1.6.2.7.2.2.1.1]
b. 6 Jul 1905
Thomas Willoughby Potter
12
Virginia Ann Potter
[1.1.1.1.6.2.7.2.2.1.1.1]
[
=>
]
11
Jr. Erskine Lewis White
[1.1.1.1.6.2.7.2.2.1.2]
b. 31 Jul 1908
+
Virginia Payson West
Olivia Whitess Sharpe
b. 10 Jan 1888
11
Olivia Whitess White
[1.1.1.1.6.2.7.2.2.1.3]
b. 31 Aug 1912
11
George Robert White
[1.1.1.1.6.2.7.2.2.1.4]
b. 4 Jul 1915
11
James Logan White
[1.1.1.1.6.2.7.2.2.1.5]
11
Mary Erskine White
[1.1.1.1.6.2.7.2.2.1.6]
7
Robert Honeyman Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8]
b. 12 Oct 1784 d. Bef 3 Dec 1838
Elizabeth Terrell Dandridge
b. 7 May 1792 d. Abt 1846
8
George Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1]
b. 1812 d. 26 Aug 1860
Elizabeth A Norwood
b. 1816 d. 1853
9
Esther F. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.1]
b. 1843
+
James B. Thompson
9
Joseph Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2]
b. 22 Dec 1845 d. 26 Nov 1917
Florence Elizabeth Henderson
b. Abt 1851 d. Abt 1876
10
Earnest Claud Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1]
b. 9 Dec 1868 d. 14 Apr 1929
Pearl Lee Mayfield
11
Edna Ruth Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1.1]
11
Earnest Carl Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1.2]
11
Mary Esther Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1.3]
b. 11 Feb 1908
11
Joe Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1.4]
b. 12 Sep 1909
11
Maude Irene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1.5]
b. 17 Oct 1911 d. 8 Dec 1944
11
Katie Beatrice Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1.6]
b. 20 Oct 1913
11
Claude Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1.7]
b. 27 Sep 1917 d. 27 Sep 1917
11
Helen Lucile Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.1.8]
10
Mary Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.2]
b. 10 Sep 1871 d. 16 Oct 1959
James William Minor
b. 30 Jun 1861 d. 5 Feb 1959
11
Fletcher Vinson Minor
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.2.1]
b. 14 Jul 1911 d. 27 Sep 1967
12
Margaret Minor
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.2.1.1]
10
Benjamin Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3]
b. 21 Dec 1872 d. 14 Jan 1968
Callie Donna Bryant
b. Dec 1861 d. 31 Dec 1904
11
Lilly Florence Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.1]
Granville McCoy
b. 21 Feb 1889 d. 4 Nov 1946
12
Edna Jewel McCoy
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.1.1]
12
Bobby Eugene McCoy
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.1.2]
[
=>
]
12
Fanny Vivian McCoy
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.1.3]
b. 2 Sep 1915
12
Johnnie Florine McCoy
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.1.4]
[
=>
]
11
James Ottie Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.2]
b. 30 Nov 1898 d. 21 Oct 1955
Martha Ofilda Winter
12
Dorcus E Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.2.1]
12
Jerome Odell Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.2.2]
12
Naoma Joyce Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.2.3]
[
=>
]
11
Ramond Eugene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.3]
b. 11 Jan 1907 d. 18 Jan 1945
Julia Ann Sprinkles
b. 2 Dec 1890 d. 15 Sep 1968
11
Ramond E Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.4]
b. Abt 1907
11
Mitchell Dean Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.5]
b. 28 Aug 1910 d. 3 Aug 1971
Jennie Wildcat
b. 26 Jan 1921 d. 10 Aug 1951
12
Mamie Darlene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.5.1]
[
=>
]
12
Lorene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.5.2]
[
=>
]
12
Robert Lee Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.5.3]
b. 13 Oct 1943 d. 31 Oct 1969 [
=>
]
11
Willie Benjamin Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.6]
Susan Elizabeth McElhaney
12
Willie Eugene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.6.1]
[
=>
]
12
Robert Edward Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.6.2]
[
=>
]
12
Harold Dean Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.6.3]
[
=>
]
12
Gerald Alan Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.6.4]
11
Ora Myrtle Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.7]
Samuel Lee Winkler, Jr
b. 23 Feb 1913 d. 3 Sep 1956
12
Ora Lee Winkler
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.7.1]
11
Joseph Samuel Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.8]
Ruby Robertson
12
Kathy Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.8.1]
[
=>
]
12
Kenneth Eugene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.8.2]
11
Jimmie Ben Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.9]
Lois Jean Waugh
12
James Calvin Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.9.1]
Alma Louise Betts
12
Charlene Louise Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.9.2]
11
Julia Florine Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.10]
+
James Keith Stull
Roy Millard Rodgers
12
Norma Jean Rodgers
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.10.1]
[
=>
]
12
Barbara Ann Rodgers
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.3.10.2]
[
=>
]
+
Marvin Mavie Thiessen
+
Frederick R. Boxberger
+
Robert D. Smith
10
Maude Irene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.4]
b. 2 Aug 1875 d. 22 Mar 1965
Emma Freeman
b. Feb 1865 d. 26 Nov 1917
10
Alva L Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.5]
10
Lottie Louise Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.2.6]
b. 29 Dec 1899 d. 22 Jun 1955
9
Liberty Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3]
b. 17 Jan 1849 d. 11 Dec 1933
Susan Antinethe Curtis
b. 29 Jan 1850 d. 27 Jul 1914
10
Isom Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1]
b. 15 Dec 1870 d. 27 Jul 1937
Frances Minerva Harvey
b. 3 Jan 1876 d. 12 Jun 1949
11
George Liberty Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.1]
b. 10 Sep 1893 d. 20 Jan 1939
Lillie Belle Denham
b. 1 Apr 1899
12
Edith Bernice Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.1.1]
[
=>
]
11
Willie Jasper Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.2]
b. 27 Apr 1897
Pearlie Lewis
b. 3 Jun 1897
12
Joe Edward Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.2.1]
[
=>
]
11
Allie Viola Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.3]
b. 9 Dec 1900
Vernon E. Faulkner
b. 6 Mar 1909
12
Naomi Ruth Faulkner
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Delvin Raymond Faulkner
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.3.2]
[
=>
]
11
Carl Curtis Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.4]
b. 10 Jan 1905
Mary Ann Sloma
b. 31 Jul 1913
12
Frances Carlene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.4.1]
12
Ruth Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.4.2]
12
Lillian Pearl Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.4.3]
11
Susan Maurine Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.5]
b. 29 Jan 1909
Jodie Clifford Hayes
b. 13 May 1904
12
Linda Nell Hayes
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.5.1]
11
Mary Mardene Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.6]
b. 2 Feb 1911
Clarence Lewis
12
Clarence George Lewis
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.6.1]
+
Hernandez
11
James Travis Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.3.1.7]
+
Ethel Virginia Patterson
9
Alfaretta Eoline Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.1.4]
b. 1851 d. 27 Sep 1894
+
Joseph Philip Cooper
8
Mildred Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.2]
b. 1814 d. 1870
Robert H. Creilly
b. 1814 d. Feb 1856
9
Mary C. Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.1]
b. Abt 1842 d. Abt 1869
9
Andrew Jackson Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.2]
b. Abt 1844 d. Abt 1862
9
Margaret J. B. Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.3]
b. 16 Mar 1845 d. 15 Feb 1905
William L. Barton
b. 10 Jul 1835 d. 18 Jul 1889
10
James Robert Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.1]
b. 9 Feb 1871 d. 1904/1962
Elizabeth Milner
b. 1861/1882 d. 1904/1971
11
Mildred Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.1.1]
b. 8 Nov 1901 d. 16 Oct 1905
11
Howard Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.1.2]
b. Abt 1907
10
Hance H. Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.2]
b. 23 Sep 1873 d. 1874/1963
Bulah Moore
d. 14 Jul 1909
11
Mildred Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.2.1]
+
Willey Shirley
10
Andrew Jackson Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.3]
b. 24 Sep 1875 d. 10 Sep 1903
+
Carrie Heart
10
Mary N. Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.4]
b. 31 Jan 1877 d. 1878/1971
Frank A. Walden
11
B. F. Walden
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.4.1]
b. 10 Aug 1911
+
Freida Mohead
Hazel Drake
12
James Franklin Walden
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.4.1.1]
[
=>
]
10
Sarah Azile Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.5]
b. 28 Jan 1879
Sam Cline
11
Hazel Cline
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.5.1]
11
True Lynn Cline
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.5.2]
10
John Dandridge Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.6]
b. 2 Jul 1880 d. 31 May 1967
Inez Hightower
b. 11 Jan 1896 d. 14 Aug 1950
11
Thomas E. Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.6.1]
Juanita Crabtree
12
Mary J. Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.6.1.1]
[
=>
]
11
John Dandridge Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.6.2]
11
Mary Margaret Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.6.3]
11
Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.6.4]
11
A. L. Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.6.5]
10
Troy Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.7]
b. 7 Jan 1884 d. 7 Feb 1884
10
Lelia Barton
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8]
Jim Jordan
11
Robert Jordan
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8.1]
Dessie Roller
12
Dessie Jordan
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8.1.1]
11
Jimmie Jordan
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8.2]
11
Lelia Jordan
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8.3]
Allen
12
James Nolen Allen
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8.3.1]
12
Lee Olen Allen
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8.3.2]
12
Margaret Rynie Allen
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8.3.3]
12
Susan Lanell Allen
[1.1.1.1.6.2.8.2.3.8.3.4]
9
George Washington Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4]
b. May 1847 d. 1848/1937
Georgia Ann Conant
b. May 1855
10
Lura Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.1]
+
J. H. Scruggs
10
Thomas Jefferson Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2]
b. Jul 1877
Etoile Ophelia Lessell
11
Preston Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.1]
Thelma Scott
12
George Thomas Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.1.1]
[
=>
]
12
Charles Preston Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.1.2]
[
=>
]
12
Martha Etoile Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.1.3]
12
Mary Nell Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.1.4]
[
=>
]
12
Jerald Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.1.5]
11
Carl Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.2]
Teddie Deaton
12
Carlene Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.2.1]
[
=>
]
11
Mildred Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.3]
Elmo Murff
12
Etiol Murff
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.3.1]
[
=>
]
12
Guy Thomas Murff
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.3.2]
[
=>
]
12
Betty Jane Murff
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.3.3]
[
=>
]
11
Ola Mae Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.4]
b. 19 Dec 1904
Calvert Gault
12
Frances Etoile Gault
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.4.1]
[
=>
]
12
Evelyn Gault
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.4.2]
[
=>
]
12
Robert Ray Gault
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.4.3]
[
=>
]
11
Lucille Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.5]
b. 29 Jan 1907
Auzie Norris Myatt
12
Charleen Myatt
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.5.1]
[
=>
]
12
Jr. Auzie Norris Myatt
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.5.2]
[
=>
]
12
Creely Neal Myatt
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.5.3]
[
=>
]
12
Carl Preston Myatt
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.5.4]
[
=>
]
11
Bonnie Laverne Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.6]
b. 4 Feb 1914
Eugene V. Davis
12
Eugene V. Davis
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.6.1]
[
=>
]
12
James Milton Davis
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.6.2]
[
=>
]
11
Lurlyne Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.7]
Burnell Wade
12
Jr. Burnell Wade
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.7.1]
[
=>
]
12
Martha Ann Wade
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.7.2]
[
=>
]
12
Dorothy Jean Wade
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.7.3]
[
=>
]
12
Virginia Wade
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.7.4]
[
=>
]
11
Troy Edward Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.8]
Syble Partridge
12
Troy Edward Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.8.1]
[
=>
]
12
James Thomas Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.2.8.2]
[
=>
]
10
Homa Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.3]
b. Nov 1881
+
Joe Bennett
10
Alma Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.4]
b. Oct 1884
+
Jeff Crider
10
Daisy Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.5]
b. Feb 1888
+
Mitchell Ogilvee
10
Maude Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.4.6]
b. Mar 1890
+
Arthur Harrison
9
Robert Gordon Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.5]
b. 17 May 1848 d. 1 Mar 1924
Jennie Lynn Brookshire
10
Electra Lynn Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1]
b. 2 Feb 1872 d. 30 Dec 1951
John Tillman Alexander
b. 2 Feb 1867 d. 12 Sep 1947
11
Ruth Electra Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.1]
b. 11 Nov 1894 d. 8 Apr 1973
+
Hannie Fortner
11
Ethel Donnon Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.2]
Bates
12
Betty Low Bates
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.2.1]
12
Jo Ann Bates
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.2.2]
11
Iska Lynn Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.3]
+
W. P. Inman
11
Otto Tillman Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.4]
b. 25 Oct 1899 d. 19 Mar 1967
+
Leona
11
John Gordon Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.5]
+
Edna
11
Edna Bell Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.6]
b. 16 Oct 1905 d. 6 Sep 1943
Volly Booth Nelson
b. 24 Jul 1903 d. 19 Nov 1971
12
Yvonne Nelson
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.6.1]
12
Jr. Volly Booth Nelson
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.6.2]
11
Letha Aline Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.7]
+
Barbough
11
Joe Wheeler Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.8]
b. 7 Mar 1910 d. 24 Feb 1963
11
Frances Delores Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.9]
b. 16 Sep 1912 d. 18 Aug 1958
Jared Mann Wilcox
b. 7 Apr 1899 d. 17 Mar 1960
12
Virginia Lynn Wilcox
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.9.1]
[
=>
]
11
Paul Wilson Alexander
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.1.10]
b. 15 Feb 1914
10
S. A. Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.2]
b. Abt 1874
10
Oscar T. Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.3]
b. Abt 1876
10
Lulla Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.4]
b. Abt 1878
10
Mahalia Delullah Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.5]
b. Abt 1881 d. Abt 1946
Gentry H. Shofner
b. Abt 1877 d. Abt 1937
11
Creilly Shofner
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.5.1]
11
Otto Shofner
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.5.2]
11
Ernestine Shofner
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.5.3]
+
Hendrix
11
Mary Shofner
[1.1.1.1.6.2.8.2.5.5.4]
+
Morgan
+
Honorra Sullivan
9
John Dandridge Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.6]
b. Abt 1852 d. 1853/1942
9
James Lewis Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.7]
b. 14 May 1854 d. 14 Oct 1941
Georgeanna Ford
b. 27 Jan 1863 d. 27 Jan 1943
10
Jennie Lee Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.1]
b. 12 Jul 1883 d. 20 Nov 1886
10
Alma Gertrude Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.2]
b. 9 Aug 1885
Gaston Allen
11
Bernice Allen
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.2.1]
James McCarter
12
Freda McCarter
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.2.1.1]
12
Martha McCarter
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.2.1.2]
11
Jimmie Lee Allen
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.2.2]
b. Abt 1915
Grace Malone
12
Brenda Allen
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.2.2.1]
10
Andrew Jackson Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3]
b. 5 Feb 1888 d. Dec 1971
Ollie Mae Baldwin
11
Albert Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.1]
Henryetta Hodges
12
Gerald Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.1.1]
12
Earl Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.1.2]
11
Jimmie Lee Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.2]
+
Orin Hamner
11
Allen Jones Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.3]
11
Eunice Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.4]
Buford Brown
12
Wayne Brown
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.4.1]
12
Bobby Brown
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.4.2]
11
Katie Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.5]
+
Lynn Daugherty
11
Raymond Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.6]
Marietta Moffett
12
Georgia Ann Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.6.1]
12
Betty Ray Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.6.2]
12
Tommy Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.3.6.3]
10
Harvey Medford Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.4]
Bessie Poole
b. 9 Mar 1896 d. 13 Jan 1974
11
Mavis Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.4.1]
T. J. McCarter
12
Tommy McCarter
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.4.1.1]
10
Bessie Earl Watson Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.5]
Andy Hamilton
11
Oscar Hamilton
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.5.1]
11
James Hamilton
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.5.2]
11
Cleta Hamilton
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.5.3]
+
Woody Russell
11
Pat Hamilton
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.5.4]
11
Bilbo Hamilton
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.5.5]
11
Dallas Hamilton
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.5.6]
10
Eunice Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.6]
b. 11 Dec 1893 d. 17 Sep 1895
10
Norman Jones Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.7]
Minnie Belle Lee
11
Leon Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.7.1]
Louise Curry
12
Lee Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.7.1.1]
12
Ronnie Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.7.1.2]
11
Jack Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.7.2]
Wilma Comer
12
Jackie Marie Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.7.2.1]
12
Natalie Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.7.2.2]
12
Chris Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.7.2.3]
10
Allie Azalee Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.8]
b. 27 Sep 1898
Elzie Grady Armstrong
11
Lorraine Armstrong
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.8.1]
John Dillard Davis
12
John Armstrong Davis
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.8.1.1]
[
=>
]
12
Connie Linda Davis
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.8.1.2]
12
Sandra Elizabeth Davis
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.8.1.3]
[
=>
]
11
Mary Lou Armstrong
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.8.2]
Bobby Russell Parker
d. 29 Sep 1966
12
Nancy Angela Parker
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.8.2.1]
[
=>
]
12
Cynthia Marilyn Parker
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.8.2.2]
+
Harry L. O'Neal
10
Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.9]
b. Abt 1900 d. Abt 1900
10
Sam Barnes Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.10]
b. 13 Aug 1905
Birdie Mae Smith
11
Paul Barnes Creely
[1.1.1.1.6.2.8.2.7.10.1]
9
Sarah C. Creilly
[1.1.1.1.6.2.8.2.8]
b. 1856 d. Abt 1865
Dan Raines
10
John Bell Raines
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.1]
10
Babe Raines
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.2]
10
Dan Raines
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.3]
10
Boyd Raines
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.4]
10
Willie Raines
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.5]
10
Inez Raines
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.6]
+
Will Pierce
10
Minnie Raines
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.7]
Ed Motley
11
Bonner Motley
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.7.1]
11
Earl Raines Motley
[1.1.1.1.6.2.8.2.8.7.2]
8
Jane T. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.3]
b. Abt 1820 d. 1843/1914
+
Ruben Allen
b. 1786/1818 d. 1843/1905
8
Adeline Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.4]
b. Abt 1822
+
William Wade Smith
8
John Terrell Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.5]
b. Abt 1831 d. 5 Mar 1870
+
Octavia E. Banhook
b. 1824/1847 d. 1869/1935
8
Jr. Robert Honeyman Dandridge
[1.1.1.1.6.2.8.6]
b. 1832 d. CHILD
+
Margaret Ann Johnson
b. 1816/1840 d. 1859/1929
7
George Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.2.9]
b. 3 Feb 1787 d. 27 Sep 1794
7
Thomas Bolling Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10]
b. 3 Feb 1789 d. 10 May 1842
Caroline Matilda Nichols
b. 1803 d. 1825/1897
8
Sarah Ann "Sally" Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.1]
b. 1823 d. Aft 1880
Charles de la Boulay Fontaine
b. 28 Dec 1817 d. 20 Aug 1871
9
John Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.1]
b. 14 Aug 1841 d. 3 Sep 1925
Sarah Amanda "Dallie" Duncan
b. Jul 1849 d. Nov 1940
10
John Brooks "Little Jack" Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.1.1]
b. 14 Oct 1871 d. 13 Aug 1967
Catherine English Crawford
11
Jack Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.1.1.1]
b. Abt 1915
11
Charles English Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.1.1.2]
Grace May Fleming
12
Charles English Fontaine, Jr.
[1.1.1.1.6.2.10.1.1.1.2.1]
12
Margaret Crawford Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.1.1.2.2]
10
Charles De La Bouley Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.1.2]
b. 26 Oct 1873 d. 20 Oct 1916
10
Andrew Duncan Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.1.3]
b. 21 Oct 1875 d. 5 May 1954
10
Maury Blackwell Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.1.4]
b. Jun 1879 d. 1946
9
Francis Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.2]
b. 14 Feb 1843 d. 8 Aug 1844
9
Frances Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.3]
b. 14 Mar 1845 d. 29 Oct 1845
9
Charles Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.4]
b. 1846
9
Ann Maury Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.5]
b. 27 Feb 1848 d. 19 May 1849
9
Benjamin Lamar Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.6]
b. Abt 1849 d. 15 Jun 1931
9
Mary Chaillon Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.7]
b. 1852 d. 1933
9
Bettie Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.8]
b. 1854
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.9]
b. 1855 d. 1896
9
Sarah M "Sally" Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.10]
b. 1857 d. 1943
9
Edward Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.11]
b. 26 Oct 1858 d. 9 Apr 1859
9
Martha "Patty" S Fontaine
[1.1.1.1.6.2.10.1.12]
b. 1862
8
Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.2]
b. Abt 1824
8
Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.3]
b. Abt 1826
8
Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.4]
b. Abt 1828
8
Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.5]
b. Abt 1830
8
Caroline M. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.6]
b. Abt 1836
8
Elizabeth B. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.7]
b. Abt 1838
8
Powhatan B. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.8]
b. Abt 1839
8
Marsha F. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.10.9]
b. Abt 1840
7
Martha A. Dandridge
[1.1.1.1.6.2.11]
b. 21 Jan 1790 d. 22 Jan 1790
7
John Marshall Dandridge
[1.1.1.1.6.2.12]
b. 8 May 1799 d. 1800/1889
6
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.3]
b. 1 Aug 1753 d. Apr 1785
Anne Stephen
b. "The Bower", Leetown, Jefferson Co., WV d. 1834
7
Adam Stephen Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1]
b. 5 Dec 1782 d. 20 Nov 1821
Sarah Pendleton
b. 18 Jun 1785 d. 13 Mar 1855
8
Ann Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.1]
b. 19 Oct 1806 d. INFANT
8
Sarah Stephena Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.2]
b. 7 Nov 1811 d. 25 Oct 1846
+
Anthony (Arthur) Kennedy
b. 1786/1813 d. 1837/1900
8
Ann Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.3]
b. 18 Jun 1813 d. 1827/1907
Thomas Elie Buchanan
b. 18 Jun 1813 d. 1889
9
Sallie Pendleton Buchanan
[1.1.1.1.6.3.1.3.1]
b. 1835 d. 1916
Dabney Carr Harrison
b. 12 Sep 1830 d. 16 Feb 1862
10
Jane Carr Harrison
[1.1.1.1.6.3.1.3.1.1]
b. 1856 d. 1864
10
Dabney Carr Harrison, Jr
[1.1.1.1.6.3.1.3.1.2]
b. 15 Oct 1858 d. 8 Jul 1931
Ellen Robinson Riley
b. 13 May 1876 d. 26 Dec 1952
11
William Riley Harrison
[1.1.1.1.6.3.1.3.1.2.1]
b. 25 Nov 1900 d. 1 May 1924
11
Dabney Carr Harrison, III
[1.1.1.1.6.3.1.3.1.2.2]
+
Edith Barrington Harrison
b. 25 Feb 1914 d. 23 Jul 1967
Marion Colston Harrison
b. 17 Mar 1909 d. 23 May 1933
12
Dabney Carr Harrison, IV
[1.1.1.1.6.3.1.3.1.2.2.1]
10
Ann Spottiswoode Dandridge Harrison
[1.1.1.1.6.3.1.3.1.3]
b. 1860 d. 1898
8
Jr. Adam Stephen Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4]
b. 13 Dec 1814 d. Jan 1890
Serena Catherine Pendleton
b. 9 Jun 1816 d. 2 Sep 1889
9
Mary Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.1]
d. 1868/1974
9
Nannie Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.2]
9
Philip Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.3]
d. CHILD
9
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.4]
d. 1869/1971
9
Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.5]
b. 28 Jan 1841 d. 29 Sep 1884
Elizabeth Pitts
b. 1834/1870 d. 1860/1950
10
Serena Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.5.1]
b. Oct 1876
Hugh Nelson Pendleton
b. 11 Jan 1875
11
Serena Dandridge Pendleton
[1.1.1.1.6.3.1.4.5.1.1]
b. 31 Jul 1902
11
Jr. Hugh Nelson Pendleton
[1.1.1.1.6.3.1.4.5.1.2]
b. 30 Aug 1906
11
Helen Boteler Pendleton
[1.1.1.1.6.3.1.4.5.1.3]
b. 2 Aug 1909
11
Isabella Lawrence Pendleton
[1.1.1.1.6.3.1.4.5.1.4]
b. 18 May 1911
10
Helen Nicholson Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.5.2]
b. Oct 1878
10
Jr. Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.5.3]
b. Nov 1882
9
Lemuel Purnell Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6]
b. Nov 1842 d. 1919
Isabelle L.
b. Oct 1845
10
Florence Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.1]
b. Nov 1880
10
Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.2]
b. Sep 1881 d. 1961
Mary R. Lloyd
b. Cal 1885
11
Elizabeth Lloyd Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.2.1]
+
Angus McDonald
11
Jr. Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.2.2]
Anne Davis
12
Anne Davis Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.2.2.1]
12
Sally Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.2.2.2]
12
III Edmund Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.2.2.3]
10
Martha Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.3]
b. Jul 1885
10
Lawrence Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.6.4]
b. Jan 1889
9
III Adam Stephen Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.7]
b. 30 Sep 1844
+
Carolyn Dane Bedinger
b. 19 Nov 1854 d. 3 Jun 1914
9
Serena Catherine Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.8]
b. 1835/1864 d. 1840/1946
9
Sarah Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.4.9]
b. 1835/1864 d. 1851/1946
+
Blackburn Hughes
b. 1825/1862 d. 1851/1940
8
Philip Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5]
b. 2 Oct 1817 d. 28 Oct 1881
Caroline FitzHugh Goldsborough
b. 1820 d. 1854
9
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.1]
b. 19 Nov 1819 d. 29 Apr 1889
9
Mary FitzHugh Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.2]
b. 1838 d. May 1893
9
Carolyn Goldsborough Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.3]
b. 1840 d. 1860
9
Ann Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.4]
b. Jan 1840 d. Apr 1840
9
Jr. Philip Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.5]
b. 4 Nov 1843 d. 1844
9
Sarah Goldsborough Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.6]
b. 1846 d. 1871
E. Holmes Boyd
b. Apr 1840 d. 1871/1933
10
Holmes Boyd
[1.1.1.1.6.3.1.5.6.1]
b. 1869 d. 1 Apr 1905
10
Eleanor Boyd
[1.1.1.1.6.3.1.5.6.2]
b. 1870 d. 1870
10
Philip Pendleton Boyd
[1.1.1.1.6.3.1.5.6.3]
b. 1870
10
Lily Dandridge Boyd
[1.1.1.1.6.3.1.5.6.4]
b. 22 Nov 1871 d. 18 Jun 1940
10
Nannie Spotswood Boyd
[1.1.1.1.6.3.1.5.6.5]
b. 22 Nov 1873 d. 26 May 1937
Peyton Randolph Harrison, III
b. 21 Jul 1859 d. 25 Aug 1941
11
Holmes Boyd Harrison
[1.1.1.1.6.3.1.5.6.5.1]
b. 22 Oct 1899 d. 22 May 1911
11
Peyton Randolph Harrison, IV
[1.1.1.1.6.3.1.5.6.5.2]
b. 2 Sep 1905 d. 16 Feb 1938
11
Anne "Nana" Spottswood Harrison
[1.1.1.1.6.3.1.5.6.5.3]
+
Bennett Taylor
9
Charles Goldsborough Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.7]
b. 1848 d. 1864
9
William FitzHugh Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.8]
b. 1838/1866 d. 1863/1945
Mary Brassfield Winn
b. 1837/1873 d. 1863/1953
10
Elsie Winn Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.8.1]
10
Jr. William FitzHugh Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.8.2]
b. 1863/1905 d. CHILD
9
Mary Evelina Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.5.9]
b. 1838/1866 d. May 1893
Robert Mercer Taliaferro Hunter
b. 21 Apr 1809 d. 18 Jul 1887
10
Jr. Robert Mercer Taliaferro Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.1]
b. 1 Apr 1839 d. 28 Nov 1861
10
James Dandridge Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.2]
b. 3 Mar 1841
Emma Lee Parker
11
Mary Evelina Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.2.1]
b. 14 May 1886 d. 26 Jan 1905
11
III Robert Mercer Taliaferro Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.2.2]
b. 12 Oct 1888
11
Stephen Spotswood Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.2.3]
b. 17 Oct 1890
10
Martha "Pink" Taliaferro Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.3]
b. 1 Apr 1844 d. 9 Feb 1909
10
Sarah Stephena Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.4]
b. 24 Apr 1846 d. 14 Apr 1865
10
Philip Stephen Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.5]
b. 17 Jul 1848
10
Muscoe Russell Garnett Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.6]
b. 18 Feb 1850 d. 28 Jul 1865
10
Annie Buchanan Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.7]
b. 23 May 1852
10
Mary Evelina Hunter
[1.1.1.1.6.3.1.5.9.8]
b. 12 Sep 1854 d. 11 Jun 1881
+
Mary Elizabeth Taylor
b. 20 Apr 1824 d. 25 Jul 1909
8
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6]
b. 19 Nov 1819 d. 29 Apr 1889
Martha Elizabeth Pendleton
b. 30 Dec 1823 d. 24 Feb 1882
9
Jane Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6.1]
b. 1840/1869 d. 1856/1950
+
William Dalton Warren
b. 1830/1867 d. 1856/1945
9
Nathaniel Pendleton Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6.2]
b. 1840/1869 d. 1846/1948
9
Sarah Kennedy Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6.3]
b. 1840/1869 d. CHILD
9
Susan Bowler Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6.4]
b. 1840/1869 d. 1856/1950
John M. Bowers
b. 1830/1867 d. 1856/1945
10
Spotswood Boyd Bowers
[1.1.1.1.6.3.1.6.4.1]
+
Martha Bryte Lane
10
Mary Stewart f Bowers
[1.1.1.1.6.3.1.6.4.2]
10
Martha Dandridge Bowers
[1.1.1.1.6.3.1.6.4.3]
10
Henry M. Bowers
[1.1.1.1.6.3.1.6.4.4]
10
William Bowers
[1.1.1.1.6.3.1.6.4.5]
9
Alice Key Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6.5]
b. 1840/1869 d. 1856/1950
+
Lewis N. Irving
b. 1830/1867 d. 1856/1945
9
Jr. Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6.6]
b. 1840/1869 d. 15 Apr 1889
9
Mary Evelina Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6.7]
b. 1840/1869
9
Martha Dandridge
[1.1.1.1.6.3.1.6.8]
b. 1840/1869 d. 1845/1950
6
Dorothea Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.4]
b. 25 Sep 1755 d. 14 Feb 1831
Patrick Henry
b. 29 May 1736 d. 6 Jun 1799
7
Dorothea Spotswood Henry
[1.1.1.1.6.4.1]
b. 2 Aug 1778 d. 17 Jun 1854
George Dabney Winston
b. 2 Aug 1771 d. 15 Jul 1831
8
Elvira Virginia Winston
[1.1.1.1.6.4.1.1]
d. 17 Jun 1854
James W. Crenshaw
b. 1786/1818 d. 1818/1898
9
Virginia Crenshaw
[1.1.1.1.6.4.1.1.1]
b. 3 Dec 1838
+
James W. Harper
b. 1810/1851 d. 1836/1929
9
Elvira Crenshaw
[1.1.1.1.6.4.1.1.2]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
James C. Marvin
b. 1810/1851 d. 1836/1929
9
Sallie Winston Crenshaw
[1.1.1.1.6.4.1.1.3]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
John Miller
b. 1810/1851 d. 1836/1929
9
Dorothea Crenshaw
[1.1.1.1.6.4.1.1.4]
b. 1818/1853 d. 1836/1934
+
David F. Smyer
b. 1810/1851 d. 1836/1929
9
Patrick Henry Crenshaw
[1.1.1.1.6.4.1.1.5]
b. 1818/1853 d. 1839/1931
+
Lula Mack
b. 1818/1859 d. 1839/1939
8
Edmund Dabney Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2]
b. 17 Sep 1799 d. 21 Sep 1875
Elizabeth "Eliza" Louisa Fontaine
b. 14 Sep 1804 d. 21 Jul 1892
9
Patrick Henry Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.1]
b. 1821 d. 1830
9
John Dabney Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.2]
b. 21 Feb 1822 d. 13 Aug 1878
9
Nancy Miller Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.3]
b. 5 Mar 1825 d. 19 Oct 1883
+
Oliver H. Black
9
William Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.4]
b. 21 Jul 1828 d. 13 Aug 1878
Emma Eloise Furr
b. 1842 d. 9 Feb 1892
10
Edmund Tobias Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.4.1]
b. 22 Jul 1871 d. 26 Dec 1944
Florence Theresa Seale
b. 9 Feb 1876 d. 28 Jun 1959
11
Eloise Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.4.1.1]
b. 7 Mar 1899
Ozeph Chester Taylor
b. 1 Jul 1867
12
Edmund Warren Taylor
[1.1.1.1.6.4.1.2.4.1.1.1]
[
=>
]
12
Dorothy Eloise Taylor
[1.1.1.1.6.4.1.2.4.1.1.2]
[
=>
]
10
Galen Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.4.2]
b. 8 Feb 1873 d. 1928
+
Aurelia Odile Despommer
10
Masina Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.4.3]
b. 28 Aug 1875 d. 1928
+
Henry Henesler
9
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.5]
b. 8 Mar 1831 d. 20 Jun 1852
9
George Dabney Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.6]
b. 17 Sep 1833 d. 24 Apr 1910
+
Mrs. Iola Overton
9
Patrick Fontaine Winston
[1.1.1.1.6.4.1.2.7]
b. 5 Mar 1845 d. 1 Apr 1906
8
Patrick Henry Winston
[1.1.1.1.6.4.1.3]
b. 28 Jan 1802
8
George Winston
[1.1.1.1.6.4.1.4]
b. 1804
8
Sallie Butler Winston
[1.1.1.1.6.4.1.5]
b. 1807
+
Charles Dandridge
b. 1786/1818 d. 1812/1898
8
William Winston
[1.1.1.1.6.4.1.6]
b. 1809
8
Edward Henry Winston
[1.1.1.1.6.4.1.7]
b. 1811
Susan Moorehead Reynolds
9
Prior Winston
[1.1.1.1.6.4.1.7.1]
b. 1821/1860 d. 1830/1937
8
Fayette Henry Winston
[1.1.1.1.6.4.1.8]
b. 1813
Martha Dix
b. 1796/1827 d. 1821/1909
9
Lucy Winston
[1.1.1.1.6.4.1.8.1]
b. 1821/1860 d. 1839/1940
+
Hoffman
b. 1813/1858 d. 1839/1935
9
Elvira Winston
[1.1.1.1.6.4.1.8.2]
b. 1821/1860 d. 1839/1940
+
J. C. Granberry
b. 1813/1858 d. 1839/1935
8
James Winston
[1.1.1.1.6.4.1.9]
b. 1815 d. 1852
7
Sarah Butler Henry
[1.1.1.1.6.4.2]
b. 4 Jan 1780 d. 10 Dec 1856
+
Robert Campbell
b. 1763/1783 d. 1797/1869
Alexander Scott
b. 1762 d. 29 Jun 1819
8
Patrick Henry Scott
[1.1.1.1.6.4.2.1]
b. 4 Jun 1815 d. 9 Jan 1865
Mary Carrington Yancey
b. Abt 1831
9
Francis Alexander Scott
[1.1.1.1.6.4.2.1.1]
b. 1 Nov 1855
+
Mary C. Pleasants
b. Abt 1852
9
Cabell Carrington Scott
[1.1.1.1.6.4.2.1.2]
b. 24 Jul 1857
9
William Bailey Scott
[1.1.1.1.6.4.2.1.3]
b. 27 Dec 1858
9
Charles Yancey Scott
[1.1.1.1.6.4.2.1.4]
b. 9 May 1860
9
Sarah Butler Scott
[1.1.1.1.6.4.2.1.5]
b. 12 Oct 1861
9
Harriet W. Scott
[1.1.1.1.6.4.2.1.6]
b. 13 Aug 1863
8
Henrietta Dandridge Scott
[1.1.1.1.6.4.2.2]
b. 24 Oct 1817
William H. Bailey
9
Elizabeth Ann Bailey
[1.1.1.1.6.4.2.2.1]
Eugene B. Pendleton
10
Allan Bowie Pendleton
[1.1.1.1.6.4.2.2.1.1]
d. 1900
10
Alice Pendleton
[1.1.1.1.6.4.2.2.1.2]
+
D. Frank Clarke
Epheshian Pickett
10
Katheryn Pickett
[1.1.1.1.6.4.2.2.1.3]
8
Catherine Henry Scott
[1.1.1.1.6.4.2.3]
b. 18 Aug 1819
+
Robert Scott
b. 1788/1820 d. 1814/1900
7
Martha Catharine Henry
[1.1.1.1.6.4.3]
b. 3 Nov 1781 d. 22 May 1801
Edward W. Henry
b. 1753/1781 d. 1803/1868
8
Dorothea Dandridge Henry
[1.1.1.1.6.4.3.1]
b. 1797/1801 d. 1800/1894
7
Jr. Patrick Henry, Jr
[1.1.1.1.6.4.4]
b. 15 Aug 1783 d. 22 Sep 1804
Elvira Ann Cabell
b. 10 Sep 1783 d. 22 Oct 1858
8
Nannie Henry
[1.1.1.1.6.4.4.1]
8
John Henry
[1.1.1.1.6.4.4.2]
8
Patrick Henry
[1.1.1.1.6.4.4.3]
8
Eliza Henry
[1.1.1.1.6.4.4.4]
8
Martha Henry
[1.1.1.1.6.4.4.5]
8
Ellen Henry
[1.1.1.1.6.4.4.6]
8
Rosa Henry
[1.1.1.1.6.4.4.7]
8
Elvira Ann Patrick Henry
[1.1.1.1.6.4.4.8]
b. 27 Sep 1804 d. 24 Jun 1870
William Howson Clark
b. 23 Jan 1805 d. 20 Oct 1873
9
Patrick Clark
[1.1.1.1.6.4.4.8.1]
b. 1826/1865 d. 1835/1942
9
Eliza Clark
[1.1.1.1.6.4.4.8.2]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Alfred Shields
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Martha Clark
[1.1.1.1.6.4.4.8.3]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Lyle Clark
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Ellen Clark
[1.1.1.1.6.4.4.8.4]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
George Lee
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Rosa Clark
[1.1.1.1.6.4.4.8.5]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Wilkins
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Elvira C. Clark
[1.1.1.1.6.4.4.8.6]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Augustine Claiborne
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
Nannie Clark
[1.1.1.1.6.4.4.8.7]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Thomas Bruce
b. 1818/1863 d. 1844/1940
9
John Clark
[1.1.1.1.6.4.4.8.8]
b. 1826/1865 d. 1847/1942
+
Coleman
b. 1826/1871 d. 1847/1950
7
George Lafayette Henry
[1.1.1.1.6.4.5]
b. 29 Oct 1785 d. 16 Mar 1813
+
Ann Elcan
b. 17 Feb 1788 d. 1 May 1808
7
Alexander Spotswood Henry
[1.1.1.1.6.4.6]
b. 2 Jun 1788 d. 6 Jan 1854
Paulina Jordan Cabell
b. 1796 d. Dec 1833
8
George Lafayette Henry
[1.1.1.1.6.4.6.1]
b. 29 Oct 1815 d. 16 May 1884
Margaretta Mason
b. May 1824
9
John Henry
[1.1.1.1.6.4.6.1.1]
b. 1832/1875 d. 1841/1951
9
Francis Marion Henry
[1.1.1.1.6.4.6.1.2]
b. 1832/1875 d. 1853/1951
+
Frances Cabell Henry
b. 19 Jun 1857 d. 19 Jan 1923
8
Sarah Winston Henry
[1.1.1.1.6.4.6.2]
b. 1822 d. 1906
George Cabell Carrington
b. 1819 d. 1880
9
John P. Merreaux Carrington
[1.1.1.1.6.4.6.2.1]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Fanny Toot
b. 1829/1874 d. 1850/1953
9
Susan Love Carrington
[1.1.1.1.6.4.6.2.2]
b. 1829/1868 d. 1847/1948
A. Y. Hundley
b. 1821/1866 d. 1847/1943
10
Alice C. Hundley
[1.1.1.1.6.4.6.2.2.1]
9
Charles Craddock Carrington
[1.1.1.1.6.4.6.2.3]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Sally H. French
b. 1829/1874 d. 1850/1953
9
Sarah Cabell Carrington
[1.1.1.1.6.4.6.2.4]
b. 1829/1868 d. 1847/1948
+
J. W. F. Bealle
b. 1821/1866 d. 1847/1943
9
Richard Bruce Carrington
[1.1.1.1.6.4.6.2.5]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Ida Harrison
b. 1829/1874 d. 1850/1953
9
Walter Coles Carrington
[1.1.1.1.6.4.6.2.6]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Nettie Bauhan
b. 1829/1874 d. 1850/1953
8
John Robert Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3]
b. 28 May 1823 d. 11 Nov 1903
Frances Elizabeth Edwards
b. 19 Apr 1829 d. 17 Feb 1904
9
Cabell Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.1]
b. 1850 d. 1951
9
Sarah S. Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.2]
b. 1851 d. Sep 1915
9
William Keen Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.3]
b. 15 Mar 1852 d. 23 Apr 1919
+
Fanny Harper
b. 1832/1880 d. 1853/1958
9
Elizabeth E. Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.4]
b. 23 Oct 1853 d. 1883
+
Reuben Witcher
b. 1824/1873 d. 1850/1949
9
Frances Cabell Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.5]
b. 19 Jun 1857 d. 19 Jan 1923
+
Francis Marion Henry
b. 1832/1875 d. 1853/1951
9
Eliza Garland Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.6]
b. 19 Aug 1859
9
Daniel Edward Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.7]
b. 1862 d. Feb 1895
9
Patrick Mason Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.8]
b. 3 Dec 1863 d. 16 Feb 1902
+
Mary Anderson
b. 1832/1880 d. 1853/1958
9
Gillie Coleman Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.9]
b. 18 Mar 1867 d. 3 Jan 1938
9
Marie Antoinette Henry
[1.1.1.1.6.4.6.3.10]
b. 9 Apr 1872 d. Feb 1944
8
Patrick Henry
[1.1.1.1.6.4.6.4]
b. Abt 1829
Clara F. Yancey
b. Abt 1833
9
John Patrick Henry
[1.1.1.1.6.4.6.4.1]
b. 1852
9
William Henry
[1.1.1.1.6.4.6.4.2]
b. 1855
9
George Henry
[1.1.1.1.6.4.6.4.3]
b. 1866
8
Maria Antoinette Henry
[1.1.1.1.6.4.6.5]
b. 1807/1836 d. 1823/1918
+
A. L. Hambrick
b. 1797/1834 d. 1823/1912
8
Marion F. Henry
[1.1.1.1.6.4.6.6]
b. 1807/1836 d. 1823/1918
+
Samuel Tyree
b. 1797/1834 d. 1823/1912
8
Paulina Henry
[1.1.1.1.6.4.6.7]
b. 1807/1836 d. 1829/1918
Barlett Jones
b. 1797/1834 d. 1829/1912
9
Cabell H. Jones
[1.1.1.1.6.4.6.7.1]
b. 1829/1868 d. 1838/1945
8
Lewis Cabell Henry
[1.1.1.1.6.4.6.8]
b. 1807/1836 d. 1813/1915
8
Laura S. Henry
[1.1.1.1.6.4.6.9]
b. 1807/1836 d. 1812/1918
7
Nathaniel West Henry
[1.1.1.1.6.4.7]
b. 7 Apr 1790 d. 6 Sep 1851
Virginia Ann Woodson
b. Abt 1796 d. 22 Oct 1838
8
Martha Catherine Henry
[1.1.1.1.6.4.7.1]
b. 15 Nov 1813 d. 10 May 1900
Charles Terrell Ward
b. Abt 1812 d. 27 Apr 1849
9
Virginia Elizabeth Ward
[1.1.1.1.6.4.7.1.1]
b. 23 Mar 1832 d. 25 Jan 1892
9
Robert Henry Ward
[1.1.1.1.6.4.7.1.2]
b. 13 Mar 1834 d. 24 Oct 1884
9
Anselm Ward
[1.1.1.1.6.4.7.1.3]
b. Sep 1846
9
Robert Henry Ward
[1.1.1.1.6.4.7.1.4]
b. 13 Mar 1881 d. 21 Oct 1891
8
Patrick Miller Henry
[1.1.1.1.6.4.7.2]
b. 1815 d. 4 May 1873
Susan Toby Robertson
b. 1820 d. 16 Aug 1880
9
Mary Virginia Henry
[1.1.1.1.6.4.7.2.1]
b. 16 Apr 1841 d. 21 Sep 1846
9
Elizabeth Ann Henry
[1.1.1.1.6.4.7.2.2]
b. 4 May 1843 d. 10 Oct 1846
9
Victoria Henry
[1.1.1.1.6.4.7.2.3]
b. 1845
9
Sarah "Sallie" Catherine Henry
[1.1.1.1.6.4.7.2.4]
b. Nov 1845
Thomas Lawton Davis
b. 17 Oct 1844 d. 16 Mar 1899
10
Henry James Davis
[1.1.1.1.6.4.7.2.4.1]
b. Abt 1869
10
Ada Virginia Davis
[1.1.1.1.6.4.7.2.4.2]
b. Jul 1871
10
Leon B. Davis
[1.1.1.1.6.4.7.2.4.3]
b. Abt 1874
10
Thomas L Davis
[1.1.1.1.6.4.7.2.4.4]
b. Abt 1878
10
Davis
[1.1.1.1.6.4.7.2.4.5]
b. Sep 1879
10
Zelma Davis
[1.1.1.1.6.4.7.2.4.6]
b. Abt 1883
9
Infant Son Henry
[1.1.1.1.6.4.7.2.5]
b. 10 May 1849
9
Emma Henry
[1.1.1.1.6.4.7.2.6]
b. Abt 1854
8
Mary B. Henry
[1.1.1.1.6.4.7.3]
b. Abt 1816 d. 1879
+
James Garrett
+
James Garrett
b. 1804/1841 d. 1830/1919
8
Lucy Ann Henry
[1.1.1.1.6.4.7.4]
b. 17 Mar 1817 d. 20 Jul 1888
John Cardwell
b. 1804/1841 d. 1836/1919
9
William Wirt Henry Cardwell
[1.1.1.1.6.4.7.4.1]
+
Rachel Shriner
b. 1836/1881 d. 1857/1960
9
Annotte Leslie Cardwell
[1.1.1.1.6.4.7.4.2]
b. Abt 1855 d. 1854/1955
+
Henry Curtis
b. 1828/1873 d. 1854/1950
9
Wyatt Henry Cardwell
[1.1.1.1.6.4.7.4.3]
b. 1836/1875 d. 1845/1952
9
Mary Virginia Cardwell
[1.1.1.1.6.4.7.4.4]
b. 1836/1875 d. 1854/1955
+
P. Peak
b. 1828/1873 d. 1854/1950
9
Wiltshire Cardwell
[1.1.1.1.6.4.7.4.5]
b. 1836/1875 d. 1857/1952
+
Elizabeth Arney
b. 1836/1881 d. 1857/1960
9
Elvira Cardwell
[1.1.1.1.6.4.7.4.6]
b. 1836/1875 d. 1845/1955
9
Jr. John Cardwell, Jr
[1.1.1.1.6.4.7.4.7]
b. 1836/1875 d. 1857/1952
+
Ellen Esmack
b. 1836/1881 d. 1857/1960
+
Charles Rosser
b. 1804/1841 d. 1830/1919
8
William Robertson Henry
[1.1.1.1.6.4.7.5]
b. Feb 1821 d. 15 Mar 1862
8
Dorothea Virginia Henry
[1.1.1.1.6.4.7.6]
b. Abt 1823 d. 1905
+
Beasley
b. 1804/1841 d. 1830/1919
7
Richard Henry
[1.1.1.1.6.4.8]
b. 27 Mar 1792 d. 24 Aug 1793
7
Edward Winston Henry
[1.1.1.1.6.4.9]
b. 21 Jan 1794 d. 12 Oct 1872
Jane Randolph Yuille
b. 1790/1810 d. 1831/1894
8
Maria Rosalie Henry
[1.1.1.1.6.4.9.1]
b. 27 Dec 1818 d. 1837/1926
William B. Lewis
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Louisa Lewis
[1.1.1.1.6.4.9.1.1]
b. 1837/1876 d. 1855/1956
+
Thomas W. Branch
b. 1829/1874 d. 1855/1951
9
William Lewis
[1.1.1.1.6.4.9.1.2]
b. 1837/1876 d. 1858/1953
+
Lucy Easly
b. 1837/1882 d. 1858/1961
9
E. W. Henry Lewis
[1.1.1.1.6.4.9.1.3]
b. 1837/1876 d. 1858/1953
+
Rosa D. Dickinson
b. 1837/1882 d. 1858/1961
9
Anne Page Lewis
[1.1.1.1.6.4.9.1.4]
b. 1837/1876 d. 1855/1956
+
John W. Collins
b. 1829/1874 d. 1855/1951
9
Alexander S. Lewis
[1.1.1.1.6.4.9.1.5]
b. 1837/1876 d. 1846/1953
8
Patrick Lafayette Henry
[1.1.1.1.6.4.9.2]
b. 1821 d. 1835/1923
+
Tillinghast
b. 1814/1850 d. 1835/1930
8
Thomas Yuille Henry
[1.1.1.1.6.4.9.3]
b. 1821 d. 1835/1923
+
Cunningham
b. 1814/1850 d. 1835/1930
8
Lucy Dorothea Henry
[1.1.1.1.6.4.9.4]
b. 1823 d. 1837/1926
Octave Leighton
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Fayetta Leighton
[1.1.1.1.6.4.9.4.1]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
9
Alberta Leighton
[1.1.1.1.6.4.9.4.2]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
8
Sarah Jane Henry
[1.1.1.1.6.4.9.5]
b. 1825 d. 1837/1926
William Armistead
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Adelia Armistead
[1.1.1.1.6.4.9.5.1]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
9
Edward Winston Armistead
[1.1.1.1.6.4.9.5.2]
b. 1837/1876 d. 1846/1953
8
Celine Henry
[1.1.1.1.6.4.9.6]
b. 25 Sep 1827 d. 1837/1926
Robert Catlett
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Winston Catlett
[1.1.1.1.6.4.9.6.1]
b. 1837/1876 d. 1846/1953
9
Jr. Robert Catlett
[1.1.1.1.6.4.9.6.2]
b. 1837/1876 d. 1858/1953
+
Jennie Daniel
b. 1837/1882 d. 1858/1961
8
Ella Henry
[1.1.1.1.6.4.9.7]
b. 1831
8
Jr. Edward Winston Henry
[1.1.1.1.6.4.9.8]
b. 1815/1844 d. 1840/1923
Anne L. Ely
b. 1814/1850 d. 1840/1930
9
D. Yuille Henry
[1.1.1.1.6.4.9.8.1]
b. 1840/1883 d. 1849/1962
9
Fannie Henry
[1.1.1.1.6.4.9.8.2]
b. 1840/1883 d. Abt 1911
8
Ada B. Henry
[1.1.1.1.6.4.9.9]
b. 1815/1844 d. 1837/1926
John G. Smith
b. 1805/1842 d. 1837/1920
9
Lucy Smith
[1.1.1.1.6.4.9.9.1]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
9
Rosalie Smith
[1.1.1.1.6.4.9.9.2]
b. 1837/1876 d. 1855/1956
+
William Smith
b. 1829/1874 d. 1855/1951
9
Georgia Smith
[1.1.1.1.6.4.9.9.3]
b. 1837/1876 d. 1855/1956
+
Cobb
b. 1829/1874 d. 1855/1951
9
Sarah Smith
[1.1.1.1.6.4.9.9.4]
b. 1837/1876 d. 1846/1956
7
John Henry
[1.1.1.1.6.4.10]
b. 16 Feb 1796 d. 7 Jan 1868
Elvira Bruce McClelland
b. 23 Apr 1808 d. 1871
8
Margaret Ann Henry
[1.1.1.1.6.4.10.1]
b. 4 May 1827
8
Elvira Henry
[1.1.1.1.6.4.10.2]
b. 25 Jul 1828
+
Jesse A. Higginbotham
b. 1804/1826 d. 1831/1911
Alexander F. Taylor
b. 1804/1826 d. 1837/1911
9
Robert Taylor
[1.1.1.1.6.4.10.2.1]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
8
William Wirt Henry
[1.1.1.1.6.4.10.3]
b. 14 Feb 1831 d. 5 Dec 1900
Lucy Gray Marshall
b. 31 Jul 1832 d. 25 Jan 1922
9
Elizabeth Henry
[1.1.1.1.6.4.10.3.1]
b. 22 Oct 1855 d. 1857/1954
+
Jr. James Lyons
b. 1831/1871 d. 28 Oct 1913
9
Jr. William Wirt Henry, Jr
[1.1.1.1.6.4.10.3.2]
b. 1860 d. 1941
+
Mary Bladen
b. 1860 d. 1934
9
Lucy Gray Henry
[1.1.1.1.6.4.10.3.3]
b. 1840/1873 d. 1857/1954
+
Mathew B. Harrison
b. 1831/1871 d. 1857/1949
9
James Marshall Henry
[1.1.1.1.6.4.10.3.4]
b. 1840/1873 d. 1848/1951
8
Margaret Ann Henry
[1.1.1.1.6.4.10.4]
b. 22 Jul 1833 d. 1881
William A. Miller
b. 1804/1826 d. 1837/1911
9
Ella Henry Miller
[1.1.1.1.6.4.10.4.1]
b. 1837/1865 d. 1844/1948
9
Florence Henry Miller
[1.1.1.1.6.4.10.4.2]
b. 1837/1865 d. 1854/1948
John Collins Dabney
b. 21 Feb 1793 d. 16 Apr 1875
10
Margaret Henry Dabney
[1.1.1.1.6.4.10.4.2.1]
+
S. Barksdale Penick
10
Miller Dabney
[1.1.1.1.6.4.10.4.2.2]
10
Frederick Dabney
[1.1.1.1.6.4.10.4.2.3]
9
John Henry Miller
[1.1.1.1.6.4.10.4.3]
b. 1837/1865 d. 1858/1945
+
Diana Hamilton
b. 1837/1872 d. 1858/1953
9
David Miller
[1.1.1.1.6.4.10.4.4]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
9
William Price Miller
[1.1.1.1.6.4.10.4.5]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
9
Rosa Cabell Miller
[1.1.1.1.6.4.10.4.6]
b. 1837/1865 d. 1844/1948
9
William Wirt Miller
[1.1.1.1.6.4.10.4.7]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
8
Thomas Stanhope McClelland Henry
[1.1.1.1.6.4.10.5]
b. 22 Jul 1833
Mary E. Gaines
b. 1815/1838 d. 1835/1922
9
Mary Ganes Henry
[1.1.1.1.6.4.10.5.1]
b. 29 May 1859
9
Jr. Thomas Stanhope Henry
[1.1.1.1.6.4.10.5.2]
b. 4 May 1863
9
Robert Gaines Henry
[1.1.1.1.6.4.10.5.3]
b. 4 Dec 1866
8
Laura Helen Henry
[1.1.1.1.6.4.10.6]
b. 15 Mar 1836 d. 1831/1916
+
James Carter
b. 1804/1826 d. 1831/1911
8
Emma Cabell Henry
[1.1.1.1.6.4.10.7]
b. 14 Feb 1838 d. 1837/1916
III James Boswell Ferguson
b. 1823
9
Elvira Ferguson
[1.1.1.1.6.4.10.7.1]
b. Abt 1860
9
IV James Boswell Ferguson
[1.1.1.1.6.4.10.7.2]
b. 1861
Eudora Witt Horner
b. 1861
10
V James Boswell Ferguson
[1.1.1.1.6.4.10.7.2.1]
b. 1887
8
John Henry
[1.1.1.1.6.4.10.8]
b. Abt 1840
7
Jane Robertson Henry
[1.1.1.1.6.4.11]
b. 15 Jan 1798 d. 19 Jan 1798
Edmund Winston
b. Abt 1745 d. 1818
7
Dorothea Spotswood Winston
[1.1.1.1.6.4.12]
b. 1775/1798 d. 1780/1882
6
John Dandridge
[1.1.1.1.6.5]
b. 15 Apr 1756 d. 20 Jul 1804
Elizabeth Booth
b. Abt 1764 d. Aft 12 Jun 1857
7
Fanny Richards Dandridge
[1.1.1.1.6.5.1]
b. 1777/1792 d. 1809/1881
+
Basil Brown
b. 1751/1783 d. 1808/1870
7
Susanna Dandridge
[1.1.1.1.6.5.2]
b. 1777/1793 d. 1819/1883
+
David Darrington
b. 1752/1784 d. 1809/1871
+
Lewis Davis
b. 1762/1794 d. 1819/1881
7
Jr. John W. Dandridge
[1.1.1.1.6.5.3]
b. 1778/1799 d. 1818/1883
+
Lucy M. H. Sharp
b. 1768/1795 d. 1817/1885
7
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.6.5.4]
b. 1778/1800 d. 1818/1887
+
Samuel Hawkins
b. 1761/1793 d. 1818/1880
7
William H. Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5]
b. Abt 1802 d. Bef 16 Mar 1868
Santa Maria
b. Abt 1800 d. 18 Jul 1824
8
Santa Maria Elizabeth Booth Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.1]
b. 15 Jul 1824 d. 5 Feb 1853
James Gaston Robinson
b. 1793/1823 d. 1850/1909
9
Ann Katherine Robinson
[1.1.1.1.6.5.5.1.1]
b. 19 Apr 1842 d. 15 Nov 1875
Joseph V.A. Tucker
b. 1817/1844 d. 1868/1931
10
Kate Goodwin Tucker
[1.1.1.1.6.5.5.1.1.1]
b. 1855/1874 d. 1890/1962
Samuel Robert Gresham
b. 1836/1865 d. 1890/1950
11
Joseph Samuel Gresham
[1.1.1.1.6.5.5.1.1.1.1]
Mary Tatum Friend
12
Martha Dandridge Gresham
[1.1.1.1.6.5.5.1.1.1.1.1]
10
Florence Dandridge Tucker
[1.1.1.1.6.5.5.1.1.2]
b. 1860/1875 d. 1865/1963
9
Virginia Robinson
[1.1.1.1.6.5.5.1.2]
b. 14 Oct 1843 d. 16 Jul 1844
9
William Francis Robinson
[1.1.1.1.6.5.5.1.3]
b. 4 May 1845 d. 3 May 1846
9
Maria Elizabeth Robinson
[1.1.1.1.6.5.5.1.4]
b. 20 Feb 1847 d. Apr 1872
Charles William Barnett
b. 1817/1847 d. 1871/1934
10
Rennie Goolsby Barnett
[1.1.1.1.6.5.5.1.4.1]
b. 27 Oct 1866 d. 27 Oct 1940
+
Reuben Mosley Buckley
b. 1841/1867 d. 1891/1954
Maria L. Jones
b. 1784/1810 d. Bef 1842
8
Ella H. Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.2]
b. 1825 d. 1849/1919
+
Frederick D. Bullock
b. 1798/1825 d. 1848/1912
Elizabeth Bullock Mosley
b. 1821 d. 1862/1916
8
Mary E. Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.3]
b. Abt 1844 d. 1845/1938
8
John S. Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.4]
b. Abt 1846 d. 1847/1936
8
Fanny R. Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.5]
b. Abt 1850 d. 1851/1944
8
William West Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.6]
b. Abt 1851 d. 1852/1941
8
Lucy B. Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.7]
b. Abt 1855 d. 1856/1949
8
Julian N. Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.8]
b. 7 Aug 1856 d. 17 Apr 1914
8
Lee Dandridge
[1.1.1.1.6.5.5.9]
b. Abt 1860 d. 1861/1950
7
Dolly Dandridge
[1.1.1.1.6.5.6]
b. 1778/1803 d. 1784/1887
7
Alexander Dandridge
[1.1.1.1.6.5.7]
b. 1778/1803 d. 1785/1884
+
Goode
b. 1752/1771 d. 1773/1856
6
Robert Ambler Dandridge
[1.1.1.1.6.6]
b. 21 Jun 1760 d. 20 Sep 1799
Mildred Aylett Allen
b. 7 Feb 1753 d. Aft May 1806
7
Richard Allen Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1]
b. 15 Jun 1784 d. 1825/1875
Fanny Anderson
b. 1766/1793 d. 1824/1882
8
Maria S. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.1]
b. 9 Jan 1804 d. 15 Sep 1804
8
Martha J. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.2]
b. 1805 d. 1806/1899
8
Spotswood Montgomery Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.3]
b. 19 Oct 1809 d. 1847/1900
Jane Frances Harding
b. 1795/1821 d. 1847/1909
9
William Archibald Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.3.1]
b. 5 Nov 1834 d. 1835/1924
9
Alfonso M. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.3.2]
b. 30 Nov 1835 d. 1836/1925
9
Marcella H. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.3.3]
b. 30 Nov 1839 d. 1840/1933
9
Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.3.4]
b. 7 Dec 1840 d. 1841/1930
9
Callimus G. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.3.5]
b. 3 Jun 1843 d. 1844/1933
9
William H. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.3.6]
b. 9 Jul 1844 d. 1845/1934
8
Archibald S. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.4]
b. 1816 d. 1817/1906
8
William G. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.5]
b. 1819 d. 1820/1909
8
Mary Frances Dandridge
[1.1.1.1.6.6.1.6]
b. 1822 d. 1823/1916
7
Alexander Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.6.2]
b. 6 Apr 1786 d. 1813/1877
+
Jane Lewis
b. 1770/1794 d. 1813/1882
7
Jr. Robert Ambler Dandridge
[1.1.1.1.6.6.3]
b. 5 Feb 1788 d. 1824/1879
Ann Goodwin
b. 1780/1802 d. 1824/1889
8
Mildred Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.6.3.1]
b. 1821 d. 1844/1915
+
Benjamin Cash
b. 1793/1821 d. 1843/1908
7
Allen Homes Dandridge
[1.1.1.1.6.6.4]
b. 22 Sep 1789 d. 29 Aug 1793
7
Elizabeth Terrell Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5]
b. 7 May 1792 d. Abt 1846
Robert Honeyman Dandridge
b. 12 Oct 1784 d. Bef 3 Dec 1838
8
George Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1]
b. 1812 d. 26 Aug 1860
Elizabeth A Norwood
b. 1816 d. 1853
9
Esther F. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.1]
b. 1843
+
James B. Thompson
9
Joseph Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2]
b. 22 Dec 1845 d. 26 Nov 1917
Florence Elizabeth Henderson
b. Abt 1851 d. Abt 1876
10
Earnest Claud Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1]
b. 9 Dec 1868 d. 14 Apr 1929
Pearl Lee Mayfield
11
Edna Ruth Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1.1]
11
Earnest Carl Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1.2]
11
Mary Esther Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1.3]
b. 11 Feb 1908
11
Joe Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1.4]
b. 12 Sep 1909
11
Maude Irene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1.5]
b. 17 Oct 1911 d. 8 Dec 1944
11
Katie Beatrice Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1.6]
b. 20 Oct 1913
11
Claude Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1.7]
b. 27 Sep 1917 d. 27 Sep 1917
11
Helen Lucile Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.1.8]
10
Mary Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.2]
b. 10 Sep 1871 d. 16 Oct 1959
James William Minor
b. 30 Jun 1861 d. 5 Feb 1959
11
Fletcher Vinson Minor
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.2.1]
b. 14 Jul 1911 d. 27 Sep 1967
12
Margaret Minor
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.2.1.1]
10
Benjamin Robert Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3]
b. 21 Dec 1872 d. 14 Jan 1968
Callie Donna Bryant
b. Dec 1861 d. 31 Dec 1904
11
Lilly Florence Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.1]
Granville McCoy
b. 21 Feb 1889 d. 4 Nov 1946
12
Edna Jewel McCoy
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.1.1]
12
Bobby Eugene McCoy
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.1.2]
[
=>
]
12
Fanny Vivian McCoy
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.1.3]
b. 2 Sep 1915
12
Johnnie Florine McCoy
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.1.4]
[
=>
]
11
James Ottie Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.2]
b. 30 Nov 1898 d. 21 Oct 1955
Martha Ofilda Winter
12
Dorcus E Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.2.1]
12
Jerome Odell Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.2.2]
12
Naoma Joyce Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.2.3]
[
=>
]
11
Ramond Eugene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.3]
b. 11 Jan 1907 d. 18 Jan 1945
Julia Ann Sprinkles
b. 2 Dec 1890 d. 15 Sep 1968
11
Ramond E Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.4]
b. Abt 1907
11
Mitchell Dean Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.5]
b. 28 Aug 1910 d. 3 Aug 1971
Jennie Wildcat
b. 26 Jan 1921 d. 10 Aug 1951
12
Mamie Darlene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.5.1]
[
=>
]
12
Lorene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.5.2]
[
=>
]
12
Robert Lee Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.5.3]
b. 13 Oct 1943 d. 31 Oct 1969 [
=>
]
11
Willie Benjamin Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.6]
Susan Elizabeth McElhaney
12
Willie Eugene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.6.1]
[
=>
]
12
Robert Edward Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.6.2]
[
=>
]
12
Harold Dean Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.6.3]
[
=>
]
12
Gerald Alan Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.6.4]
11
Ora Myrtle Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.7]
Samuel Lee Winkler, Jr
b. 23 Feb 1913 d. 3 Sep 1956
12
Ora Lee Winkler
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.7.1]
11
Joseph Samuel Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.8]
Ruby Robertson
12
Kathy Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.8.1]
[
=>
]
12
Kenneth Eugene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.8.2]
11
Jimmie Ben Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.9]
Lois Jean Waugh
12
James Calvin Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.9.1]
Alma Louise Betts
12
Charlene Louise Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.9.2]
11
Julia Florine Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.10]
+
James Keith Stull
Roy Millard Rodgers
12
Norma Jean Rodgers
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.10.1]
[
=>
]
12
Barbara Ann Rodgers
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.3.10.2]
[
=>
]
+
Marvin Mavie Thiessen
+
Frederick R. Boxberger
+
Robert D. Smith
10
Maude Irene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.4]
b. 2 Aug 1875 d. 22 Mar 1965
Emma Freeman
b. Feb 1865 d. 26 Nov 1917
10
Alva L Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.5]
10
Lottie Louise Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.2.6]
b. 29 Dec 1899 d. 22 Jun 1955
9
Liberty Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3]
b. 17 Jan 1849 d. 11 Dec 1933
Susan Antinethe Curtis
b. 29 Jan 1850 d. 27 Jul 1914
10
Isom Washington Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1]
b. 15 Dec 1870 d. 27 Jul 1937
Frances Minerva Harvey
b. 3 Jan 1876 d. 12 Jun 1949
11
George Liberty Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.1]
b. 10 Sep 1893 d. 20 Jan 1939
Lillie Belle Denham
b. 1 Apr 1899
12
Edith Bernice Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.1.1]
[
=>
]
11
Willie Jasper Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.2]
b. 27 Apr 1897
Pearlie Lewis
b. 3 Jun 1897
12
Joe Edward Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.2.1]
[
=>
]
11
Allie Viola Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.3]
b. 9 Dec 1900
Vernon E. Faulkner
b. 6 Mar 1909
12
Naomi Ruth Faulkner
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Delvin Raymond Faulkner
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.3.2]
[
=>
]
11
Carl Curtis Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.4]
b. 10 Jan 1905
Mary Ann Sloma
b. 31 Jul 1913
12
Frances Carlene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.4.1]
12
Ruth Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.4.2]
12
Lillian Pearl Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.4.3]
11
Susan Maurine Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.5]
b. 29 Jan 1909
Jodie Clifford Hayes
b. 13 May 1904
12
Linda Nell Hayes
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.5.1]
11
Mary Mardene Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.6]
b. 2 Feb 1911
Clarence Lewis
12
Clarence George Lewis
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.6.1]
+
Hernandez
11
James Travis Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.3.1.7]
+
Ethel Virginia Patterson
9
Alfaretta Eoline Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.1.4]
b. 1851 d. 27 Sep 1894
+
Joseph Philip Cooper
8
Mildred Ann Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.2]
b. 1814 d. 1870
Robert H. Creilly
b. 1814 d. Feb 1856
9
Mary C. Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.1]
b. Abt 1842 d. Abt 1869
9
Andrew Jackson Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.2]
b. Abt 1844 d. Abt 1862
9
Margaret J. B. Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.3]
b. 16 Mar 1845 d. 15 Feb 1905
William L. Barton
b. 10 Jul 1835 d. 18 Jul 1889
10
James Robert Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.1]
b. 9 Feb 1871 d. 1904/1962
Elizabeth Milner
b. 1861/1882 d. 1904/1971
11
Mildred Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.1.1]
b. 8 Nov 1901 d. 16 Oct 1905
11
Howard Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.1.2]
b. Abt 1907
10
Hance H. Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.2]
b. 23 Sep 1873 d. 1874/1963
Bulah Moore
d. 14 Jul 1909
11
Mildred Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.2.1]
+
Willey Shirley
10
Andrew Jackson Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.3]
b. 24 Sep 1875 d. 10 Sep 1903
+
Carrie Heart
10
Mary N. Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.4]
b. 31 Jan 1877 d. 1878/1971
Frank A. Walden
11
B. F. Walden
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.4.1]
b. 10 Aug 1911
+
Freida Mohead
Hazel Drake
12
James Franklin Walden
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.4.1.1]
[
=>
]
10
Sarah Azile Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.5]
b. 28 Jan 1879
Sam Cline
11
Hazel Cline
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.5.1]
11
True Lynn Cline
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.5.2]
10
John Dandridge Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.6]
b. 2 Jul 1880 d. 31 May 1967
Inez Hightower
b. 11 Jan 1896 d. 14 Aug 1950
11
Thomas E. Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.6.1]
Juanita Crabtree
12
Mary J. Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.6.1.1]
[
=>
]
11
John Dandridge Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.6.2]
11
Mary Margaret Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.6.3]
11
Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.6.4]
11
A. L. Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.6.5]
10
Troy Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.7]
b. 7 Jan 1884 d. 7 Feb 1884
10
Lelia Barton
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8]
Jim Jordan
11
Robert Jordan
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8.1]
Dessie Roller
12
Dessie Jordan
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8.1.1]
11
Jimmie Jordan
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8.2]
11
Lelia Jordan
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8.3]
Allen
12
James Nolen Allen
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8.3.1]
12
Lee Olen Allen
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8.3.2]
12
Margaret Rynie Allen
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8.3.3]
12
Susan Lanell Allen
[1.1.1.1.6.6.5.2.3.8.3.4]
9
George Washington Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4]
b. May 1847 d. 1848/1937
Georgia Ann Conant
b. May 1855
10
Lura Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.1]
+
J. H. Scruggs
10
Thomas Jefferson Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2]
b. Jul 1877
Etoile Ophelia Lessell
11
Preston Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.1]
Thelma Scott
12
George Thomas Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.1.1]
[
=>
]
12
Charles Preston Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.1.2]
[
=>
]
12
Martha Etoile Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.1.3]
12
Mary Nell Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.1.4]
[
=>
]
12
Jerald Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.1.5]
11
Carl Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.2]
Teddie Deaton
12
Carlene Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.2.1]
[
=>
]
11
Mildred Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.3]
Elmo Murff
12
Etiol Murff
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.3.1]
[
=>
]
12
Guy Thomas Murff
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.3.2]
[
=>
]
12
Betty Jane Murff
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.3.3]
[
=>
]
11
Ola Mae Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.4]
b. 19 Dec 1904
Calvert Gault
12
Frances Etoile Gault
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.4.1]
[
=>
]
12
Evelyn Gault
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.4.2]
[
=>
]
12
Robert Ray Gault
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.4.3]
[
=>
]
11
Lucille Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.5]
b. 29 Jan 1907
Auzie Norris Myatt
12
Charleen Myatt
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.5.1]
[
=>
]
12
Jr. Auzie Norris Myatt
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.5.2]
[
=>
]
12
Creely Neal Myatt
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.5.3]
[
=>
]
12
Carl Preston Myatt
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.5.4]
[
=>
]
11
Bonnie Laverne Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.6]
b. 4 Feb 1914
Eugene V. Davis
12
Eugene V. Davis
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.6.1]
[
=>
]
12
James Milton Davis
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.6.2]
[
=>
]
11
Lurlyne Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.7]
Burnell Wade
12
Jr. Burnell Wade
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.7.1]
[
=>
]
12
Martha Ann Wade
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.7.2]
[
=>
]
12
Dorothy Jean Wade
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.7.3]
[
=>
]
12
Virginia Wade
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.7.4]
[
=>
]
11
Troy Edward Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.8]
Syble Partridge
12
Troy Edward Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.8.1]
[
=>
]
12
James Thomas Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.2.8.2]
[
=>
]
10
Homa Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.3]
b. Nov 1881
+
Joe Bennett
10
Alma Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.4]
b. Oct 1884
+
Jeff Crider
10
Daisy Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.5]
b. Feb 1888
+
Mitchell Ogilvee
10
Maude Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.4.6]
b. Mar 1890
+
Arthur Harrison
9
Robert Gordon Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.5]
b. 17 May 1848 d. 1 Mar 1924
Jennie Lynn Brookshire
10
Electra Lynn Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1]
b. 2 Feb 1872 d. 30 Dec 1951
John Tillman Alexander
b. 2 Feb 1867 d. 12 Sep 1947
11
Ruth Electra Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.1]
b. 11 Nov 1894 d. 8 Apr 1973
+
Hannie Fortner
11
Ethel Donnon Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.2]
Bates
12
Betty Low Bates
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.2.1]
12
Jo Ann Bates
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.2.2]
11
Iska Lynn Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.3]
+
W. P. Inman
11
Otto Tillman Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.4]
b. 25 Oct 1899 d. 19 Mar 1967
+
Leona
11
John Gordon Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.5]
+
Edna
11
Edna Bell Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.6]
b. 16 Oct 1905 d. 6 Sep 1943
Volly Booth Nelson
b. 24 Jul 1903 d. 19 Nov 1971
12
Yvonne Nelson
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.6.1]
12
Jr. Volly Booth Nelson
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.6.2]
11
Letha Aline Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.7]
+
Barbough
11
Joe Wheeler Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.8]
b. 7 Mar 1910 d. 24 Feb 1963
11
Frances Delores Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.9]
b. 16 Sep 1912 d. 18 Aug 1958
Jared Mann Wilcox
b. 7 Apr 1899 d. 17 Mar 1960
12
Virginia Lynn Wilcox
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.9.1]
[
=>
]
11
Paul Wilson Alexander
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.1.10]
b. 15 Feb 1914
10
S. A. Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.2]
b. Abt 1874
10
Oscar T. Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.3]
b. Abt 1876
10
Lulla Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.4]
b. Abt 1878
10
Mahalia Delullah Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.5]
b. Abt 1881 d. Abt 1946
Gentry H. Shofner
b. Abt 1877 d. Abt 1937
11
Creilly Shofner
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.5.1]
11
Otto Shofner
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.5.2]
11
Ernestine Shofner
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.5.3]
+
Hendrix
11
Mary Shofner
[1.1.1.1.6.6.5.2.5.5.4]
+
Morgan
+
Honorra Sullivan
9
John Dandridge Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.6]
b. Abt 1852 d. 1853/1942
9
James Lewis Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.7]
b. 14 May 1854 d. 14 Oct 1941
Georgeanna Ford
b. 27 Jan 1863 d. 27 Jan 1943
10
Jennie Lee Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.1]
b. 12 Jul 1883 d. 20 Nov 1886
10
Alma Gertrude Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.2]
b. 9 Aug 1885
Gaston Allen
11
Bernice Allen
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.2.1]
James McCarter
12
Freda McCarter
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.2.1.1]
12
Martha McCarter
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.2.1.2]
11
Jimmie Lee Allen
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.2.2]
b. Abt 1915
Grace Malone
12
Brenda Allen
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.2.2.1]
10
Andrew Jackson Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3]
b. 5 Feb 1888 d. Dec 1971
Ollie Mae Baldwin
11
Albert Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.1]
Henryetta Hodges
12
Gerald Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.1.1]
12
Earl Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.1.2]
11
Jimmie Lee Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.2]
+
Orin Hamner
11
Allen Jones Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.3]
11
Eunice Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.4]
Buford Brown
12
Wayne Brown
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.4.1]
12
Bobby Brown
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.4.2]
11
Katie Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.5]
+
Lynn Daugherty
11
Raymond Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.6]
Marietta Moffett
12
Georgia Ann Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.6.1]
12
Betty Ray Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.6.2]
12
Tommy Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.3.6.3]
10
Harvey Medford Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.4]
Bessie Poole
b. 9 Mar 1896 d. 13 Jan 1974
11
Mavis Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.4.1]
T. J. McCarter
12
Tommy McCarter
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.4.1.1]
10
Bessie Earl Watson Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.5]
Andy Hamilton
11
Oscar Hamilton
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.5.1]
11
James Hamilton
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.5.2]
11
Cleta Hamilton
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.5.3]
+
Woody Russell
11
Pat Hamilton
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.5.4]
11
Bilbo Hamilton
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.5.5]
11
Dallas Hamilton
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.5.6]
10
Eunice Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.6]
b. 11 Dec 1893 d. 17 Sep 1895
10
Norman Jones Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.7]
Minnie Belle Lee
11
Leon Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.7.1]
Louise Curry
12
Lee Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.7.1.1]
12
Ronnie Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.7.1.2]
11
Jack Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.7.2]
Wilma Comer
12
Jackie Marie Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.7.2.1]
12
Natalie Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.7.2.2]
12
Chris Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.7.2.3]
10
Allie Azalee Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.8]
b. 27 Sep 1898
Elzie Grady Armstrong
11
Lorraine Armstrong
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.8.1]
John Dillard Davis
12
John Armstrong Davis
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.8.1.1]
[
=>
]
12
Connie Linda Davis
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.8.1.2]
12
Sandra Elizabeth Davis
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.8.1.3]
[
=>
]
11
Mary Lou Armstrong
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.8.2]
Bobby Russell Parker
d. 29 Sep 1966
12
Nancy Angela Parker
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.8.2.1]
[
=>
]
12
Cynthia Marilyn Parker
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.8.2.2]
+
Harry L. O'Neal
10
Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.9]
b. Abt 1900 d. Abt 1900
10
Sam Barnes Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.10]
b. 13 Aug 1905
Birdie Mae Smith
11
Paul Barnes Creely
[1.1.1.1.6.6.5.2.7.10.1]
9
Sarah C. Creilly
[1.1.1.1.6.6.5.2.8]
b. 1856 d. Abt 1865
Dan Raines
10
John Bell Raines
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.1]
10
Babe Raines
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.2]
10
Dan Raines
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.3]
10
Boyd Raines
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.4]
10
Willie Raines
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.5]
10
Inez Raines
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.6]
+
Will Pierce
10
Minnie Raines
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.7]
Ed Motley
11
Bonner Motley
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.7.1]
11
Earl Raines Motley
[1.1.1.1.6.6.5.2.8.7.2]
8
Jane T. Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.3]
b. Abt 1820 d. 1843/1914
+
Ruben Allen
b. 1786/1818 d. 1843/1905
8
Adeline Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.4]
b. Abt 1822
+
William Wade Smith
8
John Terrell Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.5]
b. Abt 1831 d. 5 Mar 1870
+
Octavia E. Banhook
b. 1824/1847 d. 1869/1935
8
Jr. Robert Honeyman Dandridge
[1.1.1.1.6.6.5.6]
b. 1832 d. CHILD
+
Margaret Ann Johnson
b. 1816/1840 d. 1859/1929
7
Mildred Spotswood Dandridge
[1.1.1.1.6.6.6]
b. 29 Sep 1795 d. 10 Oct 1819
+
Jr. Daniel Wade
b. 1770/1796 d. 1820/1883
6
Jr. Nathaniel West Dandridge
[1.1.1.1.6.7]
b. 26 Oct 1762
Sarah Watson
b. 1758 d. 1814
7
Martha Hale Dandridge
[1.1.1.1.6.7.1]
b. 23 Sep 1795 d. 7 Apr 1875
William Winston Fontaine
b. 25 Nov 1786 d. 1816
8
William Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1]
b. 7 Nov 1810 d. 1882
+
Elizabeth Henry Aylett
b. Nov 1798 d. 14 Nov 1818
Sarah Shelton Aylett
b. 24 Jun 1811 d. 5 Mar 1875
9
Elizabeth Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.1]
b. 28 Jun 1833
9
William Winston Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2]
b. 27 Nov 1834 d. 2 Nov 1917
Mary Adelaide Burrows
b. 4 Jan 1838 d. 28 Mar 1887
10
William Spottswood Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.1]
b. 27 Feb 1862 d. 28 Jul 1863
10
Mary Aylett Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.2]
b. 13 May 1866 d. 8 Aug 1933
10
John Lansing Burrows Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.3]
b. 18 Jun 1868 d. 11 May 1913
+
Elizabeth Rose Waggener
b. 12 Apr 1870 d. 9 Oct 1925
10
William Winston Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.4]
b. 16 Mar 1870 d. 19 Aug 1939
Florence West Evans
b. Mar 1877 d. 21 Jan 1928
11
Evan-Burrows Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.4.1]
Cornelius Vanderbilt Whitney
12
Neil “Sonny” Winston Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.4.1.1]
[
=>
]
Harold “Stubby” Herman Kruger
b. 23 Sep 1898 d. 7 Oct 1965
12
Robert "Bobby" Kruger
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.4.1.2]
+
Jack Lynch
+
Sterling Lawrence Adair
b. 18 Dec 1894 d. 14 Jan 1921
+
Mabel Kathleen Lawrence
b. Abt 1890
10
Elizabeth Adelaide Henry Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.5]
b. 6 Jan 1873 d. 19 Nov 1916
10
Marion Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.2.6]
b. 10 Jan 1880 d. 10 Jan 1880
9
Alexander Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.3]
b. Abt 1836 d. CHILD
9
Charles de la Boulay Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.4]
b. 1838 d. 1856
9
Marian Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.5]
b. 19 May 1840 d. 11 Feb 1913
+
John Hairston Redd
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
9
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6]
b. 1841 d. 1915
Annie Elizabeth Redd
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.1]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.2]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.3]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
John Winston Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.1]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.1.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.2]
11
William Fontaine Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.3]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.4]
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.5]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.5.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.5.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.5.3]
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.6]
b. 3 Dec 1897
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.7]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.8]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.8.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.4.8.2]
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.5]
b. 1877
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.6]
b. 1879
10
John Winston Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.7]
b. 1887
10
James Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.8]
b. 1888
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.6.9]
9
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.7]
b. 1845 d. 1862
9
Sarah Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.1.8]
b. 18 Jan 1848
Henry Sampson
b. 10 Mar 1847 d. 18 Sep 1915
10
Cornelia Dandridge Sampson
[1.1.1.1.6.7.1.1.8.1]
b. 1 Apr 1874 d. 13 Sep 1903
Malcolm Graham
b. Feb 1865
11
Malcolm Montrose Graham
[1.1.1.1.6.7.1.1.8.1.1]
b. 16 Sep 1898
11
Sarah Aylett Graham
[1.1.1.1.6.7.1.1.8.1.2]
+
Powell
Frank W. Simpson
12
Jr. Frank W. Simpson
[1.1.1.1.6.7.1.1.8.1.2.1]
12
Geary Graham Simpson
[1.1.1.1.6.7.1.1.8.1.2.2]
[
=>
]
12
William A. Simpson
[1.1.1.1.6.7.1.1.8.1.2.3]
8
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2]
b. 18 May 1813 d. 3 Nov 1845
Sarah Miller Cole
b. 14 Feb 1815 d. 2 Mar 1892
9
Watson Hale Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.1]
9
Nathaniel Cole Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.2]
9
Katherine Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.3]
Overton Redd Wootton
b. 1837
10
Eva Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.1]
10
Nora Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.2]
10
Lucy Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.3]
10
Sallie Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.4]
10
Maude Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.5]
10
Nathaniel Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.6]
10
William Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.7]
10
John Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.8]
10
Hale Wootton
[1.1.1.1.6.7.1.2.3.9]
9
Unity Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.4]
+
Edward Estes
9
Samuel Cole Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.5]
b. 1 May 1835 d. 3 Jun 1891
Mary Morton Anderson
b. 16 Apr 1852 d. 9 Jan 1904
10
Robert Anderson Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.5.1]
b. 7 Mar 1879 d. 1955
Genevieve Kearfott
11
Nancy Herr Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.5.1.1]
b. 13 Aug 1916 d. 30 Jun 1947
10
William Hale Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.5.2]
b. 7 Mar 1882 d. 1883/1972
10
Jr. Samuel Cole Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.5.3]
b. 1883 d. 1884/1973
10
Justina Cole Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.2.5.4]
b. 1887 d. 1969
+
Arthur B. Richardson
b. 1882 d. 1903/1973
8
Sarah Ann Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3]
b. 5 Nov 1815 d. 9 Feb 1909
Edmund Burwell Redd
b. 4 Jun 1808 d. 10 Aug 1850
9
Martha Catherine Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.1]
b. 3 Apr 1833 d. 15 Sep 1913
+
John Francis Wootton
b. Abt 1827 d. Abt 1888
9
John Hairston Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.2]
b. 8 Feb 1835 d. 4 Aug 1902
+
Marian Dandridge Fontaine
b. 19 May 1840 d. 11 Feb 1913
9
Mary Dandridge Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.3]
b. 8 Jan 1837 d. 10 Sep 1888
John Wayt
b. Abt 1831
10
Martha "Mattie" Frances Wayt
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1]
b. Jun 1874 d. Feb 1926
William Augustus Osborne
b. 15 Dec 1869 d. Jul 1942
11
Frances West Osborne
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.1]
Hiram Oscar Kerns, Jr
b. 24 May 1893 d. 5 Oct 1964
12
Elizabeth Osborne Kerns
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.1.1]
12
Edward Johnson Kerns
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.1.2]
[
=>
]
12
Hiram Oscar Kerns, III
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.1.3]
b. 28 Oct 1924 d. 25 Jun 1973 [
=>
]
11
Mary Osborne
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.2]
b. Abt 1898
11
Kate Osborne
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.3]
b. Abt 1901
11
Elizabeth Osborne
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.4]
b. Abt 1904
11
William Osborne
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.5]
b. Abt 1908
11
Marion Osborne
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.6]
b. Abt 1908
11
Dorothy Osborne
[1.1.1.1.6.7.1.3.3.1.7]
b. Abt 1910
9
William Spotswood Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.4]
b. 1 Mar 1839 d. 1 Nov 1909
Mary Taylor Wootton
b. 27 Aug 1844 d. 26 Apr 1918
10
Lucinda Dabney Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.1]
b. 1 Sep 1866 d. 9 Nov 1912
10
II Edmund Burwell Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.2]
b. 23 Feb 1868 d. CHILD
10
Martha Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.3]
b. 19 Sep 1870 d. 9 Nov 1933
+
Overton Reamey
d. Abt 1898
+
Jack B. Walker
b. 1 Jun 1859
10
Ella Spotswood Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4]
b. 5 Oct 1872 d. 25 Mar 1932
Richard Wordsworth Fischer
b. 5 Dec 1868 d. 6 Oct 1915
11
Spotswood Redd Gill Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.1]
b. 5 Apr 1896 d. Abt Jun 1923
11
Jr. Richard Wordsworth Fischer, Jr
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.2]
b. 7 Sep 1897 d. 24 Mar 1937
11
Caroline Dorothea Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.3]
IV Jesse Marden
b. 18 Jan 1906 d. 4 Jul 1962
12
Ann Marden
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.3.1]
11
John Gill Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.4]
b. 3 Feb 1901 d. 2 Jan 1950
+
Grace Elizabeth Shelfer
b. 2 Feb 1908 d. 8 Apr 1961
11
Mary Elizabeth Redd Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.5]
+
James Everett Sanner
b. 15 Jul 1896 d. Oct 1968
11
Ann Franklin Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.6]
b. 8 Sep 1905 d. Abt 1909
11
Martha Redd Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.7]
b. 7 Jan 1907 d. 11 Jan 1974
+
Frank Lewis
11
Lucinda Reamey Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.8]
b. 8 Jan 1908 d. 4 Nov 1960
+
Carl Hubbard
+
Ralph Ray Jack Williams
11
Louis Christian Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.9]
11
Matthew Redd Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.10]
b. Abt 1911 d. Dec 1916
11
Grace Brown Fischer
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.11]
Frank Beauregard Jenkins
b. Abt 1906 d. Abt 1950
12
Grace Jenkins
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.4.11.1]
10
Sarah Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.4.5]
b. 5 Oct 1872 d. 20 Jul 1873
9
James Smith Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.5]
b. Abt 1841
Sarah Hairston
10
Annie Spotswood Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.5.1]
+
John G. Hulsbush
10
Pocahontas Cabel Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.5.2]
+
Norman Thomas Mallonee
9
Celeste Tunstall Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.6]
b. Abt 1843
Samuel Pickney Caldwell
10
Alice Brandon Caldwell
[1.1.1.1.6.7.1.3.6.1]
9
Edmund Madison Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.7]
b. 18 Dec 1844 d. 2 Oct 1928
+
Anna Richardson
b. Abt 1859 d. Abt 1929
9
Annie Elizabeth Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.8]
b. 18 Jan 1847 d. Abt 1936
Patrick Henry Fontaine
b. 1841 d. 1915
10
Ella Redd Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.1]
b. 1866
+
Russell S. Stoddard
+
Alta L. Smith
10
Philip Aylett Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.2]
b. 1868
+
Jessie Kerner
10
William Spotswood Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.3]
b. Abt 1870 d. INFANT
10
Celeste Dandridge Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4]
b. 19 Aug 1873
William Thomas Creath
b. 1 Apr 1862
11
John Winston Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.1]
Elizabeth Stebbins
12
Matthew Henry Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.1.1]
11
Nancie F. Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.2]
11
William Fontaine Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.3]
11
Philip Aylett Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.4]
11
Marian Fontaine Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.5]
b. 25 Feb 1896
James Roy Oliver
12
Jr. James Roy Oliver
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.5.1]
12
Mary Lee Oliver
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.5.2]
12
Marian Aylett Oliver
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.5.3]
11
Samuel Lewis Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.6]
b. 3 Dec 1897
11
Alexander Spotswood Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.7]
b. 1 Dec 1898 d. 6 Dec 1899
11
Mary Atkinson Creath
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.8]
Newton Vaughan Colston
12
Newton Vaughan Colston
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.8.1]
12
Edward Fontaine Colston
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.4.8.2]
10
Patrick Henry Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.5]
b. 1877
10
Edmond Redd Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.6]
b. 1879
10
John Winston Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.7]
b. 1887
10
James Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.8]
b. 1888
10
Matthew Maury Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.3.8.9]
9
Ella E. Redd
[1.1.1.1.6.7.1.3.9]
b. Abt 1849 d. Abt 1919
+
Francis Watlington
b. Abt 1847 d. Abt 1917
8
Anne Fontaine
[1.1.1.1.6.7.1.4]
b. 1810/1838 d. 1807/1918
+
William Perkins
b. 21 Jul 1785 d. 8 Nov 1849
7
Watson N. Dandridge
[1.1.1.1.6.7.2]
b. 1778/1798 d. 1816/1882
+
Sarah Elizabeth Moore
b. 1773/1856 d. 1830/1937
7
Unity Dandridge
[1.1.1.1.6.7.3]
b. Abt 1799 d. 24 Oct 1823
Jesse Winston Garth
b. 17 Oct 1788 d. 8 Sep 1867
8
Sarah Dandridge Garth
[1.1.1.1.6.7.3.1]
b. 20 May 1825 d. 9 Feb 1908
+
Charles F. M. Dancy
b. 1808/1828 d. 1842/1914
7
Mary Dandridge
[1.1.1.1.6.7.4]
b. 1783/1808 d. 1799/1891
+
Ellis
b. 1773/1806 d. 1799/1886
6
Elizabeth Dandridge
[1.1.1.1.6.8]
b. 12 Sep 1764 d. 26 Apr 1833
Philip Payne
b. 29 Mar 1760 d. 7 Jul 1840
7
Jane Smith Payne
[1.1.1.1.6.8.1]
b. 1784 d. 1798/1878
+
Tamerlain W. Davies
b. 1767/1787 d. 1801/1873
7
John Smith Payne
[1.1.1.1.6.8.2]
b. 26 Jun 1786 d. 1839/1878
Susan Elwood Scott
b. 21 Mar 1794 d. 27 May 1862
8
Robert G. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.1]
b. 21 Aug 1810 d. 1844/1901
+
Sarah P. Miller
b. 1801/1822 d. 1844/1911
8
Mary Clementine Payne
[1.1.1.1.6.8.2.2]
b. 23 Dec 1812 d. 1826/1906
+
Francis W. Scott
b. 1795/1815 d. 1829/1901
8
John W. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.3]
b. 30 Nov 1814 d. 1841/1905
+
Sarah Ann Poindexter
b. 1798/1822 d. 1841/1910
8
Amanda V. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.4]
b. 14 Nov 1815 d. 1839/1909
+
George Yuille
b. 1788/1815 d. 1838/1902
8
Ann M. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.5]
b. 28 Feb 1818 d. 1832/1912
+
John C. Elliott
b. 1812
8
Philip W. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.6]
b. 11 Dec 1821 d. 1856/1912
+
Julia A. Ogden
b. 1812/1834 d. 1856/1923
8
Susan E. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.7]
b. 12 Apr 1824 d. 1838/1918
+
Jessee Hargrave
b. 1807/1827 d. 1841/1913
8
Walter Tazewell Payne
[1.1.1.1.6.8.2.8]
b. 14 Nov 1826 d. 1 Jun 1923
+
Elizabeth Kimbrough Ligon
b. 6 Jun 1827 d. 14 Mar 1893
8
Elizabeth S. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.9]
b. 3 May 1829 d. 1843/1923
+
Robert W. Nowlin
b. 1812/1832 d. 1846/1918
+
Creed Clark
b. 1812/1832 d. 1846/1918
8
Edward S. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.10]
b. 11 Jun 1831 d. 1832/1921
8
Martha Harriette Payne
[1.1.1.1.6.8.2.11]
b. 2 Apr 1836 d. 1850/1930
+
Marco B. Carter
b. 1819/1839 d. 1853/1925
8
Blanche T. Payne
[1.1.1.1.6.8.2.12]
b. 1809/1837 d. 1860/1925
+
Robert W. Withers
b. 1803/1835 d. 1860/1922
+
Susan E. N. Clark
b. Abt Mar 1812 d. 12 Sep 1889
7
Elizabeth S. Payne
[1.1.1.1.6.8.3]
b. 1788 d. 1802/1882
+
William Syme Cabell
b. 1771/1791 d. 1805/1877
7
Nathaniel West Payne
[1.1.1.1.6.8.4]
b. 1790 d. 1818/1881
+
Catherine W. Alexander
b. 1774/1798 d. 1817/1887
7
Mary C. Payne
[1.1.1.1.6.8.5]
b. 1792 d. 1808
7
Philip Matthews Payne
[1.1.1.1.6.8.6]
b. 1794 d. 1837/1886
Mary E. Mitchell
b. 1789/1815 d. 1837/1903
8
Catherine Mitchell Payne
[1.1.1.1.6.8.6.1]
b. 1815/1840 d. 1861/1928
Ferdinan Perrow
b. 1804/1836 d. 1861/1923
9
Charles Mathew Perrow
[1.1.1.1.6.8.6.1.1]
b. 1855/1885 d. 1910/1971
Mary S. Holman
10
Catherine Mitchell Perrow
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1]
Paul Campbell Bowles
11
Elizabeth Perrow Bowles
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1.1]
Jr. Charles Henry Robertson
12
Catherine Watt Robertson
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1.1.1]
12
III Charles Henry Robertson
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1.1.2]
12
Elizabeth Perrow Robertson
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1.1.3]
12
Paul Stuart Roberton
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1.1.4]
11
Paula Catherine Bowles
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1.2]
James Garland Watkins
12
Jr. James Garland Watkins, Jr
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1.2.1]
12
Mary Jane Watkins
[1.1.1.1.6.8.6.1.1.1.2.2]
[
=>
]
+
Elizabeth Cobbs
b. 1790/1810 d. 1811/1894
7
Baldwin Matthews Payne
[1.1.1.1.6.8.7]
b. 11 Dec 1796 d. 1832/1887
+
Catherine Thompson Coles
b. 10 Feb 1795
7
Ann T. Payne
[1.1.1.1.6.8.8]
b. 1799 d. 1813/1893
+
Jeremiah Pannill
b. 1782/1802 d. 1816/1888
7
Eveline Washington Payne
[1.1.1.1.6.8.9]
b. 1801 d. 1815/1895
+
Edward Ball Withers
b. 1784/1804 d. 1818/1890
7
Camilla West Payne
[1.1.1.1.6.8.10]
b. 1803 d. 1817/1897
+
Samuel Scott
b. 1786/1806 d. 1820/1892
7
Elvira Henry Payne
[1.1.1.1.6.8.11]
b. 1805 d. 1806
7
Louisa Woodson Payne
[1.1.1.1.6.8.12]
b. 11 Oct 1807 d. 1821/1901
+
John Coles
b. 26 Apr 1799
7
Clarissa Aylette Payne
[1.1.1.1.6.8.13]
b. 1809 d. 1823/1903
+
Robert Wyatt
b. 1792/1812 d. 1826/1898
6
Anna Catharina Dandridge
[1.1.1.1.6.9]
b. 27 Jul 1767
John Spotswood Moore
b. Abt 1752 d. Abt 1810
7
Anne Catherine Moore
[1.1.1.1.6.9.1]
+
Thompson (Thomas) W. Pulliam
7
Jr. John Spotswood Moore
[1.1.1.1.6.9.2]
b. Bef 1810 d. 1827/1900
Mary Virginia Murray
b. 1806/1826 d. 1827/1910
8
Sarah Elizabeth Moore
[1.1.1.1.6.9.2.1]
b. 1773/1856 d. 1830/1937
+
Watson N. Dandridge
b. 1778/1798 d. 1816/1882
Albert M. Gurley
b. 1766/1854 d. 1798/1931
9
Francis Asbury Gurley
[1.1.1.1.6.9.2.1.1]
b. 1798/1888 d. 1826/1963
Mary Frances Haynes
b. 1799/1893 d. 1826/1970
10
Julia Claire Gurley
[1.1.1.1.6.9.2.1.1.1]
Roy Simmons
11
Jr. Roy Simmons
[1.1.1.1.6.9.2.1.1.1.1]
Helen Foster Cobb
12
III Roy Simmons
[1.1.1.1.6.9.2.1.1.1.1.1]
12
William Frederick Simmons
[1.1.1.1.6.9.2.1.1.1.1.2]
12
David Chester Simmons
[1.1.1.1.6.9.2.1.1.1.1.3]
12
Anna Clare Simmons
[1.1.1.1.6.9.2.1.1.1.1.4]
6
Agnes Dandridge
[1.1.1.1.6.10]
b. 1769
6
Mary Claiborne Dandridge
[1.1.1.1.6.11]
b. 14 Jan 1772 d. 26 Jul 1847
+
George Woodson Payne
b. 9 Oct 1767 d. 1788/1858
+
Jane Pollard
b. 25 May 1744 d. 13 Apr 1821
3
Unity West
[1.1.2]
b. Abt 1657
3
Anne West
[1.1.3]
b. Abt 1660 d. Aft 1708
Henry Fox
b. 1633/1662 d. 1687/1747
4
Ann Fox
[1.1.3.1]
b. 20 Jun 1684 d. 8 May 1733
Jr. Thomas Claiborne
b. 16 Dec 1680 d. 16 Aug 1732
5
III Thomas Claiborne
[1.1.3.1.1]
b. 9 Jan 1703/04 d. 1 Dec 1735
5
Augustine Claiborne
[1.1.3.1.2]
b. 1721 d. 3 May 1789
Mary Herbert
b. 25 Aug 1728
6
Mary Herbert Claiborne
[1.1.3.1.2.1]
b. 1744 d. 25 Jul 1775
+
Charles Harrison
b. 30 Sep 1742 d. 1794
6
Herbert Claiborne
[1.1.3.1.2.2]
b. 1746 d. 1763/1836
+
Ruffin
+
Mary Burnet Browne
b. 1742/1762 d. 1763/1846
6
Thomas B. Claiborne
[1.1.3.1.2.3]
b. 1 Jan 1746/47 d. 1812
+
Scott
Mary Clayton
b. 11 Nov 1755 d. 1833
7
Esq. Philip Claiborne
[1.1.3.1.2.3.1]
b. 18 Jul 1773 d. 27 Oct 1827
Sally Sims
d. Bef 1817
8
Martha J. Claiborne
[1.1.3.1.2.3.1.1]
b. Abt 1800
8
John C. Claiborne
[1.1.3.1.2.3.1.2]
b. Abt 1804
8
Lucy S. Claiborne
[1.1.3.1.2.3.1.3]
b. 1806
8
Mary Elizabeth Claiborne
[1.1.3.1.2.3.1.4]
b. Abt 1808
6
Anne Claiborne
[1.1.3.1.2.4]
b. 30 Dec 1749 d. Est 1774/1843
V Richard Cocke
b. 20 Jun 1748 d. 24 Jan 1816
7
Richard Herbert Cocke
[1.1.3.1.2.4.1]
b. 1769 d. 1833
+
Ann Hunt Cocke
Markie
8
Martha Ann Cocke
[1.1.3.1.2.4.1.1]
Batt Henley
9
Indiana Henley
[1.1.3.1.2.4.1.1.1]
+
Emmett Robinson
+
John Peter
7
Augustine Cocke
[1.1.3.1.2.4.2]
b. 1771
7
Lucy Herbert Cocke
[1.1.3.1.2.4.3]
b. Abt 1772
+
William Ruffin
7
Buller Cocke
[1.1.3.1.2.4.4]
b. Abt 1773 d. 1787/1871
Elizabeth Barron
b. 1767/1798 d. 1787/1880
8
Elizabeth Marion Cocke
[1.1.3.1.2.4.4.1]
Louis Cruger Trezevant
9
Edward Buller Trezevant
[1.1.3.1.2.4.4.1.1]
6
Buller Claiborne
[1.1.3.1.2.5]
b. 1755
Patsy Ruffin
7
Sterling Claiborne
[1.1.3.1.2.5.1]
6
Lucy Herbert Claiborne
[1.1.3.1.2.6]
b. 1769
John Cocke
b. Abt 1745 d. 22 Aug 1798
7
Herbert Cocke
[1.1.3.1.2.6.1]
7
John Ruffin Cocke
[1.1.3.1.2.6.2]
b. 15 Jul 1783 d. 1827
+
Mary Coleman Scott
b. Abt 1787 d. 30 Sep 1857
5
Martha Claiborne
[1.1.3.1.3]
b. 17 Nov 1721 d. 23 Aug 1784
+
Patrick Napier
b. 1 Feb 1713 d. 23 Aug 1774
5
Daniel Parke Claiborne
[1.1.3.1.4]
b. Abt 1725 d. Sep 1790
Mary Anne Maury
b. 1728 d. 10 Apr 1797
6
Hannah Claiborne
[1.1.3.1.4.1]
6
Matthew Claiborne
[1.1.3.1.4.2]
6
Mary Anne Claiborne
[1.1.3.1.4.3]
b. 1750
6
Dorothea Claiborne
[1.1.3.1.4.4]
b. 18 May 1765
+
Henry Tatum
5
Elizabeth Claiborne
[1.1.3.1.5]
b. 1701/1726 d. 1718/1810
+
Benjamin Hoomes
b. 1691/1725 d. 1718/1805
5
Sarah Claiborne
[1.1.3.1.6]
b. 1701/1726 d. 1718/1810
+
Joseph Thompson
b. 1691/1725 d. 1718/1805
5
Nathaniel Claiborne
[1.1.3.1.7]
b. 1701/1726 d. 1722/1807
Jane Cole
b. 1701/1733 d. 1722/1815
6
Thomas Claiborne
[1.1.3.1.7.1]
4
Thomas Fox
[1.1.3.2]
b. 1668/1705 d. 1729/1784
Mary Tunstall
b. 1670/1729 d. 1729/1809
5
Jr. Thomas Fox
[1.1.3.2.1]
b. 1729/1757 d. 1755/1839
+
Philadelphia Claiborne
b. 1739/1758 d. 1776/1846
3
III John West
[1.1.4]
b. Abt 1666 d. 1700/1760
Judith Armistead
b. 1651/1678 d. 1700/1768
4
Charles West
[1.1.4.1]
b. 1677/1717 d. Abt 1734
3
Thomas West
[1.1.5]
b. Abt 1670 d. Aft 1714
Agnes
b. 1663/1685 d. 1707/1772
4
Francis West
[1.1.5.1]
b. 1702 d. 28 Jun 1796
Susannah Littlepage
b. 22 Jan 1718
5
William West
[1.1.5.1.1]
b. Abt 1735
Letitia Martin
6
Robert West
[1.1.5.1.1.1]
Mary Beverly Grymes
b. 12 Jul 1782 d. 8 May 1859
7
John W. West
[1.1.5.1.1.1.1]
b. Abt 1805
Maria F. Scott
8
Caroline Willis West
[1.1.5.1.1.1.1.1]
Thomas Yeatman Mosby, Jr
b. 24 Aug 1867 d. 2 Aug 1920
9
Jr. Thomas Talford Mosby
[1.1.5.1.1.1.1.1.1]
b. Oct 1891 d. May 1962
Marguarite Hill
b. Dec 1893
10
Margaret Mosby
[1.1.5.1.1.1.1.1.1.1]
10
III Thomas Talford Mosby
[1.1.5.1.1.1.1.1.1.2]
b. Cal 1922 d. Yes, date unknown
10
Barbara R. Mosby
[1.1.5.1.1.1.1.1.1.3]
11
Frederica Barbara Mosby
[1.1.5.1.1.1.1.1.1.3.1]
10
Ada Winston Mosby
[1.1.5.1.1.1.1.1.1.4]
+
Caroline D.
b. Cal 1881
5
Agnes West
[1.1.5.1.2]
b. Abt 1740 d. Abt 1800
Jr. William Dandridge
b. 1727 d. Abt 1784
6
Francis Dandridge
[1.1.5.1.2.1]
b. 1749/1768 d. 1785/1852
Lucy Webb
b. 1735/1762 d. 1784/1852
7
Nancy Dandridge
[1.1.5.1.2.1.1]
b. 1758/1785 d. 1807/1875
Jr. Bowler Cocke
b. 1750/1782 d. 1807/1869
8
Elizabeth Cocke
[1.1.5.1.2.1.1.1]
d. 1764/1847
Thomas Massie
b. 1747 d. 1834
9
David Massie
[1.1.5.1.2.1.1.1.1]
b. 17 May 1777
9
Elizabeth Watkins Massie
[1.1.5.1.2.1.1.1.2]
b. 29 Mar 1781
7
IV William Dandridge
[1.1.5.1.2.1.2]
b. 1770/1808 d. 1792/1886
+
Sally Webb
b. 1770/1814 d. 1792/1894
7
John Dandridge
[1.1.5.1.2.1.3]
b. 1770/1808 d. 1781/1886
6
Agnes Dandridge
[1.1.5.1.2.2]
b. 1753/1772 d. 1790/1859
Edward Pye Chamberlayne
b. 1758 d. 1806
7
Jr. Edward Pye Chamberlayne
[1.1.5.1.2.2.1]
b. Abt 1787
7
William Byrd Chamberlayne
[1.1.5.1.2.2.2]
b. 1789 d. 1858
Ann Williamson Mosby
b. Abt 1792
8
Lucy W. Chamberlayne
[1.1.5.1.2.2.2.1]
+
Efford Bentley
8
Edwin Harvey Chamberlayne
[1.1.5.1.2.2.2.2]
+
Sarah Madison Scott
7
Robert Chamberlayne
[1.1.5.1.2.2.3]
b. Abt 1790
7
Thomas Chamberlayne
[1.1.5.1.2.2.4]
b. Abt 1791 d. CHILD
6
Elizabeth Dandridge
[1.1.5.1.2.3]
b. 1751/1776 d. 1793/1862
Byrd Chamberlayne
b. Abt 1754 d. 1793/1853
7
Eleanor "Ellen" Chamberlayne
[1.1.5.1.2.3.1]
John Camm Pollard
8
Chamberlayne Pollard
[1.1.5.1.2.3.1.1]
7
Evelyn Byrd Chamberlayne
[1.1.5.1.2.3.2]
b. 1790 d. 1863
Jr. Robert Pollard
b. 1 Jan 1783 d. 18 Jun 1856
8
Robert Byrd Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.1]
b. 3 Jan 1810
8
William George Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.2]
b. 2 Apr 1818 d. Sep 1862
Sarah Adams Smith
b. Abt 1825
9
Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.2.1]
+
John Gascoine Moncure
8
James Otway Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.3]
b. 6 May 1820
+
George Anna Smith
8
Eliza Dandridge Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.4]
b. 7 Aug 1822 d. 7 Nov 1866
Beverly Browne Douglas
9
Elizabeth Dandridge Douglas
[1.1.5.1.2.3.2.4.1]
+
Travers Daniel Moncure
9
Mary Ellen Douglas
[1.1.5.1.2.3.2.4.2]
William T. Weathers
10
Willie True Weathers
[1.1.5.1.2.3.2.4.2.1]
10
Elizabeth Weathers
[1.1.5.1.2.3.2.4.2.2]
+
Tom Peet Cross
9
Evelyn Spotswood Douglas
[1.1.5.1.2.3.2.4.3]
b. 24 Feb 1841
James Colvin Causey
d. 6 Dec 1908
10
Beverly Douglas Causey
[1.1.5.1.2.3.2.4.3.1]
+
Mary Katherine Paul
10
Mary Douglas Causey
[1.1.5.1.2.3.2.4.3.2]
b. 16 Sep 1881
Marion Kelly Kendrick
b. Abt 1882
11
James Causey Kendrick
[1.1.5.1.2.3.2.4.3.2.1]
11
Elizabeth Dandridge Kendrick
[1.1.5.1.2.3.2.4.3.2.2]
11
Evelyn Douglas Kendrick
[1.1.5.1.2.3.2.4.3.2.3]
8
Edward Spotswood Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.5]
b. 7 Jul 1832
Mary Douglas
9
Evelyn Byrd Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.5.1]
+
Jr. Albert H. Stoddard
9
John Beverly Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.5.2]
9
Walter Weir Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.5.3]
9
James Hankins Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.5.4]
9
Henry Douglas Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.5.5]
9
William George Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.5.6]
9
Robert Spotswood Pollard
[1.1.5.1.2.3.2.5.7]
6
III William Dandridge
[1.1.5.1.2.4]
b. 1755/1781 d. 1798
5
Susanna West
[1.1.5.1.3]
b. 15 Mar 1743/44 d. 5 Dec 1780
+
West Gregory
b. 1727/1747 d. 1761/1833
+
Holt Richerson
b. 1740 d. 1800
+
Jane Cole
b. 1719
4
Nathaniel West
[1.1.5.2]
b. 1691/1718 d. 1727
4
Thomas West
[1.1.5.3]
b. 1691/1720 d. 1743
Mary Martha Cole
b. 1671/1720 d. 1715/1800
5
John West
[1.1.5.3.1]
b. 1700/1729 d. Bef 8 Feb 1787
Elizabeth Seaton
b. 1709/1732 d. 8 May 1812
6
Thomas West
[1.1.5.3.1.1]
b. 1751 d. 1829
Elizabeth Blair Bolling
b. 1768
7
Martha West
[1.1.5.3.1.1.1]
b. 1796 d. 1828
+
James Saunders Jones
b. 1786 d. 1846
7
Elizabeth Bolling West
[1.1.5.3.1.1.2]
b. 1798 d. 10 Apr 1864
Joel Walker Flood
b. 11 Jul 1789 d. 1858
8
Henry de La Warr Flood
[1.1.5.3.1.1.2.1]
b. 14 Aug 1816 d. 21 Apr 1892
Mary Elizabeth Trent
b. 1821 d. 26 Jan 1839
9
Joel Walker Flood
[1.1.5.3.1.1.2.1.1]
b. 9 Jan 1839 d. 1916
Ella Faulkner
b. 1844 d. 1885
10
Eleanor Bolling Flood
[1.1.5.3.1.1.2.1.1.1]
b. 1868 d. 17 Sep 1957
Richard Evelyn Byrd
b. 13 Aug 1860 d. 23 Oct 1925
11
Harry Flood Byrd
[1.1.5.3.1.1.2.1.1.1.1]
b. 8 Jun 1887 d. 20 Oct 1966
Anne Douglas Beverley
12
Jr. Harry Flood Byrd
[1.1.5.3.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 20 Dec 1914 [
=>
]
11
Richard Evelyn Byrd, Jr
[1.1.5.3.1.1.2.1.1.1.2]
b. 25 Oct 1888 d. 11 Mar 1957
Marie Donaldson Ames
b. 19 Jan 1889 d. 3 Sep 1974
12
Richard Evelyn Byrd, III
[1.1.5.3.1.1.2.1.1.1.2.1]
11
Thomas Bolling Byrd
[1.1.5.3.1.1.2.1.1.1.3]
b. 4 Sep 1890 d. Feb 1968
8
Eliza Bolling Flood
[1.1.5.3.1.1.2.2]
b. 1820
6
Martha West
[1.1.5.3.1.2]
b. 1739/1766 d. 1788/1856
+
George Gilbert
b. 1731/1763 d. 1788/1850
6
John West
[1.1.5.3.1.3]
b. 1730/1770 d. 16 Apr 1818
+
Anne Cornick
b. 1731/1776 d. 1752/1856
6
Delaware West
[1.1.5.3.1.4]
b. 1730/1770 d. 1810
6
Lucy West
[1.1.5.3.1.5]
b. 1730/1770 d. 1742/1851
5
Thomas West
[1.1.5.3.2]
b. 1715/1743 d. Abt 28 Feb 1810
4
Agnes West
[1.1.5.4]
b. 1691/1720 d. 1707/1802
Richard T. Gregory
b. 1681/1718 d. 1707/1796
5
Richard W. Gregory
[1.1.5.4.1]
b. 1730 d. 17 May 1817
Nancy Ann Vaughan
d. 21 Oct 1821
6
Smith Gregory
[1.1.5.4.1.1]
b. 1760 d. 8 Mar 1832
Martha
b. Abt 1766 d. Aft 1813
7
Nancy Vaughn Gregory
[1.1.5.4.1.1.1]
b. 1797 d. 13 Dec 1895
Wiley C. Hatton
b. Abt 1797 d. 11 Sep 1872
8
Rose Elizabeth Hatton
[1.1.5.4.1.1.1.1]
b. 1821 d. 1852
Thomas M. Hendrickson
b. Abt 1815 d. Aft 1865
9
Susan Hendrickson
[1.1.5.4.1.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1843 d. 1919
Isaac Newton Petty
b. 4 Dec 1841 d. 18 Nov 1875
10
Delilia May Petty
[1.1.5.4.1.1.1.1.1.1]
b. 21 Feb 1875 d. Aug 1944
Daniel Willard Spaulding
b. 1868 d. 1941
11
Marion Virginia Spaulding
[1.1.5.4.1.1.1.1.1.1.1]
Robert Fraser Reynolds
12
Ada Mae Reynolds
[1.1.5.4.1.1.1.1.1.1.1.1]
[
=>
]