News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Register for a User Account
Home
Search
Login
Find
Surnames
What's New
Most Wanted
Reports
Cemeteries
Media
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
•
First Name:
Last Name:
ID:
Rene Larcome
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Rene Larcome
[1]
2
Jane Larcome
[1.1]
b. 29 Nov 1638 d. 1708
Samuel Tucker
b. Abt 1630 d. Bef 1670
3
Mary Tucker
[1.1.1]
b. 1660 d. Aft 1710
III John Woodson
b. 1655 d. Aft 1 May 1700
4
Joseph Woodson
[1.1.1.1]
b. Abt 1680 d. 1752
Elizabeth Murry
b. 1700 d. 1750
5
John Woodson
[1.1.1.1.1]
5
Lucy Woodson
[1.1.1.1.2]
d. CHILD
5
Tucker Woodson
[1.1.1.1.3]
d. CHILD
5
Elizabeth Woodson
[1.1.1.1.4]
b. Abt 1705 d. 1756
5
Jr. Joseph Woodson
[1.1.1.1.5]
b. Abt 1736 d. Abt 1752
6
John Woodson
[1.1.1.1.5.1]
b. 1730 d. 1792
Elizabeth Hughes
b. Aft 1715 d. Abt 1731
7
Elizabeth Hughes Woodson
[1.1.1.1.5.1.1]
b. 12 May 1759 d. 15 Dec 1793
+
John Kennon
b. 1752 d. 12 Oct 1813
Elizabeth Scott
5
Mary Woodson
[1.1.1.1.6]
+
William Pierce
Mary Sanburne
b. Abt 1706
5
Joseph Woodson
[1.1.1.1.7]
b. Abt 1706
5
Sanburne Woodson
[1.1.1.1.8]
b. 11 Sep 1707 d. Bef 28 Jun 1756
Charity Childrey
b. 1708 d. 1756
6
Sarah Woodson
[1.1.1.1.8.1]
6
Jane Woodson
[1.1.1.1.8.2]
Ambrose Bramlett
b. Abt 1735 d. Feb 1804
7
Theodosia Bramlett
[1.1.1.1.8.2.1]
b. 16 Feb 1770 d. 20 Oct 1853
Benjamin Netherland
b. 28 Feb 1755 d. 10 Oct 1838
8
Powhatan Netherland
[1.1.1.1.8.2.1.1]
b. 1788 d. 27 Feb 1813
8
Mary Ann Netherland
[1.1.1.1.8.2.1.2]
b. 21 Sep 1789 d. 22 Sep 1811
8
Benjamin Netherland
[1.1.1.1.8.2.1.3]
b. 5 Mar 1797 d. 6 Jun 1881
Bryant White
7
Nelson C. White
[1.1.1.1.8.2.2]
7
Benjamin White
[1.1.1.1.8.2.3]
6
Jesse Woodson
[1.1.1.1.8.3]
6
Mary Ann Woodson
[1.1.1.1.8.4]
Elizabeth Hughes
b. Aft 1715 d. Abt 1731
6
Hughes Woodson
[1.1.1.1.8.5]
b. 1735 d. Jul 1806
Elizabeth Strange
b. 1760
7
Sarah Woodson
[1.1.1.1.8.5.1]
b. 1782
7
Thomas Woodson
[1.1.1.1.8.5.2]
b. 1788
7
Jr. Hughes Woodson
[1.1.1.1.8.5.3]
b. 30 May 1790 d. Abt Jan 1847
Sarah Mosby Winfrey
b. 16 Sep 1794
8
James Madison Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.1]
b. 16 Jun 1812
8
Elizabeth Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.2]
b. 12 Feb 1814 d. 11 Oct 1825
8
Martha T. Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.3]
b. 2 Apr 1816 d. Abt 1861
+
Joseph Woodson
b. 8 Jan 1816 d. UNKNOWN
8
Hughes A. Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.4]
b. 13 Mar 1818
8
Gustavas B. Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.5]
b. 25 May 1820
8
Nancy S. Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.6]
b. 12 Mar 1824
8
Malissa Page Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.7]
b. 2 Jan 1826 d. 11 Nov 1902
8
Sarah Ellen Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.8]
b. 26 Aug 1830
+
Thomas Woodson
d. UNKNOWN
8
William Henry Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9]
b. 18 Dec 1833 d. 15 Jun 1915
Isabella Ramsey
b. 18 May 1854
9
Thomas Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.1]
9
John Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.2]
9
Mary Ellen Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.3]
9
James D. Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.4]
9
William Weaver Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.5]
9
Sarah M. Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.6]
9
Joseph Edward Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.7]
9
Virginia Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.8]
9
Lena Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.9]
9
Artie Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.10]
9
Velotia Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.11]
b. 31 Oct 1870 d. 13 Apr 1959
+
Alonza Brown
b. Abt 1871
9
George Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.12]
b. Cal 1876 d. 4 Oct 1913
Cordelia Ann Noffsinger
b. 6 Dec 1868 d. 2 Jan 1914
9
Ethel Beulah Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.13]
b. Sep 1896
9
Eula May Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.14]
b. Jan 1898
9
Hughes W. Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.15]
b. Jan 1900
9
Pearl Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.16]
b. 1903
9
Clytie D. Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.17]
b. 1905
9
Elizabeth Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.9.18]
b. 1908
8
Virginia Ann Woodson
[1.1.1.1.8.5.3.10]
b. 13 Jul 1835
7
Joseph Woodson
[1.1.1.1.8.5.4]
b. 1792
7
Samuel Woodson
[1.1.1.1.8.5.5]
b. 1794
+
Elizabeth Michaux
b. Abt 1709
4
Samuel Tucker Woodson
[1.1.1.2]
b. Abt 1682 d. 1718
4
Benjamin Woodson
[1.1.1.3]
b. Abt 1684 d. 1778
Frances Napier
b. 5 Feb 1694/95 d. 1778
5
John Woodson
[1.1.1.3.1]
5
Booth Woodson
[1.1.1.3.2]
5
Benjamin Woodson
[1.1.1.3.3]
5
Mary Perrin Woodson
[1.1.1.3.4]
b. 1727 d. 1784
+
Joseph Fitzpatrick
5
Frances Woodson
[1.1.1.3.5]
b. 1730
George Anderson
b. Abt 1725 d. 1808
6
George Dabney Anderson
[1.1.1.3.5.1]
b. Abt 1750 d. 1811
Susannah Mimms
b. 1736 d. 25 Feb 1824
7
Judith Anderson
[1.1.1.3.5.1.1]
b. Abt 1773 d. 18 Jun 1862
Richard Beckwith Payne
b. 9 Aug 1776 d. 8 Sep 1858
8
Robert Burton Payne
[1.1.1.3.5.1.1.1]
b. 16 Aug 1795 d. 11 Mar 1875
+
Frances Gardner Anderson
b. 23 Nov 1810 d. 7 Aug 1881
+
Susannah ANDERSON
8
George Anderson Payne
[1.1.1.3.5.1.1.2]
b. 28 Mar 1797 d. 18 May 1839
8
Fleming S Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3]
b. 5 Aug 1799 d. 13 Jan 1857
Isabella Winn
b. 1805 d. 15 Jul 1882
9
Richard Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.1]
b. Abt 1825 d. Between 1881 and 1900
9
Barrett G Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.2]
b. 22 Mar 1827 d. 30 Apr 1904
9
Judith B Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.3]
b. Abt 1829
9
Flavius Josephus Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.4]
b. 7 Jul 1833 d. 20 Jan 1919
9
James Franklin Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5]
b. Nov 1837 d. Dec 1904
Angelina Ontario Keoka Chiles
b. 29 Apr 1849 d. 13 Mar 1933
10
Georgia Magnolia Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.1]
b. 30 Mar 1869 d. 2 Dec 1935
+
Harry Masoncupp
10
Alice Clark Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2]
b. 20 Feb 1872 d. 20 Dec 1963
John E. Talley
b. 1876
11
Alice Talley
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2.1]
b. Abt 1902
+
Harold King
11
Louise P Talley
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2.2]
b. Abt 1904
+
Smith
11
Frank W Talley
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2.3]
b. Abt 1906
Betty
12
Marian Talley
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2.3.1]
12
Betsy Talley
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2.3.2]
11
Maude A Talley
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2.4]
b. Abt 1909
11
Erma Talley
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2.5]
b. Abt 1911
+
Lacy Morris
11
Cecil V Talley
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.2.6]
b. Abt 1913
+
Leo Isbell
10
Walter Daniel Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3]
b. 10 May 1875 d. 22 Jul 1970
Flora Lee Martin
b. 13 Jun 1886 d. 22 Jul 1973
11
Wilbur Martin Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.1]
b. 1912 d. 29 Feb 1932
11
Robert Lee Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.2]
b. 23 Sep 1914 d. 6 Mar 1932
11
Carroll Thomas Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.3]
Frances Tomlin
12
Jr. Carroll Thomas Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.3.1]
[
=>
]
12
Michael Scott Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.3.2]
11
Virginia Cameron Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.4]
John Marshall Ballard
12
David Lee Ballard
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.4.1]
[
=>
]
11
Stuart Daniel Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.5]
+
Audrey Macirdo
+
Edna Luckard
11
James Franklin Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.6]
Elizabeth Rush
12
Dale Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.6.1]
12
Shawna Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.6.2]
12
Dawn Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.6.3]
12
Gwendolyn Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.6.4]
12
Jr. James Franklin Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.6.5]
+
Linda
11
Elizabeth Rebecca Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.7]
Samuel Goodson
12
Sharon Goodson
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.3.7.1]
[
=>
]
+
Emerson Lewis
10
Laura Belle Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4]
b. 19 Aug 1877 d. 1946
William G. Hughes
b. 1866
11
Mattie Payne Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.1]
+
Jr. Louis Saksen
b. 1866
11
Doris E. Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.2]
+
Earl Carsell
11
Aubrey Scott Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.3]
11
Roy Linwood Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.4]
11
Charlie F. Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.5]
11
William E. Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.6]
11
James D. Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.7]
11
Alfred G. Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.8]
11
Jessie B. Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.9]
11
Ruth Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.3.5.4.10]
+
William Marion
9
Eliza M Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.6]
b. Mar 1846 d. Abt 1905
Thomas Gilman Payne
b. 19 Apr 1845 d. 27 Jan 1926
10
Oliver V Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.6.1]
b. Abt 1868
10
Oteria Virginia Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.6.2]
b. 14 Aug 1868 d. 10 Feb 1952
10
Nannie Beckwith Payne
[1.1.1.3.5.1.1.3.6.3]
b. 26 Oct 1870 d. 24 Jun 1957
8
Norella Burton Payne
[1.1.1.3.5.1.1.4]
b. 25 Dec 1801 d. 9 Feb 1889
Jesse Reese Hughes
d. 6 Jan 1880
9
Robert Burton Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.4.1]
b. 3 Nov 1820 d. 4 Dec 1900
Sarah Elizabeth Cleveland
b. 13 Jun 1824 d. 24 Aug 1864
10
Margaret Lelia Hughes
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1]
b. 12 Dec 1850 d. 18 Dec 1940
III Isaac Otey Perkins, Jr.
b. 20 Dec 1846 d. 18 Jan 1913
11
Lelia Cary Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.1]
11
Louise Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.2]
11
IV Isaac Otey Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.3]
11
Braxton Lee Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.4]
11
Jeter Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.5]
11
William Beckwith Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.6]
12
Jr. William Beckwith Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.6.1]
[
=>
]
11
Robert Cleveland Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.7]
11
Nathaniel James Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.8]
b. 31 May 1877 d. 20 Apr 1962
Ethel Vernon Beard
b. 25 Sep 1879 d. 19 Jan 1934
12
Ethel Goodwin Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.8.1]
[
=>
]
11
Edwin Judson Perkins
[1.1.1.3.5.1.1.4.1.1.9]
b. Abt 1880
+
Henrietta Tapscott Snead
b. Abt 1880
8
Margaret Sydenham Payne
[1.1.1.3.5.1.1.5]
b. 23 Feb 1804 d. 19 May 1890
8
William Jordan Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6]
b. 23 Sep 1806 d. 24 Feb 1890
Sarah Elizabeth Herring
b. 1804 d. 1885
9
Alberta Jordan Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.1]
b. 15 Aug 1832 d. 6 Jun 1868
Walter Samuel Johnson
b. Abt 1812
10
Johnson
[1.1.1.3.5.1.1.6.1.1]
b. Yes, date unknown
9
Luther Rice Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.2]
b. 8 Nov 1834 d. 7 Sep 1885
Malvina Virginia Bowles
b. Abt 1839
10
Beckwith Benjamin Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.2.1]
b. Yes, date unknown
9
Nancy B. Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.3]
b. 15 Jul 1837 d. 14 Jun 1914
+
John Daniel Winn
9
Tucker W. Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.4]
b. 13 Feb 1840 d. 11 Nov 1921
Sarah F. Stines
b. 1842
10
William B. Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.4.1]
b. 1868
10
Rosa B. Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.4.2]
b. 1870
10
Alfred Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.4.3]
b. 1871
10
Georgie T. Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.4.4]
b. 1878
9
George Anderson Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.5]
b. 20 Aug 1842 d. 20 Jan 1890
Mary M. Johns
b. Abt 1856
10
Bernie Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.5.1]
b. Abt 1873
10
Magnus Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.5.2]
b. Between 15 Jun 1879 and 15 Jun 1880
9
Thomas Gilman Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.6]
b. 19 Apr 1845 d. 27 Jan 1926
+
Mollie B Payne
b. Abt 1878
Eliza M Payne
b. Mar 1846 d. Abt 1905
10
Oliver V Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.6.1]
b. Abt 1868
10
Oteria Virginia Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.6.2]
b. 14 Aug 1868 d. 10 Feb 1952
10
Nannie Beckwith Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.6.3]
b. 26 Oct 1870 d. 24 Jun 1957
9
Sarah Judson Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.7]
b. 20 Sep 1847 d. 30 Jun 1890
+
Theodore Currin
John Hillery Morris
b. 9 Sep 1840 d. 25 Jan 1922
10
Alvin Ruffin Morris
[1.1.1.3.5.1.1.6.7.1]
b. 22 Aug 1876 d. 9 Oct 1967
Mertie Brent Gillespie
b. 1 May 1880 d. 3 Mar 1973
11
Alberta Morris
[1.1.1.3.5.1.1.6.7.1.1]
b. 23 Jan 1916 d. 3 Mar 1973
Raymond R. Quesenberry
b. 15 Jul 1911
12
Betty Jo Quesenberry
[1.1.1.3.5.1.1.6.7.1.1.1]
9
Fleming H. Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.8]
b. 1850 d. 27 Jun 1865
9
Mariah Agnes Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.9]
b. 10 Aug 1853 d. 24 Nov 1930
+
John Saunders
9
Hattie Evilene Payne
[1.1.1.3.5.1.1.6.10]
b. 26 May 1856 d. 19 May 1927
+
George Clements
b. 30 Jun 1855 d. 8 Oct 1936
8
Mary Brockenbrough Payne
[1.1.1.3.5.1.1.7]
b. 15 Jul 1809 d. 3 Sep 1883
George Loving Seay
b. 15 Jul 1809 d. 3 Sep 1883
9
Joseph Morton Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.1]
9
Robert Hasley Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.2]
Lucy Oliver Cleveland
10
Chester Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.2.1]
10
Randolf Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.2.2]
10
Welford Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.2.3]
+
Clair Soule
10
Lorena Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.2.4]
10
Norella Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.2.5]
10
Sally Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.2.6]
9
Mary B. Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.3]
9
Emily Judson Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.4]
9
Georgie A. Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.5]
9
Judith Elizabeth Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.6]
9
Phillip G. Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.7]
9
Sidney Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.8]
9
Richard B. Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.9]
9
George P. Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.10]
9
Norella Burton Seay
[1.1.1.3.5.1.1.7.11]
b. 19 Jan 1837 d. 2 Apr 1882
Benjamin Anderson SOWELL
b. 29 Feb 1832 d. 13 Jul 1912
10
Mary Paulina SOWELL
[1.1.1.3.5.1.1.7.11.1]
b. 12 Aug 1869 d. 25 Mar 1952
Russell Winston JENNINGS
b. 22 Feb 1870 d. 9 May 1941
11
Norella Burton JENNINGS
[1.1.1.3.5.1.1.7.11.1.1]
b. 8 Oct 1894 d. Abt 1975
James Newton WOOD
b. Abt 1892 d. 19 Dec 1930
12
WOOD
[1.1.1.3.5.1.1.7.11.1.1.1]
12
James WOOD
[1.1.1.3.5.1.1.7.11.1.1.2]
12
Mary Norella WOOD
[1.1.1.3.5.1.1.7.11.1.1.3]
8
Susan Mims Payne
[1.1.1.3.5.1.1.8]
b. 3 Feb 1812 d. 1886
Jeremiah Cleveland
b. 1786 d. Apr 1866
9
George Beckwith Cleveland
[1.1.1.3.5.1.1.8.1]
b. 26 Jan 1842 d. 16 Feb 1932
9
Mary Susan Cleveland
[1.1.1.3.5.1.1.8.2]
b. 23 Jan 1843 d. 22 Jul 1920
Williams Pitt JENNINGS
b. 2 Nov 1835 d. 27 Jul 1928
10
Russell Winston JENNINGS
[1.1.1.3.5.1.1.8.2.1]
b. 22 Feb 1870 d. 9 May 1941
Mary Paulina SOWELL
b. 12 Aug 1869 d. 25 Mar 1952
11
Norella Burton JENNINGS
[1.1.1.3.5.1.1.8.2.1.1]
b. 8 Oct 1894 d. Abt 1975
James Newton WOOD
b. Abt 1892 d. 19 Dec 1930
12
WOOD
[1.1.1.3.5.1.1.8.2.1.1.1]
12
James WOOD
[1.1.1.3.5.1.1.8.2.1.1.2]
12
Mary Norella WOOD
[1.1.1.3.5.1.1.8.2.1.1.3]
9
Virginia Morton Cleveland
[1.1.1.3.5.1.1.8.3]
b. Sep 1845 d. 1916
9
John Poindexter Cleveland
[1.1.1.3.5.1.1.8.4]
b. 20 Aug 1846 d. 30 Jun 1924
9
James Fleming Cleveland
[1.1.1.3.5.1.1.8.5]
b. 1850 d. 7 Oct 1865
9
Judith Payne Cleveland
[1.1.1.3.5.1.1.8.6]
b. Mar 1854 d. 29 Sep 1923
8
Elizabeth Beckwith Payne
[1.1.1.3.5.1.1.9]
b. 20 Aug 1815 d. 12 Oct 1815
5
Rene Woodson
[1.1.1.3.6]
b. 1730
5
Patrick Woodson
[1.1.1.3.7]
b. 1740
4
Mary Jane Woodson
[1.1.1.4]
b. 1686 d. Oct 1735
Joseph Woodson
b. Abt 1664 d. Bef 15 Oct 1734
5
John Woodson
[1.1.1.4.1]
b. Abt 1704 d. Abt Oct 1727
5
Mary Woodson
[1.1.1.4.2]
b. Abt 1706 d. 1733/1800
+
Stephen Woodson
b. Abt 1682 d. Bef May 1761
5
Joseph Woodson
[1.1.1.4.3]
b. Abt 1709 d. 1711
5
Judith Woodson
[1.1.1.4.4]
b. 1712 d. 1738
Charles Christian
b. 1710 d. Feb 1784
6
Lucy Christian
[1.1.1.4.4.1]
b. 1735 d. 1779/1830
+
Drury Woodson
b. Abt 1730 d. 7 May 1788
6
Judith Woodson Christian
[1.1.1.4.4.2]
b. 1738 d. 22 Mar 1814
Chesley Daniel
b. 16 Jan 1729/30 d. 11 Sep 1814
7
Benjamin Daniel
[1.1.1.4.4.2.1]
7
John Granville Daniel
[1.1.1.4.4.2.2]
b. 1747 d. Aug 1802
7
George Daniel
[1.1.1.4.4.2.3]
b. 1759 d. 17 Jan 1812
7
James Chesley Daniel
[1.1.1.4.4.2.4]
b. 1762 d. 1841
7
Beverley Daniel
[1.1.1.4.4.2.5]
b. 11 Feb 1762 d. 18 Feb 1851
7
Martha Daniel
[1.1.1.4.4.2.6]
b. 24 Feb 1763 d. 2 May 1839
7
Judith Christian Daniel
[1.1.1.4.4.2.7]
b. 1765 d. 13 Nov 1817
7
Gano Daniel
[1.1.1.4.4.2.8]
b. 1768
7
Susan Daniel
[1.1.1.4.4.2.9]
b. 1771 d. 6 Jan 1827
7
Elizabeth Daniel
[1.1.1.4.4.2.10]
b. 11 Sep 1773 d. 13 Nov 1817
7
Beverly Daniel
[1.1.1.4.4.2.11]
b. 1 Apr 1774 d. 11 Sep 1854
7
Woodson Daniel
[1.1.1.4.4.2.12]
b. 19 Mar 1776 d. 27 May 1853
Elizabeth Milton
b. 1799 d. 3 Jul 1875
8
Ellen Christian Daniel
[1.1.1.4.4.2.12.1]
b. 20 Nov 1820
8
Beverly John Daniel
[1.1.1.4.4.2.12.2]
b. 1821 d. 22 Nov 1828
8
Nancy Anderson Daniel
[1.1.1.4.4.2.12.3]
b. 1824
8
Indiana Daniel
[1.1.1.4.4.2.12.4]
b. 24 May 1826
8
Elizabeth Woodson Daniel
[1.1.1.4.4.2.12.5]
b. 1830
8
Thomas Chesley Daniel
[1.1.1.4.4.2.12.6]
b. 1832
7
John Granville Daniel
[1.1.1.4.4.2.13]
b. 1778 d. 1 Jun 1870
7
Mary Polly Ann Daniel
[1.1.1.4.4.2.14]
b. 1780
James Key
d. 1824
8
Ann Key
[1.1.1.4.4.2.14.1]
8
Jr. James W. Key
[1.1.1.4.4.2.14.2]
Lucy Hopkins
9
III James Key
[1.1.1.4.4.2.14.2.1]
9
Emmett Key
[1.1.1.4.4.2.14.2.2]
8
Jefferson Key
[1.1.1.4.4.2.14.3]
8
Chesley Daniel Key
[1.1.1.4.4.2.14.4]
b. 5 Jan 1795 d. 1871
Narcissus Bailey
b. 1803 d. 10 Jul 1845
9
Hannah Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.1]
9
John Taylor Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.2]
9
Christopher Columbus Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.3]
9
Joseph Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.4]
9
Priscella Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.5]
9
James Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.6]
9
Patty Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.7]
9
Mary Ann Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.8]
9
Thomas Jefferson Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.9]
b. 17 Jan 1831 d. 1905/1908
Helen Palmer
10
Emma Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.9.1]
10
Chesley P. Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.9.2]
10
Cleburne Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.9.3]
10
Julia Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.9.4]
10
Pearle Key
[1.1.1.4.4.2.14.4.9.5]
+
Sarah L. Fryer
8
Judith Woodson Key
[1.1.1.4.4.2.14.5]
b. 8 Nov 1799 d. 1868
+
Jordan Lambert
8
Beverly D. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6]
b. 1805 d. 1843
Judith Browder
9
Ann Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.1]
9
Charles D. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.2]
9
Beverly D. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.3]
9
John H. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4]
b. 16 Apr 1836 d. 12 Apr 1921
Annie Boundgrant
b. 13 Jul 1839 d. 9 Jul 1901
10
James D. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.1]
Laura Jane Gish
11
Georgie E. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.1.1]
11
Herman H. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.1.2]
11
Mildred V. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.1.3]
11
Hampton B. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.1.4]
11
Simon Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.1.5]
d. INFANT
11
Rener May Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.1.6]
10
Annie M. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.2]
10
Mary B. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.3]
10
Fannie J. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.4]
10
David B. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.5]
10
Alice C. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.6]
10
Samuel R. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.7]
10
Ettie Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.8]
10
Nettie Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.9]
10
William C. Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.10]
10
Laura Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.11]
10
Charley Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.12]
d. INFANT
10
Earnest Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.13]
b. 20 Feb 1856
Alice May Huruston
11
Jr. Earnest Raymond Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.13.1]
b. 31 Jan 1908
+
Nina Felps
11
Thenno Key
[1.1.1.4.4.2.14.6.4.13.2]
b. 12 Apr 1911 d. INFANT
5
Martha Woodson
[1.1.1.4.5]
b. Abt 1716 d. Aft 1783
John Cannon
b. Abt 1709 d. 21 May 1757
6
William Cannon
[1.1.1.4.5.1]
b. 18 Nov 1749 d. 18 Sep 1819
Sarah Mosby
b. 17 Feb 1751 d. Bef 1798
7
Elizabeth Mosby Cannon
[1.1.1.4.5.1.1]
b. 16 May 1771
7
Martha Cannon
[1.1.1.4.5.1.2]
b. 1775 d. Oct 1817
Silas F. Flournoy
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
8
Eliza Susan Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.1]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
9
Martha Harris
[1.1.1.4.5.1.2.1.1]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
9
Alfred H. Harris
[1.1.1.4.5.1.2.1.2]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
9
Eliza Susan Harris
[1.1.1.4.5.1.2.1.3]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
8
Alfred Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
9
Alonzo Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.1]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
10
Belle Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.1.1]
10
Theodosia Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.1.2]
10
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.1.3]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
11
Genevieve McRady
[1.1.1.4.5.1.2.2.1.3.1]
10
James Patteson Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.1.4]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
9
William Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.2]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
10
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.2.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
10
William Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.2.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
10
Alfred Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.2.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
10
Lucien Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.2.4]
b. 22 Feb 1861
9
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.3]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
10
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.1]
10
Alice Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.2]
+
Charles Davis
10
Ruth Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.3]
+
B. H. Davis
10
Pattie Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.4]
Milton Walker Sims
11
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.4.1]
b. 1872
+
Charles Mills
11
Laura Sims
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.4.2]
b. 1873
+
J. Fred Smith
b. Abt 1870
11
Milton Sims
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.4.3]
b. 1876
11
Bartlett Sims
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.4.4]
b. May 1878
+
Almaide Priscilla Kerr
10
Laura Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.5]
Thomas Bell
11
Mary Bell
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.5.1]
+
Edward Gleason
10
Mary Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.6]
+
Napoleon Davis
10
Alfred F. Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.2.3.7]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
9
Martha Moore Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.4]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
9
Eliza Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.5]
b. 29 May 1829 d. INFANT
9
James Silas Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.6]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
9
Alfred F. Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.7]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
10
Mary Patteson Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.7.1]
b. 24 Apr 1866
10
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.7.2]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
10
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.7.3]
b. 21 Feb 1875
10
Spencer Alston Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.7.4]
b. Aug 1879
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
9
Maria Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.8]
b. 1837 d. 1841
9
David Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.9]
b. 1842 d. 1856
9
Charles Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.10]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
9
Mary Camp Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
9
Indiana Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.12]
b. 1847
9
Martha Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.2.13]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
8
William Cannon Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
9
Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.1]
b. 1829 d. 1829
9
Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.2]
b. 1833 d. 1833
9
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.3]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
10
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.3.1]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
10
III William Cannon Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.3.2]
b. 8 Apr 1872
10
John Walker Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.3.3]
b. 24 Jan 1874
10
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.3.4]
b. 13 Sep 1875
10
Ezell Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.3.5]
b. 9 Dec 1878
9
John J. Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.4]
b. 1838
9
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.3.5]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
10
Flournoy Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.3.5.1]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
11
John Avirett Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.3.5.1.1]
b. 22 Mar 1894
10
John Harper Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.3.5.2]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
10
Tyree Rodes Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.3.5.3]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
10
William Cannon Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.3.5.4]
b. 11 Jan 1866
10
Julian Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.3.5.5]
b. 23 Dec 1868
10
Myra Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.3.5.6]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
8
Martha C. Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.4]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
9
Silas Flournoy Trotter
[1.1.1.4.5.1.2.4.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
8
Louisa Ann Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.5]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
9
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
10
Robert Lee Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.1]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
10
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
11
Anita H. Juch
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
12
Vivian L. Heacock
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.1.1]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
12
Caroll Jane Heacock
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.1.2]
12
Edwin Arthur Heacock
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.1.3]
[
=>
]
11
Chester Arthur Juch
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
11
Flournoy Albert Juch
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
11
Stanley St. Clair Juch
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.4]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
12
Stanley Robert Juch
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.4.1]
[
=>
]
12
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.4.2]
[
=>
]
Eleanor M Juch
12
Hollis Eleanor Juch
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.4.3]
[
=>
]
11
Louis Dewey Juch
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.2.5]
10
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.3]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
10
Adella Frances Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.4]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
11
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.4.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
12
Jerome Anthony Goodall
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.4.1.1]
[
=>
]
12
John Patrick Goodall
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.4.1.2]
[
=>
]
12
Francis Joseph Goodall
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.4.1.3]
+
Frank G Curran
10
Mary Anna "Mayme" Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.5]
b. 8 Dec 1874 d. 18 Sep 1968
Maclovio Danislao De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
11
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.5.1]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
11
Orman Joe De Arnaz
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.5.2]
+
Alma Viola
10
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.6]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
10
Edna Emma Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
11
Helen May Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.1]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
11
Edna Dorothy Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.2]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
11
Anita Ruth Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.3]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
11
Norman Francis Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.4]
Margaret (Peggy) Louise Clark
12
Nancy Nell Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.4.1]
[
=>
]
12
Joseph Edward Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.4.2]
[
=>
]
12
Norma Louise Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.4.3]
[
=>
]
12
Michael Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.4.4]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
11
Kathryn Alberta Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.5]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
12
Patricia Lee McCune
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.5.1]
12
Barbara Ruth McCune
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.5.2]
[
=>
]
12
Michael Allen McCune
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.5.3]
11
Howard Joseph Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.6]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
12
Anthony Howard Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.6.1]
12
Stephnie Jeane Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.6.2]
12
Nicholas Joseph Otero
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.7.6.3]
+
Edna Mae Thompson
10
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
11
Alberta Isabel Houle
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.1]
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
Jeptha Milton Gibbs, III
b. 17 Jan 1901 d. 9 Nov 1973
12
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.1.1]
[
=>
]
12
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.1.2]
[
=>
]
12
Edward Thurston Gibbs
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.1.3]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
12
William Houle Gibbs
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.1.4]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
12
Jane Gibbs
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.1.5]
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
b. 24 Feb 1900 d. Feb 1973
11
Dorothy Louise Houle
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.2]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
12
Constance L Scully
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.2.1]
12
John Dennis Scully
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.2.2]
12
Brian C. Scully
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.2.3]
11
Anna Josephine Houle
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.3]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
12
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.3.1]
[
=>
]
11
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.4]
Eugenia Joyce Barker
12
Winifred Catherine Houle
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.4.1]
[
=>
]
12
Jennifer Alberta Houle
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.4.2]
[
=>
]
12
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.1.4.5.1.2.5.1.8.4.3]
[
=>
]
9
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.2]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
9
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.4.5.1.2.5.3]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
10
Louisa Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.3.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
11
Rosalie E. McQuade
[1.1.1.4.5.1.2.5.3.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
10
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.3.2]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
10
Edna L. Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.3.3]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
10
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.3.4]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
10
Nellie M Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.3.5]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
10
William P. Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.3.6]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
9
Laura Ann Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.4]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
10
Laura Ann Black
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.1]
10
Louisa Catherine Black
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
11
Leroy Black Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.1]
b. 1864 d. 1934
11
Mary Lou Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.2]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
12
Sadie Louise Gilbert
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.2.1]
[
=>
]
12
Robert Lester Gilbert
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.2.2]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953 [
=>
]
12
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.2.3]
12
Leon Gilbert
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.2.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
11
Laura Jane Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.3]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
12
Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.3.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown [
=>
]
12
Louise Dickey
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.3.2]
b. Jan 1899 [
=>
]
11
Emily Olivia Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.4]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
12
Thomas Leroy Tatum
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.4.1]
12
Myra Tatum
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.4.2]
[
=>
]
11
Levair Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.5]
b. Abt 1869
11
John A. Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.6]
b. 1873 d. 1874/1963
11
Ernest M. Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.7]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
11
Frank Leon Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.8]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
12
Richard Leon Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.8.1]
[
=>
]
11
James Carley Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.9]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
12
William Lambeth Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.9.1]
[
=>
]
12
James Lester
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.2.9.2]
10
Leroy M. Black
[1.1.1.4.5.1.2.5.4.3]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
9
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.5]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
9
Mary Julia Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.6]
b. 1834
+
William D. Roberts
9
Flournoy Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.7]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
10
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.1]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
11
Thomas Asbury Dawes
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.1.1]
b. 4 Apr 1895
11
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.1.2]
b. 29 Jan 1897 d. 24 Nov 1973
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
Willie Crook
b. Abt 1901
12
Fergene Dawes Richmond
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.1.2.1]
11
Alice LaFavia Dawes
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.1.3]
+
Glen Carl Moody
11
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.1.4]
b. 20 Mar 1902 d. 19 Apr 1974
Mary Ona Kitchens
12
Frank Leslie Dawes
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.1.4.1]
12
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.1.4.2]
[
=>
]
10
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.2]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
11
Martha Lafavre Bishop
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.2.1]
11
Richard Yancey Bishop
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.2.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
10
Cora Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
10
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.7.4]
b. Jul 1882
9
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.8]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
10
Lucy M. Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
11
George L Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.1.1]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
11
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.1.2]
b. 1886
11
Rosa Mai Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.1.3]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
11
Wilber Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.1.4]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
12
Mabel Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.1.4.1]
11
Thomas Webber Wilson
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.1.5]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
10
Webber Yancey
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
10
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.4.5.1.2.5.8.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
8
Mary Amanda Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.6]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
9
James Alexander Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.1]
b. 30 May 1823
9
Mary Eliza Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.2]
b. 1 Jul 1825
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
10
Maud Officer
[1.1.1.4.5.1.2.6.2.1]
b. 9 May 1847
10
Eustis Field Officer
[1.1.1.4.5.1.2.6.2.2]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
10
William P. Officer
[1.1.1.4.5.1.2.6.2.3]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
10
Myra Flournoy Knapp
[1.1.1.4.5.1.2.6.2.4]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
9
Jr. William Hume Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
9
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.4]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
9
Silas Flournoy Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
9
Henrietta Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.6]
b. 1833 d. 1833
9
Margaret Julia Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.7]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
9
Julian Clarence Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.8]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
9
Florence Huntley Field
[1.1.1.4.5.1.2.6.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
8
Madison Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.7]
b. 1807
8
Julia Ann Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.8]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
9
Eliza Mildred Feild
[1.1.1.4.5.1.2.8.1]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
10
Julia Batte
[1.1.1.4.5.1.2.8.1.1]
+
W. R. Garrett
10
Mildred Batte
[1.1.1.4.5.1.2.8.1.2]
10
E. F. Batte
[1.1.1.4.5.1.2.8.1.3]
9
Hume Rigg Feild
[1.1.1.4.5.1.2.8.2]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
8
Silas Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
9
III Silas Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.1]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
10
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.1.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
10
Silas Camp Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.1.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
9
Lucien Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.2]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
10
Caroline Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.2.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
9
Mary Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.3]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
10
James P. Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.9.3.1]
b. Bef 1863
10
Elizabeth Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.9.3.2]
b. Bef 1865
10
Mary Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.9.3.3]
b. Bef 1867
10
William W. Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.9.3.4]
b. Bef 1869
10
Silas Flournoy Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.9.3.5]
b. Bef 1871
10
Martha Rivers
[1.1.1.4.5.1.2.9.3.6]
b. Bef 1873
9
Camp Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
10
Lucien Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
11
Lillian May Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.1.1]
b. 1906
11
Mary Wise Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.1.2]
b. 1911
11
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.1.3]
b. 1914
11
Laura Louise Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.1.4]
11
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.1.5]
10
John Wise Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
11
Louise Wise Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.2.1]
b. 1907
11
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.2.2]
b. 1912
Minnie Childress Cole
12
Thomas Cole Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.2.2.1]
11
Camp Rogers Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.2.3]
11
Betty McAfee Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.2.4]
10
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
11
Eloise Walker
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
+
Raymond Grady Thomas
11
Newton Flournoy Walker
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
+
Rose Mary Bozeman
+
Valta Irene Gholston
11
Lucien John Walker
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972
Janie Lucile Stallcup
b. 1912
12
Lou Anne Walker
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.3.3.1]
[
=>
]
11
Jane Louise Walker
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.3.4]
+
Benjamin Elliot Mosher
11
Jacob Camp Walker
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.3.5]
+
Ouida Louise Gill
10
Augusta Mary Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
11
Georgia Louia May
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.4.1]
b. 1899
11
Elizabeth Wise May
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.4.2]
b. 1902
11
James Kathryn May
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.4.3]
b. 1902
11
Norma Lucile May
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.4.4]
b. 1902
11
Julia Flournoy May
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.4.5]
Robert Henry Mays
12
Judy Mays
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.4.5.1]
12
Robert Mays
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.4.5.2]
d. INFANT
10
Julia Rivers Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
11
Andrew Booty Jordan
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.5.1]
Mattie Lou Shaw
12
Jr. Andrew Booty Jordan
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.5.1.1]
[
=>
]
12
Lou Ann Jordan
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.5.1.2]
[
=>
]
12
John Franklin Jordan
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.5.1.3]
[
=>
]
12
Gwen Elizabeth Jordan
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.5.1.4]
11
Lucien Wise Jordan
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.5.2]
b. 1914
10
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
11
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.6.1]
11
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.6.2]
11
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.4.6.3]
9
Elizabeth Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.9.5]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
10
Maude Eustace Duncan
[1.1.1.4.5.1.2.9.5.1]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
10
Duncan
[1.1.1.4.5.1.2.9.5.2]
b. Bef 1870 d. 1876
8
Sarah Flournoy
[1.1.1.4.5.1.2.10]
b. 1816
7
Mary Cannon
[1.1.1.4.5.1.3]
b. Abt 1776
Elizabeth Chastain Cocke
b. 22 Jan 1753 d. Bef 1807
7
John James Cannon
[1.1.1.4.5.1.4]
b. 5 Sep 1794 d. 4 Jan 1850
7
William Cannon, Jr.
[1.1.1.4.5.1.5]
b. 1796 d. Feb 1838
5
Tucker Woodson
[1.1.1.4.6]
b. Abt 1720 d. 21 Sep 1795
+
Sarah Hughes
b. 1703/1729 d. 1755/1817
Mary Netherland
b. 1721/1750 d. 12 Dec 1775
6
Wade Netherland Woodson
[1.1.1.4.6.1]
b. 16 Jan 1763 d. 8 Apr 1847
Mary Harris
d. 22 May 1812
7
Benjamin Jordan Woodson
[1.1.1.4.6.1.1]
b. 2 Nov 1808 d. 28 May 1892
+
Rebecca Thomas Redd
b. 1808
7
Silas Wade Woodson
[1.1.1.4.6.1.2]
b. 18 May 1819 d. 9 Oct 1896
+
Olivia Adams
Mary Jane McRoberts
b. 16 Oct 1825 d. 22 Mar 1845
8
Miller Woodson
[1.1.1.4.6.1.2.1]
b. 16 May 1844 d. Jun 1865
Virginia Juliet "Jennie" Lard
b. 23 May 1846 d. 25 Jan 1907
8
Mary Alice Woodson
[1.1.1.4.6.1.2.2]
b. 14 Sep 1870 d. 8 May 1956
8
Virginia Lard Woodson
[1.1.1.4.6.1.2.3]
b. 18 Jun 1875 d. 7 Sep 1943
Emile Thomas
9
Emile Woodson Thomas
[1.1.1.4.6.1.2.3.1]
8
Silas Salmon Woodson
[1.1.1.4.6.1.2.4]
b. 18 Jun 1875 d. 28 Dec 1891
John Pleasants
b. Bef 27 Feb 1644/45 d. 12 May 1698
3
Joseph Pleasants
[1.1.2]
b. 1685/1712 d. 1714
Martha Cocke
4
John Cocke Pleasants
[1.1.2.1]
b. Abt 1710 d. 29 Dec 1776
Susanna Woodson
5
Ursula Pleasants
[1.1.2.1.1]
b. Abt 1737
+
George Ellis
+
John Brooke
5
Susannah Randolph Pleasants
[1.1.2.1.2]
b. Abt 1739
Gervas Storrs
6
Mary Virginia Storrs
[1.1.2.1.2.1]
Jr. Wade Mosby
b. 30 May 1793 d. 1869
7
Elizabeth Mosby
[1.1.2.1.2.1.1]
6
Louisa Pleasants Storrs
[1.1.2.1.2.2]
b. 1789 d. 1864
Littleberry Hardeman Mosby
b. 7 Sep 1789 d. 6 May 1847
7
Caroline Pleasants Mosby
[1.1.2.1.2.2.1]
b. 5 Sep 1816 d. 5 Sep 1876
7
Gervas Storrs Mosby
[1.1.2.1.2.2.2]
b. 1818 d. Aug 1867
Eliza Glover Burks
b. 9 Jan 1830 d. 18 Sep 1862
8
John Burks Mosby
[1.1.2.1.2.2.2.1]
b. 5 Nov 1853 d. 10 Dec 1876
8
Jr. Gervas Storrs Mosby
[1.1.2.1.2.2.2.2]
b. 19 Aug 1855 d. 1856/1945
8
II Littleberry Hardeman Mosby
[1.1.2.1.2.2.2.3]
b. 12 Mar 1857 d. 11 Jul 1878
8
Caroline P. Mosby
[1.1.2.1.2.2.2.4]
b. 20 Aug 1858 d. 6 Apr 1890
John Malcom Montgomery
b. 7 Nov 1841 d. 19 Mar 1910
9
Fannie Cameron Montgomery
[1.1.2.1.2.2.2.4.1]
b. 26 May 1878 d. 22 Feb 1950
+
Beckwith Benjamin Payne
b. 1853/1880 d. 1904/1967
9
Eliza Burks Montgomery
[1.1.2.1.2.2.2.4.2]
b. 18 Jan 1880 d. 4 Sep 1880
9
Caroline Mosby Montgomery
[1.1.2.1.2.2.2.4.3]
b. 23 Sep 1884 d. 22 Jan 1957
Jefferson Pinckney Wilkerson
b. 11 Nov 1878 d. 10 Aug 1945
10
Josephine Adams Wilkerson
[1.1.2.1.2.2.2.4.3.1]
b. Yes, date unknown
+
Marshall Lewis Spiars
b. Yes, date unknown
10
Jefferson Pinkney Wilkerson
[1.1.2.1.2.2.2.4.3.2]
b. Yes, date unknown
+
Ida Judson Harrold
b. Yes, date unknown
10
Caroline Mosby Wilkerson
[1.1.2.1.2.2.2.4.3.3]
b. Yes, date unknown
+
Bascom Bradley Hamilton
b. Yes, date unknown
10
Frances Montgomery Wilkerson
[1.1.2.1.2.2.2.4.3.4]
b. Yes, date unknown
+
Benjamin T. Ellis
b. Yes, date unknown
8
Eliza Burks Mosby
[1.1.2.1.2.2.2.5]
b. 25 Feb 1860 d. 25 Feb 1868
8
Mosby
[1.1.2.1.2.2.2.6]
b. 15 Sep 1862 d. 15 Sep 1862
7
Susan Mosby
[1.1.2.1.2.2.3]
b. Abt 1820
7
Pauline Pleasants Mosby
[1.1.2.1.2.2.4]
b. 1820 d. 1910
7
Linnaeus Speed Mosby
[1.1.2.1.2.2.5]
b. Abt 1822 d. 1854
7
John Sydnor Mosby
[1.1.2.1.2.2.6]
b. Abt 1824 d. 1863
7
Richard Montgomery Mosby
[1.1.2.1.2.2.7]
b. Abt 1826
7
Virginius Mosby
[1.1.2.1.2.2.8]
b. Abt 1828 d. 1860
7
James Wade Mosby
[1.1.2.1.2.2.9]
b. Abt 1830 d. 1864
+
Joshua Storrs
5
Matthew Pleasants
[1.1.2.1.3]
b. Abt 1741
+
Anne Railey
b. 16 Sep 1759 d. Abt 1826
5
James Pleasants
[1.1.2.1.4]
b. Abt 1745
Anne Randolph
b. 1732
6
Jr. James Pleasants
[1.1.2.1.4.1]
b. 1769 d. 1836
Susanna Rose
7
John Hampden Pleasants
[1.1.2.1.4.1.1]
+
Ann Eliza Irving
+
Mary Massie
6
Tarleton Woodson Pleasants
[1.1.2.1.4.2]
b. Abt 1771
+
Sarah Pleasants
Talitha Crew
b. 10 Feb 1788
7
Edward S. Pleasants
[1.1.2.1.4.2.1]
b. 15 Dec 1817
Tace Elizabeth Bates
b. 20 Sep 1826
8
Charlotte Harris Pleasants
[1.1.2.1.4.2.1.1]
b. 15 Nov 1847
8
Edward Bates Pleasants
[1.1.2.1.4.2.1.2]
b. 2 Aug 1850
8
Walter Henry Pleasants
[1.1.2.1.4.2.1.3]
b. 4 Feb 1852
8
Sadie Elizabeth Pleasants
[1.1.2.1.4.2.1.4]
b. 24 Jan 1854
5
Joseph Pleasants
[1.1.2.1.5]
b. Abt 1745 d. 1785
Elizabeth Jordan
6
Joseph Carlin Pleasants
[1.1.2.1.5.1]
b. Abt 1769
+
Susanna Burton
6
Dorothy Pleasants
[1.1.2.1.5.2]
b. Abt 1770
+
Albert Smith
d. Bef Dec 1789
+
John Burch
6
Mahala Pleasants
[1.1.2.1.5.3]
b. Abt 1771
6
Clementina Pleasants
[1.1.2.1.5.4]
b. Abt 1773
+
Thomas Martin Burton
6
Sophia Pleasants
[1.1.2.1.5.5]
b. Abt 1775
+
Thomas Woodfin
6
Jordan Pleasants
[1.1.2.1.5.6]
b. Abt 1781 d. Abt 1837
+
Elizabeth Tyler
b. 1785
5
Archibald Pleasants
[1.1.2.1.6]
b. 11 Jan 1745/46 d. 25 Jul 1836
Jane Randolph Woodson
b. Abt 1752
6
John Woodson Pleasants
[1.1.2.1.6.1]
b. 23 Nov 1778 d. 31 Mar 1836
Elizabeth W. Seleman
b. 4 May 1784 d. 5 Dec 1862
7
Emmeline Pleasants
[1.1.2.1.6.1.1]
b. 16 Sep 1810 d. 25 Mar 1875
Alexander Mebane
b. 1 Sep 1806 d. 1 Jul 1846
8
Charles Pleasants Mebane
[1.1.2.1.6.1.1.1]
b. 12 Jun 1835 d. 8 Aug 1898
Elizabeth Amie Mebane
b. 21 Jun 1839 d. 15 Jul 1866
9
Mary F. Mebane
[1.1.2.1.6.1.1.1.1]
b. 1862
+
Bartlett Yancey Womack
b. 12 Oct 1856 d. 24 Mar 1897
5
Tarleton Pleasants
[1.1.2.1.7]
b. Abt 1747
+
Margaret Pleasants
5
John Pleasants
[1.1.2.1.8]
b. Abt 1749
+
Agnes Woodson
+
Sarah Cox
Elizabeth Woodson
b. Abt 1708 d. 1737/1802
4
Jesse Pleasants
[1.1.2.2]
b. Abt 1733 d. 1804
Elizabeth Smith
b. 1745 d. 1810
5
John Smith Pleasants
[1.1.2.2.1]
b. 1785 d. 1856
+
Nancy Thweatt