News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
William Claiborne
1600 - 1676 (75 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
William Claiborne
[1]
b. 10 Aug 1600 d. 1676
Elizabeth Butler
b. 1609 d. Aft 1 Mar 1687/88
2
Mary Claiborne
[1.1]
b. 1643 d. 9 Feb 1709/10
Robert Harris
b. Abt 1635 d. 1701
3
William Harris
[1.1.1]
b. 1672 d. 1720
Temperance Overton
b. 2 Mar 1678 d. 19 Feb 1715
4
Jemima Harris
[1.1.1.1]
b. 1709 d. 1764
William Overton
b. 1706 d. Abt 1764
5
John Overton
[1.1.1.1.1]
b. 20 Jan 1755 d. 23 Apr 1822
+
Susanna Garland
+
Anne Bacon
d. 11 Apr 1842
5
Nancy Anne Overton
[1.1.1.1.2]
+
John Winston
5
Sally Overton
[1.1.1.1.3]
+
Jr. John Syme
b. 1752 d. 1793
5
Elizabeth Overton
[1.1.1.1.4]
+
Samuel Overton
5
William Overton
[1.1.1.1.5]
5
James Overton
[1.1.1.1.6]
d. Feb 1782
+
Mildred
5
Mary Overton
[1.1.1.1.7]
+
Richard Morris
d. 1821
4
Benjamin Harris
[1.1.1.2]
b. 1705
4
James Harris
[1.1.1.3]
b. 1708
4
William Harris
[1.1.1.4]
b. 1703 d. 6 Dec 1792
Ann Elizabeth Burnett
5
William Harris
[1.1.1.4.1]
b. 1724 d. Dec 1792
Henrietta Baker
b. Abt 1722
6
Mary Harris
[1.1.1.4.1.1]
b. 10 Feb 1728/29 d. 1819
+
Augustine Davenport
b. 1728 d. 1819
6
Jesse Harris
[1.1.1.4.1.2]
b. 1754 d. 1833
Frances Ward
b. 1757
7
William H. Harris
[1.1.1.4.1.2.1]
b. 4 Sep 1804 d. 20 Dec 1875
Evelina Ranchor Finch
b. 1 Feb 1809
8
Hammet J. Harris
[1.1.1.4.1.2.1.1]
b. 1826
8
Thomas Dow Harris
[1.1.1.4.1.2.1.2]
b. 8 Sep 1827
8
William Otho Harris
[1.1.1.4.1.2.1.3]
b. 20 Sep 1828
8
Molinda Harris
[1.1.1.4.1.2.1.4]
b. Abt 1832
8
Jane Harris
[1.1.1.4.1.2.1.5]
8
Samuel R. Harris
[1.1.1.4.1.2.1.6]
8
Jesse F. Harris
[1.1.1.4.1.2.1.7]
8
James Edward Harris
[1.1.1.4.1.2.1.8]
8
Calvin G. Harris
[1.1.1.4.1.2.1.9]
7
George Washington Harris
[1.1.1.4.1.2.2]
b. 4 Feb 1793 d. 16 Mar 1843
Margaret Gaddis
b. Abt 1793 d. 11 Sep 1861
8
Duncan R. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1]
b. 1831 d. 1905
Clementine Abigail Summy
b. 28 Jul 1837 d. 1921
9
Samuel Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.1]
b. Abt 1876
9
Juliett Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.2]
b. Abt 1863
9
Margaret Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.3]
b. Abt 1865
9
David Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.4]
b. Abt 1868 d. 1870
9
Effie May Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.5]
b. Abt 1877
9
Charles M. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.6]
b. 1869 d. 1947
Ollie Briggs
b. 1875 d. 1902
10
Emmet Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.6.1]
b. 1902 d. 1928
10
Glen Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.6.2]
b. 1898 d. 1899
10
Russell Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.6.3]
9
Mary E. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.7]
b. Abt Nov 1859 d. 1870
9
George Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.8]
b. Abt 1861
9
Ella May Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.9]
b. Abt 1872
9
O. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.10]
b. Abt 1874
Nancy Taylor
b. Abt 1833 d. Between 1855 and 1858
9
John W. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.11]
b. Abt 1849 d. 1852
9
William N. Harriss
[1.1.1.4.1.2.2.1.12]
b. Abt 1855
Lizzie
b. Abt 1856
10
Eva Harriss
[1.1.1.4.1.2.2.1.12.1]
b. Abt 1879
9
Frances E. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.1.13]
b. Abt 1852
8
Woodson Alexander Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2]
b. 23 Dec 1814 d. 27 Apr 1890
Polly Briggs
b. Abt 1812 d. 24 Dec 1865
9
Richard Briggs Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1]
b. 4 Jan 1847 d. 6 Feb 1942
Sarrah Ann Hedrick
b. 18 Jan 1848 d. 30 Nov 1929
10
Nellie Viola Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.1]
b. 18 Jan 1872 d. 20 Jul 1899
Louis L. "Jack" Fry
b. 12 Sep 1870 d. 6 Mar 1952
11
Homer Lee Fry
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.1.1]
b. 18 Jan 1894 d. 21 Dec 1965
11
Curtis Lezell Fry
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.1.2]
b. Feb 1896 d. 6 Aug 1923
11
Thelma Fry
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.1.3]
b. 9 Jul 1898 d. 15 Aug 1899
11
Leila Maude Fry
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.1.4]
b. 17 Oct 1892 d. 17 Apr 1893
10
Amanda Mae Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.2]
b. 1878 d. 1904
+
Charles E. Farris
b. Between 1856 and 1883 d. Between 1908 and 1969
10
Lorand Lee Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3]
b. 10 Mar 1869 d. 7 Jul 1943
Bettie Mae Gough
b. 23 May 1874 d. 13 Feb 1959
11
James Clyde Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.1]
Carrie Estelle Phillips
12
Clydene Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.1.1]
11
Juanita Jewell Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.2]
b. 22 Mar 1910 d. 17 Feb 1934
Charles Robertson Salmons
12
Bettye Margaret Salmons
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.2.1]
[
=>
]
11
Wynona Ruth Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.3]
John Henderson Boyd
12
James Edgar Boyd
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.3.1]
12
Johnnie Ruth Boyd
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.3.2]
11
Lorenia Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.4]
b. 19 Jan 1904 d. 22 Apr 1904
11
Lora Gough Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.5]
b. 27 Oct 1912 d. 28 Oct 1958
11
Leonard Lee Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.6]
b. 16 Feb 1896 d. 1941
11
Nellie Viola Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.7]
+
Guy Raymond Mercer
11
Prudence Florence Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.3.8]
+
George Charlie Huffstuttler
b. 16 Mar 1910 d. 26 May 1951
10
Sarah Ann Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4]
b. 6 Dec 1875 d. 1 Dec 1943
John Virgil McReynolds
b. 1870 d. 21 May 1936
11
Lloyd Leon McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.1]
Fleta Della Gallegher
12
Ernest Leon McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.1.1]
12
Geraldine McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.1.2]
11
Orton Bush McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.2]
Gladys Hardy
12
Jr. Orton Bush McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.2.1]
+
Elizabeth Ann Thackle
11
Ethel Bernice McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.3]
b. 27 Aug 1901 d. 1901
11
Lillian Mae McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.4]
+
Walter Bennett
11
Harris Weldon McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.5]
Lula Nell Showman
12
Barbara Ann McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.5.1]
b. 8 Apr 1936
12
John Virgil II McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.5.2]
b. 2 Nov 1939 d. Dec 1939
12
LaVerne Mae McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.5.3]
11
Sarah Elizabeth McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.6]
b. 23 Feb 1910 d. 1910
11
Anna LaVerne McReynolds
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.7]
William Bascom Guffin
12
Sandra Ann Guffin
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.7.1]
12
Paul Bascom Guffin
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.7.2]
12
Marilyn Ruth Guffin
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.7.3]
12
Robert Wayne Guffin
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.4.7.4]
10
Dixie Alice Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.5]
b. 27 Sep 1881 d. 3 Nov 1963
John Merrell Smith
b. 14 Oct 1871 d. 10 Dec 1940
11
Vera Lee Smith
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.5.1]
John Remonte
12
Robert Lee Remonte
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.5.1.1]
[
=>
]
10
Granville Eugene Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.6]
b. 10 Oct 1866 d. 18 Aug 1949
Deirdre Margaret Kallaher
b. 9 Jul 1879 d. 9 Aug 1962
11
Leon Granville Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.6.1]
Margaret Elizabeth Wootton
12
Margaret Elizabeth Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.6.1.1]
[
=>
]
12
Judith Loretta Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.6.1.2]
[
=>
]
11
Richard William Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.6.2]
b. 20 Jan 1901
Virginia Ann Stage
b. 28 Jan 1903
12
Virgina Ann Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.6.2.1]
11
Gordon W. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.6.3]
+
Mable Johnson Isat
+
Leona
10
Woodson Alexander Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.7]
b. 15 Sep 1884 d. 7 Mar 1969
Mary Michener Williams
b. 10 Aug 1890 d. 25 Mar 1972
11
Mary Maud Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.7.1]
b. 27 Aug 1920 d. 23 Aug 1924
11
Richard Alexander Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.7.2]
Cornelia Catherine Cardwell
12
Robert Woodson Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.7.2.1]
[
=>
]
12
Jr. Richard Alexander Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.7.2.2]
[
=>
]
+
Thelda Cauble Dunlop
11
Woodson Herbert Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.7.3]
Charlotte Louise Burke
12
Mary Louise Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.7.3.1]
11
Corporal, U.S. Army Ida Ann Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.7.4]
10
Frederick Raymond Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.8]
b. 17 Aug 1889 d. 9 May 1965
Mellitona Villerreal
11
Shirley Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.8.1]
+
William Thomas Croisant
11
Beverly Ann Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.1.8.2]
+
Jr. Richard Samuel Dowell
9
Margaret Jane Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.2]
b. Jan 1838 d. 8 Oct 1910
+
William Martin
+
T. G. Mattison
William Barkley
10
Isabella Barkley
[1.1.1.4.1.2.2.2.2.1]
b. 13 Nov 1855 d. 15 Oct 1871
+
John G. Wilkins
9
Prudence Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.3]
b. 6 Aug 1840 d. 8 Apr 1918
Alexander M. Bush
b. 26 Dec 1839 d. 13 Feb 1911
10
Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.1]
b. Abt 1862
10
Alice Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.2]
b. 28 May 1863 d. 1865
10
James Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.3]
b. 19 Jan 1864 d. 1881
10
William Harvey Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.4]
b. Abt 1858
Sarah
b. 1865 d. 1948
11
James Newton Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.4.1]
b. 5 Oct 1881 d. 1898
11
Jr. William Harvey Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.4.2]
b. 1898
Sally
12
Ivy Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.4.2.1]
12
Alvin Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.4.2.2]
12
Fred Bush
[1.1.1.4.1.2.2.2.3.4.2.3]
9
Paulina Harriss
[1.1.1.4.1.2.2.2.4]
b. 13 May 1845 d. 1865
9
Disa Ellen Harriss
[1.1.1.4.1.2.2.2.5]
b. Abt 1849 d. 22 May 1865
9
Phebe Angelina Harris
[1.1.1.4.1.2.2.2.6]
b. 4 Sep 1852 d. 22 Feb 1931
William Hamilton Kindred
b. 4 Apr 1846 d. 2 Jan 1922
10
Oscar Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.1]
b. Abt 1871
10
Lee R. Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.2]
b. Abt 1871
10
Charles Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.3]
b. Abt 1873
10
George Washington Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4]
b. 9 Apr 1878 d. 4 Nov 1960
Alice Arvella Ballard
11
Amy Ruby Faye Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.1]
Bert Henry Robison
12
Clarence Robison
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.1.1]
12
Clarice Willie Robison
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.1.2]
12
Virgil Robison
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.1.3]
12
Margaret Robison
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.1.4]
12
Christine Robison
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.1.5]
12
Lynne Robison
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.1.6]
12
Faye Robison
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.1.7]
11
Burley Theodore Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.2]
Emma Frances Stone
12
Roy Dale Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.2.1]
12
Gene Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.2.2]
12
Kristi Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.2.3]
11
Beatrice Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.3]
Dillard Hardin
12
R. V. Hardin
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.3.1]
11
Reuben William "Bill" Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.4]
+
Jimmie Potter
11
Arthur Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.5]
Jolene Shatswell
12
Sandra Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.5.1]
12
Charolette Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.5.2]
12
Michael Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.5.3]
11
Cecil Arch Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.6]
Karen Sue Jones
12
Steven Greg Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.6.1]
12
Angela Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.6.2]
11
Cletus Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.7]
Sarah Lou Summers
12
James Donald Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.7.1]
12
Debbie Lynne Kindred
[1.1.1.4.1.2.2.2.6.4.7.2]
+
Mary Meason
b. Abt 1830
8
Frederick Nash Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3]
b. 25 Aug 1824 d. 1913
Margaret Hedrick
b. 1823 d. 1899
9
Ransom Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.1]
b. 1845 d. 1926
Emma Rigor
b. 1849 d. 1928
10
Owen A. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.1.1]
b. 1875 d. 1875
10
Granvill Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.1.2]
b. Abt 1871
10
Leora B. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.1.3]
b. Abt 1873
10
William Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.1.4]
b. Abt 1876
9
Elizabeth Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.2]
b. Abt 1847
9
Sarah Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.3]
b. Abt Jun 1850
+
August D. McNeill
b. 1849 d. 1879
9
F. Melvina Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.4]
b. Abt 1854
9
Benjamin Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.5]
b. Abt 1855
9
Hulda Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.6]
b. 8 Mar 1858 d. 21 May 1932
+
Robert Kerley
b. 23 Apr 1856 d. 28 Dec 1931
9
Emsley Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.7]
b. Abt Jun 1860
9
Dorah Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.8]
b. 1863 d. 1889
9
William Oscar Harris
[1.1.1.4.1.2.2.3.9]
b. Abt 1865
8
Margaret M. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.4]
b. Abt 1829
+
William Maltby
8
Jr. George Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5]
b. 12 Oct 1835 d. 5 Jul 1907
Emeline Mixer
b. 1833 d. 1882
9
Linda Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.1]
b. 1867 d. 1939
Philip Briggs
b. 1868 d. 1902
10
Opal Briggs
[1.1.1.4.1.2.2.5.1.1]
b. 1895
Doran Lanier
b. 1893 d. 1923
11
Zelma Mae Lanier
[1.1.1.4.1.2.2.5.1.1.1]
b. 1921 d. 1940
10
Gracie Briggs
[1.1.1.4.1.2.2.5.1.2]
b. 1887 d. 1900
10
Briggs
[1.1.1.4.1.2.2.5.1.3]
b. 1902 d. 1902
10
Virgil Briggs
[1.1.1.4.1.2.2.5.1.4]
10
Claude Briggs
[1.1.1.4.1.2.2.5.1.5]
9
Angeline Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.2]
b. Abt 1856
+
Green
9
Emsley Duncan Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.3]
b. 1857 d. 1932
Amanda Brown
b. 1858 d. 1929
10
Ethel Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.3.1]
b. 1882 d. 1924
Nat Leeper
11
Wilma Grace Leeper
[1.1.1.4.1.2.2.5.3.1.1]
+
Echternkamp
11
Delbert Harris Leeper
[1.1.1.4.1.2.2.5.3.1.2]
11
Irene Leeper
[1.1.1.4.1.2.2.5.3.1.3]
+
Test
11
Clara Corinne Leeper
[1.1.1.4.1.2.2.5.3.1.4]
+
Roberts
+
Weeks
10
Pearl Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.3.2]
b. 1884
Benbridge Reich
b. 1883 d. 1948
11
Anne Reich
[1.1.1.4.1.2.2.5.3.2.1]
+
Burdick
9
Dudley Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.4]
b. Abt May 1860 d. 1861
9
Cicero Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.5]
b. 1870 d. 1945
Sada Dunn
b. 1875 d. 1902
10
Velma Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.5.1]
b. 1902 d. 1941
+
Bartello
10
George Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.5.2]
10
Harold Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.5.3]
10
Lloyd Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.5.4]
+
Clara Waters
b. 1869 d. 1949
9
Laura Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.6]
b. Abt 1874
+
Orr
9
Margaret U. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.7]
b. 1862 d. 1863
9
Rosa Harris
[1.1.1.4.1.2.2.5.8]
b. 1865 d. 1875
8
Nancy Harris
[1.1.1.4.1.2.2.6]
b. 1816 d. 1892
+
Henderson Rush
8
Ransom C. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.7]
b. 1826
+
Julia Finch
8
Jesse Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8]
b. Abt 1817
Elizabeth Workman
b. Abt 1810
9
Jesse Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8.1]
b. Abt 1839
Matilda Stinson
10
Mary Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8.1.1]
b. Abt 1862
10
Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8.1.2]
b. Abt 1864
9
Benjamin Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8.2]
b. Abt 1842
9
William N. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8.3]
b. Abt 1843
9
M. A. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8.4]
b. Abt 1849
9
S. M. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8.5]
b. Abt 1854
9
N. J. Harris
[1.1.1.4.1.2.2.8.6]
b. Abt 1856
8
Mary Harris
[1.1.1.4.1.2.2.9]
b. 1819
Benjamin May
b. 1819
9
Elizabeth May
[1.1.1.4.1.2.2.9.1]
b. Abt 1840
9
Elias May
[1.1.1.4.1.2.2.9.2]
b. Abt 1845
9
John May
[1.1.1.4.1.2.2.9.3]
b. Abt 1847
9
Margaret May
[1.1.1.4.1.2.2.9.4]
b. Abt 1849
8
Frances Harris
[1.1.1.4.1.2.2.10]
b. 28 Apr 1820 d. 13 Jun 1908
+
Robert Williams
8
Emsley Harris
[1.1.1.4.1.2.2.11]
b. 1822
+
Lucretia Nix
+
Minerva Jane Long
7
Ransom Harris
[1.1.1.4.1.2.3]
b. 19 Aug 1783 d. 3 Jul 1841
Elizabeth Wood
b. 15 Nov 1783
8
Mountford Harris
[1.1.1.4.1.2.3.1]
b. 25 Jul 1812
8
Jason C. Harris
[1.1.1.4.1.2.3.2]
b. 1815
8
John T. Harris
[1.1.1.4.1.2.3.3]
b. 1818
8
Ransom Wood Harris
[1.1.1.4.1.2.3.4]
b. Between 1820 and 1821
8
Elizabeth Ann Harris
[1.1.1.4.1.2.3.5]
b. 1823
8
Tapheny Harris
[1.1.1.4.1.2.3.6]
b. 16 Jun 1825
8
Martha P. Harris
[1.1.1.4.1.2.3.7]
b. 1806
8
Nancy Harris
[1.1.1.4.1.2.3.8]
b. 1808
8
Delinda Harris
[1.1.1.4.1.2.3.9]
b. 1810
8
Calvin Harris
[1.1.1.4.1.2.3.10]
7
Thomas Dubley Harris
[1.1.1.4.1.2.4]
b. 1 Feb 1796 d. 14 Dec 1882
+
Dolly Ann Roach
7
Louisa Harris
[1.1.1.4.1.2.5]
b. Abt 1780
+
Redwine
7
Turner Harris
[1.1.1.4.1.2.6]
b. 18 Feb 1799 d. 9 Mar 1876
Elizabeth Rush
b. 2 Oct 1811
8
Dolsey Ann Harris
[1.1.1.4.1.2.6.1]
b. 17 Oct 1827
8
Turner Mc. Harris
[1.1.1.4.1.2.6.2]
b. 1 Nov 1829
8
Thomas Jefferson Harris
[1.1.1.4.1.2.6.3]
b. 3 Jul 1832
8
Elizabeth R. Harris
[1.1.1.4.1.2.6.4]
b. 1834
8
Jesse M. Harris
[1.1.1.4.1.2.6.5]
b. Abt 1836
8
Harris
[1.1.1.4.1.2.6.6]
b. Abt 1838
8
Frances Eveline Harris
[1.1.1.4.1.2.6.7]
b. 1841
8
William Giles Harris
[1.1.1.4.1.2.6.8]
b. 18 Jul 1843
8
Sanuel Harwood Harris
[1.1.1.4.1.2.6.9]
b. 6 Aug 1846
8
Caroline Harris
[1.1.1.4.1.2.6.10]
b. 29 Jul 1848
8
Angeline Mariah Harris
[1.1.1.4.1.2.6.11]
b. 1855
7
Frances Harris
[1.1.1.4.1.2.7]
b. 1 Oct 1790 d. 10 Apr 1872
William Burkhead
b. 1 Apr 1785
8
Lorenzo Dow Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.1]
b. 28 Dec 1808
8
Marenda Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.2]
b. 20 Aug 1811
8
Jesse Harris Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.3]
b. 1 Nov 1814
8
Callista Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.4]
b. 17 Aug 1816
8
Peggy Wood Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.5]
b. 23 Dec 1818
8
William McKindrick Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.6]
b. 31 Jan 1822
8
Lingrum S. Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.7]
b. 17 May 1824
8
Frances W. Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.8]
b. 13 Jul 1826
8
Ann Burris Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.9]
b. 11 May 1829
8
Nancy R. Burkhead
[1.1.1.4.1.2.7.10]
b. 20 Mar 1832
7
Jesse S. Harris
[1.1.1.4.1.2.8]
b. Abt 1788
Sarah Lambeth
b. Abt 1790 d. 1845
8
Harris
[1.1.1.4.1.2.8.1]
b. Abt 1818
8
Thomas Dudley Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2]
b. Nov 1821 d. 1900
Margaret E. Smith
b. 27 Jan 1832 d. 22 Sep 1894
9
Kate Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.1]
b. 1873
+
J. H. Shofner
9
William Franklin Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.2]
b. 1851
9
Frances M. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.3]
b. 1856
9
Charles Vlandingham Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.4]
b. 18 Mar 1859 d. 20 May 1883
+
Nannie Stewart
9
Laura Larissa Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.5]
b. Oct 1860
+
William R. Smith
9
Mary Alice Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.6]
b. Oct 1862
9
Sarah M. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.7]
b. 1865
9
Harriet Annetta N. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.8]
b. 1867
9
George T. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.2.9]
b. 1869
8
Tabitha Harris
[1.1.1.4.1.2.8.3]
b. Abt 1824
Wiley B. Sandlin
b. Abt 1815 d. 1899
9
Robert Lee Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.1]
b. Jan 1863
Sarah
b. Mar 1868
10
D. Mary Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.1.1]
b. Jul 1896
10
A. July Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.1.2]
b. Feb 1900
10
L. Ella Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.1.3]
b. Nov 1888
10
C. Roy Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.1.4]
b. Feb 1890
10
Lerleen Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.1.5]
b. Jun 1895
9
Louisa E. Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.2]
b. Aug 1865
George C. Lacy
b. Feb 1851
10
Andy P. Lacy
[1.1.1.4.1.2.8.3.2.1]
b. Nov 1890
10
Ruth Lacy
[1.1.1.4.1.2.8.3.2.2]
b. Sep 1893
9
Sarah A. Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.3]
b. Abt 1843
+
Tom Elkhart
9
Thomas R. Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.4]
b. Abt 1845
9
Frances Emmajean Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.5]
b. Abt 1847
William Hart
10
Lewis W. Hart
[1.1.1.4.1.2.8.3.5.1]
b. Abt 1867
10
Sarah A. Hart
[1.1.1.4.1.2.8.3.5.2]
b. Abt 1870
9
James Gilbert Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6]
b. 1 Aug 1851 d. 10 May 1906
Dora C. Hayes
b. 2 Dec 1866 d. 29 Feb 1952
10
Martha Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6.1]
10
James Lee Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6.2]
10
Hugh Martin Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6.3]
10
William Paterson Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6.4]
10
Wily Gilbert Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6.5]
10
Thomas Jefferson Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6.6]
10
Phillip Telle Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6.7]
10
Jesse Van Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.6.8]
9
Nicholas Jesse Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.7]
b. Feb 1853 d. 10 Aug 1944
Rebecca Lelia Henley
b. 1870 d. 8 Jul 1941
10
Harry T. Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.7.1]
b. Jan 1892
10
Clardy Benjamin Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.7.2]
b. Mar 1895
10
John Creton Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.7.3]
10
Vella M. Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.7.4]
b. Abt 1912
10
Vernon Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.7.5]
b. 2 Jun 1918 d. 7 Apr 1971
10
Ethel Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.7.6]
9
Martha J. Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.8]
b. Abt 1854
+
Wooten
9
Mary E. Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.9]
b. Abt 1856
+
Eli Hart
9
William Jefferson Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.10]
b. Abt 1862 d. 25 Mar 1943
Ella King
b. 29 Mar 1866 d. 11 Mar 1906
10
Verna Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.10.1]
10
Lacy Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.10.2]
10
Etoile Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.10.3]
10
Collins Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.10.4]
10
Bonnie Sandlin
[1.1.1.4.1.2.8.3.10.5]
8
Frances Harris
[1.1.1.4.1.2.8.4]
b. Abt 1827
Beasley Graves
b. 1824
9
Mary T. Graves
[1.1.1.4.1.2.8.4.1]
b. 1852
9
John M. Graves
[1.1.1.4.1.2.8.4.2]
b. 1854
9
Emily Graves
[1.1.1.4.1.2.8.4.3]
b. 1856
9
Jesse Graves
[1.1.1.4.1.2.8.4.4]
b. 1859
8
Jesse Sutton Harris
[1.1.1.4.1.2.8.5]
b. Abt 1829
8
George W."Burpp" Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6]
b. 1812 d. 1885
Mary Ann Estes
b. 3 Sep 1823 d. 1 Jul 1891
9
Mary Jane Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.1]
b. 12 Nov 1842 d. 3 May 1927
John Sylvannus Taber
b. 28 May 1839 d. 13 Jan 1917
10
William Albert Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.1]
b. 11 Mar 1862 d. 30 Dec 1910
Mary Marcella Ashley
11
Brown Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.1.1]
b. 3 Apr 1891 d. 29 Nov 1943
11
Annie Myrtle Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.1.2]
b. 1 Aug 1893
11
Beulah Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.1.3]
b. Jul 1887
11
Elmer Sylvester Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.1.4]
Vera Newberry
12
Jr. Elmer Sylvester Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.1.4.1]
[
=>
]
Myrtle Jackson
b. Abt 1883
12
Beulah Inez Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.1.4.2]
12
Willaim A. Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.1.4.3]
10
Edna Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.2]
b. 6 Mar 1868 d. 14 Aug 1933
M. Perry Middleton
b. 5 Apr 1861
11
Mortie Middleton
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.2.1]
b. 31 Dec 1892
11
William Middleton
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.2.2]
b. 6 Mar 1902
11
Brooks Middleton
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.2.3]
b. 9 Dec 1905
10
John Monroe Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.3]
b. 1872
Ollie McCollum
b. 23 Oct 1875
11
Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.3.1]
b. 16 Jan 1897 d. 16 Jan 1897
10
George Levi Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.4]
b. 10 Mar 1874 d. 15 Apr 1960
Vista Legrand Edmondson
b. 23 Jul 1876 d. 24 Nov 1964
11
Leoris Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.4.1]
b. 21 Nov 1897 d. 22 Apr 1898
11
Charles Raymond Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.4.2]
+
Edna Mitchell
11
Mary Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.4.3]
b. 1902
11
Nora Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.4.4]
11
Holmes "Chuck" Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.4.5]
11
William Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.4.6]
b. Abt 1910
11
Sue Beth Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.4.7]
10
Anna Orr Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5]
b. 15 Dec 1876 d. 24 Feb 1910
John Rudolph Swart
b. 11 Aug 1875 d. 10 Jul 1955
11
Ora Lee Swart
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.1]
Roy Eden Thompson
b. 19 Jun 1886 d. 22 Mar 1970
12
Anna Roy Thompson
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.1.1]
[
=>
]
12
Kathryn Thompson
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.1.2]
12
James Donald Thompson
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.1.3]
[
=>
]
12
Wilma Louise Thompson
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.1.4]
[
=>
]
12
Geraldine Thompson
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.1.5]
[
=>
]
11
Rush Orlando Swart
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.2]
Lucille Skidmore
b. 21 Apr 1908
12
Peggy Louise Swart
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.2.1]
11
Buford Clyde Swart
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.3]
b. 2 Feb 1902 d. 12 Jul 1965
Alma Wilson
12
Billy Joe Swart
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.3.1]
11
John Talmadge Swart
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.4]
b. 10 Feb 1906
Vera Smith
b. 12 May 1906 d. 6 Jun 1955
12
Charlotte Jean Swart
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.4.1]
12
Joanna Swart
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.5.4.2]
10
Ben Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.6]
b. 28 Apr 1883 d. 7 Dec 1901
10
May Bell Taber
[1.1.1.4.1.2.8.6.1.7]
b. 8 Sep 1886
+
Seaman Jones
b. 13 Sep 1883 d. 26 May 1964
9
Albert B. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.2]
b. 1846
9
Thomas Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.3]
b. 1848
9
Robert T. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.4]
b. 1849 d. 1943
9
Jesse W. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.5]
b. 1851
9
Sarepta Lenora Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.6]
b. 1854
+
Benjamin F. Chandler
9
Martha E. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.7]
b. 1862 d. 16 Jan 1889
+
H. Batton
9
George F. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.8]
b. 1864 d. Apr 1950
Bessie L Smith
b. Abt 1876
10
Ruth H. Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.8.1]
10
Vera Estes Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.8.2]
b. 9 Sep 1895 d. 17 Oct 1918
10
Carly Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.8.3]
b. Abt 1903
10
Bess Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.8.4]
b. Abt 1908
9
Minnie Ann Harriss
[1.1.1.4.1.2.8.6.9]
b. 14 Feb 1867 d. 12 Dec 1890
+
B. L. Elliot
9
Ella Harris
[1.1.1.4.1.2.8.6.10]
b. Abt 1862
8
Louise Harris
[1.1.1.4.1.2.8.7]
b. Abt 1813
David McKee
b. Abt 1810
9
Sally McKee
[1.1.1.4.1.2.8.7.1]
b. 1842
8
Rozilla "Zylah" Harris
[1.1.1.4.1.2.8.8]
b. Abt 1815 d. 5 May 1846
Francis Thomas Tucker
b. 24 Feb 1813 d. 28 Apr 1895
9
James E. Tucker
[1.1.1.4.1.2.8.8.1]
b. 23 Apr 1834 d. 23 Jan 1855
9
John L. Tucker
[1.1.1.4.1.2.8.8.2]
b. 1836 d. 19 Jul 1863
+
Matilda Shafer
9
Sarah Ann Tucker
[1.1.1.4.1.2.8.8.3]
b. 16 Mar 1838 d. 2 May 1898
Jacob Stover
b. 30 Jul 1826 d. 3 May 1905
10
Annie Stover
[1.1.1.4.1.2.8.8.3.1]
10
Michael Stover
[1.1.1.4.1.2.8.8.3.2]
10
Elizabeth Stover
[1.1.1.4.1.2.8.8.3.3]
9
Nancy Jane Tucker
[1.1.1.4.1.2.8.8.4]
b. 26 Dec 1840 d. 15 Jan 1921
William Henry Nicholson
b. 19 Oct 1836 d. 3 Apr 1919
10
Rosilla Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.1]
10
James Andrew Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.2]
10
John Issac Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.3]
10
Sarah Ellen Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.4]
10
William Stephen Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.5]
10
Minnie G. Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.6]
10
Thomas Elija Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.7]
10
George Bliar Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.8]
10
Charles Edwin Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.9]
10
Clayton Augustus Nicholson
[1.1.1.4.1.2.8.8.4.10]
9
Louisa Ellen Tucker
[1.1.1.4.1.2.8.8.5]
b. 23 Feb 1843 d. 2 May 1916
Joseph Nichols
b. 20 Feb 1821 d. 9 Mar 1888
10
Charles Calvin Nichols
[1.1.1.4.1.2.8.8.5.1]
b. 1868
10
James Thomas Nichols
[1.1.1.4.1.2.8.8.5.2]
b. 18 Nov 1865 d. 24 Jul 1953
10
William Webster Nichols
[1.1.1.4.1.2.8.8.5.3]
10
Joseph Wilson Nichols
[1.1.1.4.1.2.8.8.5.4]
10
Zilliah Ann Nichols
[1.1.1.4.1.2.8.8.5.5]
9
Mary Tucker
[1.1.1.4.1.2.8.8.6]
b. 7 Feb 1846 d. 17 Aug 1846
7
Nancy Harris
[1.1.1.4.1.2.9]
b. 1785/1786
Woodson Daniel
b. 1782 d. 1830
8
Travis Daniel
[1.1.1.4.1.2.9.1]
b. 21 Feb 1806
8
Frances Daniel
[1.1.1.4.1.2.9.2]
b. 3 Jan 1808
8
Nancy Daniel
[1.1.1.4.1.2.9.3]
b. 5 Aug 1809
8
Julia Ann Daniel
[1.1.1.4.1.2.9.4]
b. 22 Jun 1812
8
Thomas H. Daniel
[1.1.1.4.1.2.9.5]
b. 1814
8
Woodson Daniel
[1.1.1.4.1.2.9.6]
b. 1816 d. 6 Sep 1903
8
Daniel
[1.1.1.4.1.2.9.7]
b. 1819
8
C. Murphy Daniel
[1.1.1.4.1.2.9.8]
b. 1822
7
Emsley Harris
[1.1.1.4.1.2.10]
d. Oct 1846
Patience Robards Roberts
8
Frances Harris
[1.1.1.4.1.2.10.1]
b. 1826
8
Mary Ann Harris
[1.1.1.4.1.2.10.2]
b. 1828
8
Lundy P. Harris
[1.1.1.4.1.2.10.3]
b. 9 Feb 1830
8
Jesse Winburn Harris
[1.1.1.4.1.2.10.4]
b. 6 Jan 1832
8
William Harris
[1.1.1.4.1.2.10.5]
b. 1833
8
John Ward Harris
[1.1.1.4.1.2.10.6]
b. 1837
8
Thomas Douglass Harris
[1.1.1.4.1.2.10.7]
b. 15 Oct 1841 d. 28 Jun 1914
+
Ann Eliza Haltom
b. 15 Jun 1838 d. 7 Feb 1911
8
Emsley Lee Harris
[1.1.1.4.1.2.10.8]
b. 1840
8
Miranda E Harris
[1.1.1.4.1.2.10.9]
b. 1843
8
Nancy Adeline Harris
[1.1.1.4.1.2.10.10]
b. 1845
6
William Harris
[1.1.1.4.1.3]
b. 13 Jan 1753 d. 26 Jan 1802
+
Mary Hudson
6
James Harris
[1.1.1.4.1.4]
6
John Harris
[1.1.1.4.1.5]
5
Overton Harris
[1.1.1.4.2]
Anne Nelson
6
Nelson Harris
[1.1.1.4.2.1]
Mary Prior
7
Hilary Harris
[1.1.1.4.2.1.1]
Phoebe Ann Hobson
8
Maria Harris
[1.1.1.4.2.1.1.1]
8
Joseph Hobson Harris
[1.1.1.4.2.1.1.2]
d. 1858
8
John Nelson Harris
[1.1.1.4.2.1.1.3]
8
Lavinia Harris
[1.1.1.4.2.1.1.4]
+
Daniel Hatcher
8
Christiana Harris
[1.1.1.4.2.1.1.5]
8
Hilary V. Harris
[1.1.1.4.2.1.1.6]
d. 1865
8
Sarah Octavia Harris
[1.1.1.4.2.1.1.7]
8
Abner Harris
[1.1.1.4.2.1.1.8]
+
Flora Harris
8
Willis Overton Harris
[1.1.1.4.2.1.1.9]
+
Caroline Adams
4
Robert Harris
[1.1.1.5]
b. 1696 d. 8 Aug 1765
Mourning Glenn
b. 1702 d. 1776
5
Anne Harris
[1.1.1.5.1]
b. 31 Mar 1724 d. Aft 1770
John Dabney
b. 17 Oct 1725 d. 1821
6
Sarah Ann Dabney
[1.1.1.5.1.1]
b. 2 Oct 1740 d. 10 Jan 1822
Thomas Waller
b. 29 Jul 1732 d. 10 Feb 1788
7
Mary Waller
[1.1.1.5.1.1.1]
b. 26 Feb 1761 d. 1850
7
Anna Waller
[1.1.1.5.1.1.2]
b. 11 Nov 1762 d. 5 Aug 1834
Joel Harris
b. 25 Apr 1761 d. 1826
8
Ira Harris
[1.1.1.5.1.1.2.1]
b. Abt 1785 d. 1863
Sarah Lewis
9
Charles Warner Harris
[1.1.1.5.1.1.2.1.1]
b. 15 Feb 1822 d. 23 Apr 1860
Angeline Mildred Brown
b. 9 Oct 1832
10
Mary Howell Harris
[1.1.1.5.1.1.2.1.1.1]
b. 15 Sep 1854 d. 12 Jan 1857
10
Charles Lee Harris
[1.1.1.5.1.1.2.1.1.2]
b. 24 Jul 1857
9
Waller Harris
[1.1.1.5.1.1.2.1.2]
+
Mary Frances Brown
9
Mary Ann Harris
[1.1.1.5.1.1.2.1.3]
Burlington Dabney Brown
b. 17 May 1820 d. 26 Apr 1886
10
Hugh Hescott Brown
[1.1.1.5.1.1.2.1.3.1]
b. 7 Apr 1846
+
Mary Ann Metier
10
Ira Lewis Brown
[1.1.1.5.1.1.2.1.3.2]
b. 2 Mar 1848
10
Linn Roy Brown
[1.1.1.5.1.1.2.1.3.3]
b. 5 Nov 1849 d. 22 Mar 1850
10
Frank Brown
[1.1.1.5.1.1.2.1.3.4]
+
Bettie French
10
Harry Brown
[1.1.1.5.1.1.2.1.3.5]
+
Virginia Ann Bishop
10
Ralph Brown
[1.1.1.5.1.1.2.1.3.6]
10
Hattie Brown
[1.1.1.5.1.1.2.1.3.7]
+
Samuel Hatcher
10
Nettie Brown
[1.1.1.5.1.1.2.1.3.8]
+
E .A. Lofton
9
Benjamin Harris
[1.1.1.5.1.1.2.1.4]
9
Lewis Harris
[1.1.1.5.1.1.2.1.5]
7
Agnes Waller
[1.1.1.5.1.1.3]
b. 17 Nov 1764 d. 7 Nov 1817
+
Sharp Smith
b. 1747/1767 d. 1792/1853
7
Sarah Waller
[1.1.1.5.1.1.4]
b. 24 Jan 1767 d. 22 Mar 1829
+
Joseph Spicer
b. 1750/1770 d. 1795/1856
7
Carr Waller
[1.1.1.5.1.1.5]
b. 12 Mar 1769 d. 7 May 1843
+
Elizabeth Martin
b. 1765/1785 d. 1800/1869
+
Susannah Edwards
b. 1765/1785 d. 1800/1869
7
Dabney Waller
[1.1.1.5.1.1.6]
b. 20 Feb 1772 d. 6 Jun 1849
Elizabeth Minor
b. 26 Sep 1768 d. 7 Jan 1832
8
Thomas Carr Waller
[1.1.1.5.1.1.6.1]
b. 29 Jul 1799
7
Pomfrett Waller
[1.1.1.5.1.1.7]
b. 8 May 1774 d. 29 Apr 1814
+
Sallie Woolfolk
b. 1770/1789 d. 1805/1873
7
Dorothy Waller
[1.1.1.5.1.1.8]
b. 31 Mar 1777 d. 2 Dec 1838
+
E. T. Rowzie
b. 1760/1780 d. 1805/1866
7
John Waller
[1.1.1.5.1.1.9]
b. 10 Feb 1780 d. 10 Sep 1824
7
Elizabeth Waller
[1.1.1.5.1.1.10]
b. 2 Mar 1783 d. 7 Jun 1872
6
Mary Dabney
[1.1.1.5.1.2]
b. 14 Sep 1742 d. 31 Oct 1818
Thomas Carr Minor
b. 5 Aug 1740 d. 16 Feb 1816
7
Elizabeth Minor
[1.1.1.5.1.2.1]
b. 26 Sep 1768 d. 7 Jan 1832
Dabney Waller
b. 20 Feb 1772 d. 6 Jun 1849
8
Thomas Carr Waller
[1.1.1.5.1.2.1.1]
b. 29 Jul 1799
6
William Dabney
[1.1.1.5.1.3]
b. 2 Jun 1750 d. 5 May 1836
+
Jane Quarles
b. 1742/1773 d. 1776/1855
6
John Dabney
[1.1.1.5.1.4]
b. 3 May 1749 d. 11 Mar 1831
Margueretta Smith
b. 1742/1762 d. 1777/1846
7
George Dabney
[1.1.1.5.1.4.1]
8
Benjamin Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1]
b. 15 Sep 1757 d. 25 May 1806
Sarah Smith
b. 27 Feb 1775 d. 21 Dec 1851
9
Martha Burwell Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.1]
b. 15 Sep 1802 d. 1883
Lewis Webb Chamberlayne
b. 1798 d. 1854
10
Lucy Parke Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1]
b. 1842 d. 1927
George William Bagby
b. 1828 d. 1883
11
Virginia Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.1]
III Henry Taylor
12
IV Henry Taylor
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.1.1]
[
=>
]
11
Lewis Webb Chamberlayne Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.2]
d. CHILD
11
John Hampden Chamberlayne Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.3]
11
Martha Burwell Dabney Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.4]
11
Woodville Latham Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.5]
d. INFANT
11
Parke Chamberlayne Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.6]
11
Jr. George William Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.7]
11
Robert Coleman Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.8]
11
Ellen Matthews Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.9]
11
Philip Haxall Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.10]
d. 1926
Mary Clarkson Allen
12
II Philip Haxall Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.10.1]
12
Virginia Allen Bagby
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.1.10.2]
10
II Edward Pye Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.2]
b. 21 Jan 1821 d. 1877
10
Hartwell Macon Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3]
b. 1836 d. 1905
Elmina McDearmon
b. 1842 d. 1894
11
William Nelson Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.1]
11
Thomas Gallaudet Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.2]
d. 1894
11
John Stewart Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.3]
d. CHILD
11
Edward Pye Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.4]
Emma Frances Furbush
12
Ada Lee Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.4.1]
12
Jr. Edward Pye Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.4.2]
12
Charles Hartwell Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.4.3]
12
Frances Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.4.4]
12
Ellen Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.4.5]
12
A. Bentley Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.4.6]
11
Sarah Dabney Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5]
Thomas Walter Davis
12
Hartwell Chamberlayne Davis
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5.1]
b. Mar 1900 [
=>
]
12
Virginia Davis
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5.2]
12
Harrison Bolen Davis
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5.3]
12
Rebecca Cook Davis
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5.4]
12
Dorothy McDearmon Davis
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5.5]
12
Parke Chamberlayne Davis
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5.6]
12
Edward Dabney Davis
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5.7]
12
Jr. Thomas Walter Davis
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.5.8]
11
Lewis Webb Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.6]
d. 1906
12
Mary Frances Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.3.6.1]
10
John Hampden Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4]
b. 2 Jun 1838 d. 18 Feb 1882
Mary Walker Gibson
d. 1905
11
Jr. John Hampden Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.1]
b. 30 Jan 1878 d. 3 Oct 1925
+
Alice Doyle
11
Lucy Atkinson Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.2]
b. 9 Jul 1875
Jr. Richard Clarke Scott
12
Churchill Gibson Scott
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.2.1]
b. 1 Feb 1905
12
John Hampden Chamberlayne Scott
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.2.2]
b. 1903 d. 1904
Clarence Maynard
12
Lucy Chamberlayne Maynard
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.2.3]
d. INFANT
11
Martha Dabney Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.3]
b. 3 Jul 1874
+
Ph.D. Walter Scott McNeil
Edward Pleasants Valentine
b. 6 Apr 1864 d. 24 Mar 1908
12
Martha Chamberlayne Valentine
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.3.1]
b. 1895 [
=>
]
12
Ann Pleasants Valentine
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.3.2]
b. 1898 [
=>
]
11
Ph.D. Lewis Parke Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.4]
b. 3 Jun 1879 d. 1917
Elizabeth Claiborne Mann
12
Mary Gibson Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.4.1]
12
Elizabeth Claiborne Mann Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.4.2]
11
Ph.D. Churchill Gibson Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.5]
b. 23 Dec 1876
Elizabeth Bolling
12
Edward Pye Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.5.1]
12
III John Hampden Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.5.2]
11
Bessie Gibson Chamberlayne
[1.1.1.5.1.4.1.1.1.4.6]
b. 8 Aug 1880
9
Philip Augustine Lee Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.2]
b. 4 Mar 1800 d. 1878
9
Thomas Gregory Smith Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.3]
b. 4 Jan 1798 d. 28 Feb 1885
+
Mary Adelaide Tyler
Martha Burwell Armistead
9
George Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4]
b. 25 Mar 1779 d. 31 Dec 1827
Susanna Littlepage Quarles
b. 12 Mar 1778 d. 18 Apr 1827
10
George Henry Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.1]
b. 8 Apr 1798 d. 27 May 1842
+
Martha Tebbs
10
James Lyons Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.2]
b. 25 Jul 1808 d. Bef 1887
+
Elizabeth Washington Dade
10
Ann West Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.3]
b. 2 Sep 1793 d. 1869
+
Benjamin Dabney
+
John Lumpkin
10
Emily Anderson Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.4]
b. 22 Nov 1794
+
Gabriel Gray
10
Elizabeth Camp Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.5]
b. 27 Sep 1796 d. 1866
10
Susanna Quarles Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.6]
b. 27 Sep 1796 d. 1798
10
Susanna Dandridge Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.7]
b. 26 Nov 1799 d. 1800
10
Mary Eleanor Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.8]
b. 7 Feb 1801
+
Benjamin Pendleton Hoomes
10
Benjamin Franklin Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.9]
b. 12 Oct 1802 d. Bef 1887
+
Nelson
10
Agnes Dandridge Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.10]
b. 29 Jun 1804 d. 13 Jun 1880
+
Boughton
+
George Augustus Spiller
10
Frances Anderson Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.11]
b. 31 Jan 1806 d. Bef 1887
+
John Taliaferro
+
Custis Carter
10
boy Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.12]
b. 23 Apr 1807 d. 23 Apr 1807
10
John Fushee Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.13]
b. 10 Dec 1810 d. 1811
10
Thomas Smith Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.14]
b. 7 Apr 1812
+
Rebecca Dylees
10
Harriet Richardson Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.15]
b. 12 Sep 1815 d. 1817
10
Maria Hoomes Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.4.16]
b. 2 Dec 1817 d. Bef 1887
+
William F. Turner
9
Benjamin Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.5]
b. 1784
9
Anne Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.1.6]
b. 1786
+
Thomas Smith
8
James Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.2]
8
Thomas Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.3]
8
George Dabney
[1.1.1.5.1.4.1.4]
7
James Dabney
[1.1.1.5.1.4.2]
7
Nancy Dabney
[1.1.1.5.1.4.3]
7
John Dabney
[1.1.1.5.1.4.4]
6
Anna Dabney
[1.1.1.5.1.5]
b. Abt 1751 d. Aft 1784
+
Henry Terrill
b. 1730
6
Elizabeth Jennings Dabney
[1.1.1.5.1.6]
b. 18 Jun 1751 d. 21 Jul 1826
Bernard Brown
b. 28 Jan 1749/50 d. 26 Feb 1800
7
Reuben Dabney Brown
[1.1.1.5.1.6.1]
b. 16 Jan 1777 d. 5 Jul 1849
Lucy Thompson Brown
b. 17 Jan 1784
8
Susanna T. Brown
[1.1.1.5.1.6.1.1]
b. 29 Mar 1809 d. 3 Feb 1855
H. Nimrod Brown
b. 5 Apr 1797 d. 11 Aug 1835
9
Reuben Brown
[1.1.1.5.1.6.1.1.1]
b. Abt 1825
8
George Thompson Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2]
b. 29 Dec 1807 d. 7 Jun 1883
Amanda Brown
b. 16 Jan 1809 d. 5 Mar 1882
9
Sarah P. Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.1]
b. Abt 1846
+
Benjamin Adams
b. Abt 1844
9
Reuben Dabney Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.2]
b. 20 Jun 1848
Margaret Matilda Crenshaw
10
Mary Elizabeth Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.2.1]
9
William Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.3]
b. Abt 1834
9
Lucy Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.4]
b. Abt 1844
+
Adams
9
Llewellyn Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.5]
b. Abt 1830
9
Benjamin Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.6]
b. Abt 1840
9
Amanda C. Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.7]
b. Apr 1822 d. 16 Sep 1839
9
Susan Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.8]
b. Abt 1842
+
John Chenault
9
George Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.9]
b. Abt 1832
9
Clifton Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.10]
b. Abt 1837
9
Charles Brown
[1.1.1.5.1.6.1.2.11]
b. Abt 1850
8
Brightberry Brown
[1.1.1.5.1.6.1.3]
b. Abt 1811
8
Llewellyn Brown
[1.1.1.5.1.6.1.4]
b. Abt 1815
8
Francina Rhodes Brown
[1.1.1.5.1.6.1.5]
b. 1819 d. 1894
7
Bernard M. Brown
[1.1.1.5.1.6.2]
b. 15 Mar 1781 d. 1825
Miriam Cave Maupin
b. 19 Dec 1783
8
Thompson Brown
[1.1.1.5.1.6.2.1]
b. 6 Oct 1803
+
Sarah Brown
8
Sarah J. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2]
b. 11 Apr 1805
Clifton Brown
b. 6 Aug 1799
9
Tazwell Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.1]
+
Isabella Brown
9
Virginia A. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.2]
9
T. H. B. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.3]
Elizabeth Ellen Carpenter
10
Lulu Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.1]
b. 8 Jul 1870 d. 18 Jan 1943
Augustus Renick McNeill
b. 26 Nov 1859 d. 19 Jun 1932
11
Augustus Cleland McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.1.1]
b. 11 Jul 1887 d. 26 Aug 1938
Nannie Bell Gilkessen
12
John Gilkeson McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.1.1.1]
b. 28 Apr 1918 d. 12 Mar 1966
12
Robert Spottswood McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.1.1.2]
12
Thomas Bernard McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.1.1.3]
11
Daniel Brown McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.1.2]
b. 4 Mar 1889 d. 14 Mar 1943
+
Lulu Darrow
10
Verdie Leigh Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.2]
b. 13 Feb 1861 d. 24 Nov 1920
Edward Williams McNeill
b. 15 Jun 1857 d. 16 Feb 1927
11
Chauncey S. McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.2.1]
b. 1886
+
Carolyn Lee
11
Llewellyn Brown McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.2.2]
b. Cal 1881
Elizabeth Heiskell
12
Jean McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.2.2.1]
11
Roland Karl McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.2.3]
b. 5 Jun 1889 d. 23 Jan 1934
+
Marie Inskeep
11
Verdie Genevieve McNeill
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.2.4]
+
Harry Cronin
10
DeWitt Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.3]
10
Bernard Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.4]
10
Sallie Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.5]
10
Edward Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.3.6]
9
William A. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.4]
9
Susan Brown
[1.1.1.5.1.6.2.2.5]
8
Pyrenia D. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.3]
b. 31 Dec 1806
+
Tilman J. Maupin
8
Elizabeth Dabney Brown
[1.1.1.5.1.6.2.4]
b. 8 Aug 1822
+
Clifton Brown
b. 6 Aug 1799
8
Sidna R. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.5]
b. 8 Jan 1812
8
Bernard L. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6]
b. 9 Aug 1816 d. 10 Feb 1868
Mary Elizabeth Dailey
b. Abt 1817 d. 18 May 1907
9
Lucy Blanche Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.1]
b. 10 Aug 1853 d. 2 Feb 1935
+
McCrum
9
Oscar Lee Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.2]
b. 31 Aug 1851 d. 4 May 1888
9
Alice Goodman Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.3]
b. 15 Feb 1862 d. 28 Jan 1890
9
Florence A Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.4]
b. 29 Nov 1845 d. 9 Dec 1928
9
Adeliza Frances Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.5]
b. 14 Jan 1844 d. 4 Jan 1934
9
Laura Sedna Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.6]
b. 17 Sep 1847 d. 31 May 1860
9
Charles Bernard Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.7]
b. 12 Nov 1857
9
Roberta Lee Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.8]
b. 23 Nov 1865 d. 12 Apr 1931
9
Clarence Hugh Dailey Brown
[1.1.1.5.1.6.2.6.9]
b. 11 Dec 1859 d. 4 Sep 1884
8
Smith W. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.7]
b. 19 Apr 1814
Martha M. Brown
b. 4 May 1813 d. 15 Apr 1850
9
Mary Emnier Brown
[1.1.1.5.1.6.2.7.1]
b. 31 May 1847
9
Elizabeth Lewis Brown
[1.1.1.5.1.6.2.7.2]
b. 19 Oct 1845 d. 9 Feb 1848
9
Allen Henry Brown
[1.1.1.5.1.6.2.7.3]
b. 29 Apr 1841 d. 12 May 1864
9
Lucie Mariam Brown
[1.1.1.5.1.6.2.7.4]
b. 15 Apr 1854
9
John Jarman Brown
[1.1.1.5.1.6.2.7.5]
b. 17 Feb 1849 d. Feb 1903
+
Marie E. Mallory
b. 6 Jun 1826 d. 8 Jun 1886
8
James D. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.8]
b. 11 Feb 1826
+
Kate Ford
8
Allen W. Brown
[1.1.1.5.1.6.2.9]
b. 21 Nov 1809
+
Mary Koogler
8
Francis Brown
[1.1.1.5.1.6.2.10]
+
Adams
7
Ira Benajah Brown
[1.1.1.5.1.6.3]
b. 5 Jun 1794 d. 26 Feb 1842
Frances Jarman Mullins
b. 1 Dec 1798 d. 23 May 1835
8
Burlington Dabney Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1]
b. 17 May 1820 d. 26 Apr 1886
Mary Ann Harris
9
Hugh Hescott Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1.1]
b. 7 Apr 1846
+
Mary Ann Metier
9
Ira Lewis Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1.2]
b. 2 Mar 1848
9
Linn Roy Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1.3]
b. 5 Nov 1849 d. 22 Mar 1850
9
Frank Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1.4]
+
Bettie French
9
Harry Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1.5]
+
Virginia Ann Bishop
9
Ralph Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1.6]
9
Hattie Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1.7]
+
Samuel Hatcher
9
Nettie Brown
[1.1.1.5.1.6.3.1.8]
+
E .A. Lofton
8
Virginia Frances Brown
[1.1.1.5.1.6.3.2]
b. 17 Dec 1822 d. 1883
William Kavanaugh Hocker
b. 1820 d. 1897
9
Lucy B. Hocker
[1.1.1.5.1.6.3.2.1]
Powhatan Patteson Truehart
b. 6 Nov 1851
10
Virginia Truehart
[1.1.1.5.1.6.3.2.1.1]
b. 1879
+
Edward Kilbourne
9
Fannie Hocker
[1.1.1.5.1.6.3.2.2]
9
Nannie Hocker
[1.1.1.5.1.6.3.2.3]
8
James Landon Brown
[1.1.1.5.1.6.3.3]
b. 22 Jun 1824 d. 7 Jun 1852
8
Sarah Ann Brown
[1.1.1.5.1.6.3.4]
b. 1 Mar 1826 d. 1 May 1846
8
Samantha Susan Brown
[1.1.1.5.1.6.3.5]
b. 21 Mar 1828 d. 30 Mar 1896
+
James Nathan Gentry
8
Jacintha Catherine Brown
[1.1.1.5.1.6.3.6]
b. 10 Aug 1830 d. 10 Jun 1880
+
William Kavanaugh Oldham
8
Angeline Mildred Brown
[1.1.1.5.1.6.3.7]
b. 9 Oct 1832
+
John Harris Miller
Charles Warner Harris
b. 15 Feb 1822 d. 23 Apr 1860
9
Mary Howell Harris
[1.1.1.5.1.6.3.7.1]
b. 15 Sep 1854 d. 12 Jan 1857
9
Charles Lee Harris
[1.1.1.5.1.6.3.7.2]
b. 24 Jul 1857
8
Brown
[1.1.1.5.1.6.3.8]
b. 28 Feb 1835
8
Mary Elizabeth Brown
[1.1.1.5.1.6.3.9]
b. 17 Jan 1818 d. 1 Aug 1854
Roberts
9
Brown Roberts
[1.1.1.5.1.6.3.9.1]
9
Frank Roberts
[1.1.1.5.1.6.3.9.2]
9
Fannie Roberts
[1.1.1.5.1.6.3.9.3]
9
William Roberts
[1.1.1.5.1.6.3.9.4]
9
John Roberts
[1.1.1.5.1.6.3.9.5]
+
Mary Caruthers
7
Lucy Brown
[1.1.1.5.1.6.4]
b. 7 Nov 1778 d. 16 Feb 1852
+
Nathaniel Thompson
d. 1874
7
Sarah Brown
[1.1.1.5.1.6.5]
b. 6 Jun 1792 d. 2 May 1852
Beverly A. Brown
8
Virginia Brown
[1.1.1.5.1.6.5.1]
8
Emaline Brown
[1.1.1.5.1.6.5.2]
+
Alexander Mosely
8
Lucy Frances Brown
[1.1.1.5.1.6.5.3]
+
John Hawthorne
+
John Holbrooke
8
Sarah Brown
[1.1.1.5.1.6.5.4]
+
Vernon Cobbs
8
Edwin Brown
[1.1.1.5.1.6.5.5]
+
Bettie Thompson
7
Charles M. Brown
[1.1.1.5.1.6.6]
b. 3 May 1783 d. 1879
Mary Brown
b. 1783 d. 1879
8
Ezra M. Brown
[1.1.1.5.1.6.6.1]
+
Sally Tilman
8
Bettie Brown
[1.1.1.5.1.6.6.2]
+
William H. Jones
8
Elvira Brown
[1.1.1.5.1.6.6.3]
+
Ayers
8
Bezaleel Ira Brown
[1.1.1.5.1.6.6.4]
Mary Ann Garth
9
Brown
[1.1.1.5.1.6.6.4.1]
+
Oscar Early
8
Charles Thomas Brown
[1.1.1.5.1.6.6.5]
8
Algernon Brown
[1.1.1.5.1.6.6.6]
8
Oswin Brown
[1.1.1.5.1.6.6.7]
7
Asa Brightberry Brown
[1.1.1.5.1.6.7]
b. 5 Jun 1794 d. 30 Jan 1839
Marie Brown
8
Thomas Ally Brown
[1.1.1.5.1.6.7.1]
8
Martha Brown
[1.1.1.5.1.6.7.2]
8
Bernard Brown
[1.1.1.5.1.6.7.3]
+
Susan Brown
8
Bettie Brown
[1.1.1.5.1.6.7.4]
+
Samuel Woodson
7
Benjamin Hescott Brown
[1.1.1.5.1.6.8]
b. 12 Mar 1790 d. 5 Dec 1875
Judith Fretwell
b. 8 Mar 1782 d. 13 Feb 1870
8
William Bernard Brown
[1.1.1.5.1.6.8.1]
Belle Clayton
9
Jennie Brown
[1.1.1.5.1.6.8.1.1]
9
Amanda Brown
[1.1.1.5.1.6.8.1.2]
+
McMahon
9
James Brown
[1.1.1.5.1.6.8.1.3]
8
Thomas Brown
[1.1.1.5.1.6.8.2]
8
Charles Wesley Brown
[1.1.1.5.1.6.8.3]
Venia Spurgeon
9
Mollie Brown
[1.1.1.5.1.6.8.3.1]
9
Benjamin Brown
[1.1.1.5.1.6.8.3.2]
8
Iurenia Brown
[1.1.1.5.1.6.8.4]
+
Sampson Wright
8
Virginia Brown
[1.1.1.5.1.6.8.5]
+
Alexander Blake
8
Betsy Brown
[1.1.1.5.1.6.8.6]
+
Richardson
8
Francina Brown
[1.1.1.5.1.6.8.7]
+
Mark Long
8
Velunia Ann Brown
[1.1.1.5.1.6.8.8]
+
John Ingraham
8
Elvenie Brown
[1.1.1.5.1.6.8.9]
+
Griggs
7
Bezaleel G. Brown
[1.1.1.5.1.6.9]
b. 22 Sep 1787 d. 20 Apr 1825
Elizabeth E. Michie
8
William Dabney Brown
[1.1.1.5.1.6.9.1]
8
Martha Brown
[1.1.1.5.1.6.9.2]
C. H. Parrott
9
Lizzie Parrott
[1.1.1.5.1.6.9.2.1]
9
W. H. Parrott
[1.1.1.5.1.6.9.2.2]
9
C. C. Parrott
[1.1.1.5.1.6.9.2.3]
9
Soonie Parrott
[1.1.1.5.1.6.9.2.4]
8
Cynthia Brown
[1.1.1.5.1.6.9.3]
+
William Harris Brown
8
Addison Brown
[1.1.1.5.1.6.9.4]
8
John Augustus Brown
[1.1.1.5.1.6.9.5]
+
Columbia Brown
8
Angeline Brown
[1.1.1.5.1.6.9.6]
+
George Kemper
7
Robert Thompson Brown
[1.1.1.5.1.6.10]
b. 16 Jan 1777 d. 30 Mar 1851
Elizabeth Crenshaw
b. Abt 1779 d. 1852
8
Anna Dabney Brown
[1.1.1.5.1.6.10.1]
b. 5 Jul 1799 d. 21 Apr 1880
+
John Wesley Harris
b. 5 Apr 1795 d. 2 Apr 1870
8
Frances Brown
[1.1.1.5.1.6.10.2]
b. Abt 1818
+
William Parker
b. Abt 1815
8
James Madison Brown
[1.1.1.5.1.6.10.3]
b. Abt 1815
Mary E.
b. Abt 1826
9
Lucy Brown
[1.1.1.5.1.6.10.3.1]
b. Abt 1847
8
Sarah Jane Brown
[1.1.1.5.1.6.10.4]
b. Abt 1806
+
George Rogers
b. Abt 1806
8
Elizabeth Brown
[1.1.1.5.1.6.10.5]
b. Abt 1808 d. 1877
+
Arthur Hambrick
8
Nancy T. Brown
[1.1.1.5.1.6.10.6]
+
Charles H. Ledsinger
8
Lucy Brown
[1.1.1.5.1.6.10.7]
+
Ira Ledbetter
8
Mary Brown
[1.1.1.5.1.6.10.8]
+
William P. Browning
8
Bernard Brown
[1.1.1.5.1.6.10.9]
Elizabeth Franklin
9
Brightberry T. Brown
[1.1.1.5.1.6.10.9.1]
b. Aug 1834
+
Martha Hoskins
7
Thomas Harris Brown
[1.1.1.5.1.6.11]
b. 16 Apr 1785
+
Lucy Goodman
Mildred Brown
b. 7 Nov 1788
8
Robin Brown
[1.1.1.5.1.6.11.1]
+
Crenshaw
8
Lavinia Brown
[1.1.1.5.1.6.11.2]
+
John Holbrook
8
Emaline Brown
[1.1.1.5.1.6.11.3]
+
William G. Fretwell
8
Eliza Dabney Brown
[1.1.1.5.1.6.11.4]
+
Lewis Campbell
8
Susan Brown
[1.1.1.5.1.6.11.5]
+
Benjamin Childress
8
Parthenia Brown
[1.1.1.5.1.6.11.6]
+
William Haydon
8
Lucy Ann Brown
[1.1.1.5.1.6.11.7]
+
Richard Noel
7
Francina Brown
[1.1.1.5.1.6.12]
b. 24 May 1775 d. 3 May 1846
John Rodes
b. 2 Jun 1766 d. 1839
8
William Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.1]
b. 1765/1801 d. 1806/1880
+
Elizabeth Clarissa Yancey
b. 1775/1803 d. 1806/1885
+
Clarissa Yancey
8
Jacintha Tazewell Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.2]
b. 20 Aug 1809
John Massie Smith
9
John Massie Smith
[1.1.1.5.1.6.12.2.1]
9
Frances Rodes Smith
[1.1.1.5.1.6.12.2.2]
9
Charles Thompson Smith
[1.1.1.5.1.6.12.2.3]
9
Bettie Massie Smith
[1.1.1.5.1.6.12.2.4]
9
William Henry Smith
[1.1.1.5.1.6.12.2.5]
9
Robert Hardin Smith
[1.1.1.5.1.6.12.2.6]
James M. Harris
9
James Clifton Harris
[1.1.1.5.1.6.12.2.7]
9
Lizzie Woods Harris
[1.1.1.5.1.6.12.2.8]
9
Mary Alice Harris
[1.1.1.5.1.6.12.2.9]
8
Sydney Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.3]
Powhatan Jones
9
Judith Francena Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.3.1]
8
Ryland Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.4]
+
Virginia Woods
8
Sarah Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.5]
+
Samuel Woods
8
John Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.6]
+
Ann
8
Frances Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.7]
+
Garland Brown
8
Virginia Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.8]
+
Wilson C. Smith
8
Tyree Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.9]
8
Lucy Rodes
[1.1.1.5.1.6.12.10]
+
Newlands
6
Susan Dabney
[1.1.1.5.1.7]
b. 1756 d. 1784/1850
+
Thomas Harris
b. 3 Apr 1755 d. 12 Sep 1842
6
Lucy Dabney
[1.1.1.5.1.8]
b. Abt 1757 d. 1747/1849
+
Thomas McReynolds
6
Rebecca Dabney
[1.1.1.5.1.9]
b. Abt 1759 d. 1773/1849
+
Thomas Warner
b. 1732/1764 d. 1773/1844
6
Cornelius Dabney
[1.1.1.5.1.10]
b. Abt 1761 d. 1747/1846
+
Jane Harris
+
Frances Harris
6
Nancy Dabney
[1.1.1.5.1.11]
b. Abt 1763 d. 1773/1849
+
John Hunter
b. 1732/1764 d. 1773/1844
5
Christopher Harris
[1.1.1.5.2]
b. 17 Feb 1724/25 d. 3 Feb 1794
Mary Elizabeth Dabney
b. 13 Jun 1726 d. 1760
6
Dabney Harris
[1.1.1.5.2.1]
b. 15 Dec 1745 d. 1746/1835
6
Sarah Harris
[1.1.1.5.2.2]
b. 11 Jun 1747 d. 5 Jul 1796
James Martin
b. 1 May 1730 d. 5 Mar 1799
7
Christopher Martin
[1.1.1.5.2.2.1]
b. 28 Jul 1760
Ann Turner
8
Sinai Martin
[1.1.1.5.2.2.1.1]
b. Abt 1815 d. 29 Nov 1869
6
Robert Harris
[1.1.1.5.2.3]
b. 24 Aug 1749 d. 18 Nov 1833
Nancy Grubbs
b. 24 Nov 1749 d. 30 Apr 1835
7
Catherine Harris
[1.1.1.5.2.3.1]
b. Abt 1787
+
James Stone
7
Mary Harris
[1.1.1.5.2.3.2]
b. Abt 1781
+
William Woods
7
Tyree Harris
[1.1.1.5.2.3.3]
b. Abt 1782
Sally Garland
8
Robert Harris
[1.1.1.5.2.3.3.1]
b. 22 Feb 1818
Frances Copher
9
Tyree Harris
[1.1.1.5.2.3.3.1.1]
9
Susan Harris
[1.1.1.5.2.3.3.1.2]
+
Hill
8
Thomas Berry Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2]
b. 1815 d. 1892
Mary Frances Harris
b. 10 Nov 1827 d. 28 Feb 1906
9
Martha Overton Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2.1]
9
Sallie Tyree Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2.2]
+
A. M. Wathall
9
Susan Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2.3]
9
William Christopher Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2.4]
9
Mary Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2.5]
+
J. A. Vansant
9
Overton Thomas Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2.6]
9
Tyree Crawford Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2.7]
9
Isabel Harris
[1.1.1.5.2.3.3.2.8]
8
Malinda Harris
[1.1.1.5.2.3.3.3]
+
Samuel Jameson
8
Caleb Rice Harris
[1.1.1.5.2.3.3.4]
Minerva
9
John Stone Harris
[1.1.1.5.2.3.3.4.1]
8
Paulina Harris
[1.1.1.5.2.3.3.5]
+
Joseph Frakes
8
William Hayden Harris
[1.1.1.5.2.3.3.6]
Amelia Ellington
9
Joseph Harris
[1.1.1.5.2.3.3.6.1]
8
Susan Harris
[1.1.1.5.2.3.3.7]
+
John Jameson
8
Overton Harris
[1.1.1.5.2.3.3.8]
+
Mary Ellington
8
Benjamin F. Harris
[1.1.1.5.2.3.3.9]
Lucy Hensley
9
Mary Susan Harris
[1.1.1.5.2.3.3.9.1]
+
Vivion
9
Alnett Harris
[1.1.1.5.2.3.3.9.2]
+
Vivion
9
William T. Harris
[1.1.1.5.2.3.3.9.3]
9
Benjamin W. Harris
[1.1.1.5.2.3.3.9.4]
9
Samuel H. Harris
[1.1.1.5.2.3.3.9.5]
8
Sallie Ann Harris
[1.1.1.5.2.3.3.10]
+
Archibald Dinwiddie
8
Mary Catherine Harris
[1.1.1.5.2.3.3.11]
d. 1904
+
George Burroughs
8
James Berry Harris
[1.1.1.5.2.3.3.12]
Lucy Cockerel
9
William Thomas Harris
[1.1.1.5.2.3.3.12.1]
9
Effie Harris
[1.1.1.5.2.3.3.12.2]
+
Howard Sutherland
9
John T. Harris
[1.1.1.5.2.3.3.12.3]
9
James W. Harris
[1.1.1.5.2.3.3.12.4]
9
Martha Virginia Harris
[1.1.1.5.2.3.3.12.5]
+
Henderson Hancock
9
Katherine Harris
[1.1.1.5.2.3.3.12.6]
+
Howard Sutherland
8
Tyree Crawford Harris
[1.1.1.5.2.3.3.13]
d. 1854
Lavinia Hughes
9
William L. Harris
[1.1.1.5.2.3.3.13.1]
9
Mary Cameron Harris
[1.1.1.5.2.3.3.13.2]
+
Vorries
9
Harris
[1.1.1.5.2.3.3.13.3]
+
William McCracken
7
Higgason Harris
[1.1.1.5.2.3.4]
b. 3 Apr 1774 d. Aft 1839
Nancy Garland
b. Abt 1780 d. Bef 1840
8
Lucy Ann Harris
[1.1.1.5.2.3.4.1]
b. 7 Jul 1809 d. 2 Oct 1877
John Martin Ogan
b. 30 Jan 1812 d. 17 Jun 1893
9
Sierra Nevada Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.1]
b. 3 Aug 1853 d. 24 Jun 1938
Christopher Columbus Smith
b. 5 Sep 1841 d. 14 Aug 1910
10
Hazel Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.1]
b. Abt 1886
10
Euphemia Ann Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.2]
Albert Wallis Mathews
b. 29 Oct 1882 d. 3 Jan 1956
11
Myrtle E. Mathews
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.2.1]
Earl Vernon
12
Earlene Vernon
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.2.1.1]
12
Robert Vernon
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.2.1.2]
11
Jr. Albert Wallis Mathews
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.2.2]
Amy Helene Clark
12
Glenn Wallace Mathews
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.2.2.1]
12
Myrtle Arlene Mathews
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.2.2.2]
10
Mamie Josephine Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3]
b. Abt 1874
William W. Anderson
11
Rebecca Nevada Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.1]
b. 5 May 1897
Carl W. Haag
b. 2 Feb 1888 d. 20 Jul 1940
12
Jean Lee Haag
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.1.1]
12
Joyce Ann Haag
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.1.2]
12
Phil W. Haag
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.1.3]
11
Warren Alvord Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.2]
Edna Mae
12
John Nathan Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.2.1]
12
Mamie Mae Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.2.2]
12
Alice Nevada Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.2.3]
+
Elsie Faulkner Elam
11
Alice Phillis Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.3]
Kenneth Paul Meriam
12
Kenneth Terry Meriam
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.3.1]
12
Jeffery Paul Meriam
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.3.2]
11
Bessie Alberta Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.4]
+
Chester Elliot
11
Esther Margaret Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.5]
J. Garrison
12
Margaret Garrison
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.5.1]
11
Zilla May Anderson
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.6]
Frank Haag
12
Dennis Haag
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.6.1]
12
Donald Haag
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.3.6.2]
10
Margaret Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.4]
b. Abt 1882
+
Byron Nesbit
10
Orlando Jarvis Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.5]
b. 27 May 1880 d. 16 Aug 1965
+
Clara Stewart
10
Charles Taylor Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6]
b. 23 Feb 1875 d. 2 Oct 1969
Sarah Maud Blanch
b. 8 Mar 1873 d. 5 Sep 1952
11
Evelyn Muriel Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.1]
b. 5 Sep 1900 d. 6 May 1972
Walter Irving Long
12
Jr. Walter Irving Long
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.1.1]
12
Ardeene LaVerne Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.1.2]
12
Evelyn Lorraine Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.1.3]
12
Easton Lodge Long
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.1.4]
11
Charlotte Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.2]
b. 19 Feb 1919 d. 28 Feb 1919
11
Charles Christopher Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.3]
b. 14 Jun 1906
+
Velma Spraker
Millie McLarrin
12
Charles David Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.3.1]
11
Elbert Leroy Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.4]
b. 22 Nov 1903 d. Jun 1955
11
Florence Agnes Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.5]
b. 21 Aug 1901 d. 19 Jan 1922
Roy Shedd
12
Lucille Shedd
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.5.1]
11
Hazel Maud Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.6]
b. 19 Oct 1913 d. SeeNotes
Merlin French
12
Susie French
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.6.1]
12
Nancy French
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.6.2]
12
Frankie French
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.6.3]
12
Cindy French
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.6.4]
11
Mervyn Ogan Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.7]
b. 7 Dec 1910 d. 29 May 1943
11
Edmond Lodge Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.8]
Helen Scanlon
12
Jr. Edmond Lodge Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.8.1]
11
Roberta Mabel Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.9]
Ray Bence
12
John Bence
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.9.1]
12
Diane Bence
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.6.9.2]
10
Robert Calvin Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.7]
b. Abt 1891 d. 26 Dec 1962
+
Goldie
10
Lila Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.8]
b. Abt 1889
10
Lola Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.9]
b. Abt 1871 d. Abt 1892
William Sleightam
11
William Sleightam
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.9.1]
10
Maude Nevada Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.10]
b. 5 Nov 1894 d. Abt 1948
+
Norm Nelson
Arnold Melvin Gifford
b. 2 Oct 1892
11
Fern Jane Gifford
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.10.1]
b. 5 Nov 1918 d. 3 Oct 1924
11
June Doris Gifford
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.10.2]
Edwin Bruce Gould
12
James Carter Gould
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.10.2.1]
11
Loren Clifton Gifford
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.10.3]
Jean Evelyn Blackburn
12
Alan Leslie Gifford
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.10.3.1]
12
Lorna Jean Gifford
[1.1.1.5.2.3.4.1.1.10.3.2]
9
James Robert Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.2]
b. 1851 d. 12 Mar 1939
Effie B. Hansborough
d. Bef 1900
10
Oscar Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.2.1]
b. 30 Sep 1873 d. 14 Aug 1896
10
John Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.2.2]
b. Nov 1875
10
Olive Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.2.3]
b. May 1885
10
Bertha Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.2.4]
b. Oct 1881
10
Julia Adelia Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.2.5]
b. 2 Aug 1879 d. 11 Jul 1954
Frank Harvey Carlisle
11
Percy Carlisle
[1.1.1.5.2.3.4.1.2.5.1]
b. 1902
11
Frank H. Carlisle
[1.1.1.5.2.3.4.1.2.5.2]
11
Collier C. Carlisle
[1.1.1.5.2.3.4.1.2.5.3]
+
Mattson
+
Catherine Brown
d. 16 Aug 1920
9
Elizabeth J. Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.3]
b. 1848 d. 22 Apr 1895
William Alexander Smith
b. 26 Mar 1844 d. 1929
10
Roy Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.3.1]
10
Lucinda Smith
[1.1.1.5.2.3.4.1.3.2]
bur. 1891
9
William Higgason Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4]
b. Jan 1847 d. 25 Mar 1901
Lydia Hannah Hamilton
b. 29 May 1854 d. 10 Oct 1935
10
William Lester Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.1]
b. 13 Apr 1876 d. 31 Oct 1960
Addie Vivian Caldwell
b. 14 Jun 1881 d. 5 Jan 1970
11
Maxwell Eugene Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.1.1]
Dorothy Amen
d. 25 Jul 1936
12
Ph.D. Eugene Amen Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.1.1.1]
Beatrice Marie Whitmore
12
Thomas Merrit Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.1.1.2]
12
Kathleen Marie Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.1.1.3]
12
Richard Maxwell Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.1.1.4]
10
Lucy Adeline Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.2]
b. Aug 1888
Hall
11
Harry R. Hall
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.2.1]
b. 7 Sep 1905
10
Leland Stanford Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.3]
b. Jan 1890 d. 19 May 1930
+
D.
10
James Marvin Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.4]
Marie Hulda Briggs
11
Marvin Eugene Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.4.1]
10
Helena Mabel Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.5]
b. Abt 1874
+
James J. Phillips
10
Isiah Lyle Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.6]
b. 13 Nov 1878 d. 5 Jul 1947
Edna Grider
b. Abt 1892 d. 17 Jul 1917
11
John Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.6.1]
b. Abt 1917 d. 1 Jul 1920
10
Robert Martin Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.7]
b. 9 Nov 1885 d. 2 Jan 1968
+
E. M.
10
Harry Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.8]
b. 22 Sep 1882 d. 31 Aug 1931
Gilberta Mae Ottman
b. 1891
11
Harry Kenneth Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.8.1]
Mary Ermin Martin
12
Sally Irene Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.4.8.1.1]
9
Euphemia Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.5]
b. 1845
John Smith Boyd Shuart
10
Helen E. Shuart
[1.1.1.5.2.3.4.1.5.1]
b. 1862 d. 21 Feb 1931
Henry Switzgebel
11
Louise Switzgebel
[1.1.1.5.2.3.4.1.5.1.1]
11
Alice Switzgebel
[1.1.1.5.2.3.4.1.5.1.2]
9
Thomas Dudley Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.6]
b. 1843
Hattie E.
b. Abt 1853
10
Irving Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.6.1]
b. Abt 1869
10
Nettie E. Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.6.2]
b. Abt 1870
10
Arthur D. Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.6.3]
b. Dec 1873 d. 30 Aug 1959
+
Pearl
b. Jul 1876
+
Mae G.
d. 24 Feb 1949
9
Zella Frances Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.7]
b. 10 Jun 1841 d. 4 Jul 1917
Henry J. Verser
b. Abt 1833
10
Alonzo C. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.1]
b. Jan 1873 d. 22 Dec 1915
Carrie M.
11
Viola C. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.1.1]
11
Myrtle L. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.1.2]
b. Mar 1897
10
Lula F. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.2]
b. Feb 1877
10
James H. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.3]
b. Jul 1872
+
Mabel E. le Gette
10
Charles B. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.4]
b. 1866 d. 30 Apr 1933
+
Ida M. Keney
10
Albert Dudley Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.5]
b. 14 Jan 1865 d. 27 Dec 1929
Emma F.
b. Jan 1870
11
Alvin Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.5.1]
12
Alvin Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.5.1.1]
11
Ruby F. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.5.2]
11
Pearl Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.5.3]
b. 1894
11
Clara L. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.5.4]
b. 1898
11
Ray P. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.5.5]
b. 1900
10
John H. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.6]
b. Abt 1863
+
Sophie Walter
d. 3 Sep 1943
10
Clara A. Verser
[1.1.1.5.2.3.4.1.7.7]
b. 1859
+
O. F. Hansborough
+
Googins
9
Parthena Catherine Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.8]
b. 23 Oct 1838 d. 18 Oct 1875
Dudley Wells
b. 24 Sep 1829 d. 29 May 1907
10
Leona Ogan Wells
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.1]
b. 26 Dec 1867 d. 1948
+
Henry F. Weston
10
Mary Jane% Wells
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.2]
b. 8 Aug 1858
+
Byron James Stone
+
Charles Frank
10
Martha Ann Wells
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.3]
b. 8 Aug 1858 d. 14 Jul 1947
Nelson Lee Stockton
b. 23 Aug 1853 d. 15 Jul 1923
11
Amy Lee Stockton
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.3.1]
11
Alfred James Stockton
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.3.2]
b. 27 Jan 1882 d. 16 Apr 1953
Ethel Enid Carter
b. 18 Feb 1890 d. 26 Jul 1955
12
Jack Carter Stockton
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.3.2.1]
b. 26 Mar 1919 d. 18 Jan 1965
+
Carrie Kinward
+
Agnes Isabel Quirke
11
Edna Parthena Stockton
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.3.3]
+
Carney
+
Truman James Hull
11
Marjorie May Stockton
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.3.4]
b. 10 Mar 1892 d. 17 Nov 1969
Percy Ray Mathews
12
William Stockton Mathews
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.3.4.1]
12
Bettie Lee Mathews
[1.1.1.5.2.3.4.1.8.3.4.2]
9
Mary Ann Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.1.9]
b. 19 Mar 1837 d. 14 Mar 1917
+
Wesley Parson Campbell
8
Nancy Harris
[1.1.1.5.2.3.4.2]
b. 27 May 1812
8
Teresa Harris
[1.1.1.5.2.3.4.3]
b. 22 Apr 1815 d. 1915
+
Milton Jones
b. 1812 d. 1905
8
Rebecca Harris
[1.1.1.5.2.3.4.4]
b. 27 Jul 1820
8
Cathrine Harris
[1.1.1.5.2.3.4.5]
b. 12 Apr 1822
8
Elizabeth Berry Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6]
b. 16 May 1817 d. 17 Dec 1906
James Simeral Ogan
b. 12 May 1815 d. 4 Feb 1900
9
John Higgason Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.1]
b. 23 Sep 1844 d. 1 Nov 1930
Mary M. Doty
b. 14 Jun 1848 d. 7 Apr 1918
10
Eveline Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.1.1]
b. 4 Jan 1875 d. Abt 1950
+
Grant Stutsman
d. 1943
Logan Hern
b. Abt 1865
11
John Wesley Higgenson Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.1.1.1]
b. 10 Feb 1895 d. 16 Jan 1944
12
Lawrence Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.1.1.1.1]
10
Ida May Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.1.2]
b. 19 Jul 1869 d. Bef 1880
10
Louetta Theresa Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.1.3]
b. 23 Feb 1885 d. 13 Sep 1927
J. W. Jackson
11
Ivan W. Jackson
[1.1.1.5.2.3.4.6.1.3.1]
b. 18 Nov 1907 d. 4 Nov 1931
+
Delos Giles
d. Abt 1950
10
Mary Ellen Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.1.4]
b. 11 Jun 1868 d. 1950
George S. Metcalf
11
George Metcalf
[1.1.1.5.2.3.4.6.1.4.1]
+
Taylor
9
Juliana Rachel Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.2]
b. 23 Nov 1846 d. 29 May 1912
J. Rice Hern
b. Abt 1828 d. 27 Jul 1921
10
Jay J. Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.1]
b. 21 Mar 1862 d. 12 Sep 1929
Etta E. Wraton
b. Oct 1871
11
Russell Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.1.1]
11
Carl Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.1.2]
11
Bertha M. Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.1.3]
b. Oct 1893
11
Leslie W. Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.1.4]
b. Oct 1891
11
Lenore Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.1.5]
10
Patrick M. Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.2]
b. Abt 1881
+
Anna F.
10
Carl Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.3]
b. Abt 1878
10
Elizabeth Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.4]
b. Abt 1875
+
Joel Hern
10
Jerome Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.5]
b. Abt 1870
10
Ernest Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.6]
b. Abt 1867
10
Logan Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.7]
b. Abt 1865
Eveline Ogan
b. 4 Jan 1875 d. Abt 1950
11
John Wesley Higgenson Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.7.1]
b. 10 Feb 1895 d. 16 Jan 1944
12
Lawrence Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.7.1.1]
10
George Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.8]
b. 25 Aug 1887 d. 6 Feb 1966
10
Harris Herbert Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.9]
b. 29 Nov 1883 d. 5 Oct 1971
Genevieve Bleitzman Banta
b. Abt 1887 d. Abt 1930
11
Barbara Ellen Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.9.1]
b. 16 Apr 1919 d. 30 Jan 1950
11
Emma Elizabeth Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.9.2]
+
Wayne Maxwell
11
Harriet Bernice Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.9.3]
b. 1909
William Vance
12
Shirley May Vance
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.9.3.1]
11
Helen Frances Hern
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.9.4]
William S. Reid
d. Dec 1970
12
Patricia Lynn Reid
[1.1.1.5.2.3.4.6.2.9.4.1]
+
Earl Lumar Mathiot
9
Theresa Jane Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.3]
b. 31 Aug 1838 d. 14 Nov 1918
Thomas Jefferson Maxey
b. 8 Oct 1828 d. 28 Aug 1903
10
Mary E. Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.1]
b. 4 Feb 1859 d. 26 Mar 1860
10
Alice Jane Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.2]
b. 20 Feb 1861 d. 31 Jan 1949
+
George Washington Topham
b. 13 May 1865 d. 6 Mar 1932
10
Mildred Florence Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.3]
b. 26 Oct 1867 d. 4 Jun 1938
Claude T. Trimble
11
Tevis Maxey Trimble
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.3.1]
Bernice Gruver
b. 18 Oct 1902
12
Danna Lee Trimble
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.3.1.1]
b. 28 Nov 1923 d. 18 Feb 1963
10
Clayborn Thomas Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.4]
b. 24 May 1864 d. 17 May 1944
Anna Isabelle Bose
b. 31 Aug 1866 d. 31 Mar 1948
11
Elizabeth Theresa Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.4.1]
b. 27 Oct 1904
+
Eugene Louis Demarco
11
Margaret Anne Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.4.2]
Vincent Alexander Swenson
b. 12 Feb 1913 d. 22 Mar 1970
12
Janet Lynn Swenson
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.4.2.1]
12
Laura Louise Swenson
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.4.2.2]
11
Frank Louis Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.4.3]
Georgia Lee Waddington
12
Frances Lee Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.4.3.1]
12
Beth Ann Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.4.3.2]
10
Joshua Frank Maxey
[1.1.1.5.2.3.4.6.3.5]
b. Abt 1860
9
Mary Eleanor Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.4]
b. 23 Sep 1842 d. 16 Sep 1933
Nicholas Rollins Harris
b. 1835 d. 1902
10
Nicholas Rolland Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.1]
b. 10 Mar 1874 d. 1938
+
Edna Shafer
10
James Dudley Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.2]
b. 28 Dec 1869 d. 10 Feb 1946
Susan Abbie Walker
b. 15 Mar 1883 d. 25 Jul 1956
11
Eleanor Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.2.1]
Ronald Stuart Bond
b. 15 Jul 1911 d. 10 Dec 1959
12
Linda Ann Bond
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.2.1.1]
+
Clyde C. Disher
10
Marshall C. Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.3]
b. 6 Mar 1868 d. 10 Dec 1957
Susan Surface
11
Russell S. Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.3.1]
b. 12 Feb 1896 d. 7 Apr 1970
Marjorie Williams
12
Rolland W. Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.3.1.1]
12
Warren Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.3.1.2]
10
Cyrus Harris
[1.1.1.5.2.3.4.6.4.4]
b. 15 May 1892 d. 17 May 1922
+
Annie Murphy
9
Millie Ann Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.5]
b. 24 Feb 1840 d. 5 Dec 1923
9
Sarah Catherine Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.6]
b. 19 Oct 1854 d. 27 Jul 1937
John Milton Smith
b. 1838 d. 1890
10
Marshall W. Smith
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.1]
b. 1888 d. 1889
10
Maude Smith
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.2]
b. 24 Feb 1877 d. 3 Oct 1965
William H. Diehl
d. Jan 1945
11
Dorothy Diehl
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.2.1]
b. Abt 1797
10
Nelson F. Smith
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.3]
b. 20 Apr 1884 d. 4 Mar 1965
Grace E. Hales
11
Smith
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.3.1]
Chesley M. Pinkham
12
Milton H. Pinkham
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.3.1.1]
12
Nelson B. Pinkham
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.3.1.2]
12
Donald Pinkham
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.3.1.3]
10
Roy M. Smith
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.4]
b. Apr 1882 d. 1960
10
Sadie Smith
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.5]
d. Aft 1965
Ed Bronk
d. Bef 1965
11
Kenneth Bronk
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.5.1]
Joseph Christopher Martin
b. 6 Nov 1853 d. 26 Dec 1922
10
Guelda Lane Martin
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.6]
b. 30 Jun 1896 d. 25 May 1967
Joseph Weiland Schweizer
b. 29 Nov 1891 d. 16 May 1961
11
John Joseph Schweizer
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.6.1]
Marga Marie Gregory
12
Marla Sue Schweizer
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.6.1.1]
11
Marie Dorothy Schweizer
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.6.2]
Angelo Peter Granaroli
12
David Martin Granaroli
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.6.2.1]
12
Carolyn Giovanni Granaroli
[1.1.1.5.2.3.4.6.6.6.2.2]
9
Harrison William Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.7]
b. 12 Apr 1860 d. Bef 1869
9
James Washington Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8]
b. 13 Feb 1857 d. 4 Jan 1933
Ada Ann Spooner
b. 26 Feb 1851 d. 14 Feb 1931
10
Ralph Milo Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.1]
b. 28 May 1889 d. 24 Aug 1970
+
Edna Mae Hansen
b. 9 Sep 1880 d. 16 Jan 1954
+
Mary Frances Fern-Fisk Moss Ashmore
b. 6 May 1913 d. 21 Oct 1970
10
Elizabeth Cornelia Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.2]
b. 20 Jul 1880 d. 7 Mar 1970
Harbron Williams Morris
b. 10 Feb 1885 d. 1949
11
Marion Elizabeth Morris
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.2.1]
Curtis Gerald Linkey
b. 23 Jul 1908
12
Lila Morris Linkey
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.2.1.1]
George Andrew Mangis
12
Martha Elizabeth Mangis
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.2.1.2]
11
Frances Harbron Morris
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.2.2]
Edgar William Morris, Jr
12
James Gregory Morris
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.2.2.1]
12
Barbara Jane Morris
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.2.2.2]
10
Milton Ellsworth Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.3]
b. 27 Oct 1884 d. 13 Jan 1898
10
Perry Warren Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.4]
b. 13 Feb 1883 d. 20 Oct 1949
10
Rolland James Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.5]
b. 14 Nov 1886 d. 3 Sep 1966
Myrtle Ella Treloar
b. 20 Mar 1889 d. 4 Aug 1967
11
Reginald Treloar Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.5.1]
Donna May Buker
12
Chester Vance Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.5.1.1]
12
Laura Lee Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.5.1.2]
12
Susan Elizabeth Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.5.1.3]
10
Charles Simeral Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.8.6]
b. Oct 1879 d. 5 Oct 1956
+
Maude Anna Tregoning
b. 25 Jan 1881 d. 1 May 1953
+
Frances Cora Autchins
9
Ogan
[1.1.1.5.2.3.4.6.9]
d. INFANT
8
Mary Harris
[1.1.1.5.2.3.4.7]
b. 3 Dec 1801
+
James Miller
8
Thomas Harris
[1.1.1.5.2.3.4.8]
b. 20 Dec 1802
8
Tyree Harris
[1.1.1.5.2.3.4.9]
b. 1803 d. 16 May 1846
+
Nancy Harris Jones
b. 1803 d. Aft 1860
8
Sarah Harris
[1.1.1.5.2.3.4.10]
b. 23 Sep 1804 d. 17 Nov 1893
David Rice
b. 4 Sep 1800 d. 28 Mar 1886
9
Higgason Harris Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1]
b. 6 Jun 1831 d. 16 Sep 1923
+
Martha Hagan
b. Jul 1835
Sarah E. Sappington
b. Abt 1855 d. 2 Jan 1882
10
Sarah E. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.1]
b. 17 Jul 1876
Jess Olds
11
William Harris Olds
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.1.1]
b. 1908 d. 1911
11
Clarence Rice Olds
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.1.2]
+
Dolly Dent
11
Lorraine Olds
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.1.3]
+
Waldo Wade
b. 1894
+
lon F. McQuitty
10
Tyre Harris Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.2]
Myrtle M. Bullard
b. Abt 1885
11
Martha Elizabeth Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.2.1]
b. 21 Nov 1907
Clifford O. Carr
12
Lorene C. Carr
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.2.1.1]
[
=>
]
12
Lillian Beatrice Carr
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.2.1.2]
[
=>
]
+
Kenneth Holmes
11
Elmore Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.2.2]
b. 3 Jun 1911 d. Sep 1964
Lucille Derring
12
Michael Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.2.2.1]
11
Hollis Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.2.3]
Helen
d. 10 Oct 1969
12
Robert Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.2.3.1]
10
Parmer Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.3]
b. 7 Mar 1880 d. 21 Jun 1914
Elizabeth Frances Telljohn
11
Kenneth Palmer Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.3.1]
Racine Brown
12
Carolyn Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.3.1.1]
[
=>
]
+
Roslaind Kane
11
Mildred Irene Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.3.2]
b. 16 Sep 1911
11
Virgil E. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.3.3]
b. 23 Aug 1908
+
Mable R. Rice
+
Maureen Sapp
11
Una Lampkin Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.3.4]
b. 18 Jan 1906
Clare Luther Thomas
12
Loa Kay Thomas
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.3.4.1]
[
=>
]
10
Joseph Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.4]
b. Feb 1880
10
Mary S. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.5]
b. Abt 1875 d. 27 Aug 1936
Mary Sapshire Cropper
b. 27 Nov 1837 d. 11 Jun 1874
10
Lelia B. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.6]
b. 20 Jul 1870 d. 20 Dec 1957
Benjamin B. Manford
b. 24 Jan 1857 d. 3 Dec 1935
11
William Berkeley Manford
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.6.1]
11
Van Camp Manford
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.6.2]
b. 17 Apr 1890 d. 28 Jan 1960
Beulah
b. Cal 1897
12
Jack Manford
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.6.2.1]
12
Harold Manford
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.6.2.2]
+
Hattie
11
Olepha Manford
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.6.3]
b. Cal 1894
10
William F. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.7]
b. 15 Aug 1871 d. 11 Sep 1954
Bessie H. Olds
b. 20 Aug 1883
11
Estelle Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.7.1]
b. Abt 1903
William Buescher
12
Maribeth Buescher
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.7.1.1]
[
=>
]
12
Carolyn Beth Buescher
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.7.1.2]
[
=>
]
12
James Wesley Buescher
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.7.1.3]
[
=>
]
12
Una Mae Buescher
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.7.1.4]
[
=>
]
12
Sarah Estelle Buescher
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.7.1.5]
[
=>
]
12
Rose Marie Buescher
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.7.1.6]
[
=>
]
10
Mary S. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.8]
b. Est 1874/1875
10
John Richard Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9]
b. 17 Dec 1859
Henizella Easley
b. 16 Oct 1867 d. Aft 1934
11
Gertrude Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.1]
Walter Overstreet
b. 11 Jan 1887 d. 22 Feb 1958
12
Raymond Overstreet
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.1.1]
[
=>
]
11
Charles Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.2]
b. 13 Oct 1889 d. Jun 1964
Rose Mueller
12
Dorthy Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.2.1]
11
Myrtle Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.3]
b. 5 Jul 1891
Ray Jones
12
Catherine Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.3.1]
[
=>
]
12
Norton P. Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.3.2]
[
=>
]
11
Osa B. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.4]
b. 31 Mar 1894 d. Mar 1967
Boyd Edwards
12
Gordon Edwards
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.4.1]
[
=>
]
12
James Edwards
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.4.2]
11
Arthur Bryan Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.5]
Anna Rose Caspari
b. 1889
12
Arthur Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.5.1]
12
Ruth Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.5.2]
12
Lorraine Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.5.3]
11
Margaret W. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.6]
b. 13 Feb 1898
Orsen King
b. Abt 1880
12
Margie King
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.6.1]
[
=>
]
11
Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.9.7]
b. 15 Aug 1902 d. 1902
+
Collie Robinson
10
David G. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.10]
b. 8 Oct 1857 d. 19 Mar 1943
Mary Lizzie Davis
b. Abt 1869
11
Harold F. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.10.1]
b. Abt 1912
Muriel Jakes
12
Joseph Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.10.1.1]
[
=>
]
12
Barbara Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.10.1.2]
[
=>
]
12
Wayne Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.10.1.3]
[
=>
]
11
Garland L. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.10.2]
11
Lloyd Franklin Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.10.3]
11
Vesta Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.10.4]
10
Franklin D. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.11]
b. 23 Sep 1862 d. 27 Mar 1936
Mae Howell
11
Harris Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.11.1]
11
Ailene Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.11.2]
10
Penelope Winslow Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.1.12]
b. Abt 1866
9
Sarah E. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.2]
b. 14 Aug 1846 d. 20 Aug 1954
Edward Camplin Burnett
b. 13 Oct 1838 d. 10 Jan 1894
10
Cornelius F. Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.1]
b. 27 Dec 1874 d. 17 Mar 1880
10
Minnie E. Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.2]
b. Abt 1871 d. 1909
10
Lora Lee Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.3]
b. 23 Oct 1877 d. 28 Jan 1893
10
John Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.4]
b. Aug 1883
May Barnett
11
Lora Bess Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.4.1]
11
Mildred Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.4.2]
11
Leon Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.4.3]
10
Carrie Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.5]
b. 22 Jun 1880 d. 6 Dec 1963
Odis Zumwalt
b. 19 Jan 1880 d. Nov 1963
11
Cletus Zumwalt
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.5.1]
11
Fredia Zumwalt
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.5.2]
10
Sallie Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.6]
+
Jack Martyn
b. 6 Dec 1891
10
Edward Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.7]
Ara Nichols
11
Ray Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.7.1]
11
E. P. Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.7.2]
11
Spencer Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.7.3]
11
Wallace Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.7.4]
11
Harry Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.7.5]
11
Ruth Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.7.6]
11
Gladys Fay Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.7.7]
10
Frank Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.8]
10
Mamie Burnett
[1.1.1.5.2.3.4.10.2.9]
b. Mar 1895
9
John J. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3]
b. 17 Mar 1836 d. 11 Jul 1910
Isabelle J. Nichols
b. 2 Jan 1840 d. 20 Jul 1879
10
Oren Crane Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.1]
b. 26 Oct 1872 d. 18 Jan 1896
10
Cora Lee Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.2]
b. 12 Oct 1870 d. 10 Jul 1894
10
Luther H. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.3]
b. 8 Sep 1866 d. 6 Apr 1938
+
Fannie M. Quarles
b. 8 Sep 1857 d. 20 Feb 1938
10
Celsus D. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4]
b. 7 Jul 1868 d. 8 Jul 1958
Laura G. Green
b. 21 Jul 1870 d. 18 Nov 1926
11
Herbert F. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.1]
b. 9 Jun 1900 d. 18 Apr 1958
Mona Elaine Klingner
12
Joseph Weldon Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.1.1]
12
Dorothy Elaine Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.1.2]
11
Howard B. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.2]
Alma Estes
b. 23 Jun 1910
12
Larry Gene Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.2.1]
[
=>
]
12
Carol Jane Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.2.2]
12
Sally Lou Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.2.3]
[
=>
]
11
Susan I. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.3]
b. 17 Mar 1908
Paul Rose
12
Sylvia Rose
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.3.1]
[
=>
]
12
Jerry Paul Rose
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.4.3.2]
+
Kenneth Polson
10
Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.3.5]
b. Aft 1865 d. INFANT
+
Sallie A. Douglass
b. Abt 1846 d. 15 Sep 1888
9
David Barton Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.4]
b. 7 Mar 1849 d. 2 May 1929
Nancy B. Slater
b. Aug 1857 d. 12 Apr 1926
10
Charles Perry Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.4.1]
b. 19 Jul 1882 d. 17 Mar 1885
10
Mary M. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.4.2]
b. May 1888
Burdette Martin
11
Joella Martin
[1.1.1.5.2.3.4.10.4.2.1]
10
Kate Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.4.3]
b. Sep 1884
+
Floyd Forsee
10
Lottie Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.4.4]
b. May 1886
+
Wallace Rice
9
Henry Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.5]
b. Abt 1831 d. Bef 1882
9
Mosias Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.6]
b. 14 Dec 1838
9
Julina Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.7]
b. 17 Aug 1833 d. 4 Apr 1924
Tyree N. Jones
b. 3 May 1832 d. 29 Jan 1882
10
Mosias D. Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.1]
b. Abt 1859
10
John Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.2]
b. Est 1860/1870
10
Mary J. Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.3]
b. Abt 1861
10
Savilla Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.4]
b. Abt 1873
10
Leander Perry Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.5]
b. 6 Aug 1857 d. 7 Jul 1947
Alice Northway Coonce
b. 29 Jul 1858 d. 13 Feb 1889
11
Ocra E. Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.5.1]
b. 27 Sep 1888 d. 7 Apr 1891
11
Charles Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.5.2]
11
Iva Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.5.3]
Mary Belle Wallace
b. 14 Apr 1858 d. 19 Dec 1945
11
Ray Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.5.4]
10
Sarah E. Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6]
b. 2 Nov 1853 d. 23 Dec 1921
Richard Crenshaw
b. 21 May 1853
11
Elmer Crenshaw
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6.1]
Maude Morris
12
Joe Perry Crenshaw
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6.1.1]
b. 28 Apr 1903 [
=>
]
11
Nellie Maude Crenshaw
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6.2]
Lawerance Richard Sapp
12
Opal Sapp
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6.2.1]
12
Kenneth Sapp
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6.2.2]
12
Martin Sapp
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6.2.3]
12
Adrain Sapp
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6.2.4]
11
Mary Crenshaw
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.6.3]
+
Forbes
10
Doll Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.7]
Bev Hart
11
Nellie Hart
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.7.1]
+
Raymond Mountjoy
11
Virginia Hart
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.7.2]
+
John Luckley
10
Isabelle Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.8]
10
Lidy Jones
[1.1.1.5.2.3.4.10.7.9]
9
Martha A. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.8]
b. 20 Mar 1843 d. 26 Dec 1878
William P. Boqua
b. 14 Jan 1833 d. 27 Nov 1891
10
Sarah Boqua
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.1]
b. Abt 1878
10
Laura Boqua
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.2]
b. Abt 1871
10
Dora Boqua
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.3]
b. Abt 1873
Lee Vandiver
11
William Vandever
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.3.1]
b. Bef 1893
+
Mary Delmore
b. 1873 d. 4 Jul 1936
11
Jose Vandiver
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.3.2]
11
Boqua Vandiver
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.3.3]
11
Dorthy Vandiver
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.3.4]
11
Clyde Vandiver
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.3.5]
11
Rollie Vandiver
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.3.6]
11
Archie Vandiver
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.3.7]
10
Rosa Boqua
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.4]
b. Abt 1877
Claude Christian
11
Lorraine Christian
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.4.1]
11
Carl Christian
[1.1.1.5.2.3.4.10.8.4.2]
9
Amanda Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.9]
b. 29 Jan 1830 d. 24 Jul 1868
Caleb Armitage
b. Abt 1823 d. Bef 11 Sep 1871
10
Sarah Francis Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1]
b. 21 Jun 1850 d. 16 Jun 1933
James M. Delmore
b. 1844/1845
11
Thomas E. Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.1]
b. Jul 1870
+
Ellen
b. Aft 1850
11
William David Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.2]
b. Feb 1872 d. 6 Apr 1949
+
Grace May DeFord
b. Bef 1890
11
Mary Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.3]
b. 1873 d. 4 Jul 1936
+
William Vandever
b. Bef 1893
11
James Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.4]
b. 1875
+
Gussie
b. Aft 1855
11
Manda Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.5]
b. 1877
11
Henry Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.6]
b. 1879
11
Elizabeth Lucille Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.7]
b. 1888
+
John R. Williams
b. Aft 1850
11
Ann Clare Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.8]
b. 11 Sep 1889 d. 5 Sep 1970
+
Halleck
b. Aft 1850
+
F. F. Tryon
b. Aft 1850
11
Victor Delmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.1.9]
b. 1891 d. 1945
10
Julia K. Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2]
b. 1859 d. 1942
Philip J. Gilmore
b. 1854 d. 1941
11
Nora Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.1]
b. Abt 1879
+
Ben Skinner
Allen
12
Mary Allen
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.1.1]
12
Alma Allen
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.1.2]
Chappman
12
Philip Chappman
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.1.3]
12
Rosella Chappman
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.1.4]
12
Geneva Chappman
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.1.5]
11
John E. Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.2]
b. 21 Nov 1884 d. 15 Sep 1913
+
Stella
11
Fritz Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.3]
b. 14 Sep 1900 d. 15 Oct 1901
11
Louis Ancil Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.4]
b. 24 Jun 1896 d. 13 Feb 1962
11
Keith Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.5]
b. 10 Mar 1900 d. 7 Feb 1971
Mena Proctor
b. 8 Feb 1903
12
Kenneth Keith Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.5.1]
[
=>
]
12
Karl Richard Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.5.2]
[
=>
]
11
Ann Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.6]
+
Charles Sutton
11
Roy Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.7]
Josephine Dennis
12
Goldie Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.7.1]
12
Woodrow Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.7.2]
11
Nettie Gilmore
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.2.8]
10
Nettie Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.3]
b. Abt 1862
+
Minor Ballenger
b. Abt 1853
10
Higgason Harrison Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.4]
b. 20 Oct 1855 d. 23 Feb 1941
10
John Fletcher Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.5]
b. 7 Jun 1853 d. 16 Jun 1929
+
Mary J. Jamison
b. Bef 1868
10
William D. Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.6]
b. 1848 d. 26 Dec 1863
10
G. Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.7]
b. Abt 1863
10
Andrew Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.8]
b. Abt 1866
10
Everett Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.9]
b. Abt 1866
10
Eva Armitage
[1.1.1.5.2.3.4.10.9.10]
9
Thomas B. Rice
[1.1.1.5.2.3.4.10.10]
b. 21 Jun 1841
8
Garland Harris
[1.1.1.5.2.3.4.11]
b. 14 Apr 1807
8
Jr. Higgason Harris
[1.1.1.5.2.3.4.12]
7
Nancy Harris
[1.1.1.5.2.3.5]
b. Abt 1785
+
William Stone
7
Lucy Harris
[1.1.1.5.2.3.6]
b. 1770 d. Bef 1839
7
Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.3.7]
b. 7 May 1782 d. 1838
6
Tyree Harris
[1.1.1.5.2.4]
b. 24 Jun 1751 d. 1752/1841
6
Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.5]
b. 9 May 1752 d. 1753/1846
6
Mourning Harris
[1.1.1.5.2.6]
b. 4 Jun 1754 d. 1755/1848
+
Foster Jones
d. 1814
6
Christopher Harris
[1.1.1.5.2.7]
b. 21 Jul 1755 d. 27 Jul 1841
Elizabeth Grubbs
7
Tyree Harris Harris
[1.1.1.5.2.7.1]
b. 21 Feb 1778
7
Nancy Harris
[1.1.1.5.2.7.2]
b. 2 Feb 1782
+
Josiah Thorpe
7
Mourning Harris
[1.1.1.5.2.7.3]
b. 31 Oct 1783 d. 4 Jul 1865
+
Zacariah Thorpe
7
Robert Harris
[1.1.1.5.2.7.4]
b. 6 Mar 1787
Mary Taylor
b. 24 Sep 1778 d. 18 Apr 1858
8
Shelton Harris
[1.1.1.5.2.7.4.1]
b. 20 Sep 1820 d. 9 May 1896
+
Caroline Duncan
Martha Thorpe
9
Mary Emma Harris
[1.1.1.5.2.7.4.1.1]
9
Robert Harris
[1.1.1.5.2.7.4.1.2]
+
Theresa Anderson
8
Fannie Harris
[1.1.1.5.2.7.4.2]
+
Thomas Coyle
8
Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.7.4.3]
+
Joseph Pearson
8
James Harris
[1.1.1.5.2.7.4.4]
Mary Searcy
9
Caroline Harris
[1.1.1.5.2.7.4.4.1]
+
Jeremiah Broadduss
9
Fannie Harris
[1.1.1.5.2.7.4.4.2]
9
Mattie Harris
[1.1.1.5.2.7.4.4.3]
9
Joseph Harris
[1.1.1.5.2.7.4.4.4]
+
Callie Gaines
9
Robert Harris
[1.1.1.5.2.7.4.4.5]
+
Leslie Hurley
8
Mary Harris
[1.1.1.5.2.7.4.5]
+
Bolin
8
Hensley Harris
[1.1.1.5.2.7.4.6]
Emma Benton
9
Minnie Harris
[1.1.1.5.2.7.4.6.1]
9
Hattie Harris
[1.1.1.5.2.7.4.6.2]
9
Amanda Harris
[1.1.1.5.2.7.4.6.3]
7
Thomas Harris
[1.1.1.5.2.7.5]
b. 18 Jan 1780 d. 1806
+
Mary Annie Booten
6
Mary Harris
[1.1.1.5.2.8]
b. 10 Jun 1757 d. 1758/1851
+
George Jones
Agnes McCord
b. 1723/1749 d. 1784/1839
6
William Harris
[1.1.1.5.2.9]
b. 12 Nov 1768 d. 1799/1859
Ann Oldham
b. 1773 d. 1796/1867
7
Richard M. Harris
[1.1.1.5.2.9.1]
b. 1790/1816 d. 1823/1896
+
Louisa Oldham
b. 1789/1823 d. 1823/1904
7
Jesse Harris
[1.1.1.5.2.9.2]
b. 1790/1816 d. 1823/1896
+
Jemima Fowler
b. 1789/1823 d. 1823/1904
7
Agnes M. Harris
[1.1.1.5.2.9.3]
b. 1790/1814 d. 1836/1902
+
Milton Oldham
b. 1779/1811 d. 1836/1898
+
Jessie Oldham
b. 1764/1784 d. 1799/1868
6
Samuel Harris
[1.1.1.5.2.10]
b. 1 Sep 1777 d. 1840
+
Nancy Wilkerson
b. 1773/1792 d. 1808/1877
6
Barnabas Harris
[1.1.1.5.2.11]
b. 1 Oct 1779 d. 1810/1869
+
Elizabeth Oldham
b. 1775/1795 d. 1810/1879
6
Overton Harris
[1.1.1.5.2.12]
b. 25 Oct 1782 d. 1827
+
Nancy Oldham
b. 1778/1798 d. 1813/1882
6
Jane Harris
[1.1.1.5.2.13]
b. 18 Sep 1763 d. 1820
Richard Gentry
b. 1763 d. 1793
7
David Gentry
[1.1.1.5.2.13.1]
b. 1787
Susannah Maupin
b. Abt 1790 d. 2 Feb 1858
8
Elizabeth Gentry
[1.1.1.5.2.13.1.1]
b. 1805 d. 1851
8
Marcus Gentry
[1.1.1.5.2.13.1.2]
8
Benjamin Gentry
[1.1.1.5.2.13.1.3]
8
Jane Gentry
[1.1.1.5.2.13.1.4]
+
William Stevenson
8
Nancy Gentry
[1.1.1.5.2.13.1.5]
+
William Means
8
Sidney Gentry
[1.1.1.5.2.13.1.6]
+
Margaret Robinson
7
Richard Gentry
[1.1.1.5.2.13.2]
6
John Harris
[1.1.1.5.2.14]
b. 14 Mar 1765 d. 1810
Margaret Maupin
b. 1 Feb 1767 d. 25 Oct 1855
7
John Harris
[1.1.1.5.2.14.1]
b. 4 Dec 1795 d. 7 Aug 1873
Henrietta Simpson
b. 2 Feb 1804 d. 24 Apr 1881
8
Josephine Harris
[1.1.1.5.2.14.1.1]
b. 28 Jun 1832 d. 11 Jan 1913
Charles Esmonde Kearney
b. 8 Mar 1820 d. 3 Jan 1898
9
Jr. Charles Esmonde Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1]
b. 9 Sep 1870 d. 28 Jan 1953
Rollena Merritt Gilluly
b. 4 May 1869 d. 4 Sep 1947
10
Margaret Josephine Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.1]
b. 3 Aug 1904 d. Jul 1965
+
Albert W. Trummel
10
III Charles Esmonde Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2]
Isabel Perry Heisler
11
Barbara Joyce Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.1]
Jardon Strnad
12
Sarah Elizabeth Strnad
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.1.1]
12
Philip Charles David Strnad
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.1.2]
11
Ann Esmonde Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.2]
Wilbur Darrel Boroughs
12
William Dean Boroughs
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.2.1]
[
=>
]
12
Susan Gail Boroughs
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.2.2]
12
Paul Bartley Boroughs
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.2.3]
11
Margaret Merritt Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.3]
+
Walter Eugene Combs
Raymond Joseph Mead
12
Doris Lynn Mead
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.3.1]
[
=>
]
12
Charles Eugene Mead
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.3.2]
[
=>
]
12
Jane Isabel Mead
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.3.3]
[
=>
]
12
Andrew Joseph Mead
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.2.3.4]
10
James Walton Wheeler Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.3]
Dorothy Jane
11
James Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.3.1]
b. Abt 1940 d. Abt 1945
Alta Viola Harper
10
Robert E. Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.4]
Lola Joy Morrison
11
Robert Charles Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.4.1]
Leisha Colleen Sorrells
12
Whitney Gayle Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.4.1.1]
11
David Winston Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.1.4.2]
+
Laura Orsheln
9
Francis Esmonde Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.2]
b. 27 Aug 1853 d. 4 May 1855
9
Mary Louise Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.3]
b. 17 Feb 1856 d. 28 Sep 1950
9
Julia M. Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.4]
b. 1 Sep 1858 d. 13 Feb 1935
+
Frank Wornall
b. 1841/1861 d. 1886/1947
9
Elizabeth Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.5]
b. 1866 d. 1894/1960
+
John L. Nofsinger
b. 1849/1869 d. 1894/1955
9
William Bernard Kearney
[1.1.1.5.2.14.1.1.6]
b. 20 Nov 1860 d. 15 Aug 1862
8
Henrietta S. Harris
[1.1.1.5.2.14.1.2]
b. 18 May 1823 d. 24 Mar 1859
Joel Lipscomb
b. 21 Oct 1813 d. 27 Dec 1893
9
Henrietta Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.1]
b. 19 Mar 1859 d. 20 Mar 1859
9
Nathan Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.2]
b. 3 Jul 1843 d. 12 Aug 1906
+
Letitia Cantrett
b. 1837/1860 d. Oct 1922
9
William S. Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.3]
b. 1842 d. 25 Jun 1863
9
Louisa S. Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.4]
b. 1845 d. 1876/1939
+
John E. Watson
b. 1824/1851 d. 1876/1937
9
Francis Malcomb Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.5]
b. 1 Jul 1847 d. 4 Apr 1944
+
William Zere Hickman
b. 13 Aug 1845 d. 31 Mar 1921
9
John Harris Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.6]
b. 1849 d. 3 Aug 1929
9
R. Bernard Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.7]
b. 1856 d. 3 Sep 1911
9
James H. Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.8]
b. 1857 d. 1858/1947
9
Zachary T. Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.9]
b. 1848 d. 1849/1938
9
Jr. Joel Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.10]
b. 11 May 1851 d. 8 Aug 1854
9
Charles H. Lipscomb
[1.1.1.5.2.14.1.2.11]
b. 17 May 1853 d. 2 Sep 1854
8
Mary Frances Harris
[1.1.1.5.2.14.1.3]
b. 9 Dec 1825 d. 26 Jun 1910
+
Charles B. McCarty
b. 4 Oct 1821 d. 23 Jun 1852
Seth Edmund Ward
b. 4 Mar 1820 d. 9 Dec 1903
9
Hugh Campbell Ward
[1.1.1.5.2.14.1.3.1]
b. 10 Mar 1863 d. 15 Aug 1909
+
Vassie James
b. 1857/1881 d. 1903/1969
9
John Edmund Ward
[1.1.1.5.2.14.1.3.2]
b. 21 Jun 1861 d. 1862/1951
9
Mary F. Ward
[1.1.1.5.2.14.1.3.3]
b. 1842/1868
8
John Simpson Harris
[1.1.1.5.2.14.1.4]
b. 22 Aug 1827 d. 16 Feb 1897
Ann Wood
b. 17 Dec 1844 d. 18 Jun 1931
9
Jorinne Harris
[1.1.1.5.2.14.1.4.1]
b. 16 Jul 1865 d. 1930
+
William Mather Turner
b. 1843/1870 d. 1895/1956
9
John Joseph Harris
[1.1.1.5.2.14.1.4.2]
b. 16 Jul 1867 d. 9 Aug 1941
+
Ruth Brough Moore
b. 1860/1882 d. 1904/1970
9
Arthur Harris
[1.1.1.5.2.14.1.4.3]
b. 27 Feb 1869 d. 29 Jul 1870
9
O'Verta Harris
[1.1.1.5.2.14.1.4.4]
b. 21 May 1871 d. 22 Nov 1929
+
Frank Joseph Pfahler
b. 1850/1877 d. 1902/1963
9
Virginia Harris
[1.1.1.5.2.14.1.4.5]
b. 28 Mar 1873 d. 17 Feb 1874
8
Julia Ann Harris
[1.1.1.5.2.14.1.5]
b. 31 Jan 1829 d. 29 Aug 1922
+
John J. Mastin
b. 14 Dec 1830 d. 7 Aug 1890
8
Susan Harris
[1.1.1.5.2.14.1.6]
b. 27 Jun 1834 d. 9 Apr 1895
William Rodney Bernard
b. 8 Dec 1823 d. 25 Nov 1906
9
Jr. William R. Bernard
[1.1.1.5.2.14.1.6.1]
b. 6 Apr 1867 d. 30 Aug 1867
9
Annie E. Bernard
[1.1.1.5.2.14.1.6.2]
b. 6 Jun 1868 d. 25 Jan 1902
9
Nettie Bernard
[1.1.1.5.2.14.1.6.3]
b. 1847/1874 d. Jul 1913
+
Frank Henderson
b. 1838/1873 d. Jun 1911
8
Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.14.1.7]
b. 16 Jan 1841 d. 10 Sep 1922
Thomas Hoyle Mastin
b. 11 Dec 1839 d. 24 Jun 1905
9
Jr. John J. Mastin
[1.1.1.5.2.14.1.7.1]
b. Mar 1870 d. 31 Mar 1899
9
Jack Adams Mastin
[1.1.1.5.2.14.1.7.2]
b. Mar 1870 d. 1871/1964
9
Theo Mastin
[1.1.1.5.2.14.1.7.3]
b. 1859/1886 d. 1890/1969
+
E. Edgar Lovejoy
b. 1849/1884 d. 1890/1963
9
Thomas H. Mastin
[1.1.1.5.2.14.1.7.4]
b. 1859/1886 d. 1865/1966
8
Sarah Ann Harris
[1.1.1.5.2.14.1.8]
b. 24 Mar 1820 d. 24 Apr 1898
Peter Behan
b. 18 Dec 1809 d. 10 Jun 1889
9
Katherine M. Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.1]
b. 1839 d. Apr 1915
+
Samuel J. Huffaker
b. 1830 d. May 1897
9
John Harris Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.2]
b. 25 Oct 1845 d. 7 Jun 1912
9
Laura Smith Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.3]
b. 1847 d. 1848/1941
9
Silas Price Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.4]
b. 1850 d. 26 Apr 1900
Lillie Ella Jones
b. 11 Nov 1861
10
Eugene Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.4.1]
b. 23 Apr 1883
10
Roscoe Julian Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.4.2]
b. 25 Sep 1896 d. 29 May 1965
+
Marie O'Keefe
10
Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.4.3]
b. 7 Mar 1889
9
Julia Mastin Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.5]
b. 1855 d. Aft 1892
9
Susan Ann Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.6]
b. 23 Mar 1859 d. 13 Jul 1938
+
Robert Campbell Price
b. 1842/1862 d. 1911
9
Hugh Gary Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.7]
b. 1864 d. 1 Nov 1909
9
Jr. Peter Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.8]
b. 1866 d. 1867/1956
9
Henrietta Behan
[1.1.1.5.2.14.1.8.9]
b. 1841 d. 1842/1935
7
Robert Harris
[1.1.1.5.2.14.2]
b. 27 Oct 1786 d. 1817/1876
Jael Ellison
b. 1782/1802 d. 1817/1886
8
William Christopher Harris
[1.1.1.5.2.14.2.1]
Lyda Francis
9
Overton Woods Harris
[1.1.1.5.2.14.2.1.1]
9
Robert Rodes Harris
[1.1.1.5.2.14.2.1.2]
9
Thomas Francis Harris
[1.1.1.5.2.14.2.1.3]
9
Mary Bohanan Harris
[1.1.1.5.2.14.2.1.4]
9
Eliza Christopher Harris
[1.1.1.5.2.14.2.1.5]
8
Joseph Ellison Harris
[1.1.1.5.2.14.2.2]
b. 13 Jan 1821
+
Jennie McDonald
Eva Bishop
9
May Harris
[1.1.1.5.2.14.2.2.1]
9
Mary Ann Harris
[1.1.1.5.2.14.2.2.2]
+
Charles Bowling
9
Malinda Harris
[1.1.1.5.2.14.2.2.3]
+
Fred Rettish
9
Pearl Harris
[1.1.1.5.2.14.2.2.4]
+
George Walker
9
Ada Harris
[1.1.1.5.2.14.2.2.5]
+
William Muff
9
Robert M. Harris
[1.1.1.5.2.14.2.2.6]
+
Anna Payne
8
Jael Kavanaugh Harris
[1.1.1.5.2.14.2.3]
b. 30 Sep 1824
+
Martin B. Garvin
8
Malinda Miller Harris
[1.1.1.5.2.14.2.4]
b. 20 Sep 1822
+
Anderson Yates
8
James Overton Harris
[1.1.1.5.2.14.2.5]
b. 22 Apr 1829
Abigail Chamberlain
9
William Harris
[1.1.1.5.2.14.2.5.1]
9
John Harris
[1.1.1.5.2.14.2.5.2]
9
Annie Pauline Harris
[1.1.1.5.2.14.2.5.3]
8
Nancy Hocker Harris
[1.1.1.5.2.14.2.6]
b. 28 Apr 1831
8
Susan Miller Harris
[1.1.1.5.2.14.2.7]
b. 8 Jun 1833
+
Benjamin Franklin Crooke
8
Sarah Wallace Harris
[1.1.1.5.2.14.2.8]
b. 26 Dec 1835
8
Pauline Rodes Harris
[1.1.1.5.2.14.2.9]
b. 17 Nov 1826
8
Mary Ann Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.14.2.10]
b. 4 Sep 1814 d. 1904
James Cooper
b. Feb 1814 d. 1895
9
Eberle Bascom Cooper
[1.1.1.5.2.14.2.10.1]
b. 1843 d. 1917
+
Ellen E. Lowen
8
Margaret Frances Harris
[1.1.1.5.2.14.2.11]
b. 27 May 1819
+
Simeon Hume
8
Robert Rodes Harris
[1.1.1.5.2.14.2.12]
b. 17 Nov 1816
Turner
9
Robert Rodes Harris
[1.1.1.5.2.14.2.12.1]
8
John McCord Harris
[1.1.1.5.2.14.2.13]
b. 4 Mar 1813
Ellen Anderson
9
Robert Harris
[1.1.1.5.2.14.2.13.1]
9
Nannette Harris
[1.1.1.5.2.14.2.13.2]
+
William Willis
+
Garrison
7
Christopher Harris
[1.1.1.5.2.14.3]
b. 1 Apr 1788 d. 14 Apr 1871
+
Elizabeth Berry
b. 5 Feb 1800 d. 1884
Sally Wallace
b. Sep 1787 d. 26 Oct 1836
8
Christopher Harris
[1.1.1.5.2.14.3.1]
b. 20 Apr 1819 d. Abt 16 Jul 1860
8
James Anderson Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2]
b. Abt 1817
Susan Taylor
9
Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.1]
b. Abt 1850
+
Harry Bush
9
Susan Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.2]
+
George R. Engleman
9
Margaret Miller Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.3]
+
Ephraim Woods
9
Annie Montgomery Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.4]
+
Frank Engleman
9
Samuel Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.5]
9
Reuben Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.6]
Eliza Engleman
10
Samuel Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.6.1]
10
Lavisa Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.6.2]
10
James Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.6.3]
9
Nannie Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.7]
+
George P. Bright
9
Sally Wallace Harris
[1.1.1.5.2.14.3.2.8]
+
Samuel Baughman
8
Tabitha Harris
[1.1.1.5.2.14.3.3]
b. 17 Mar 1815 d. 2 Jan 1882
+
Christopher Irvine Miller
8
Ann Eliza Harris
[1.1.1.5.2.14.3.4]
b. 18 Jun 1813
+
Robert Covington
8
John Miller Wallace Harris
[1.1.1.5.2.14.3.5]
b. 30 May 1821 d. 15 Sep 1862
8
Mary Woods Harris
[1.1.1.5.2.14.3.6]
b. 25 Sep 1823 d. 1903
+
John M. Park
8
Sarah Overton Harris
[1.1.1.5.2.14.3.7]
b. 10 Jul 1828
+
Thomas Moberley Oldham
8
Margaret Frances Harris
[1.1.1.5.2.14.3.8]
b. 8 Apr 1826 d. 13 Aug 1900
+
Joseph Warren Moore
7
Overton Harris
[1.1.1.5.2.14.4]
b. 24 Nov 1789 d. 1844
Mary Rice Woods
b. 24 Sep 1795 d. 31 Aug 1876
8
John Woods Harris
[1.1.1.5.2.14.4.1]
b. 31 Aug 1816
Ann Mary McClure
9
Frances Bond Harris
[1.1.1.5.2.14.4.1.1]
9
John Woods Harris
[1.1.1.5.2.14.4.1.2]
Susan Oldham
10
Jr. John Woods Harris
[1.1.1.5.2.14.4.1.2.1]
10
Mary Harris
[1.1.1.5.2.14.4.1.2.2]
9
Martha Maupin Harris
[1.1.1.5.2.14.4.1.3]
+
William Jackson Hendricks
9
Virgil McClure Harris
[1.1.1.5.2.14.4.1.4]
+
Isabel McKinley
9
Jane Woods Harris
[1.1.1.5.2.14.4.1.5]
+
John Johnson Rogers
8
William Anderson Harris
[1.1.1.5.2.14.4.2]
b. 25 Mar 1823
Elizabeth Robnett
9
Pleasant Robnett Harris
[1.1.1.5.2.14.4.2.1]
9
James Harris
[1.1.1.5.2.14.4.2.2]
9
Mary Catherine Bingham Harris
[1.1.1.5.2.14.4.2.3]
8
Martha Ryland Harris
[1.1.1.5.2.14.4.3]
b. 15 Jan 1821
+
John Mills Maupin
8
James Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4]
b. 17 May 1818
Sabra Jackson
9
Susan Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.1]
b. Jan 1871
William Stockton Dorsey
b. 23 Aug 1867 d. 4 Sep 1934
10
Dorothy B. Dorsey
[1.1.1.5.2.14.4.4.1.1]
b. Cal 1901
10
Anne J. Dorsey
[1.1.1.5.2.14.4.4.1.2]
b. Cal 1906
10
Margaret Dorsey
[1.1.1.5.2.14.4.4.1.3]
b. Jul 1893
10
James H. Dorsey
[1.1.1.5.2.14.4.4.1.4]
b. Feb 1899
9
Sallie Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.2]
+
Bradley
9
Overton Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.3]
9
Julia Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.4]
+
Johnston
9
Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.5]
+
Samuel Baker
9
Louise Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.6]
+
Holland
9
David H. Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.7]
9
Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.8]
+
John Trimble
9
Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.9]
+
H. C. Pierce
9
John S. Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.10]
9
James M. Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.11]
9
W. B. Harris
[1.1.1.5.2.14.4.4.12]
8
Sarah Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.14.4.5]
b. 22 Jul 1824
+
George Hunt
8
Mary Frances Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6]
b. 10 Nov 1827 d. 28 Feb 1906
Thomas Berry Harris
b. 1815 d. 1892
9
Martha Overton Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6.1]
9
Sallie Tyree Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6.2]
+
A. M. Wathall
9
Susan Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6.3]
9
William Christopher Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6.4]
9
Mary Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6.5]
+
J. A. Vansant
9
Overton Thomas Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6.6]
9
Tyree Crawford Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6.7]
9
Isabel Harris
[1.1.1.5.2.14.4.6.8]
8
Overton Michael Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7]
Amanda Wood
9
Clifton Woods Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.1]
9
James Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.2]
9
William Overton Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.3]
9
Lilly F. Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.4]
9
Beulah Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.5]
+
E. C. Yancey
9
Mary Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.6]
9
J. Brown Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.7]
9
Emmet Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.8]
9
Nellie Harris
[1.1.1.5.2.14.4.7.9]
7
Elizabeth Harris
[1.1.1.5.2.14.5]
b. 30 Sep 1791 d. 1819/1885
+
Anderson Woods
b. 1774/1794 d. 1819/1880
7
James Harris
[1.1.1.5.2.14.6]
b. 7 May 1794 d. 1825/1884
+
Mourning Bennett
b. 1790/1810 d. 1825/1894
7
Frances Harris
[1.1.1.5.2.14.7]
b. 26 Mar 1802 d. 1830/1896
+
James Miller
b. 1785/1805 d. 1830/1891
7
Susan Harris
[1.1.1.5.2.14.8]
b. 10 May 1808 d. 1836/1902
+
William H. Duncan
b. 1791/1811 d. 1836/1897
7
William Harris
[1.1.1.5.2.14.9]
b. 16 May 1805 d. 1806/1895
+
Malinda Duncan
6
Benjamin Harris
[1.1.1.5.2.15]
b. 28 Nov 1760 d. 1761/1850
+
Jones
+
Nancy Burgin
6
James Harris
[1.1.1.5.2.16]
b. 1770 d. 1798
+
Susannah Gass
6
Margaret Harris
[1.1.1.5.2.17]
b. 1772 d. INFANT
6
Isabell Harris
[1.1.1.5.2.18]
b. 9 Aug 1775 d. 1803/1869
+
John Bennett
b. 1758/1778 d. 1803/1864
5
Rachel Harris
[1.1.1.5.3]
b. 24 Jun 1744 d. 1745/1838
+
William Dalton
5
Elizabeth Frances Harris
[1.1.1.5.4]
b. 27 Jan 1745/46 d. 1788
William Crawford
b. 2 Aug 1733 d. 12 May 1828
6
William Harris Crawford
[1.1.1.5.4.1]
b. 15 Mar 1775 d. 16 Apr 1867
5
William Harris
[1.1.1.5.5]
b. 15 Nov 1752 d. 20 May 1846
+
Hannah Jameson
+
Michie
5
Tyree Harris
[1.1.1.5.6]
b. 8 Apr 1728 d. 1729/1818
+
Elizabeth Chapman
b. 30 Mar 1791
+
Mary Ann Simpson
5
Mourning Glenn Harris
[1.1.1.5.7]
b. 27 Mar 1732 d. Between 1805 / 1808
John Jouett
b. 1720 d. 1805
6
Matthew Jouett
[1.1.1.5.7.1]
6
John Jouett
[1.1.1.5.7.2]
6
Robert Jouett
[1.1.1.5.7.3]
6
Margaret Jouett
[1.1.1.5.7.4]
+
Nathan Crawford
6
Mary Jouett
[1.1.1.5.7.5]
6
Frances Jouett
[1.1.1.5.7.6]
6
Elizabeth Jouett
[1.1.1.5.7.7]
+
Clifton Rodes
b. 8 Aug 1768 d. 1828
6
Charles Jouett
[1.1.1.5.7.8]
6
Susan Jouett
[1.1.1.5.7.9]
5
Lucy Harris
[1.1.1.5.8]
b. 12 Apr 1734 d. 1803
William Shelton
b. Abt 1730 d. 1803
6
Mourning Shelton
[1.1.1.5.8.1]
+
Arch Woods
6
William Harris Shelton
[1.1.1.5.8.2]
6
Dabney Jackson Shelton
[1.1.1.5.8.3]
6
Sarah Shelton
[1.1.1.5.8.4]
6
Lucy Shelton
[1.1.1.5.8.5]
6
Agnes Shelton
[1.1.1.5.8.6]
6
Weatherston Shelton
[1.1.1.5.8.7]
6
Thomas Shelton
[1.1.1.5.8.8]
5
Sarah Harris
[1.1.1.5.9]
b. 24 May 1736 d. 31 Jan 1803
John Rodes
b. 6 Nov 1729 d. 16 Jul 1810
6
Henrietta Rodes
[1.1.1.5.9.1]
b. 26 May 1761 d. 1 Jun 1846
Bernis Brown
b. 15 Aug 1752 d. 30 Oct 1814
7
Sarah Brown
[1.1.1.5.9.1.1]
b. 17 Jan 1783 d. 1825
Thomas Jones
b. 1777 d. 1863
8
Henrietta Brown Jones
[1.1.1.5.9.1.1.1]
b. 8 Jan 1810 d. 16 Dec 1891
John McNeill
b. 26 Feb 1793 d. 3 Jun 1876
9
Sarah Nancy McNeill
[1.1.1.5.9.1.1.1.1]
b. 14 Feb 1833 d. 1 Feb 1884
Edmund Alexander Ramsey
b. 1 Feb 1822 d. 19 Mar 1899
10
John M. Ramsey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.1]
b. 1851 d. Apr 1891
Harriet Gertrude Wright
11
John E. Ramsey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.1.1]
b. Apr 1887
+
Avis Wise
11
Harry T. Ramsey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.1.2]
b. 29 May 1890
+
Jessie Doyle
10
Cora E. Ramsey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.2]
b. 1857
+
John Halbert
10
Edmond Thomas Ramsey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.3]
b. 15 Apr 1864 d. 5 May 1938
+
May McNeilly Breast
b. 1 Apr 1871 d. 23 Jan 1965
10
Mary Ella Ramsey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4]
b. 1853 d. 1894
William Gourley
b. 1847 d. 1914
11
Lillie M. Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.1]
b. 6 Jul 1880 d. 14 Sep 1916
Charles Grider Bruce
b. 12 Jun 1879 d. 1933
12
Ella Lucille Bruce
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.1.1]
b. 19 Feb 1903 d. 22 Mar 1930
12
James Robert Bruce
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.1.2]
[
=>
]
11
John A. Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.2]
b. 1874 d. 1912
11
Samuel Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.3]
b. 1887
11
Rebecca Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.4]
b. 18 Sep 1882 d. 29 Nov 1963
David D. Walker
b. 30 Nov 1878 d. 19 Feb 1946
12
Jr. David D. Walker
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.4.1]
[
=>
]
11
Merle Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.5]
b. 8 May 1890
11
Sara Elizabeth Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.6]
b. 1894
Wesley James Hailey
12
Charles Hailey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.6.1]
12
Jr. Wesley James Hailey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.6.2]
[
=>
]
11
Jr. William Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.7]
+
Jim
11
Arthur Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.8]
+
Alfa Whitsett
11
Henry Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.9]
Hazel Lipe
12
Raymond W. Gourley
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.4.9.1]
b. 5 Feb 1902 d. 5 May 1966
10
Marietta Ramsey
[1.1.1.5.9.1.1.1.1.5]
b. 1854
+
Denney
9
Joseph B. McNeill
[1.1.1.5.9.1.1.1.2]
b. 1835 d. 24 Aug 1920
Jane M. Keys
10
Sarah E. McNeill
[1.1.1.5.9.1.1.1.2.1]
b. Abt 1858
10
John Cage McNeill
[1.1.1.5.9.1.1.1.2.2]
b. Abt 1857
+
Emma J. Staggs
+
Sarah Catherine McNeely
b. 1846
9
Elizabeth A. McNeill
[1.1.1.5.9.1.1.1.3]
b. 1841
+
Benjamin H. Hargrave
7
Henrietta Brown
[1.1.1.5.9.1.2]
b. 6 Mar 1787
+
John Ruff
7
Anna Brown
[1.1.1.5.9.1.3]
b. 25 Apr 1789 d. 6 May 1817
John Dickerson
8
Henrietta Rodes Dickerson
[1.1.1.5.9.1.3.1]
Henry Tazewell Austin
9
Felix Houston Austin
[1.1.1.5.9.1.3.1.1]
7
Bernis Brown
[1.1.1.5.9.1.4]
b. 5 May 1791
7
Tyree Rodes Brown
[1.1.1.5.9.1.5]
b. 13 Jun 1793 d. 26 Dec 1836
Sarah Nicholas
d. 28 Dec 1836
8
Julian Henrietta Rodes Brown
[1.1.1.5.9.1.5.1]
b. 7 Apr 1818
+
Charles Carthrae
8
Sidna Elizabeth Brown
[1.1.1.5.9.1.5.2]
b. 18 May 1821
+
Addison Carthrae
8
Madison Nicholas Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3]
b. 21 Mar 1815 d. 17 Dec 1880
Mary Sewell Hopkins
d. 6 Jun 1896
9
Tyree Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.1]
b. 31 Jan 1860 d. 23 Sep 1893
Sallie Rust
10
Roger Q. Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.1.1]
10
Rust B. Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.1.2]
10
Richard Tyree Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.1.3]
9
Thomas Jefferson Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.2]
Clemmie Rust
10
Kate Strother Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.2.1]
10
Pocahontas Rust Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.2.2]
9
Mary Virginia Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.3]
+
Morris Osburn
9
Julian Catherine Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.4]
+
Alfred T. Irvine
d. 8 Mar 1875
9
Frances Elizabeth Brown
[1.1.1.5.9.1.5.3.5]
d. 19 Jun 1861
7
Benjamin Thompson Brown
[1.1.1.5.9.1.6]
b. 6 Jan 1796 d. 15 Jun 1867
Lucy Ann Richards
8
Lucian Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1]
b. 29 Mar 1850 d. 17 May 1930
Frances Michie
b. 18 Jul 1856 d. 11 Jul 1928
9
Mary Nelson Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.1]
b. 20 Feb 1883
9
Frances Ann Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.2]
b. 12 Feb 1886
9
Elizabeth Louise Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.3]
b. 14 Dec 1888
9
John Richards Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.4]
b. 12 Jun 1891
Lorena C. Miller
10
Mary Joan Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.4.1]
+
James Ross Oyler
9
Lucian Howard Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.5]
b. 19 Sep 1894
Gladys Layman
10
Robert Randolph Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.5.1]
Gloria M. Luerdrick
11
Randolph Michie Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.5.1.1]
11
Kevin David Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.5.1.2]
11
Douglas Christopher Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.5.1.3]
11
Gregory Shaffer Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.5.1.4]
11
Paul Martin Brown
[1.1.1.5.9.1.6.1.5.1.5]
8
Elizabeth Brown
[1.1.1.5.9.1.6.2]
8
John R. Brown
[1.1.1.5.9.1.6.3]
+
Candice Hall
8
Lucy Ann Brown
[1.1.1.5.9.1.6.4]
8
Jefferson Randolph Brown
[1.1.1.5.9.1.6.5]
+
Florence Carter
8
James R. Brown
[1.1.1.5.9.1.6.6]
+
Lillie Smith
8
Bernis B. Brown
[1.1.1.5.9.1.6.7]
+
Elizabeth Imbodin
7
Elizabeth Brown
[1.1.1.5.9.1.7]
b. 23 Jul 1798
+
Charles Carthrae
7
John R. Brown
[1.1.1.5.9.1.8]
b. 7 Jan 1801
7
Mary A. Brown
[1.1.1.5.9.1.9]
b. 30 Oct 1780 d. 11 Dec 1795
7
Brown
[1.1.1.5.9.1.10]
b. 1 Dec 1781
7
Nancy Brown
[1.1.1.5.9.1.11]
b. 26 Dec 1784
6
Mary Rodes
[1.1.1.5.9.2]
b. 14 Feb 1757 d. 21 Feb 1773
6
Robert Rodes
[1.1.1.5.9.3]
b. 11 May 1759 d. Bef 1859
Elizabeth Dulaney
7
Mary Eddings Rodes
[1.1.1.5.9.3.1]
b. 27 Jun 1782
+
James Estill
7
Clifton Rodes
[1.1.1.5.9.3.2]
Amanda Owsley
8
Charles H. Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.1]
+
Mary Davis
8
John S. Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.2]
8
Sallie E. Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.3]
+
Thomas E. Tutt
8
Myra S. Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.4]
8
Boyle O. Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.5]
+
Susan C. Cromwell
8
William Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.6]
8
Clifton Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.7]
8
Ann E. Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.8]
+
John G. Barrett
8
Amanda Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.9]
+
William C. Anderson
+
Stephen L. Yerkes
8
Elizabeth Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.10]
+
Joseph Helm
8
Robert Rodes
[1.1.1.5.9.3.2.11]
+
Mary Grider
7
Sallie Harris Rodes
[1.1.1.5.9.3.3]
+
Anthony W. Rollins
7
Elizabeth Rodes
[1.1.1.5.9.3.4]
+
Wallce Estill
7
Nancy Rodes
[1.1.1.5.9.3.5]
+
Samuel Stone
7
John Rodes
[1.1.1.5.9.3.6]
7
William Rodes
[1.1.1.5.9.3.7]
Pauline G. Clay
8
Green Clay Rodes
[1.1.1.5.9.3.7.1]
8
William Cassius Rodes
[1.1.1.5.9.3.7.2]
8
Eliza Rodes
[1.1.1.5.9.3.7.3]
+
Robert H. Stone
8
Sallie Rodes
[1.1.1.5.9.3.7.4]
+
John Watson
8
Belle Amelia Rodes
[1.1.1.5.9.3.7.5]
+
John H. McDowell
6
Ann Rodes
[1.1.1.5.9.4]
b. 22 Jul 1763
+
John Garth
6
John Rodes
[1.1.1.5.9.5]
b. 2 Jun 1766 d. 1839
Francina Brown
b. 24 May 1775 d. 3 May 1846
7
William Rodes
[1.1.1.5.9.5.1]
b. 1765/1801 d. 1806/1880
+
Elizabeth Clarissa Yancey
b. 1775/1803 d. 1806/1885
+
Clarissa Yancey
7
Jacintha Tazewell Rodes
[1.1.1.5.9.5.2]
b. 20 Aug 1809
John Massie Smith
8
John Massie Smith
[1.1.1.5.9.5.2.1]
8
Frances Rodes Smith
[1.1.1.5.9.5.2.2]
8
Charles Thompson Smith
[1.1.1.5.9.5.2.3]
8
Bettie Massie Smith
[1.1.1.5.9.5.2.4]
8
William Henry Smith
[1.1.1.5.9.5.2.5]
8
Robert Hardin Smith
[1.1.1.5.9.5.2.6]
James M. Harris
8
James Clifton Harris
[1.1.1.5.9.5.2.7]
8
Lizzie Woods Harris
[1.1.1.5.9.5.2.8]
8
Mary Alice Harris
[1.1.1.5.9.5.2.9]
7
Sydney Rodes
[1.1.1.5.9.5.3]
Powhatan Jones
8
Judith Francena Rodes
[1.1.1.5.9.5.3.1]
7
Ryland Rodes
[1.1.1.5.9.5.4]
+
Virginia Woods
7
Sarah Rodes
[1.1.1.5.9.5.5]
+
Samuel Woods
7
John Rodes
[1.1.1.5.9.5.6]
+
Ann
7
Frances Rodes
[1.1.1.5.9.5.7]
+
Garland Brown
7
Virginia Rodes
[1.1.1.5.9.5.8]
+
Wilson C. Smith
7
Tyree Rodes
[1.1.1.5.9.5.9]
7
Lucy Rodes
[1.1.1.5.9.5.10]
+
Newlands
6
Tyree Rodes
[1.1.1.5.9.6]
b. 24 Dec 1771 d. 17 Jul 1827
Cynthia Holland
b. 1789 d. 1863
7
Sarah Myra Bell Rodes
[1.1.1.5.9.6.1]
b. 18 Oct 1812 d. 12 Mar 1865
+
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
John Harper Rivers
b. 23 Mar 1802 d. 11 Jun 1836
8
William Rhodes Rivers
[1.1.1.5.9.6.1.1]
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
Martha Julia Flournoy
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
9
Myra Rivers
[1.1.1.5.9.6.1.1.1]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
9
Julian Rivers
[1.1.1.5.9.6.1.1.2]
b. 23 Dec 1868
9
William Cannon Rivers
[1.1.1.5.9.6.1.1.3]
b. 11 Jan 1866
9
Tyree Rodes Rivers
[1.1.1.5.9.6.1.1.4]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
9
John Harper Rivers
[1.1.1.5.9.6.1.1.5]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
9
Flournoy Rivers
[1.1.1.5.9.6.1.1.6]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
10
John Avirett Rivers
[1.1.1.5.9.6.1.1.6.1]
b. 22 Mar 1894
6
Charles Rodes
[1.1.1.5.9.7]
b. 22 Feb 1774
6
Sarah Harris Rodes
[1.1.1.5.9.8]
b. 3 Jul 1777
+
William Davenport
+
Micajah Woods
6
Clifton Rodes
[1.1.1.5.9.9]
b. 8 Aug 1768 d. 1828
+
Elizabeth Jouett
5
Robert Harris
[1.1.1.5.10]
b. 8 Mar 1740/41 d. 1796
Lucretia Brown
b. 1746
6
Tyree Rodes Harris
[1.1.1.5.10.1]
b. 15 Mar 1765 d. 1841
6
Elijah Harris
[1.1.1.5.10.2]
6
Bazleel B. Bernice Harris
[1.1.1.5.10.3]
6
Lucretia Harris
[1.1.1.5.10.4]
6
Mourning Harris
[1.1.1.5.10.5]
6
Nancy Harris
[1.1.1.5.10.6]
+
Jr. Ratliff Boon
b. 1755 d. 1815
6
Lucy Harris
[1.1.1.5.10.7]
6
Patsy Harris
[1.1.1.5.10.8]
6
Sarah Harris
[1.1.1.5.10.9]
5
Susan Harris
[1.1.1.5.11]
b. 1751
5
Frances Elizabeth Harris
[1.1.1.5.12]
b. 4 Jul 1738 d. 1788
+
Joel Crawford
b. 16 Oct 1736 d. 1788
5
Mary Harris
[1.1.1.5.13]
b. 10 Feb 1729 d. 1819
James Harris
b. 1722 d. Sep 1792
6
Joel Harris
[1.1.1.5.13.1]
b. 25 Apr 1761 d. 1826
Anna Waller
b. 11 Nov 1762 d. 5 Aug 1834
7
Ira Harris
[1.1.1.5.13.1.1]
b. Abt 1785 d. 1863
Sarah Lewis
8
Charles Warner Harris
[1.1.1.5.13.1.1.1]
b. 15 Feb 1822 d. 23 Apr 1860
Angeline Mildred Brown
b. 9 Oct 1832
9
Mary Howell Harris
[1.1.1.5.13.1.1.1.1]
b. 15 Sep 1854 d. 12 Jan 1857
9
Charles Lee Harris
[1.1.1.5.13.1.1.1.2]
b. 24 Jul 1857
8
Waller Harris
[1.1.1.5.13.1.1.2]
+
Mary Frances Brown
8
Mary Ann Harris
[1.1.1.5.13.1.1.3]
Burlington Dabney Brown
b. 17 May 1820 d. 26 Apr 1886
9
Hugh Hescott Brown
[1.1.1.5.13.1.1.3.1]
b. 7 Apr 1846
+
Mary Ann Metier
9
Ira Lewis Brown
[1.1.1.5.13.1.1.3.2]
b. 2 Mar 1848
9
Linn Roy Brown
[1.1.1.5.13.1.1.3.3]
b. 5 Nov 1849 d. 22 Mar 1850
9
Frank Brown
[1.1.1.5.13.1.1.3.4]
+
Bettie French
9
Harry Brown
[1.1.1.5.13.1.1.3.5]
+
Virginia Ann Bishop
9
Ralph Brown
[1.1.1.5.13.1.1.3.6]
9
Hattie Brown
[1.1.1.5.13.1.1.3.7]
+
Samuel Hatcher
9
Nettie Brown
[1.1.1.5.13.1.1.3.8]
+
E .A. Lofton
8
Benjamin Harris
[1.1.1.5.13.1.1.4]
8
Lewis Harris
[1.1.1.5.13.1.1.5]
6
Thomas Harris
[1.1.1.5.13.2]
b. 3 Apr 1755 d. 12 Sep 1842
+
Susan Dabney
b. 1756 d. 1784/1850
6
Nathan Harris
[1.1.1.5.13.3]
b. 2 Mar 1757 d. 6 Jun 1848
6
James Harris
[1.1.1.5.13.4]
b. 7 Jul 1766 d. Aft 1822
6
Mourning Harris
[1.1.1.5.13.5]
b. 3 May 1760 d. 20 Nov 1837
+
Cornelius Maupin
b. 8 Jan 1760 d. 10 Apr 1846
6
Lucy Harris
[1.1.1.5.13.6]
b. 12 Apr 1754 d. 1830
Higgason Grubbs
b. 1739 d. 30 Jun 1830
7
Nancy Grubbs
[1.1.1.5.13.6.1]
b. 24 Nov 1749 d. 30 Apr 1835
Robert Harris
b. 24 Aug 1749 d. 18 Nov 1833
8
Catherine Harris
[1.1.1.5.13.6.1.1]
b. Abt 1787
+
James Stone
8
Mary Harris
[1.1.1.5.13.6.1.2]
b. Abt 1781
+
William Woods
8
Tyree Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3]
b. Abt 1782
Sally Garland
9
Robert Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.1]
b. 22 Feb 1818
Frances Copher
10
Tyree Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.1.1]
10
Susan Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.1.2]
+
Hill
9
Thomas Berry Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2]
b. 1815 d. 1892
Mary Frances Harris
b. 10 Nov 1827 d. 28 Feb 1906
10
Martha Overton Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2.1]
10
Sallie Tyree Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2.2]
+
A. M. Wathall
10
Susan Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2.3]
10
William Christopher Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2.4]
10
Mary Elizabeth Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2.5]
+
J. A. Vansant
10
Overton Thomas Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2.6]
10
Tyree Crawford Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2.7]
10
Isabel Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.2.8]
9
Malinda Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.3]
+
Samuel Jameson
9
Caleb Rice Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.4]
Minerva
10
John Stone Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.4.1]
9
Paulina Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.5]
+
Joseph Frakes
9
William Hayden Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.6]
Amelia Ellington
10
Joseph Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.6.1]
9
Susan Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.7]
+
John Jameson
9
Overton Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.8]
+
Mary Ellington
9
Benjamin F. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.9]
Lucy Hensley
10
Mary Susan Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.9.1]
+
Vivion
10
Alnett Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.9.2]
+
Vivion
10
William T. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.9.3]
10
Benjamin W. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.9.4]
10
Samuel H. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.9.5]
9
Sallie Ann Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.10]
+
Archibald Dinwiddie
9
Mary Catherine Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.11]
d. 1904
+
George Burroughs
9
James Berry Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.12]
Lucy Cockerel
10
William Thomas Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.12.1]
10
Effie Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.12.2]
+
Howard Sutherland
10
John T. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.12.3]
10
James W. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.12.4]
10
Martha Virginia Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.12.5]
+
Henderson Hancock
10
Katherine Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.12.6]
+
Howard Sutherland
9
Tyree Crawford Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.13]
d. 1854
Lavinia Hughes
10
William L. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.13.1]
10
Mary Cameron Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.13.2]
+
Vorries
10
Harris
[1.1.1.5.13.6.1.3.13.3]
+
William McCracken
8
Higgason Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4]
b. 3 Apr 1774 d. Aft 1839
Nancy Garland
b. Abt 1780 d. Bef 1840
9
Lucy Ann Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.1]
b. 7 Jul 1809 d. 2 Oct 1877
John Martin Ogan
b. 30 Jan 1812 d. 17 Jun 1893
10
Sierra Nevada Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1]
b. 3 Aug 1853 d. 24 Jun 1938
Christopher Columbus Smith
b. 5 Sep 1841 d. 14 Aug 1910
11
Hazel Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.1]
b. Abt 1886
11
Euphemia Ann Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.2]
Albert Wallis Mathews
b. 29 Oct 1882 d. 3 Jan 1956
12
Myrtle E. Mathews
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.2.1]
[
=>
]
12
Jr. Albert Wallis Mathews
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.2.2]
[
=>
]
11
Mamie Josephine Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.3]
b. Abt 1874
William W. Anderson
12
Rebecca Nevada Anderson
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.3.1]
b. 5 May 1897 [
=>
]
12
Warren Alvord Anderson
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.3.2]
[
=>
]
12
Alice Phillis Anderson
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.3.3]
[
=>
]
12
Bessie Alberta Anderson
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.3.4]
12
Esther Margaret Anderson
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.3.5]
[
=>
]
12
Zilla May Anderson
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.3.6]
[
=>
]
11
Margaret Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.4]
b. Abt 1882
+
Byron Nesbit
11
Orlando Jarvis Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.5]
b. 27 May 1880 d. 16 Aug 1965
+
Clara Stewart
11
Charles Taylor Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6]
b. 23 Feb 1875 d. 2 Oct 1969
Sarah Maud Blanch
b. 8 Mar 1873 d. 5 Sep 1952
12
Evelyn Muriel Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.1]
b. 5 Sep 1900 d. 6 May 1972 [
=>
]
12
Charlotte Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.2]
b. 19 Feb 1919 d. 28 Feb 1919
12
Charles Christopher Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.3]
b. 14 Jun 1906 [
=>
]
12
Elbert Leroy Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.4]
b. 22 Nov 1903 d. Jun 1955
12
Florence Agnes Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.5]
b. 21 Aug 1901 d. 19 Jan 1922 [
=>
]
12
Hazel Maud Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.6]
b. 19 Oct 1913 d. SeeNotes [
=>
]
12
Mervyn Ogan Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.7]
b. 7 Dec 1910 d. 29 May 1943
12
Edmond Lodge Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.8]
[
=>
]
12
Roberta Mabel Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.6.9]
[
=>
]
11
Robert Calvin Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.7]
b. Abt 1891 d. 26 Dec 1962
+
Goldie
11
Lila Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.8]
b. Abt 1889
11
Lola Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.9]
b. Abt 1871 d. Abt 1892
William Sleightam
12
William Sleightam
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.9.1]
11
Maude Nevada Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.10]
b. 5 Nov 1894 d. Abt 1948
+
Norm Nelson
Arnold Melvin Gifford
b. 2 Oct 1892
12
Fern Jane Gifford
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.10.1]
b. 5 Nov 1918 d. 3 Oct 1924
12
June Doris Gifford
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.10.2]
[
=>
]
12
Loren Clifton Gifford
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.1.10.3]
[
=>
]
10
James Robert Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2]
b. 1851 d. 12 Mar 1939
Effie B. Hansborough
d. Bef 1900
11
Oscar Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2.1]
b. 30 Sep 1873 d. 14 Aug 1896
11
John Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2.2]
b. Nov 1875
11
Olive Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2.3]
b. May 1885
11
Bertha Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2.4]
b. Oct 1881
11
Julia Adelia Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2.5]
b. 2 Aug 1879 d. 11 Jul 1954
Frank Harvey Carlisle
12
Percy Carlisle
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2.5.1]
b. 1902
12
Frank H. Carlisle
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2.5.2]
12
Collier C. Carlisle
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.2.5.3]
+
Mattson
+
Catherine Brown
d. 16 Aug 1920
10
Elizabeth J. Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.3]
b. 1848 d. 22 Apr 1895
William Alexander Smith
b. 26 Mar 1844 d. 1929
11
Roy Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.3.1]
11
Lucinda Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.3.2]
bur. 1891
10
William Higgason Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4]
b. Jan 1847 d. 25 Mar 1901
Lydia Hannah Hamilton
b. 29 May 1854 d. 10 Oct 1935
11
William Lester Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.1]
b. 13 Apr 1876 d. 31 Oct 1960
Addie Vivian Caldwell
b. 14 Jun 1881 d. 5 Jan 1970
12
Maxwell Eugene Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.1.1]
[
=>
]
11
Lucy Adeline Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.2]
b. Aug 1888
Hall
12
Harry R. Hall
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.2.1]
b. 7 Sep 1905
11
Leland Stanford Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.3]
b. Jan 1890 d. 19 May 1930
+
D.
11
James Marvin Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.4]
Marie Hulda Briggs
12
Marvin Eugene Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.4.1]
11
Helena Mabel Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.5]
b. Abt 1874
+
James J. Phillips
11
Isiah Lyle Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.6]
b. 13 Nov 1878 d. 5 Jul 1947
Edna Grider
b. Abt 1892 d. 17 Jul 1917
12
John Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.6.1]
b. Abt 1917 d. 1 Jul 1920
11
Robert Martin Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.7]
b. 9 Nov 1885 d. 2 Jan 1968
+
E. M.
11
Harry Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.8]
b. 22 Sep 1882 d. 31 Aug 1931
Gilberta Mae Ottman
b. 1891
12
Harry Kenneth Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.4.8.1]
[
=>
]
10
Euphemia Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.5]
b. 1845
John Smith Boyd Shuart
11
Helen E. Shuart
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.5.1]
b. 1862 d. 21 Feb 1931
Henry Switzgebel
12
Louise Switzgebel
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.5.1.1]
12
Alice Switzgebel
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.5.1.2]
10
Thomas Dudley Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.6]
b. 1843
Hattie E.
b. Abt 1853
11
Irving Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.6.1]
b. Abt 1869
11
Nettie E. Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.6.2]
b. Abt 1870
11
Arthur D. Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.6.3]
b. Dec 1873 d. 30 Aug 1959
+
Pearl
b. Jul 1876
+
Mae G.
d. 24 Feb 1949
10
Zella Frances Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7]
b. 10 Jun 1841 d. 4 Jul 1917
Henry J. Verser
b. Abt 1833
11
Alonzo C. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.1]
b. Jan 1873 d. 22 Dec 1915
Carrie M.
12
Viola C. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.1.1]
12
Myrtle L. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.1.2]
b. Mar 1897
11
Lula F. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.2]
b. Feb 1877
11
James H. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.3]
b. Jul 1872
+
Mabel E. le Gette
11
Charles B. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.4]
b. 1866 d. 30 Apr 1933
+
Ida M. Keney
11
Albert Dudley Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.5]
b. 14 Jan 1865 d. 27 Dec 1929
Emma F.
b. Jan 1870
12
Alvin Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.5.1]
[
=>
]
12
Ruby F. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.5.2]
12
Pearl Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.5.3]
b. 1894
12
Clara L. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.5.4]
b. 1898
12
Ray P. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.5.5]
b. 1900
11
John H. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.6]
b. Abt 1863
+
Sophie Walter
d. 3 Sep 1943
11
Clara A. Verser
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.7.7]
b. 1859
+
O. F. Hansborough
+
Googins
10
Parthena Catherine Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.8]
b. 23 Oct 1838 d. 18 Oct 1875
Dudley Wells
b. 24 Sep 1829 d. 29 May 1907
11
Leona Ogan Wells
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.8.1]
b. 26 Dec 1867 d. 1948
+
Henry F. Weston
11
Mary Jane% Wells
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.8.2]
b. 8 Aug 1858
+
Byron James Stone
+
Charles Frank
11
Martha Ann Wells
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.8.3]
b. 8 Aug 1858 d. 14 Jul 1947
Nelson Lee Stockton
b. 23 Aug 1853 d. 15 Jul 1923
12
Amy Lee Stockton
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.8.3.1]
12
Alfred James Stockton
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.8.3.2]
b. 27 Jan 1882 d. 16 Apr 1953 [
=>
]
12
Edna Parthena Stockton
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.8.3.3]
12
Marjorie May Stockton
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.8.3.4]
b. 10 Mar 1892 d. 17 Nov 1969 [
=>
]
10
Mary Ann Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.1.9]
b. 19 Mar 1837 d. 14 Mar 1917
+
Wesley Parson Campbell
9
Nancy Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.2]
b. 27 May 1812
9
Teresa Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.3]
b. 22 Apr 1815 d. 1915
+
Milton Jones
b. 1812 d. 1905
9
Rebecca Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.4]
b. 27 Jul 1820
9
Cathrine Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.5]
b. 12 Apr 1822
9
Elizabeth Berry Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6]
b. 16 May 1817 d. 17 Dec 1906
James Simeral Ogan
b. 12 May 1815 d. 4 Feb 1900
10
John Higgason Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.1]
b. 23 Sep 1844 d. 1 Nov 1930
Mary M. Doty
b. 14 Jun 1848 d. 7 Apr 1918
11
Eveline Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.1.1]
b. 4 Jan 1875 d. Abt 1950
+
Grant Stutsman
d. 1943
Logan Hern
b. Abt 1865
12
John Wesley Higgenson Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.1.1.1]
b. 10 Feb 1895 d. 16 Jan 1944 [
=>
]
11
Ida May Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.1.2]
b. 19 Jul 1869 d. Bef 1880
11
Louetta Theresa Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.1.3]
b. 23 Feb 1885 d. 13 Sep 1927
J. W. Jackson
12
Ivan W. Jackson
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.1.3.1]
b. 18 Nov 1907 d. 4 Nov 1931
+
Delos Giles
d. Abt 1950
11
Mary Ellen Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.1.4]
b. 11 Jun 1868 d. 1950
George S. Metcalf
12
George Metcalf
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.1.4.1]
+
Taylor
10
Juliana Rachel Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2]
b. 23 Nov 1846 d. 29 May 1912
J. Rice Hern
b. Abt 1828 d. 27 Jul 1921
11
Jay J. Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.1]
b. 21 Mar 1862 d. 12 Sep 1929
Etta E. Wraton
b. Oct 1871
12
Russell Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.1.1]
12
Carl Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.1.2]
12
Bertha M. Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.1.3]
b. Oct 1893
12
Leslie W. Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.1.4]
b. Oct 1891
12
Lenore Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.1.5]
11
Patrick M. Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.2]
b. Abt 1881
+
Anna F.
11
Carl Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.3]
b. Abt 1878
11
Elizabeth Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.4]
b. Abt 1875
+
Joel Hern
11
Jerome Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.5]
b. Abt 1870
11
Ernest Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.6]
b. Abt 1867
11
Logan Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.7]
b. Abt 1865
Eveline Ogan
b. 4 Jan 1875 d. Abt 1950
12
John Wesley Higgenson Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.7.1]
b. 10 Feb 1895 d. 16 Jan 1944 [
=>
]
11
George Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.8]
b. 25 Aug 1887 d. 6 Feb 1966
11
Harris Herbert Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.9]
b. 29 Nov 1883 d. 5 Oct 1971
Genevieve Bleitzman Banta
b. Abt 1887 d. Abt 1930
12
Barbara Ellen Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.9.1]
b. 16 Apr 1919 d. 30 Jan 1950
12
Emma Elizabeth Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.9.2]
12
Harriet Bernice Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.9.3]
b. 1909 [
=>
]
12
Helen Frances Hern
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.2.9.4]
[
=>
]
10
Theresa Jane Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3]
b. 31 Aug 1838 d. 14 Nov 1918
Thomas Jefferson Maxey
b. 8 Oct 1828 d. 28 Aug 1903
11
Mary E. Maxey
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.1]
b. 4 Feb 1859 d. 26 Mar 1860
11
Alice Jane Maxey
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.2]
b. 20 Feb 1861 d. 31 Jan 1949
+
George Washington Topham
b. 13 May 1865 d. 6 Mar 1932
11
Mildred Florence Maxey
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.3]
b. 26 Oct 1867 d. 4 Jun 1938
Claude T. Trimble
12
Tevis Maxey Trimble
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.3.1]
[
=>
]
11
Clayborn Thomas Maxey
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.4]
b. 24 May 1864 d. 17 May 1944
Anna Isabelle Bose
b. 31 Aug 1866 d. 31 Mar 1948
12
Elizabeth Theresa Maxey
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.4.1]
b. 27 Oct 1904
12
Margaret Anne Maxey
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.4.2]
[
=>
]
12
Frank Louis Maxey
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.4.3]
[
=>
]
11
Joshua Frank Maxey
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.3.5]
b. Abt 1860
10
Mary Eleanor Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.4]
b. 23 Sep 1842 d. 16 Sep 1933
Nicholas Rollins Harris
b. 1835 d. 1902
11
Nicholas Rolland Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.4.1]
b. 10 Mar 1874 d. 1938
+
Edna Shafer
11
James Dudley Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.4.2]
b. 28 Dec 1869 d. 10 Feb 1946
Susan Abbie Walker
b. 15 Mar 1883 d. 25 Jul 1956
12
Eleanor Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.4.2.1]
[
=>
]
11
Marshall C. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.4.3]
b. 6 Mar 1868 d. 10 Dec 1957
Susan Surface
12
Russell S. Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.4.3.1]
b. 12 Feb 1896 d. 7 Apr 1970 [
=>
]
11
Cyrus Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.4.4]
b. 15 May 1892 d. 17 May 1922
+
Annie Murphy
10
Millie Ann Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.5]
b. 24 Feb 1840 d. 5 Dec 1923
10
Sarah Catherine Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6]
b. 19 Oct 1854 d. 27 Jul 1937
John Milton Smith
b. 1838 d. 1890
11
Marshall W. Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.1]
b. 1888 d. 1889
11
Maude Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.2]
b. 24 Feb 1877 d. 3 Oct 1965
William H. Diehl
d. Jan 1945
12
Dorothy Diehl
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.2.1]
b. Abt 1797
11
Nelson F. Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.3]
b. 20 Apr 1884 d. 4 Mar 1965
Grace E. Hales
12
Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.3.1]
[
=>
]
11
Roy M. Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.4]
b. Apr 1882 d. 1960
11
Sadie Smith
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.5]
d. Aft 1965
Ed Bronk
d. Bef 1965
12
Kenneth Bronk
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.5.1]
Joseph Christopher Martin
b. 6 Nov 1853 d. 26 Dec 1922
11
Guelda Lane Martin
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.6]
b. 30 Jun 1896 d. 25 May 1967
Joseph Weiland Schweizer
b. 29 Nov 1891 d. 16 May 1961
12
John Joseph Schweizer
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.6.1]
[
=>
]
12
Marie Dorothy Schweizer
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.6.6.2]
[
=>
]
10
Harrison William Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.7]
b. 12 Apr 1860 d. Bef 1869
10
James Washington Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8]
b. 13 Feb 1857 d. 4 Jan 1933
Ada Ann Spooner
b. 26 Feb 1851 d. 14 Feb 1931
11
Ralph Milo Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.1]
b. 28 May 1889 d. 24 Aug 1970
+
Edna Mae Hansen
b. 9 Sep 1880 d. 16 Jan 1954
+
Mary Frances Fern-Fisk Moss Ashmore
b. 6 May 1913 d. 21 Oct 1970
11
Elizabeth Cornelia Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.2]
b. 20 Jul 1880 d. 7 Mar 1970
Harbron Williams Morris
b. 10 Feb 1885 d. 1949
12
Marion Elizabeth Morris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.2.1]
[
=>
]
12
Frances Harbron Morris
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.2.2]
[
=>
]
11
Milton Ellsworth Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.3]
b. 27 Oct 1884 d. 13 Jan 1898
11
Perry Warren Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.4]
b. 13 Feb 1883 d. 20 Oct 1949
11
Rolland James Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.5]
b. 14 Nov 1886 d. 3 Sep 1966
Myrtle Ella Treloar
b. 20 Mar 1889 d. 4 Aug 1967
12
Reginald Treloar Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.5.1]
[
=>
]
11
Charles Simeral Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.8.6]
b. Oct 1879 d. 5 Oct 1956
+
Maude Anna Tregoning
b. 25 Jan 1881 d. 1 May 1953
+
Frances Cora Autchins
10
Ogan
[1.1.1.5.13.6.1.4.6.9]
d. INFANT
9
Mary Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.7]
b. 3 Dec 1801
+
James Miller
9
Thomas Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.8]
b. 20 Dec 1802
9
Tyree Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.9]
b. 1803 d. 16 May 1846
+
Nancy Harris Jones
b. 1803 d. Aft 1860
9
Sarah Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.10]
b. 23 Sep 1804 d. 17 Nov 1893
David Rice
b. 4 Sep 1800 d. 28 Mar 1886
10
Higgason Harris Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1]
b. 6 Jun 1831 d. 16 Sep 1923
+
Martha Hagan
b. Jul 1835
Sarah E. Sappington
b. Abt 1855 d. 2 Jan 1882
11
Sarah E. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.1]
b. 17 Jul 1876
Jess Olds
12
William Harris Olds
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.1.1]
b. 1908 d. 1911
12
Clarence Rice Olds
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.1.2]
12
Lorraine Olds
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.1.3]
11
Tyre Harris Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.2]
Myrtle M. Bullard
b. Abt 1885
12
Martha Elizabeth Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.2.1]
b. 21 Nov 1907 [
=>
]
12
Elmore Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.2.2]
b. 3 Jun 1911 d. Sep 1964 [
=>
]
12
Hollis Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.2.3]
[
=>
]
11
Parmer Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.3]
b. 7 Mar 1880 d. 21 Jun 1914
Elizabeth Frances Telljohn
12
Kenneth Palmer Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.3.1]
[
=>
]
12
Mildred Irene Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.3.2]
b. 16 Sep 1911
12
Virgil E. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.3.3]
b. 23 Aug 1908
12
Una Lampkin Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.3.4]
b. 18 Jan 1906 [
=>
]
11
Joseph Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.4]
b. Feb 1880
11
Mary S. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.5]
b. Abt 1875 d. 27 Aug 1936
Mary Sapshire Cropper
b. 27 Nov 1837 d. 11 Jun 1874
11
Lelia B. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.6]
b. 20 Jul 1870 d. 20 Dec 1957
Benjamin B. Manford
b. 24 Jan 1857 d. 3 Dec 1935
12
William Berkeley Manford
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.6.1]
12
Van Camp Manford
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.6.2]
b. 17 Apr 1890 d. 28 Jan 1960 [
=>
]
12
Olepha Manford
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.6.3]
b. Cal 1894
11
William F. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.7]
b. 15 Aug 1871 d. 11 Sep 1954
Bessie H. Olds
b. 20 Aug 1883
12
Estelle Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.7.1]
b. Abt 1903 [
=>
]
11
Mary S. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.8]
b. Est 1874/1875
11
John Richard Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.9]
b. 17 Dec 1859
Henizella Easley
b. 16 Oct 1867 d. Aft 1934
12
Gertrude Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.9.1]
[
=>
]
12
Charles Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.9.2]
b. 13 Oct 1889 d. Jun 1964 [
=>
]
12
Myrtle Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.9.3]
b. 5 Jul 1891 [
=>
]
12
Osa B. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.9.4]
b. 31 Mar 1894 d. Mar 1967 [
=>
]
12
Arthur Bryan Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.9.5]
[
=>
]
12
Margaret W. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.9.6]
b. 13 Feb 1898 [
=>
]
12
Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.9.7]
b. 15 Aug 1902 d. 1902
+
Collie Robinson
11
David G. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.10]
b. 8 Oct 1857 d. 19 Mar 1943
Mary Lizzie Davis
b. Abt 1869
12
Harold F. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.10.1]
b. Abt 1912 [
=>
]
12
Garland L. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.10.2]
12
Lloyd Franklin Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.10.3]
12
Vesta Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.10.4]
11
Franklin D. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.11]
b. 23 Sep 1862 d. 27 Mar 1936
Mae Howell
12
Harris Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.11.1]
12
Ailene Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.11.2]
11
Penelope Winslow Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.1.12]
b. Abt 1866
10
Sarah E. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2]
b. 14 Aug 1846 d. 20 Aug 1954
Edward Camplin Burnett
b. 13 Oct 1838 d. 10 Jan 1894
11
Cornelius F. Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.1]
b. 27 Dec 1874 d. 17 Mar 1880
11
Minnie E. Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.2]
b. Abt 1871 d. 1909
11
Lora Lee Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.3]
b. 23 Oct 1877 d. 28 Jan 1893
11
John Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.4]
b. Aug 1883
May Barnett
12
Lora Bess Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.4.1]
12
Mildred Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.4.2]
12
Leon Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.4.3]
11
Carrie Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.5]
b. 22 Jun 1880 d. 6 Dec 1963
Odis Zumwalt
b. 19 Jan 1880 d. Nov 1963
12
Cletus Zumwalt
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.5.1]
12
Fredia Zumwalt
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.5.2]
11
Sallie Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.6]
+
Jack Martyn
b. 6 Dec 1891
11
Edward Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.7]
Ara Nichols
12
Ray Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.7.1]
12
E. P. Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.7.2]
12
Spencer Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.7.3]
12
Wallace Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.7.4]
12
Harry Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.7.5]
12
Ruth Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.7.6]
12
Gladys Fay Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.7.7]
11
Frank Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.8]
11
Mamie Burnett
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.2.9]
b. Mar 1895
10
John J. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3]
b. 17 Mar 1836 d. 11 Jul 1910
Isabelle J. Nichols
b. 2 Jan 1840 d. 20 Jul 1879
11
Oren Crane Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3.1]
b. 26 Oct 1872 d. 18 Jan 1896
11
Cora Lee Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3.2]
b. 12 Oct 1870 d. 10 Jul 1894
11
Luther H. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3.3]
b. 8 Sep 1866 d. 6 Apr 1938
+
Fannie M. Quarles
b. 8 Sep 1857 d. 20 Feb 1938
11
Celsus D. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3.4]
b. 7 Jul 1868 d. 8 Jul 1958
Laura G. Green
b. 21 Jul 1870 d. 18 Nov 1926
12
Herbert F. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3.4.1]
b. 9 Jun 1900 d. 18 Apr 1958 [
=>
]
12
Howard B. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3.4.2]
[
=>
]
12
Susan I. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3.4.3]
b. 17 Mar 1908 [
=>
]
11
Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.3.5]
b. Aft 1865 d. INFANT
+
Sallie A. Douglass
b. Abt 1846 d. 15 Sep 1888
10
David Barton Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.4]
b. 7 Mar 1849 d. 2 May 1929
Nancy B. Slater
b. Aug 1857 d. 12 Apr 1926
11
Charles Perry Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.4.1]
b. 19 Jul 1882 d. 17 Mar 1885
11
Mary M. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.4.2]
b. May 1888
Burdette Martin
12
Joella Martin
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.4.2.1]
11
Kate Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.4.3]
b. Sep 1884
+
Floyd Forsee
11
Lottie Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.4.4]
b. May 1886
+
Wallace Rice
10
Henry Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.5]
b. Abt 1831 d. Bef 1882
10
Mosias Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.6]
b. 14 Dec 1838
10
Julina Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7]
b. 17 Aug 1833 d. 4 Apr 1924
Tyree N. Jones
b. 3 May 1832 d. 29 Jan 1882
11
Mosias D. Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.1]
b. Abt 1859
11
John Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.2]
b. Est 1860/1870
11
Mary J. Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.3]
b. Abt 1861
11
Savilla Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.4]
b. Abt 1873
11
Leander Perry Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.5]
b. 6 Aug 1857 d. 7 Jul 1947
Alice Northway Coonce
b. 29 Jul 1858 d. 13 Feb 1889
12
Ocra E. Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.5.1]
b. 27 Sep 1888 d. 7 Apr 1891
12
Charles Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.5.2]
12
Iva Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.5.3]
Mary Belle Wallace
b. 14 Apr 1858 d. 19 Dec 1945
12
Ray Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.5.4]
11
Sarah E. Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.6]
b. 2 Nov 1853 d. 23 Dec 1921
Richard Crenshaw
b. 21 May 1853
12
Elmer Crenshaw
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.6.1]
[
=>
]
12
Nellie Maude Crenshaw
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.6.2]
[
=>
]
12
Mary Crenshaw
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.6.3]
11
Doll Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.7]
Bev Hart
12
Nellie Hart
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.7.1]
12
Virginia Hart
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.7.2]
11
Isabelle Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.8]
11
Lidy Jones
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.7.9]
10
Martha A. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8]
b. 20 Mar 1843 d. 26 Dec 1878
William P. Boqua
b. 14 Jan 1833 d. 27 Nov 1891
11
Sarah Boqua
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.1]
b. Abt 1878
11
Laura Boqua
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.2]
b. Abt 1871
11
Dora Boqua
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.3]
b. Abt 1873
Lee Vandiver
12
William Vandever
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.3.1]
b. Bef 1893
12
Jose Vandiver
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.3.2]
12
Boqua Vandiver
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.3.3]
12
Dorthy Vandiver
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.3.4]
12
Clyde Vandiver
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.3.5]
12
Rollie Vandiver
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.3.6]
12
Archie Vandiver
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.3.7]
11
Rosa Boqua
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.4]
b. Abt 1877
Claude Christian
12
Lorraine Christian
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.4.1]
12
Carl Christian
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.8.4.2]
10
Amanda Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9]
b. 29 Jan 1830 d. 24 Jul 1868
Caleb Armitage
b. Abt 1823 d. Bef 11 Sep 1871
11
Sarah Francis Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1]
b. 21 Jun 1850 d. 16 Jun 1933
James M. Delmore
b. 1844/1845
12
Thomas E. Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.1]
b. Jul 1870
12
William David Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.2]
b. Feb 1872 d. 6 Apr 1949
12
Mary Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.3]
b. 1873 d. 4 Jul 1936
12
James Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.4]
b. 1875
12
Manda Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.5]
b. 1877
12
Henry Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.6]
b. 1879
12
Elizabeth Lucille Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.7]
b. 1888
12
Ann Clare Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.8]
b. 11 Sep 1889 d. 5 Sep 1970
12
Victor Delmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.1.9]
b. 1891 d. 1945
11
Julia K. Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2]
b. 1859 d. 1942
Philip J. Gilmore
b. 1854 d. 1941
12
Nora Gilmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2.1]
b. Abt 1879 [
=>
]
12
John E. Gilmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2.2]
b. 21 Nov 1884 d. 15 Sep 1913
12
Fritz Gilmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2.3]
b. 14 Sep 1900 d. 15 Oct 1901
12
Louis Ancil Gilmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2.4]
b. 24 Jun 1896 d. 13 Feb 1962
12
Keith Gilmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2.5]
b. 10 Mar 1900 d. 7 Feb 1971 [
=>
]
12
Ann Gilmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2.6]
12
Roy Gilmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2.7]
[
=>
]
12
Nettie Gilmore
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.2.8]
11
Nettie Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.3]
b. Abt 1862
+
Minor Ballenger
b. Abt 1853
11
Higgason Harrison Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.4]
b. 20 Oct 1855 d. 23 Feb 1941
11
John Fletcher Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.5]
b. 7 Jun 1853 d. 16 Jun 1929
+
Mary J. Jamison
b. Bef 1868
11
William D. Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.6]
b. 1848 d. 26 Dec 1863
11
G. Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.7]
b. Abt 1863
11
Andrew Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.8]
b. Abt 1866
11
Everett Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.9]
b. Abt 1866
11
Eva Armitage
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.9.10]
10
Thomas B. Rice
[1.1.1.5.13.6.1.4.10.10]
b. 21 Jun 1841
9
Garland Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.11]
b. 14 Apr 1807
9
Jr. Higgason Harris
[1.1.1.5.13.6.1.4.12]
8
Nancy Harris
[1.1.1.5.13.6.1.5]
b. Abt 1785
+
William Stone
8
Lucy Harris
[1.1.1.5.13.6.1.6]
b. 1770 d. Bef 1839
8
Elizabeth Harris
[1.1.1.5.13.6.1.7]
b. 7 May 1782 d. 1838
7
Mourning Grubbs
[1.1.1.5.13.6.2]
b. 23 Jun 1766 d. 26 Aug 1843
Squire Boone
b. 13 Oct 1760 d. 28 Jun 1817
8
Thomas Boone
[1.1.1.5.13.6.2.1]
b. Abt 1785
8
Higgason Grubbs Boone
[1.1.1.5.13.6.2.2]
b. 8 Oct 1806
8
Nancy Boone
[1.1.1.5.13.6.2.3]
b. 24 Dec 1811
James Small
9
James Small
[1.1.1.5.13.6.2.3.1]
9
Anna Small
[1.1.1.5.13.6.2.3.2]
9
T. Frelinghuyser Small
[1.1.1.5.13.6.2.3.3]
9
Broxton Small
[1.1.1.5.13.6.2.3.4]
9
Higgason Small
[1.1.1.5.13.6.2.3.5]
9
Joseph Small
[1.1.1.5.13.6.2.3.6]
9
Frank Small
[1.1.1.5.13.6.2.3.7]
6
Sarah Harris
[1.1.1.5.13.7]
+
Harrison
6
Susannah Harris
[1.1.1.5.13.8]
+
Nicholas Burnley
6
Ann Harris
[1.1.1.5.13.9]
+
Haden
6
Jane Harris
[1.1.1.5.13.10]
+
Cornelius Dabney
b. Abt 1761 d. 1747/1846
4
George Harris
[1.1.1.6]
b. Bef 13 Apr 1701 d. 1761