News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Register for a User Account
Home
Search
Login
Find
Surnames
What's New
Most Wanted
Reports
Cemeteries
Media
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
•
First Name:
Last Name:
ID:
Opechancanough Mangopeesomon
Abt 1554 - 1646 (92 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Opechancanough Mangopeesomon
[1]
b. Abt 1554 d. 1646
+
Cleopatra, Queen of Egypt VII
b. 69 BC d. 12 Aug 30 BC
2
Nectowance
[1.1]
b. Bef 1600 d. Aft 1645
2
Nicketti
[1.2]
b. Abt 1625
John Hughes
b. Abt 1615
3
Elizabeth Hughes
[1.2.1]
b. Abt 1660
Nathaniel Davis
b. 1660
4
Samuel Davis
[1.2.1.1]
4
Philip Davis
[1.2.1.2]
4
Robert Davis
[1.2.1.3]
4
Mary Davis
[1.2.1.4]
b. 1685
Samuel Burks
b. Abt 1682/1685 d. 1756
5
John Peartree Burks
[1.2.1.4.1]
b. 1707 d. 1773
5
Jr. Samuel Burks
[1.2.1.4.2]
b. Abt 1707 d. Abt 1753
+
Elizabeth
5
Mary Burks
[1.2.1.4.3]
b. 1708 d. 1777
Obadiah Smith
d. 18 Feb 1777
6
Charles Smith
[1.2.1.4.3.1]
6
Luke Smith
[1.2.1.4.3.2]
b. 23 Aug 1744
6
Susanna Smith
[1.2.1.4.3.3]
b. 28 Apr 1746 d. Bef 1769
Isaac Winston
b. Abt 1745 d. 1821
7
Elizabeth Smith Winston
[1.2.1.4.3.3.1]
b. 23 Dec 1766 d. 11 Jan 1840
+
Cornelius Dabney
b. 7 Jun 1756 d. 13 Oct 1821
6
Peartree Smith
[1.2.1.4.3.4]
b. 13 Jun 1748
+
Isabella Hopkins
6
Elizabeth Smith
[1.2.1.4.3.5]
b. 28 Nov 1750 d. Bef 7 Aug 1769
+
Isaac Winston
b. Abt 1745 d. 1821
6
William Smith
[1.2.1.4.3.6]
b. 15 Nov 1752 d. 1800
+
Elizabeth Mayo
6
Jr. Obadiah Smith
[1.2.1.4.3.7]
b. 7 May 1755
6
Lucy Smith
[1.2.1.4.3.8]
b. 8 Dec 1756
III James Powell Cocke
b. 1747 d. 1829
7
Martha Cocke
[1.2.1.4.3.8.1]
Valentine Wood Southall
b. 1789/1790 d. 22 Aug 1861
8
William Southall
[1.2.1.4.3.8.1.1]
8
James C. Southall
[1.2.1.4.3.8.1.2]
8
Jr. Valentine Wood Southall
[1.2.1.4.3.8.1.3]
8
Lucy Southall
[1.2.1.4.3.8.1.4]
+
Charles Sharpe
8
Mary Southall
[1.2.1.4.3.8.1.5]
b. 1836 d. 1930
+
J. Thompson Brown
d. Bef 1876
Charles Scott Venable
b. 19 Apr 1827 d. 11 Aug 1900
9
Charles Scott Venable, MD
[1.2.1.4.3.8.1.5.1]
b. 13 Jun 1877 d. 20 Sep 1961
9
Sallie C Venable
[1.2.1.4.3.8.1.5.2]
b. Oct 1879
6
Joseph Smith
[1.2.1.4.3.9]
b. Nov 1761
5
Richard Burks
[1.2.1.4.4]
b. 1709
5
Elizabeth Burks
[1.2.1.4.5]
b. 1709 d. 21 Sep 1756
William Cabell
b. 9 Mar 1699 d. 12 Apr 1774
6
Mary Cabell
[1.2.1.4.5.1]
b. 2 Feb 1726 d. Jun 1760
+
William H. Risley
6
William H. Cabell
[1.2.1.4.5.2]
b. 13 Mar 1730 d. 23 Mar 1798
Margaret Meredith Jordan
b. 1738 d. Mar 1812
7
Landon Cabell
[1.2.1.4.5.2.1]
Judith Scott Rose
8
Landon Rose Cabell
[1.2.1.4.5.2.1.1]
+
Marion Fontaine Cabell
b. 1809 d. 1834
8
Robert Henry Cabell
[1.2.1.4.5.2.1.2]
b. 19 Feb 1799 d. Feb 1876
7
William Cabell, Jr
[1.2.1.4.5.2.2]
b. 25 Mar 1759 d. 22 Nov 1822
Anne Carrington
b. 9 Jun 1760 d. 3 Mar 1838
8
Elvira Ann Cabell
[1.2.1.4.5.2.2.1]
b. 10 Sep 1783 d. 22 Oct 1858
Jr. Patrick Henry, Jr
b. 15 Aug 1783 d. 22 Sep 1804
9
Nannie Henry
[1.2.1.4.5.2.2.1.1]
9
John Henry
[1.2.1.4.5.2.2.1.2]
9
Patrick Henry
[1.2.1.4.5.2.2.1.3]
9
Eliza Henry
[1.2.1.4.5.2.2.1.4]
9
Martha Henry
[1.2.1.4.5.2.2.1.5]
9
Ellen Henry
[1.2.1.4.5.2.2.1.6]
9
Rosa Henry
[1.2.1.4.5.2.2.1.7]
9
Elvira Ann Patrick Henry
[1.2.1.4.5.2.2.1.8]
b. 27 Sep 1804 d. 24 Jun 1870
William Howson Clark
b. 23 Jan 1805 d. 20 Oct 1873
10
Patrick Clark
[1.2.1.4.5.2.2.1.8.1]
b. 1826/1865 d. 1835/1942
10
Eliza Clark
[1.2.1.4.5.2.2.1.8.2]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Alfred Shields
b. 1818/1863 d. 1844/1940
10
Martha Clark
[1.2.1.4.5.2.2.1.8.3]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Lyle Clark
b. 1818/1863 d. 1844/1940
10
Ellen Clark
[1.2.1.4.5.2.2.1.8.4]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
George Lee
b. 1818/1863 d. 1844/1940
10
Rosa Clark
[1.2.1.4.5.2.2.1.8.5]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Wilkins
b. 1818/1863 d. 1844/1940
10
Elvira C. Clark
[1.2.1.4.5.2.2.1.8.6]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Augustine Claiborne
b. 1818/1863 d. 1844/1940
10
Nannie Clark
[1.2.1.4.5.2.2.1.8.7]
b. 1826/1865 d. 1844/1945
+
Thomas Bruce
b. 1818/1863 d. 1844/1940
10
John Clark
[1.2.1.4.5.2.2.1.8.8]
b. 1826/1865 d. 1847/1942
+
Coleman
b. 1826/1871 d. 1847/1950
James Bruce
b. 20 Mar 1763 d. 12 May 1837
9
Charles Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.9]
Sarah Alexander Seddon
10
Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.9.1]
10
Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.9.2]
10
Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.9.3]
10
Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.9.4]
10
Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.9.5]
10
Philip Alexander Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.9.6]
b. 7 Mar 1856 d. 16 Aug 1933
Elizabeth Tunstall Taylor
11
Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.9.6.1]
9
Ellen Carter Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.10]
9
Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.11]
9
Bruce
[1.2.1.4.5.2.2.1.12]
8
Margaret Ann Cabell
[1.2.1.4.5.2.2.2]
b. 24 Nov 1785 d. 3 Apr 1863
Thomas Stanhope McClelland
b. 4 Feb 1777 d. 30 Aug 1835
9
Elvira Bruce McClelland
[1.2.1.4.5.2.2.2.1]
b. 23 Apr 1808 d. 1871
John Henry
b. 16 Feb 1796 d. 7 Jan 1868
10
Margaret Ann Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.1]
b. 4 May 1827
10
Elvira Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.2]
b. 25 Jul 1828
+
Jesse A. Higginbotham
b. 1804/1826 d. 1831/1911
Alexander F. Taylor
b. 1804/1826 d. 1837/1911
11
Robert Taylor
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.2.1]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
10
William Wirt Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.3]
b. 14 Feb 1831 d. 5 Dec 1900
Lucy Gray Marshall
b. 31 Jul 1832 d. 25 Jan 1922
11
Elizabeth Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.3.1]
b. 22 Oct 1855 d. 1857/1954
+
Jr. James Lyons
b. 1831/1871 d. 28 Oct 1913
11
Jr. William Wirt Henry, Jr
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.3.2]
b. 1860 d. 1941
+
Mary Bladen
b. 1860 d. 1934
11
Lucy Gray Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.3.3]
b. 1840/1873 d. 1857/1954
+
Mathew B. Harrison
b. 1831/1871 d. 1857/1949
11
James Marshall Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.3.4]
b. 1840/1873 d. 1848/1951
10
Margaret Ann Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4]
b. 22 Jul 1833 d. 1881
William A. Miller
b. 1804/1826 d. 1837/1911
11
Ella Henry Miller
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.1]
b. 1837/1865 d. 1844/1948
11
Florence Henry Miller
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.2]
b. 1837/1865 d. 1854/1948
John Collins Dabney
b. 21 Feb 1793 d. 16 Apr 1875
12
Margaret Henry Dabney
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.2.1]
12
Miller Dabney
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.2.2]
12
Frederick Dabney
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.2.3]
11
John Henry Miller
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.3]
b. 1837/1865 d. 1858/1945
+
Diana Hamilton
b. 1837/1872 d. 1858/1953
11
David Miller
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.4]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
11
William Price Miller
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.5]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
11
Rosa Cabell Miller
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.6]
b. 1837/1865 d. 1844/1948
11
William Wirt Miller
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.4.7]
b. 1837/1865 d. 1845/1945
10
Thomas Stanhope McClelland Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.5]
b. 22 Jul 1833
Mary E. Gaines
b. 1815/1838 d. 1835/1922
11
Mary Ganes Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.5.1]
b. 29 May 1859
11
Jr. Thomas Stanhope Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.5.2]
b. 4 May 1863
11
Robert Gaines Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.5.3]
b. 4 Dec 1866
10
Laura Helen Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.6]
b. 15 Mar 1836 d. 1831/1916
+
James Carter
b. 1804/1826 d. 1831/1911
10
Emma Cabell Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.7]
b. 14 Feb 1838 d. 1837/1916
III James Boswell Ferguson
b. 1823
11
Elvira Ferguson
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.7.1]
b. Abt 1860
11
IV James Boswell Ferguson
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.7.2]
b. 1861
Eudora Witt Horner
b. 1861
12
V James Boswell Ferguson
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.7.2.1]
b. 1887
10
John Henry
[1.2.1.4.5.2.2.2.1.8]
b. Abt 1840
9
Margaret Cabell McClelland
[1.2.1.4.5.2.2.2.2]
b. 1820 d. 1875
9
Martha Edmonia Preston McClelland
[1.2.1.4.5.2.2.2.3]
b. 22 May 1831 d. 31 Jan 1891
Eli Shores Tutwiler
b. May 1826 d. 3 Feb 1891
10
Thomas Stanhope McClelland Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.1]
b. 15 Jan 1855 d. 14 Jul 1919
10
James Bruce McClelland Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.2]
b. 3 Dec 1856 d. 9 Jan 1940
10
Anna Scott Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.3]
b. 1860 d. 24 Jun 1873
10
Margaret Garland Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.4]
b. 19 Feb 1861
10
Argyle Trevillian Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.5]
b. 20 Apr 1863 d. 30 Sep 1943
10
Mary Cabell Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.6]
b. 4 Feb 1864 d. 18 Mar 1940
10
Jr. Eli Shores Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.7]
b. 1866 d. 17 Nov 1866
10
Henry Martyn Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.8]
b. 1867 d. 29 Nov 1906
10
William Wirt Henry Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.9]
b. Cal 1871
10
Clarence Carrington Cabell Tutwiler
[1.2.1.4.5.2.2.2.3.10]
b. 15 Nov 1873 d. 3 Mar 1956
8
Ann Carrington Cabell
[1.2.1.4.5.2.2.3]
b. 20 Sep 1787 d. 7 Jul 1854
John James Flournoy
b. 15 Oct 1782 d. 1862
9
Ann Eliza Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.1]
b. 1808
+
Henry Wood
9
William Cabell Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2]
b. 31 Dec 1809 d. 31 Mar 1861
Martha Watkins Venable
b. 5 Jun 1816 d. 1905
10
Ann Cabell Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.1]
b. Abt 1835 d. Abt 1837
10
II John James Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.2]
b. 13 Apr 1837 d. 7 Jan 1875
10
William Venable Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.3]
b. Abt 1839 d. Abt 1842
10
Benjamin Stanhope Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.4]
b. Abt 1841 d. Abt 1842
10
Frances Florida Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.5]
b. 6 Jul 1843
+
John P. Fitzgerald
10
Sarah Venable Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.6]
b. 12 Aug 1845
+
J. C. Painter
10
George Mallory Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.7]
b. Abt 1848 d. Abt 1853
10
Landon Cabell Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8]
b. 4 Mar 1850
Martha G. Givens
b. 1858 d. 9 May 1884
11
Bessie Venable Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.1]
b. 29 Jan 1878
+
Brown
11
Florida Fitzgerald Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.2]
b. 31 Aug 1879
11
Sarah Wright Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.3]
b. 9 Apr 1881
+
Butts
11
Martha Watkins Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.4]
b. 24 Dec 1882
Susan Cabell Cobbs
b. 5 Nov 1864
11
Mary Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.5]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
11
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.6]
b. 20 Sep 1890
11
Mildred Cobbs Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.7]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
11
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.8]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
11
Thomas Stanhope Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.8.9]
b. 24 Oct 1896
10
Alice Eliza Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.9]
b. 4 Nov 1852
+
Littleton Fitzgerald
10
Charles Bruce Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.2.10]
b. 11 Nov 1854
+
Virginia Dalby
9
Thomas Stanhope Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3]
b. 15 Dec 1811 d. 12 Mar 1883
Susan Ann Love
d. 21 Apr 1848
10
Allen Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.1]
d. Abt 1849
10
Mary P. Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.2]
b. 11 Sep 1838 d. 1874
John F. Cobbs
11
Susan Cabell Cobbs
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.2.1]
b. 5 Nov 1864
Landon Cabell Flournoy
b. 4 Mar 1850
12
Mary Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.2.1.1]
b. 9 Mar 1889
12
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.2.1.2]
b. 20 Sep 1890
12
Mildred Cobbs Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.2.1.3]
b. 6 Sep 1892
12
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.2.1.4]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
12
Thomas Stanhope Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.2.1.5]
b. 24 Oct 1896
10
Cabell Edward Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.3]
b. 30 Jun 1840 d. 1864
10
John James Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.4]
b. 11 Apr 1842
10
Louisa Cabell Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.5]
b. 3 May 1844
+
William W. Cobbs
10
Henry Wood Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.6]
b. 6 Jun 1846
+
Rose Buena Wood
Mildred H. Coles
d. 1901
10
Walter Cole Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.7]
10
Helen Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.8]
b. 9 May 1856
+
John R. Patton
10
Ann Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.9]
b. Abt 1858 d. Abt 1862
10
Thomas Stanhope Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.10]
b. 8 May 1860
10
Cole Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.11]
b. 1 Oct 1862
10
Lettice Carrington Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.12]
b. 21 Aug 1865
10
Charles Carrington Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.3.13]
b. 17 Feb 1871
9
Patrick Henry Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.4]
b. 4 Mar 1813 d. 3 Mar 1887
Susan Edmunds
10
Nicholas Edmunds Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.4.1]
b. 23 Mar 1841
+
Catharine Patrick Wood
10
William Stanhope Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.4.2]
b. 23 Dec 1845
+
Bettie A. Wilson
10
Ann Cabell Flournoy
[1.2.1.4.5.2.2.3.4.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1848
8
Edward A. Cabell
[1.2.1.4.5.2.2.4]
b. 9 Feb 1797 d. 3 Mar 1869
Mary Rice Garland
b. 10 May 1804 d. Sep 1893
9
Patrick Henry Cabell
[1.2.1.4.5.2.2.4.1]
b. 10 May 1827 d. 19 Oct 1865
+
Pattie Waller Aylett
b. 1812/1841 d. 1828/1923
8
Mayo Cabell
[1.2.1.4.5.2.2.5]
b. 7 Nov 1800 d. 5 May 1869
Mary Cornelia Daniel
b. 18 Oct 1804 d. 7 Mar 1843
9
William Daniel Cabell
[1.2.1.4.5.2.2.5.1]
b. 13 Jan 1834 d. 31 Aug 1870
+
Elizabeth Nicholas Cabell
b. 16 Jul 1834 d. 5 Apr 1863
7
Elizabeth Cabell
[1.2.1.4.5.2.3]
b. 1774 d. 5 Nov 1801
William H. Cabell
b. 16 Dec 1772 d. 12 Jan 1853
8
Nicholas Carrington Cabell
[1.2.1.4.5.2.3.1]
b. 9 Feb 1796 d. 13 Oct 1821
8
Louisa Elizabeth Cabell
[1.2.1.4.5.2.3.2]
b. 19 Feb 1798 d. 8 Jan 1865
Henry Carrington
b. 17 Sep 1793 d. 5 Dec 1867
9
William Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.2.3.2.1]
b. 27 Aug 1821 d. 29 Dec 1851
Maria Louisa Dabney
b. 15 Jun 1825 d. 5 Aug 1902
10
Louisa Edmonia Carrington
[1.2.1.4.5.2.3.2.1.1]
b. 1846 d. Abt 1847
10
Elizabeth Lewis Carrington
[1.2.1.4.5.2.3.2.1.2]
b. 14 Oct 1849
10
Williamine "Willa" Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.2.3.2.1.3]
b. 20 Jun 1852 d. 16 Feb 1934
Robert Alexander Lancaster
b. 1829 d. 1902
11
Henry Carrington Lancaster
[1.2.1.4.5.2.3.2.1.3.1]
b. 12 Nov 1882
9
Paulina Edmonia Carrington
[1.2.1.4.5.2.3.2.2]
b. 22 Oct 1825
William W. Read
b. 1827 d. 1889
10
Maria C. Read
[1.2.1.4.5.2.3.2.2.1]
b. 1850
Thomas A. Watkins
b. 1849
11
Edmonia C. Watkins
[1.2.1.4.5.2.3.2.2.1.1]
+
Charles Jeter Hatcher
8
Abraham Joseph Cabell
[1.2.1.4.5.2.3.3]
b. 24 Apr 1800 d. Oct 1831
6
Joseph Cabell
[1.2.1.4.5.3]
b. 19 Sep 1732 d. 1 Mar 1798
Mary Hopkins
b. Jan 1735 d. 12 Jul 1811
7
Elizabeth Cabell
[1.2.1.4.5.3.1]
b. 1753 d. 31 Jan 1771
William Megginson
b. Abt 1747 d. 31 Aug 1776
8
Joseph Cabell Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1]
b. 28 Jan 1771 d. 11 Apr 1811
Sarah Bolling
b. 1 Oct 1774
9
William Cabell Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1.1]
b. 17 Apr 1794 d. 2 Nov 1847
+
Amanda M Bocock
b. 1800
9
Elizabeth C. Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1.2]
b. 1796
+
William Berkeley
b. 1792
9
Archibald Bolling Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1.3]
b. 9 Mar 1798 d. 6 Feb 1851
+
Ann R. White
b. 1 Aug 1807 d. 8 Oct 1829
+
Elizabeth Roberts
b. 2 Nov 1807
9
Jr. Joseph Cabell Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1.4]
b. 11 Feb 1800 d. 28 Mar 1858
+
Almira Montgomery
b. 14 Sep 1801 d. 13 Apr 1831
9
Samuel Bolling Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1.5]
b. 14 Jan 1802
+
Mary Ann Johnston
b. 19 Mar 1809
9
Jane Randolph Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1.6]
b. 1804
+
Nathaniel R. Powell
b. 1800
9
John Randolph Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1.7]
b. 1 May 1806 d. Jul 1875
+
Mary R. Dunn
b. 1814
9
Benjamin Cabell Megginson
[1.2.1.4.5.3.1.1.8]
b. 31 Jul 1809 d. 20 Apr 1887
+
Fannie Blain
b. 1819 d. 11 Mar 1879
+
Maria Campbell Hening
b. Abt Apr 1846
7
Jr. Joseph Cabell
[1.2.1.4.5.3.2]
b. 6 Jan 1762 d. 31 Aug 1831
Pocahontas Rebecca Bolling
b. Abt 1766 d. 1803
8
Benjamin William Sheridan Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1]
b. 1793 d. 1862
Sarah Eppes Doswell
b. 27 Apr 1802 d. 5 Aug 1874
9
Pocahontas Rebecca Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.1]
b. 29 Jun 1819 d. 3 Feb 1858
9
John Roy Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.2]
b. 24 Mar 1823 d. Aug 1896
9
Virginia J Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.3]
b. 1825 d. 1832
9
William Lewis Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4]
b. 1 Jan 1827 d. 22 Feb 1911
Harriet Amanda Rector
b. 3 Jun 1837 d. 16 Apr 1887
10
William Lewis Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.1]
d. 1864
10
Benjamin Elias Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.2]
b. 18 Nov 1858 d. 8 Feb 1931
Sadie Earle Pearre
b. 18 Sep 1869 d. 16 Jun 1921
11
Jr. Benjamin Elias Cabell, Jr
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.2.1]
b. 9 Sep 1899 d. 11 Apr 1964
Olivia
b. 1896
12
Sarah Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.2.1.1]
11
Earle Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.2.2]
Elizabeth
b. Abt 1906
12
Elizabeth Lee Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.2.2.1]
10
Katie Doswell Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.3]
b. 6 Jan 1861 d. 1927
+
John R. Currie
b. 24 Apr 1889
+
James Clarence Muse
b. 17 Jun 1860 d. 8 Jan 1943
10
Pocahontas Rebecca Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.4]
b. Abt 1866 d. CHILD
10
Powhatan Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.5]
b. 9 Sep 1867 d. Bef 28 Sep 1867
10
John Joseph Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.6]
b. 28 Oct 1870 d. 8 Oct 1903
Phoebe Ann Lee
11
Shingo Marie Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.6.1]
b. 24 Dec 1898 d. Dec 1974
Richard Paul Lemin
b. 6 Oct 1888 d. 6 Apr 1967
12
Margaret Ann Lemin
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.6.1.1]
12
James Edgar Lemin
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.6.1.2]
12
Earl Vincent Lemin
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.6.1.3]
12
Mary Katherine Lemin
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.6.1.4]
12
Joseph William Lemin
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.6.1.5]
10
Lawrence Duval Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.7]
b. 22 Aug 1874 d. 24 Nov 1946
11
Charles Pearre Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.7.1]
b. 11 Oct 1903 d. 25 May 1971
Octavia Jacklyn DeHymel
12
Benjamin Elias Cabell, IV
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.7.1.1]
12
Charles Pearre Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.7.1.2]
12
Catharine Dewitt Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.7.1.3]
+
Frances Cabell
b. 22 Apr 1877 d. 20 Aug 1949
10
Lewis Rector Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.4.8]
b. 3 Jan 1879
9
Powhatan Bolling Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.5]
b. 17 Oct 1828 d. 14 Dec 1859
9
Algernon Sidney Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.6]
b. 25 Nov 1832
9
George Craighead Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.7]
b. 25 Jan 1836 d. 23 Jun 1906
9
Sarah Epes Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.8]
b. 25 Nov 1838 d. 9 Nov 1876
9
Joseph Robert Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.9]
b. 28 May 1840 d. 10 May 1864
9
Benjamin Edward Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.1.10]
b. 8 Dec 1842 d. 17 Mar 1862
Anne Everard Bolling
b. 13 Mar 1778 d. 26 Jan 1834
8
Jane Randolph Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.2]
b. 1805 d. 1833
+
Philip T. Allen
8
John B. Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.3]
b. 1808
+
Mary C. Wardlaw
d. 1835
+
Martha Posey
8
Elizabeth Robertson Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.4]
b. 1809 d. 1852
+
James B. Paulett
+
Archibald Dixon
8
Robert Bolling Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5]
b. 22 Feb 1812 d. 27 Dec 1876
+
Anne E. Herndon
d. 1834
Eleanor Hart
b. 11 Aug 1816 d. 4 Jun 1904
9
Mary Frances Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.1]
b. 14 Jan 1836 d. 2 Nov 1837
9
Jane Randolph Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.2]
b. 27 Mar 1838 d. 4 Sep 1839
9
Pocahontas Rebecca Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.3]
b. 14 Jun 1840 d. 18 Sep 1872
9
Mary Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.4]
b. 6 Apr 1843 d. 31 Oct 1873
9
Sue Cowan Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.5]
b. 6 Nov 1845
9
Alethair Spalding Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.6]
b. 18 Sep 1847 d. 4 Apr 1933
9
Laura B Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.7]
b. 24 Feb 1851 d. 19 Dec 1947
9
Alice S Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.8]
b. 1853
9
Caroline Allin Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.9]
b. 8 Jan 1854
9
Inah Gabriella Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.10]
b. 27 Jun 1858 d. 14 Jan 1947
9
Robert Bolling Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.11]
b. 9 Aug 1859
9
Joseph Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.5.12]
b. 3 May 1862 d. 17 Dec 1935
8
George W. Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.6]
b. 1814
+
Mary R. Williams
8
Mary Ann Hopkins Cabell
[1.2.1.4.5.3.2.7]
b. 1824
+
E. L. Willard
7
Mary Hopkins Cabell
[1.2.1.4.5.3.3]
b. 22 Feb 1769 d. 26 Mar 1858
John Breckinridge
b. 2 Dec 1760 d. 14 Dec 1806
8
Joseph Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.1]
b. 14 Jul 1788 d. 1 Sep 1823
Mary Clay Smith
b. 31 Aug 1787 d. 9 Oct 1864
9
John Cabel Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.1.1]
b. 16 Jan 1821 d. 17 May 1875
Mary Cyrene Burch
10
Elizabeth Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.1.1.1]
+
Samuel Meredith
10
John Witherspoon Owen Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.1.1.2]
b. Abt 1851
Louise Tevis
b. Abt 1859
11
Lloyd Tevis Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.1.1.2.1]
b. Abt 1878
11
John Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.1.1.2.2]
b. Jul 1879 d. 11 Jul 1927
Adelaide Murphy
12
III John Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.1.1.2.2.1]
8
Letitia Preston Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.2]
b. Abt 1790
Alfred W. Grayson
b. Abt 1785
9
John Breckinridge Grayson
[1.2.1.4.5.3.3.2.1]
d. 1862
Peter H. Porter
b. Abt 1785
9
Peter A. Porter
[1.2.1.4.5.3.3.2.2]
d. 1864
8
John Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.3]
b. 4 Jul 1797 d. 4 Aug 1841
Margaret Miller
b. 1802 d. 1838
9
Mary Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.3.1]
b. 1826 d. 1854
9
Samuel Miller Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.3.2]
b. 3 Nov 1828 d. 28 May 1891
+
Virginia Castleman
b. 4 Jul 1827 d. 1903
9
Margaret Elizabeth Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.3.3]
b. 1832 d. 1864
Maley Babcock
b. 1 Apr 1821
9
Agatha Marshall Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.3.4]
b. 13 Jul 1841 d. 30 Oct 1882
8
Robert Jefferson Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4]
b. 8 Mar 1800 d. 27 Dec 1871
Ann Sophonisba Preston
b. 9 Apr 1803 d. 20 Dec 1844
9
Mary Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.1]
b. 6 Apr 1828 d. 13 Jan 1902
William Warfield
b. 30 May 1827 d. 21 Jan 1907
10
Benjamin Breckinridge Warfield
[1.2.1.4.5.3.3.4.1.1]
b. 5 Nov 1851 d. 16 Feb 1921
9
Sophonisba Preston Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.2]
b. 1839 d. 1880
9
Joseph Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3]
b. 14 Jan 1842 d. 18 Aug 1920
Louise Ludlow Dudley
b. 20 Feb 1849 d. 19 Sep 1911
10
Robert J. Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.1]
b. 1869 d. 1871
10
Mary Dudley Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.2]
b. 20 Jul 1869 d. 1939
John Fore Hines, Sr
b. 22 Sep 1869 d. 19 Oct 1941
11
Louise D Hines
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.2.1]
+
Horace Isaiah Greenwood
b. 30 Apr 1901 d. 3 Oct 1964
11
John Fore Hines, Jr
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.2.2]
Mary Janet Earle
12
John Fore Hines, 3rd
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.2.2.1]
12
Ralph Earle Hines
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.2.2.2]
b. 26 May 1938 d. 19 Feb 1967
11
Mary Breckinridge Hines
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.2.3]
Edward Blanchard Hodge, III
12
Edward Blanchard Hodge, IV
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.2.3.1]
10
Joseph Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.3]
b. 6 Mar 1872 d. 11 Feb 1898
10
Louise Dudley Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.4]
b. 1873 d. 1874
10
Ethelbert Ludlow Dudley Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.5]
b. 17 Jul 1875 d. 26 Jul 1914
10
Mabel Warfield Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.6]
b. 16 Feb 1877 d. 24 Mar 1877
10
Lucian Scott Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.7]
b. 1 Dec 1878 d. 1941
10
Lucy Hayes Breckenridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.8]
b. 7 Jan 1881 d. Abt 1959
10
Scott Dudley Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.9]
b. 23 May 1882 d. 1 Aug 1941
10
Charles Henry Preston Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.10]
b. 6 Sep 1884 d. 19 Jul 1885
10
Henry Dudley Skillman Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.11]
b. 25 May 1886 d. 2 May 1960
10
Margaret Scott Skillman Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.12]
b. 1 May 1889 d. 30 Jan 1970
10
John Preston Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.4.3.13]
b. 29 Oct 1890
+
Margaret Faulkner
b. 1828
8
William Lewis Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5]
b. 22 Jul 1803 d. 26 Nov 1876
+
Sarah Ann Tompkins
b. 8 Apr 1809 d. 31 May 1900
Frances Caroline Prevost
b. 24 Aug 1806 d. 12 Nov 1870
9
Joseph Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.1]
b. 11 Mar 1825 d. 10 Aug 1839
9
John Bartow Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.2]
b. 27 Oct 1826
9
Robert James Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.3]
b. 2 Dec 1828 d. 8 Jul 1867
+
Katherine Grosh Hunt
b. 26 May 1833 d. 12 Dec 1909
9
Marcus Stanhope Prevost Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.4]
b. 17 Oct 1830 d. 25 Jul 1870
+
Lucy Leonis Long
b. 31 Oct 1832 d. 17 Oct 1917
9
William Lewis Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.5]
b. 12 Nov 1832 d. 5 Jul 1890
+
Anna Priscilla Clark
b. 6 Nov 1836 d. 12 Mar 1901
9
Lewis Green Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.6]
b. 19 Sep 1834 d. 10 Sep 1835
9
Frances Provost Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.7]
b. 12 Oct 1836 d. 16 Mar 1900
9
Mary Hopkins Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.8]
b. 1 Feb 1839 d. 12 Apr 1880
+
John Milton McKnight
b. 8 Jan 1832 d. 25 Mar 1894
9
Stanhope Prevost Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.9]
b. 30 Apr 1841
+
Rosa Logan McKnight
b. 2 Feb 1830 d. 13 Aug 1868
9
Theodosia Prevost Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.10]
b. 11 Aug 1843 d. 25 Jun 1844
9
Cabell Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.11]
b. 22 Nov 1846 d. 13 Nov 1907
+
Julia Symes Marshall
b. 20 Oct 1843 d. 5 Oct 1920
9
Laetitia Porter Breckinridge
[1.2.1.4.5.3.3.5.12]
b. 24 Aug 1849 d. 18 Apr 1852
7
Ann Cabell
[1.2.1.4.5.3.4]
b. 15 Feb 1771 d. 27 Jul 1840
Robert Carter Harrison
b. 14 Jun 1765 d. 9 Sep 1840
8
Susanne Randolph Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.1]
b. 1789 d. 12 Oct 1860
+
Hugh Brent
b. 1785
+
Charles Lewis
b. 1785
8
Mary Hopkins Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.2]
b. 9 Apr 1791 d. 10 Jun 1834
Samuel Q. Richardson
b. 1787 d. 11 Feb 1835
9
Anna Cabell Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.1]
b. 1814 d. 1887
+
William Todd
b. 1810
9
Sarah Bainbridge Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.2]
b. 8 Oct 1815 d. Aft 1894
+
John Leighton
b. 4 May 1813 d. 16 Aug 1885
9
Mary H. Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.3]
b. 10 May 1817
+
Richard Fell Richmond
b. 23 May 1810 d. 17 Nov 1857
9
John Crowley Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.4]
b. 4 May 1824 d. 1841
9
Robert Carter Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.5]
b. 18 May 1826 d. Jun 1896
Maria Louisa Harris
b. 1838 d. Dec 1920
10
Mary Cabell Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.5.1]
d. 10 Apr 1925
10
Carter H. Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.5.2]
d. 1871
10
Jr. Robert Carter Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.5.3]
d. 1875
9
Jr. Samuel Q. Richardson
[1.2.1.4.5.3.4.2.6]
b. 20 Jun 1828
+
Mary Jane Williamson
b. 1837
8
Joseph Cabell Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.3]
b. 27 May 1793 d. 7 Sep 1860
Sophia Rice
b. 21 Dec 1798
9
Anna Cabell Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.3.1]
b. 27 Sep 1819
+
Joseph A. Graves
b. 1815
9
Robert Carter Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.3.2]
b. 5 Oct 1821 d. 1893
9
Lucy Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.3.3]
b. 23 Sep 1827
+
John Jordan
b. 1823
9
Maria Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.3.4]
b. 16 Jun 1830
+
Nathan H. Clarkson
b. 1829
9
Mary Hopkins Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.3.5]
b. 10 Jun 1835
+
Lewis H. Corbin
b. 1831
9
Susan Randolph Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.3.6]
b. 9 Oct 1837
+
George T. Gaines
b. 1833
8
II Carter Henry Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4]
b. 30 Sep 1796 d. 9 Oct 1825
Caroline Evelyn Russell
b. 15 Jun 1797 d. 14 Aug 1875
9
III Carter Henry Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1]
b. 15 Feb 1825 d. 28 Oct 1893
Sophonisba Grayson Preston
b. 27 Oct 1833 d. Sep 1876
10
Sophie Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.1]
+
A. Roland Thomson
10
Carolina Dudley "Lina" Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.2]
b. 28 Mar 1857 d. 21 Feb 1943
+
Heaton Owsley
10
IV Carter Henry Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.3]
b. 23 Apr 1860 d. 25 Dec 1953
Edith Ogden
b. 16 Nov 1862 d. 22 May 1955
11
Jr. Carter Henry Harrison, V
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.3.1]
b. 28 Jun 1890 d. 9 Nov 1964
Lucy Brady Cook
12
Lucy Brady Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.3.1.1]
12
Edith Ogden Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.3.1.2]
12
Carolyn Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.3.1.3]
12
Joanne Howell Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.3.1.4]
11
Edity Ogden Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.3.2]
10
William Preston Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.4]
b. 12 Apr 1869 d. 28 Jun 1940
Ada Marie Sandberg
b. 12 Mar 1882 d. 22 Oct 1947
11
Preston Carter Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.4.1.4.1]
b. 4 Apr 1921 d. 11 Jan 1941
+
Margaret E. Stearns
b. 1829 d. 1887
8
Ann Cabell Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.5]
b. 28 Aug 1798
Samuel M. Brown
b. 26 Mar 1790 d. 1844
9
Virginia Harrison Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.1]
b. 1819 d. 1828
9
Letitia Preston Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.2]
b. 1820 d. 1828
9
Robert Harrison Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.3]
b. 1822 d. 1828
9
George Mason Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.4]
b. 21 Sep 1824 d. 1861
+
Sara A. Hicklin
b. 1828
9
William Breckinridge Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.5]
b. 5 Feb 1828 d. 1861
+
Lenora V. Thompson
b. 1832
9
Samuel Mansfield Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.6]
b. 30 Apr 1830
9
Ann Mary Cabell Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.7]
b. 1834 d. 1854
9
Theodosia Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.8]
b. 1836 d. 1836
9
Joshua Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.9]
b. 1838 d. 1838
9
Carter Henry Brown
[1.2.1.4.5.3.4.5.10]
b. 1840
8
Jr. Robert Carter Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.6]
b. Oct 1800
Theodosia Thompkins
b. 1808
9
Sarah Ann Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.6.1]
b. 20 Sep 1833
+
David Castleman
b. 1829
8
Elizabeth Lewis Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.7]
b. Sep 1802 d. 26 Jun 1870
James Devore
b. 10 May 1796 d. 6 Mar 1854
9
Samuel Devore
[1.2.1.4.5.3.4.7.1]
b. 1826
9
Robert Harrison Devore
[1.2.1.4.5.3.4.7.2]
b. Abt 1826 d. 11 Jun 1882
Mary Ann Etherington
b. 22 Mar 1826 d. 13 Jan 1915
10
Robert Harrison Devore, Jr
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.1]
b. 1847 d. 15 Dec 1895
10
Martha Devore
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.2]
b. Abt 1850
10
Ann Devore
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.3]
b. Abt 1859
10
Lettie Devore
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.4]
b. Abt 1860
10
Mammie Devore
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.5]
b. 3 Feb 1862 d. 13 May 1943
? J McMichael
b. Jul 1860
11
Ripy Devore McMichael
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.5.1]
b. 16 Nov 1892 d. 16 Jul 1973
Virginia B "Vergie" Kemper
b. 14 Nov 1895 d. 23 Aug 1929
12
David J McMichael
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.5.1.1]
12
Mary E McMichael
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.5.1.2]
12
Ripy Devore McMichael
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.5.1.3]
11
Robert McMichael
[1.2.1.4.5.3.4.7.2.5.2]
b. Jan 1898
8
Sarah Randolph Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.8]
b. Oct 1804
+
Isaac Lansdale
b. 1800
Bulkley
b. 1800
9
Robert H. Bulkley
[1.2.1.4.5.3.4.8.1]
b. 1826
8
Virginia Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.9]
b. 4 Jul 1806 d. 1902
David Castleman
b. 30 Oct 1786 d. 23 May 1852
9
Ann Cabell Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.1]
b. 28 Dec 1825 d. 27 Jan 1890
Henry W. D. Kuyle
b. Abt 1824 d. 6 Oct 1850
10
David Castleman Kuyle
[1.2.1.4.5.3.4.9.1.1]
b. 1846 d. 1847
10
Virginia Castleman Kuyle
[1.2.1.4.5.3.4.9.1.2]
b. 14 May 1848 d. 4 Jun 1908
+
David Castleman Tandy
b. 1821
9
Margaret Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.2]
b. 1827
9
Virginia Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.3]
b. 4 Jul 1827 d. 1903
+
Samuel Miller Breckinridge
b. 3 Nov 1828 d. 28 May 1891
9
Lewis Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.4]
b. 8 Oct 1828
+
Susan Mary Herndon
b. 1850
9
David Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.5]
b. 1829
+
Sarah Ann Harrison
b. 20 Sep 1833
9
Susan Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.6]
b. 1829
9
Robert Carter Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.7]
b. 19 Aug 1831 d. 22 Jun 1852
9
Mary Ann Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.8]
b. 10 May 1836
+
William Webb
b. 1832
9
John Breckinridge Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.9]
b. 30 Jun 1842
+
Barbee
b. 1846
9
Frances Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.10]
b. 10 Apr 1844
+
George Bernard Eastin
b. 1842
9
Humphreys Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.11]
b. 10 Apr 1844
+
Eva Garrard
b. 1847
9
Sarah Belle Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.12]
b. 17 Apr 1846
+
John W. Carroll
b. 1842 d. 15 Mar 1890
9
George Alfred Castleman
[1.2.1.4.5.3.4.9.13]
b. 4 Oct 1847
+
Lucie Read Cable
b. 1867
8
Pocahontas Rebecca Peyton Harrison
[1.2.1.4.5.3.4.10]
b. Aug 1809
Samuel Sloane
b. 1805
9
Mary Sloane
[1.2.1.4.5.3.4.10.1]
b. 1831
9
Virginia Sloane
[1.2.1.4.5.3.4.10.2]
b. 1833
9
Robert Harrison Sloane
[1.2.1.4.5.3.4.10.3]
b. 1835
9
Jr. Samuel Sloane
[1.2.1.4.5.3.4.10.4]
b. 1837
7
Elizabeth Cabell
[1.2.1.4.5.3.5]
b. 1772 d. 6 Feb 1855
+
William J. Lewis
b. 4 Jul 1766
6
George Cabell
[1.2.1.4.5.4]
b. Abt 1742
6
John Cabell
[1.2.1.4.5.5]
b. 1742 d. 1815
Paulina Jordan
b. Abt 1741 d. 31 Jul 1781
7
George Cabell
[1.2.1.4.5.5.1]
b. 1 Nov 1766 d. Dec 1823
Sarah Winston
b. 9 Feb 1747/48 d. Aug 1776
8
Sarah Cabell
[1.2.1.4.5.5.1.1]
d. CHILD
8
Paulina Jordan Cabell
[1.2.1.4.5.5.1.2]
b. 1796 d. Dec 1833
Alexander Spotswood Henry
b. 2 Jun 1788 d. 6 Jan 1854
9
George Lafayette Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.1]
b. 29 Oct 1815 d. 16 May 1884
Margaretta Mason
b. May 1824
10
John Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.1.1]
b. 1832/1875 d. 1841/1951
10
Francis Marion Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.1.2]
b. 1832/1875 d. 1853/1951
+
Frances Cabell Henry
b. 19 Jun 1857 d. 19 Jan 1923
9
Sarah Winston Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.2]
b. 1822 d. 1906
George Cabell Carrington
b. 1819 d. 1880
10
John P. Merreaux Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.2.2.1]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Fanny Toot
b. 1829/1874 d. 1850/1953
10
Susan Love Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.2.2.2]
b. 1829/1868 d. 1847/1948
A. Y. Hundley
b. 1821/1866 d. 1847/1943
11
Alice C. Hundley
[1.2.1.4.5.5.1.2.2.2.1]
10
Charles Craddock Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.2.2.3]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Sally H. French
b. 1829/1874 d. 1850/1953
10
Sarah Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.2.2.4]
b. 1829/1868 d. 1847/1948
+
J. W. F. Bealle
b. 1821/1866 d. 1847/1943
10
Richard Bruce Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.2.2.5]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Ida Harrison
b. 1829/1874 d. 1850/1953
10
Walter Coles Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.2.2.6]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Nettie Bauhan
b. 1829/1874 d. 1850/1953
9
John Robert Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3]
b. 28 May 1823 d. 11 Nov 1903
Frances Elizabeth Edwards
b. 19 Apr 1829 d. 17 Feb 1904
10
Cabell Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.1]
b. 1850 d. 1951
10
Sarah S. Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.2]
b. 1851 d. Sep 1915
10
William Keen Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.3]
b. 15 Mar 1852 d. 23 Apr 1919
+
Fanny Harper
b. 1832/1880 d. 1853/1958
10
Elizabeth E. Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.4]
b. 23 Oct 1853 d. 1883
+
Reuben Witcher
b. 1824/1873 d. 1850/1949
10
Frances Cabell Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.5]
b. 19 Jun 1857 d. 19 Jan 1923
+
Francis Marion Henry
b. 1832/1875 d. 1853/1951
10
Eliza Garland Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.6]
b. 19 Aug 1859
10
Daniel Edward Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.7]
b. 1862 d. Feb 1895
10
Patrick Mason Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.8]
b. 3 Dec 1863 d. 16 Feb 1902
+
Mary Anderson
b. 1832/1880 d. 1853/1958
10
Gillie Coleman Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.9]
b. 18 Mar 1867 d. 3 Jan 1938
10
Marie Antoinette Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.3.10]
b. 9 Apr 1872 d. Feb 1944
9
Patrick Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.4]
b. Abt 1829
Clara F. Yancey
b. Abt 1833
10
John Patrick Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.4.1]
b. 1852
10
William Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.4.2]
b. 1855
10
George Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.4.3]
b. 1866
9
Maria Antoinette Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.5]
b. 1807/1836 d. 1823/1918
+
A. L. Hambrick
b. 1797/1834 d. 1823/1912
9
Marion F. Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.6]
b. 1807/1836 d. 1823/1918
+
Samuel Tyree
b. 1797/1834 d. 1823/1912
9
Paulina Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.7]
b. 1807/1836 d. 1829/1918
Barlett Jones
b. 1797/1834 d. 1829/1912
10
Cabell H. Jones
[1.2.1.4.5.5.1.2.7.1]
b. 1829/1868 d. 1838/1945
9
Lewis Cabell Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.8]
b. 1807/1836 d. 1813/1915
9
Laura S. Henry
[1.2.1.4.5.5.1.2.9]
b. 1807/1836 d. 1812/1918
8
Edmund Winston Cabell
[1.2.1.4.5.5.1.3]
b. Abt 1797
8
George Kuhn Cabell
[1.2.1.4.5.5.1.4]
b. Abt 1799 d. 1873
+
Eliza Garland
8
Alice Cabell
[1.2.1.4.5.5.1.5]
b. 1800 d. 1846
Walter Coles Carrington
b. 4 Mar 1794 d. 1858
9
Edward Coles Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.1]
Mary Coleman
10
Thomas Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.1.1]
+
Fowlkes
+
Cockerill
9
Jr. Walter Coles Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.2]
+
Isadora Meredith Myrick
Mary Jett
10
III. Walter Coles Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.2.1]
9
George Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.3]
b. 1819 d. 1880
Sarah Winston Henry
b. 1822 d. 1906
10
John P. Merreaux Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.3.1]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Fanny Toot
b. 1829/1874 d. 1850/1953
10
Susan Love Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.3.2]
b. 1829/1868 d. 1847/1948
A. Y. Hundley
b. 1821/1866 d. 1847/1943
11
Alice C. Hundley
[1.2.1.4.5.5.1.5.3.2.1]
10
Charles Craddock Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.3.3]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Sally H. French
b. 1829/1874 d. 1850/1953
10
Sarah Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.3.4]
b. 1829/1868 d. 1847/1948
+
J. W. F. Bealle
b. 1821/1866 d. 1847/1943
10
Richard Bruce Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.3.5]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Ida Harrison
b. 1829/1874 d. 1850/1953
10
Walter Coles Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.3.6]
b. 1829/1868 d. 1850/1945
+
Nettie Bauhan
b. 1829/1874 d. 1850/1953
9
Paul Jones Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4]
b. Abt 1822
+
Catherine Carrington
Margaret A. Thompson
d. 1887
10
Alice Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.1]
d. INFANT
10
Lucas Thompson Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.2]
d. INFANT
10
Susan Cary Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.3]
10
John M. Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.4]
10
Paul Julian Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.5]
10
Caroline T. Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.6]
10
Eleanor S. Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.7]
d. 1893
10
Mary Love Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.8]
10
Alice Lee Carrington
[1.2.1.4.5.5.1.5.4.9]
8
John Breckingridge Cabell
[1.2.1.4.5.5.1.6]
b. 1801 d. 1883
+
Martha Bickerton Bouldin
b. Abt 1805 d. 1862
8
William J. Lewis Cabell
[1.2.1.4.5.5.1.7]
b. 1806 d. 1830
+
Eliza Daniel
d. Bef Oct 1830
8
Marion Fontaine Cabell
[1.2.1.4.5.5.1.8]
b. 1809 d. 1834
+
Landon Rose Cabell
7
William Daniel
[1.2.1.4.5.5.2]
b. 1770 d. 20 Nov 1839
Margaret Baldwin
b. 19 Sep 1784 d. Oct 1826
8
Eliza Daniel
[1.2.1.4.5.5.2.1]
d. Bef Oct 1830
+
William J. Lewis Cabell
b. 1806 d. 1830
8
Mary Cornelia Daniel
[1.2.1.4.5.5.2.2]
b. 18 Oct 1804 d. 7 Mar 1843
Mayo Cabell
b. 7 Nov 1800 d. 5 May 1869
9
William Daniel Cabell
[1.2.1.4.5.5.2.2.1]
b. 13 Jan 1834 d. 31 Aug 1870
+
Elizabeth Nicholas Cabell
b. 16 Jul 1834 d. 5 Apr 1863
+
Elizabeth Brierton Jones
6
Nicholas Cabell
[1.2.1.4.5.6]
b. 29 Oct 1750 d. 18 Aug 1803
Hannah Carrington
b. 28 Mar 1751 d. 7 Aug 1817
7
William H. Cabell
[1.2.1.4.5.6.1]
b. 16 Dec 1772 d. 12 Jan 1853
Elizabeth Cabell
b. 1774 d. 5 Nov 1801
8
Nicholas Carrington Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.1]
b. 9 Feb 1796 d. 13 Oct 1821
8
Louisa Elizabeth Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.2]
b. 19 Feb 1798 d. 8 Jan 1865
Henry Carrington
b. 17 Sep 1793 d. 5 Dec 1867
9
William Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.2.1]
b. 27 Aug 1821 d. 29 Dec 1851
Maria Louisa Dabney
b. 15 Jun 1825 d. 5 Aug 1902
10
Louisa Edmonia Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.2.1.1]
b. 1846 d. Abt 1847
10
Elizabeth Lewis Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.2.1.2]
b. 14 Oct 1849
10
Williamine "Willa" Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.2.1.3]
b. 20 Jun 1852 d. 16 Feb 1934
Robert Alexander Lancaster
b. 1829 d. 1902
11
Henry Carrington Lancaster
[1.2.1.4.5.6.1.2.1.3.1]
b. 12 Nov 1882
9
Paulina Edmonia Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.2.2]
b. 22 Oct 1825
William W. Read
b. 1827 d. 1889
10
Maria C. Read
[1.2.1.4.5.6.1.2.2.1]
b. 1850
Thomas A. Watkins
b. 1849
11
Edmonia C. Watkins
[1.2.1.4.5.6.1.2.2.1.1]
+
Charles Jeter Hatcher
8
Abraham Joseph Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.3]
b. 24 Apr 1800 d. Oct 1831
Agnes Sarah Bell Gamble
b. 22 Aug 1783 d. 15 Feb 1863
8
Catherine Ann Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.4]
b. 12 Aug 1806 d. 1807
8
Emma Catherine Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.5]
b. 10 Mar 1808 d. 31 Mar 1887
Paul Sydenham Carrington
b. 10 May 1798 d. 29 Jul 1866
9
Adaline Mayo Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.1]
9
Isaac Howell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2]
b. 7 Mar 1827 d. 30 Jan 1887
Mary Coles
d. 1860
10
Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.1]
d. INFANT
10
Elizabeth Dandrige Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.2]
b. 1855 d. 1924
10
John Rice Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.3]
b. 1857 d. 1869 OR 1884
10
Emma Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.4]
b. 1859 d. 1884
Anne Seddon Smith
d. LIV. 1895
10
Heyward Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.5]
b. 1866 d. 1883
10
Nannie Seddon Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.6]
b. 1868 d. 1869
10
Marion Morson Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.7]
b. 1869 d. 1869
10
Malcolm Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.8]
b. 1874
10
Mary Coles Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.9]
b. 1876
10
Seddon Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.10]
b. 1880
10
Margaret Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.2.11]
b. 1883
9
Robert Gamble Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.3]
b. 1828
Jane C. Spiller
10
Frank Bernard Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.3.1]
d. Bef 1930
9
Abram Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.4]
b. 15 Oct 1831 d. 30 Jun 1862
Anne Cabell Read
b. 1831 d. Apr 1893
10
William Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.4.1]
b. 13 Nov 1853
10
Clement Read Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.4.2]
b. 12 Jul 1855 d. 1899
10
II. Paul S. Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.4.3]
b. 1 Oct 1857 d. Bef 1930
10
Alexander Broadnax Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.4.4]
b. 22 Jul 1859 d. LIV. 1930
10
Annie Lee Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.4.5]
b. 21 Jul 1862 d. 8 Jan 1927
9
William Allen Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.5]
b. Abt 1833 d. 17 Jul 1866
Mildred Coles Carrington
b. 2 Nov 1839 d. 1 Jan 1923
10
Jr. William Allen Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.5.1]
d. INFANT
10
Edgar Wirt Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.5.2]
b. 26 May 1865 d. 1894
9
Alexander Broadnax Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.6]
b. Abt 1834 d. 1910
Frances Isabelle Venable
b. Abt 1838 d. 14 Jan 1885
10
Alexander Berkeley Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.6.1]
b. 27 Jan 1862
10
Charles Venable Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.6.2]
b. 29 Jul 1866 d. 1927
10
Gratton Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.6.3]
b. 3 Sep 1868 d. LIV. 1924
10
Frances Venable Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.6.4]
b. 9 Jun 1872
+
Sarah Ewell
d. Aft 1887
9
Edgar Wirt Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.7]
b. 1835 d. 31 May 1862
+
Mary H. Hanna
9
Louisa Cabell Carrington
[1.2.1.4.5.6.1.5.8]
b. 30 Apr 1837 d. 16 Jan 1902
Andrew "Black Andrew" Reid Venable
b. 4 Apr 1830 d. 12 Sep 1913
10
Adeline Carrington Venable
[1.2.1.4.5.6.1.5.8.1]
b. 12 Sep 1861
10
Susan Watkins Venable
[1.2.1.4.5.6.1.5.8.2]
b. 6 Jul 1863
10
Emma Cabell Venable
[1.2.1.4.5.6.1.5.8.3]
b. 2 Sep 1867
10
William Henry Venable
[1.2.1.4.5.6.1.5.8.4]
b. 2 Sep 1870
10
Edgar Wirt Venable
[1.2.1.4.5.6.1.5.8.5]
b. 17 Oct 1872
10
Richard Venable
[1.2.1.4.5.6.1.5.8.6]
b. 1876 d. 1876
8
Robert Gamble Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6]
b. 9 Dec 1809 d. 16 Nov 1889
Margaret Sophia Caskie
b. 22 Sep 1823 d. 3 Jul 1867
9
James Caskie Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.1]
b. 9 Feb 1844
9
William Henry Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.2]
b. 13 Nov 1845 d. 1864
+
Frances Elizabeth Irvine
b. 1 May 1846 d. 1 Jun 1928
+
Jennie M. Thomas
b. Abt 1877
9
Jr. Robert Gamble Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.3]
b. 16 Jul 1847 d. 1922
Anne Harris Branch
b. 31 Dec 1859 d. 14 Feb 1915
10
James Branch Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.3.1]
b. 14 Apr 1879 d. 5 May 1958
Priscilla Bradley Shepherd
d. Mar 1949
11
Ballard Hartwell Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.3.1.1]
+
Margaret Waller Freeman
10
III Robert Gamble Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.3.2]
b. 27 Apr 1881 d. 1968
10
John Lottier Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.3.3]
b. 27 Feb 1883
9
Edward Carrington Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.4]
b. 4 Jan 1850 d. 13 Jun 1883
+
Isaetta Read Carrington
b. 12 Sep 1855 d. 27 Oct 1923
9
Elizabeth Caskie Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.5]
b. 1 May 1851
9
Arthur Gratton Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.6]
b. 12 May 1853
9
Agnes Bell Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.7]
b. 18 Nov 1856
9
Henry Landon Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.8]
b. 3 Nov 1858
9
Margaret Constance Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.6.9]
b. 2 Dec 1862
8
Elizabeth Hannah Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.7]
b. 9 Sep 1811 d. 7 Nov 1892
8
William Wirt Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.8]
b. 1 Nov 1812
8
Edward Carrington Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.9]
b. 5 Feb 1816
8
John Grattan Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.10]
b. 17 Jun 1817
+
Agnes C. Coles
d. 31 Jan 1901
+
Sarah Marshall Tankersley
d. 15 Mar 1855
8
Henry Coalter Cabell
[1.2.1.4.5.6.1.11]
b. 14 Feb 1820 d. 31 Jan 1889
7
Frederic Cabell
[1.2.1.4.5.6.2]
b. 1775 d. 5 Mar 1841
Alice Winston
b. 1784
8
Mary Mildred Cabell
[1.2.1.4.5.6.2.1]
b. 15 Jan 1802 d. 3 Mar 1880
John Horsley
9
Edmond Winston Horsley
[1.2.1.4.5.6.2.1.1]
Lucy Wilhelmina Gwatkin
10
Edmonia Winston Horsley
[1.2.1.4.5.6.2.1.1.1]
+
P. L. Saunders
8
Frederic Montimer Cabell
[1.2.1.4.5.6.2.2]
b. 15 Jan 1802 d. 1873
8
Sarah Lynne Cabell
[1.2.1.4.5.6.2.3]
b. 27 Aug 1804 d. 16 Jul 1820
8
Alice Winston Cabell
[1.2.1.4.5.6.2.4]
b. Apr 1806 d. INFANT
8
Edmund Cabell
[1.2.1.4.5.6.2.5]
b. 12 Jul 1808
8
Clifford Cabell
[1.2.1.4.5.6.2.6]
b. 17 Aug 1810 d. 18 Sep 1871
8
Virginia Pauline Cabell
[1.2.1.4.5.6.2.7]
b. 15 Jul 1812 d. 23 May 1894
John Ware Mosby
b. 30 Jun 1804 d. 28 Dec 1875
9
Clifford C. Mosby
[1.2.1.4.5.6.2.7.1]
b. 2 Jun 1834 d. 5 Sep 1834
9
Alice Jane Mosby
[1.2.1.4.5.6.2.7.2]
b. 8 Jul 1836
John Churchill Garner
10
John Floyd Churchill Garner
[1.2.1.4.5.6.2.7.2.1]
Anne
11
Winston Churchill Garner
[1.2.1.4.5.6.2.7.2.1.1]
9
Frederick Cabell Mosby
[1.2.1.4.5.6.2.7.3]
b. 7 Jun 1840 d. 22 Nov 1841
9
Mary Winston Mosby
[1.2.1.4.5.6.2.7.4]
b. 19 Feb 1843 d. 1 Jan 1847
9
Ella Floy Mosby
[1.2.1.4.5.6.2.7.5]
b. 29 Aug 1846
9
Carrington Winston Mosby
[1.2.1.4.5.6.2.7.6]
b. 30 Sep 1849
+
Cora Cannon Clark
8
Lewis Carrington Cabell
[1.2.1.4.5.6.2.8]
b. 12 Jun 1814 d. 1896
7
Elizabeth Cabell
[1.2.1.4.5.6.3]
b. 1776 d. 1802
William Bradley Hare
b. 1760 d. 1818
8
Sarah Elizabeth Hare
[1.2.1.4.5.6.3.1]
Samuel McDowell Reid
9
Mary Louisa Reid
[1.2.1.4.5.6.3.1.1]
James Jones White
10
Isabelle White
[1.2.1.4.5.6.3.1.1.1]
+
William George Brown
7
Jr. Nicholas Cabell
[1.2.1.4.5.6.4]
b. 24 Dec 1780 d. 25 Jun 1805
Margaret Read Venable
b. 11 May 1782 d. 3 May 1857
8
Elizabeth Nicholas Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.1]
b. 20 Aug 1803 d. 17 Jul 1822
8
Nathaniel Francis Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2]
b. 23 Jul 1807 d. 1 Sep 1891
Anne Blaws Cocke
b. 15 Sep 1811 d. 20 Feb 1862
9
Francis Hartwell Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.1]
b. 27 Jan 1833 d. 10 Oct 1844
9
Elizabeth Nicholas Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.2]
b. 16 Jul 1834 d. 5 Apr 1863
+
William Daniel Cabell
b. 13 Jan 1834 d. 31 Aug 1870
9
Philip Barraud Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3]
b. 16 Jun 1836 d. 16 Mar 1904
Julia Calvert Bolling
b. 4 Aug 1834
10
Elizabeth Nicholas Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.1]
b. 1861 d. 1862
10
Joseph Hartwell Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.2]
b. 24 Dec 1863 d. 1955
Margaret Polk Logan
b. 3 Jun 1875 d. 18 Feb 1904
11
Philip Francis Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.2.1]
b. 22 Nov 1896 d. 15 Feb 1927
Constance Hollingsworth
b. 15 Jun 1901
12
Barbara Dallas Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.2.1.1]
11
Honoria Muldrup Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.2.2]
Jr. Sydney Baldwin Self
12
III Sydney Baldwin Self
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.2.2.1]
12
Shirley Chipson Self
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.2.2.2]
12
Hartwell Cabell Self
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.2.2.3]
Louise Telford Groesbeck
b. 9 Mar 1879 d. Dec 1965
11
Mary Groesbeck Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.2.3]
b. 25 Jul 1911
10
Francis Barraud Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.3]
b. 14 Jul 1866 d. 22 Nov 1893
10
Philip Mason Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.3.4]
b. 4 Jan 1869
9
Frances Grace Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.4]
b. 16 Jul 1852
+
Richard Kenna Campbell
9
Cary Charles Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.5]
b. 20 Nov 1854 d. 1856
9
Sarah Faulcon Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.2.6]
+
Mary M. Keller
8
Anne Cabell
[1.2.1.4.5.6.4.3]
b. 1809
5
Charles Burks
[1.2.1.4.6]
b. 1711
4
Martha Hannah Davis
[1.2.1.5]
b. 14 Jul 1703 d. 13 Feb 1765
Jr. Abraham Venable
b. 22 Mar 1700/01 d. 16 Dec 1768
5
Hugh Lewis Venable
[1.2.1.5.1]
+
Mary Martin
5
William Venable
[1.2.1.5.2]
d. 17 Apr 1792
+
Ann Clark
5
Ann Venable
[1.2.1.5.3]
+
Phillip King
5
Abraham Bedford Venable
[1.2.1.5.4]
b. 9 Jan 1725 d. 20 Mar 1778
Elizabeth Micheaux
b. 18 Jun 1731 d. 1801
6
John Venable
[1.2.1.5.4.1]
d. Bef 23 Sep 1782
+
Elizabeth Raine
b. 26 Oct 1755
6
Nathaniel Venable
[1.2.1.5.4.2]
b. Abt 1755
+
Martha Venable
b. 18 May 1765 d. 1858
5
Charles Venable
[1.2.1.5.5]
b. 1730 d. Nov 1815
+
Elizabeth Smith
5
Nathaniel Venable
[1.2.1.5.6]
b. 21 Nov 1733 d. 27 Dec 1804
Elizabeth Michaux Woodson
b. 6 Jun 1740 d. 27 Sep 1791
6
Samuel Woodson Venable
[1.2.1.5.6.1]
b. 19 Sep 1756 d. 7 Sep 1821
Mary Scott Carrington
b. 21 Jun 1758 d. 15 May 1837
7
Elizabeth Woodson Venable
[1.2.1.5.6.1.1]
b. 11 May 1782 d. 7 Apr 1858
William Morton Watkins
b. 22 Apr 1773 d. 5 Feb 1865
8
Mary Carrington Carrington
[1.2.1.5.6.1.1.1]
b. 23 Sep 1803 d. 4 Dec 1887
8
Samuel Venable Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.2]
b. 17 Oct 1805 d. 28 Mar 1872
+
Louisa M. Scott
b. 1810 d. 27 Jan 1875
8
William Joel Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.3]
b. 4 Jan 1808 d. 10 Aug 1884
8
Richard Venable Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.4]
b. 1812 d. 1890
+
Anne E. Carrington
b. 1829 d. 1882
Mary Ann Elizabeth Baskerville
b. 14 Jul 1819 d. 6 Jul 1873
9
Elizabeth Ann Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.4.1]
+
Thomas Read Carrington
9
Julia Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.4.2]
Tazewell Morton Carrington
10
Richard Venable Carrington
[1.2.1.5.6.1.1.4.2.1]
10
Jr. Tazewell Morton Carrington
[1.2.1.5.6.1.1.4.2.2]
10
II William Tucker Carrington
[1.2.1.5.6.1.1.4.2.3]
9
Thomas A. Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.4.3]
b. 1849
Maria C. Read
b. 1850
10
Edmonia C. Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.4.3.1]
+
Charles Jeter Hatcher
9
Nellie Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.4.4]
b. 1858
Henry Paul Carrington
b. 7 Aug 1848 d. 29 Mar 1900
10
Virginia Carrington
[1.2.1.5.6.1.1.4.4.1]
Peter Williams
11
Jr. Peter William
[1.2.1.5.6.1.1.4.4.1.1]
11
Nannie Williams
[1.2.1.5.6.1.1.4.4.1.2]
11
Nellie Carrington Williams
[1.2.1.5.6.1.1.4.4.1.3]
10
Nancy Carrington
[1.2.1.5.6.1.1.4.4.2]
John C. Lawson
11
Jr. John C. Lawson
[1.2.1.5.6.1.1.4.4.2.1]
10
Nellie Carrington
[1.2.1.5.6.1.1.4.4.3]
10
Jr. Henry Paul Carrington
[1.2.1.5.6.1.1.4.4.4]
+
McKenzie
8
Thomas Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.5]
b. 5 Jun 1816 d. 26 Sep 1901
8
Isaac Read Watkins
[1.2.1.5.6.1.1.6]
b. 27 Jun 1821 d. 22 Dec 1885
7
Margaret Read Venable
[1.2.1.5.6.1.2]
b. 11 May 1782 d. 3 May 1857
Jr. Nicholas Cabell
b. 24 Dec 1780 d. 25 Jun 1805
8
Elizabeth Nicholas Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.1]
b. 20 Aug 1803 d. 17 Jul 1822
8
Nathaniel Francis Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2]
b. 23 Jul 1807 d. 1 Sep 1891
Anne Blaws Cocke
b. 15 Sep 1811 d. 20 Feb 1862
9
Francis Hartwell Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.1]
b. 27 Jan 1833 d. 10 Oct 1844
9
Elizabeth Nicholas Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.2]
b. 16 Jul 1834 d. 5 Apr 1863
+
William Daniel Cabell
b. 13 Jan 1834 d. 31 Aug 1870
9
Philip Barraud Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3]
b. 16 Jun 1836 d. 16 Mar 1904
Julia Calvert Bolling
b. 4 Aug 1834
10
Elizabeth Nicholas Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.1]
b. 1861 d. 1862
10
Joseph Hartwell Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.2]
b. 24 Dec 1863 d. 1955
Margaret Polk Logan
b. 3 Jun 1875 d. 18 Feb 1904
11
Philip Francis Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.2.1]
b. 22 Nov 1896 d. 15 Feb 1927
Constance Hollingsworth
b. 15 Jun 1901
12
Barbara Dallas Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.2.1.1]
11
Honoria Muldrup Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.2.2]
Jr. Sydney Baldwin Self
12
III Sydney Baldwin Self
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.2.2.1]
12
Shirley Chipson Self
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.2.2.2]
12
Hartwell Cabell Self
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.2.2.3]
Louise Telford Groesbeck
b. 9 Mar 1879 d. Dec 1965
11
Mary Groesbeck Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.2.3]
b. 25 Jul 1911
10
Francis Barraud Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.3]
b. 14 Jul 1866 d. 22 Nov 1893
10
Philip Mason Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.3.4]
b. 4 Jan 1869
9
Frances Grace Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.4]
b. 16 Jul 1852
+
Richard Kenna Campbell
9
Cary Charles Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.5]
b. 20 Nov 1854 d. 1856
9
Sarah Faulcon Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.2.6]
+
Mary M. Keller
8
Anne Cabell
[1.2.1.5.6.1.2.3]
b. 1809
7
Anne Mayo Venable
[1.2.1.5.6.1.3]
b. 4 Jun 1784
Jr. Isaac Read
b. 1784 d. 1869
8
William W. Read
[1.2.1.5.6.1.3.1]
b. 1827 d. 1889
Paulina Edmonia Carrington
b. 22 Oct 1825
9
Maria C. Read
[1.2.1.5.6.1.3.1.1]
b. 1850
Thomas A. Watkins
b. 1849
10
Edmonia C. Watkins
[1.2.1.5.6.1.3.1.1.1]
+
Charles Jeter Hatcher
7
Mary Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.4]
b. 23 Aug 1786 d. 28 Dec 1867
+
William M. Womack
7
Clementina Venable
[1.2.1.5.6.1.5]
b. 6 Jun 1788 d. 11 Aug 1841
+
William S. Reid
7
Henningham Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.6]
b. 19 Jan 1790 d. 1861
Robert Hanna Anderson
b. 1785 d. 1821
8
Robert Carrington Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1]
b. 12 Jul 1817 d. 10 Oct 1906
Francis Parke Poindexter
b. Abt 1820 d. 1874
9
Elizabeth Parke Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.1]
b. 1840 d. 1878
George H. Gilmer
10
Thomas Walker Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.1]
b. 1862
10
Robert Anderson Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.2]
b. 1864 d. Abt 1884
10
George H. Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.3]
b. 1866
Maggie Painter
11
Parke Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.3.1]
11
George H. Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.3.2]
d. Abt 1920
11
Thomas Walker Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.3.3]
11
Graham Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.3.4]
b. Abt 1890
+
Lena Tucker
10
Ellen Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.4]
b. Abt 1868 d. 1912
+
Darst
10
Parke Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.5]
b. Abt 1870
10
Fannie Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.6]
b. 1872 d. Abt 1899
10
Beverley Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.7]
b. 1876
10
James Gilmer
[1.2.1.5.6.1.6.1.1.8]
b. 1876
9
Robert Poindexter Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.2]
b. 1843 d. 1912
Frances Mildred Horsley
d. Abt 1880
10
Eliza Parke Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.2.1]
10
Mary Cabell Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.2.2]
b. 1870 d. Abt 1896
10
Frances Poindexter Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.2.3]
b. 1872
10
Parke Poindexter Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.2.4]
b. Abt 1877
+
Edward Gannaway
10
Roberta Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.2.5]
b. Abt 1879 d. Abt 1891
Jeannie Eggleston
d. 1916
10
Emmiline Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.2.6]
b. 1890
+
Augustus Britt
10
Robert Poindexter Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.2.7]
b. 1892
9
Margaret Woods Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.3]
b. 13 Sep 1846 d. 4 Jan
George Langhorne Brown
b. 7 Sep 1845 d. 24 Feb 1915
10
Margaret Woods Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.1]
+
George Franklin Cole
10
William Edward Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.2]
+
Louise Jones
10
J. Sinclair Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.3]
+
Jane Johnston
10
Mary Jane Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.4]
+
J.W. Howell
d. 1921
10
Fannie Poindexter Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.5]
Carl G. Bowers
11
Virginia Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.5.1]
11
Elouise Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.5.2]
11
Margaret Bowers
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.5.3]
b. 1890
11
Carl Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.5.4]
b. 1902
10
George Langhorne Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.6]
+
Minnie Bischoff
10
J.R. Calloway Brown
[1.2.1.5.6.1.6.1.3.7]
+
Effie Bucher
9
Henningham Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.4]
b. 1850 d. 1884
9
Fannie Lightfoot Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.5]
b. 1852 d. 1883
Alexander Hall
10
Robert Anderson Hall
[1.2.1.5.6.1.6.1.5.1]
b. 1878
+
Pocahontas Gantt
10
Fannie Hall
[1.2.1.5.6.1.6.1.5.2]
b. 1880
+
Charles Barrell
10
Jean Hall
[1.2.1.5.6.1.6.1.5.3]
b. 1883
9
Henry Watkins Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.6]
b. 1856
Willie Bell
d. 1895
10
Ellen Poindexter Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.6.1]
b. 1888 d. 1895
10
Margaret Woods Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.6.2]
b. 1890 d. 1913
+
Hamilton
10
Lanier Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.6.3]
b. 1892 d. 1895
Alvia Smith
10
Mary Parke Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.6.4]
10
Henry Watkins Anderson
[1.2.1.5.6.1.6.1.6.5]
b. 1898
+
Mary Batt
7
Nathaniel E. Venable
[1.2.1.5.6.1.7]
b. 5 Dec 1791 d. 21 Sep 1847
Mary Embra Scott
b. 1793 d. 11 Nov 1865
8
Mary Priscilla Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1]
b. 8 Oct 1815 d. 14 Oct 1881
Thomas Frederick Venable
b. 24 Feb 1812 d. 25 Dec 1881
9
William Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.1]
b. Abt 1835
9
Nathaniel Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.2]
b. Abt 1837
9
Abraham Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.3]
b. Abt 1839
9
Clement Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.4]
b. Abt 1840
9
Harriet Ann Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.5]
b. 19 Aug 1841 d. 12 Aug 1923
Henry Watkins Edmunds
b. 10 Oct 1837 d. 14 Aug 1926
10
Edwin Edmunds
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.1]
+
Kate Irwin
10
Thomas Venable Edmunds
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.2]
b. 23 Sep 1867 d. 4 Mar 1935
Florence Brown
b. 2 Oct 1875 d. 2 Jun 1957
11
Pauline Gray Edmunds
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.2.1]
Hugh Ames Sexton
12
Amy Hill Sexton
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.2.1.1]
10
Mary Embra Edmunds
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.3]
b. 7 Sep 1872 d. Nov 1945
Minos Ebenezer Miller
b. 24 Oct 1856 d. 21 Jun 1936
11
Harriet Venable Miller
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.3.1]
b. 16 May 1897 d. 16 Feb 1975
11
Mary Pauline Miller
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.3.2]
b. 19 Jul 1900 d. 6 Nov 1906
11
Andrew Pickens Miller
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.3.3]
Gertrude Groff
12
Charles Groff Miller
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.3.3.1]
[
=>
]
12
Jr. Andrew Pickens Miller
[1.2.1.5.6.1.7.1.5.3.3.2]
[
=>
]
9
Catherine Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.6]
b. Abt 1844
9
M. Walter Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.7]
b. Abt 1846
9
Gertrude Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.8]
b. Abt 1848
+
William A. Hocker
9
Robert Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.9]
b. Abt 1850
9
Cantey Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.10]
b. Abt 1852
9
Frederick Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.11]
b. Abt 1855
9
Charles Venable
[1.2.1.5.6.1.7.1.12]
b. Abt 1857
8
Harriet Morton Venable
[1.2.1.5.6.1.7.2]
b. 1816
8
Agnes Catherine Venable
[1.2.1.5.6.1.7.3]
b. 9 Nov 1817 d. 14 Oct 1881
+
Nathaniel Abraham Venable
b. 1814
8
Sara Scott Venable
[1.2.1.5.6.1.7.4]
b. 9 Jul 1821 d. 13 Apr 1873
8
Elizabeth Goodridge Venable
[1.2.1.5.6.1.7.5]
b. 21 Jul 1823 d. 1 Feb 1874
William Fontaine Carrington
b. 26 Jan 1822 d. 14 Sep 1883
9
James McDowell Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.5.1]
d. 1925
9
M. G. Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.5.2]
b. Abt 1846
9
Mildred Lightfoot Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.5.3]
b. 12 Oct 1846 d. 19 Mar 1883
9
William Allen Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.5.4]
b. 30 Apr 1849 d. 14 Jul 1892
9
Maria Nash Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.5.5]
b. 14 Feb 1852 d. 18 Sep 1920
9
Austin Downs Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.5.6]
b. 11 Apr 1856 d. 1886
9
Nathaniel Venable Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.5.7]
b. Nov 1860 d. YOUNG
8
Samuel Woodson Venable
[1.2.1.5.6.1.7.6]
b. 7 May 1825 d. 13 Oct 1897
Elizabeth Travis Carrington
b. 9 Apr 1824 d. 9 Dec 1898
9
Josephine Venable
[1.2.1.5.6.1.7.6.1]
b. Abt 1861
8
Charles Scott Venable
[1.2.1.5.6.1.7.7]
b. 19 Apr 1827 d. 11 Aug 1900
Margaret Cantey McDowell
b. 26 Mar 1836 d. 15 Jan 1874
9
Francis Preston Venable
[1.2.1.5.6.1.7.7.1]
b. 17 Nov 1856 d. 17 May 1934
9
Mary McDowell Venable
[1.2.1.5.6.1.7.7.2]
b. 27 Aug 1861 d. 10 Feb 1942
9
Lillie Cantey McDowell Venable
[1.2.1.5.6.1.7.7.3]
b. 19 Sep 1864 d. Jul 1901
9
Charles Scott Venable
[1.2.1.5.6.1.7.7.4]
b. 9 Dec 1866 d. 5 Jul 1867
9
Natalie Embra Venable
[1.2.1.5.6.1.7.7.5]
b. 15 Jul 1868 d. 11 Nov 1961
Mary Southall
b. 1836 d. 1930
9
Charles Scott Venable, MD
[1.2.1.5.6.1.7.7.6]
b. 13 Jun 1877 d. 20 Sep 1961
9
Sallie C Venable
[1.2.1.5.6.1.7.7.7]
b. Oct 1879
8
Nathaniel Henry Venable
[1.2.1.5.6.1.7.8]
b. 1829 d. 18 Feb 1868
+
Tennessee Marr
8
Isaac Watkins Read Venable
[1.2.1.5.6.1.7.9]
b. 1832
8
Frances Isabelle Venable
[1.2.1.5.6.1.7.10]
b. Abt 1838 d. 14 Jan 1885
Alexander Broadnax Carrington
b. Abt 1834 d. 1910
9
Alexander Berkeley Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.10.1]
b. 27 Jan 1862
9
Charles Venable Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.10.2]
b. 29 Jul 1866 d. 1927
9
Gratton Cabell Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.10.3]
b. 3 Sep 1868 d. LIV. 1924
9
Frances Venable Carrington
[1.2.1.5.6.1.7.10.4]
b. 9 Jun 1872
8
Paul Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.7.11]
b. 8 Aug 1840 d. 5 Mar 1915
+
Agnes Spruel Gray
7
Paul Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8]
b. 16 Oct 1794 d. 4 Apr 1876
+
Davis
Emily Eaton Carrington
b. 28 Jan 1805 d. 28 Jan 1871
8
Sally Tucker Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1]
b. 12 Sep 1825 d. 12 Dec 1897
William Goodridge Venable
b. 2 May 1819 d. 29 Feb 1908
9
David Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.1]
b. 1846 d. INFANT
9
Frederick Nantz Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.2]
b. 26 Mar 1848 d. Abt 1862
9
Mildred Lightfoot Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.3]
b. 24 Mar 1850 d. 1935
William Francis M. Lyte
b. 16 Mar 1847 d. 27 Jan 1877
10
William Venable Lyte
[1.2.1.5.6.1.8.1.3.1]
b. 4 Apr 1875
10
Emily Moore Lyte
[1.2.1.5.6.1.8.1.3.2]
b. 2 Oct 1876 d. 26 Sep 1970
9
Paul Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.4]
b. 3 Aug 1852 d. Sep 1908
Georgianna Carpenter
b. 30 Oct 1856 d. 1957
10
Emory Moore Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.4.1]
10
Margaret Ellie Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.4.2]
b. Jul 1885 d. Aug 1904
10
Alice Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.4.3]
b. 1887 d. 1908
9
Sally Emily Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.5]
b. 10 Feb 1855 d. 3 Jan 1897
9
Frances Proctor Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.6]
b. 1857 d. Abt 1859
9
Jr. William Goodridge Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.7]
b. 1 Dec 1859
Sadie Heiskell Anderson
b. 23 Dec 1836 d. 20 Mar 1907
10
William Anderson Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.7.1]
b. 26 Oct 1886
10
James Heiskell Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.7.2]
b. Bef 1889 d. INFANT
10
Sidney Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.7.3]
b. 22 Aug 1890
10
Douglas Randolph Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.7.4]
b. 1 Aug 1892
10
Frederick Nantz Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.7.5]
b. 23 Aug 1898 d. Abt 1898
9
Albert Sidney Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.8]
b. 3 Sep 1862 d. 1936
Sallie Elizabeth Garden
b. 27 Feb 1868 d. 1951
10
Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.8.1]
d. INFANT
10
Sidney Johnson Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.8.2]
b. 13 Nov 1894
9
George Custis Moore Venable
[1.2.1.5.6.1.8.1.9]
b. 11 Oct 1867 d. Oct 1875
8
Mary Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8.2]
b. 1826
+
F. Edward Hughes
8
George Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3]
b. 27 Aug 1827 d. 13 Mar 1901
Margaret A. Moseley
9
Julia Friend Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.1]
b. 22 Mar 1856 d. 22 Oct 1875
9
Emily Eaton Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.2]
b. 1 Nov 1861 d. 5 Feb 1889
9
Arthur Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.3]
b. 23 Nov 1863 d. 6 Apr 1889
9
Henrietta Imogene Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.4]
b. 19 Aug 1865 d. 22 Oct 1880
9
Kathleen Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.5]
b. 23 Jun 1867
9
Mary Tucker Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.6]
b. 21 Jun 1869
9
George Vernon Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.7]
b. 1870
Jane Layburn Moseley
b. 18 Nov 1869
10
Bennett Moseley Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.7.1]
10
Margaret Cabell Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.7.2]
10
Louise Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.7.3]
9
Paulina Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.8]
b. 19 Mar 1880 d. LIV. 1924
+
Phillips
9
Sallie Tucker Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.9]
b. 1882
+
Thomas Haskins Garden
9
Margaret Irving Venable
[1.2.1.5.6.1.8.3.10]
b. 23 Dec 1887
+
William Gordon
8
Mary Elizabeth Venable
[1.2.1.5.6.1.8.4]
b. 26 Oct 1829 d. 1 Dec 1903
Frederick Edward Hughes
b. 22 Aug 1830 d. 20 Oct 1895
9
Daniel Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.1]
9
Paul Venable Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.2]
b. Aug 1852 d. YOUNG
9
George Venable Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.3]
b. 29 Nov 1854 d. 22 Mar 1909
Jennie Amanda Riggs
d. Bef 25 Aug 1904
10
Marietta Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.3.1]
10
III Frederick Edward Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.3.2]
10
Verna Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.3.3]
10
George Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.3.4]
10
Jennie Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.3.5]
10
Isabella Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.3.6]
Mabel Vera Martin
d. LIV. 1909
10
Clarence Huges
[1.2.1.5.6.1.8.4.3.7]
9
Louisa Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.4]
b. 18 Sep 1857
Courtland H. Calhoun
10
George P. Calhoun
[1.2.1.5.6.1.8.4.4.1]
b. 1 Nov 1879 d. 5 Jun 1884
10
Mary Grace Calhoun
[1.2.1.5.6.1.8.4.4.2]
b. 10 Sep 1882 d. 30 Oct 1899
10
Roy Calhoun
[1.2.1.5.6.1.8.4.4.3]
b. 22 Aug 1887
10
Philo Calhoun
[1.2.1.5.6.1.8.4.4.4]
b. 12 Oct 1888
10
Martha A. Calhoun
[1.2.1.5.6.1.8.4.4.5]
b. 2 Nov 1892 d. 17 May 1945
9
John Venable Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5]
b. 17 Oct 1858
Anna Laura Curl
10
Johnnie V. Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5.1]
10
Henry Curl Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5.2]
b. 5 Jul 1885
10
Mary Ethel Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5.3]
b. 27 Jun 1887
10
Julia C. Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5.4]
b. 13 Sep 1889
10
Anna Laura Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5.5]
b. 21 May 1891
10
Lillian L. Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5.6]
b. 13 Apr 1894
10
Lycile I. Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5.7]
b. 13 Apr 1894
10
Rosine C. Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.5.8]
b. 5 Jun 1898
9
Frederick Venable Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.6]
b. 2 Mar 1863
Rosalie Jane Phillips
10
Karen Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.6.1]
10
John Venable Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.6.2]
10
Jr. Frederick Venable Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.6.3]
b. 1 Nov 1880
10
Phillips Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.6.4]
b. 28 Oct 1887 d. 3 May 1909
10
Reynolds D. Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.6.5]
b. 4 Mar 1891
10
Marion B. Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.6.6]
b. 28 May 1894
10
Adelaide B. Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.6.7]
b. 18 Feb 1897
9
Mary Belle Hughes
[1.2.1.5.6.1.8.4.7]
b. 8 Sep 1868
8
Emily Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8.5]
b. 7 May 1832
8
Margaret Agnes Venable
[1.2.1.5.6.1.8.6]
b. 17 Dec 1835
+
Jesse Irvine
d. 14 Nov 1895
8
Henrietta Clementina Venable
[1.2.1.5.6.1.8.7]
b. 15 May 1839 d. Nov 1856
8
Louisa Jane Venable
[1.2.1.5.6.1.8.8]
b. 20 Dec 1841 d. 1916
Bennett Williamson Moseley
9
Emily Carrington Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.1]
b. 6 Mar 1868
William Nicholas Brown
b. 1850
10
William Moseley Brown
[1.2.1.5.6.1.8.8.1.1]
10
Paul Venable Brown
[1.2.1.5.6.1.8.8.1.2]
10
Rosa Lewis Brown
[1.2.1.5.6.1.8.8.1.3]
10
Louise Carrington Brown
[1.2.1.5.6.1.8.8.1.4]
10
James Bennett Brown
[1.2.1.5.6.1.8.8.1.5]
9
Jane Layburn Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.2]
b. 18 Nov 1869
George Vernon Venable
b. 1870
10
Bennett Moseley Venable
[1.2.1.5.6.1.8.8.2.1]
10
Margaret Cabell Venable
[1.2.1.5.6.1.8.8.2.2]
10
Louise Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.8.8.2.3]
9
Paul Venable Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.3]
b. 28 Apr 1871 d. 18 Jul 1888
9
Jr. Bennett Williamson Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.4]
b. 3 Jan 1874 d. Aft 1924
Willie Ficklen
10
Jr. Bennett Williamson Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.4.1]
10
John Bancroft Ficklen Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.4.2]
10
Frances Venable Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.4.3]
9
Henry Winston Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.5]
b. 26 Jul 1876
9
Alfred McDowell Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.6]
b. 20 Aug 1878 d. Aft 1924
+
Nell Skinner
9
George Carrington Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.7]
b. 27 Aug 1880
+
Frances Lewis
9
Mildred Cabell Moseley
[1.2.1.5.6.1.8.8.8]
b. 10 May 1882
8
Paul Anna Vernon Venable
[1.2.1.5.6.1.8.9]
b. 11 Jul 1845 d. 30 Dec 1898
Junius (Julius) S. Koiner
9
Anna Venable Koiner
[1.2.1.5.6.1.8.9.1]
d. YOUNG
9
Jr. Junius S. Koiner
[1.2.1.5.6.1.8.9.2]
Holmes
10
Arthur Koiner
[1.2.1.5.6.1.8.9.2.1]
10
III Junius Koiner
[1.2.1.5.6.1.8.9.2.2]
9
Emily Carrington Koiner
[1.2.1.5.6.1.8.9.3]
+
George Carpenter
9
Florence Koiner
[1.2.1.5.6.1.8.9.4]
+
W. L. Lail
8
Arthur Venable
[1.2.1.5.6.1.8.10]
b. 1846 d. INFANT
8
Paul Nathaniel Venable
[1.2.1.5.6.1.8.11]
b. 14 Feb 1850 d. Jul 1852
7
Agnes Woodson Venable
[1.2.1.5.6.1.9]
b. 4 Nov 1796 d. 6 Aug 1856
Henry Edward Watkins
b. 19 Feb 1782 d. 6 Aug 1856
8
Elizabeth Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.1]
8
Henry E. Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.2]
8
Samuel Woodson Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.3]
+
Alice Winston Horsley
8
Mary Cabell Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.4]
8
Agnes W. Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.5]
+
Embry Scott
8
Richard V. Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.6]
+
Mary Michaux
8
Margaret C. Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.7]
8
Henrietta M. Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.8]
8
Catherine A. Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.9]
8
Frances Leigh Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.10]
+
Edley Irvine
8
Francis Nathaniel Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.11]
b. 24 Apr 1813
Martha Ann Scott
9
Agnes Venable Watkins
[1.2.1.5.6.1.9.11.1]
b. 5 Nov 1843 d. 6 Mar 1909
Milton Preston Jarnagin
b. 8 Jun 1826 d. 12 May 1895
10
Hettie Shields Jarnagin
[1.2.1.5.6.1.9.11.1.1]
b. 12 Dec 1872
10
Martha Scott Jarnagin
[1.2.1.5.6.1.9.11.1.2]
b. 7 Dec 1876
10
Frank Watkins Jarnagin
[1.2.1.5.6.1.9.11.1.3]
b. 14 Oct 1879
10
Jr. Milton Preston Jarnagin
[1.2.1.5.6.1.9.11.1.4]
b. 17 Sep 1881
10
Mary Bynum Jarnagin
[1.2.1.5.6.1.9.11.1.5]
b. 27 Oct 1883
Hugh Rodham
11
Jr. Hugh Rodham
[1.2.1.5.6.1.9.11.1.5.1]
b. 1 Apr 1912
11
Mary Rodham
[1.2.1.5.6.1.9.11.1.5.2]
b. 1 Oct 1913
11
Sayre Rodham
[1.2.1.5.6.1.9.11.1.5.3]
7
Jr. Samuel Woodson Venable
[1.2.1.5.6.1.10]
b. 1 Nov 1797 d. 6 Oct 1855
Jane Reid
8
Mary Carrington Venable
[1.2.1.5.6.1.10.1]
James M. McNutt
9
Jane Reid McNutt
[1.2.1.5.6.1.10.1.1]
9
Mary Morton McNutt
[1.2.1.5.6.1.10.1.2]
9
Flora McNutt
[1.2.1.5.6.1.10.1.3]
9
Isabella Venable McNutt
[1.2.1.5.6.1.10.1.4]
9
Samuel Woodson McNutt
[1.2.1.5.6.1.10.1.5]
9
Margaret McNutt
[1.2.1.5.6.1.10.1.6]
9
James McNutt
[1.2.1.5.6.1.10.1.7]
7
Abram Watkins Venable
[1.2.1.5.6.1.11]
b. 17 Oct 1799 d. 21 Feb 1876
+
Isabella Alston Brown
b. 1807 d. 14 Apr 1876
7
Mildred Coles Venable
[1.2.1.5.6.1.12]
b. 27 Mar 1803
+
Charles Shepperson
6
Abraham Bedford Venable
[1.2.1.5.6.2]
b. 20 Nov 1758 d. 26 Dec 1811
6
Betsy Anne Venable
[1.2.1.5.6.3]
b. 11 Nov 1760 d. 1826
Thomas Watkins
b. 12 Feb 1761 d. 1797
7
Elizabeth Woodson Watkins
[1.2.1.5.6.3.1]
b. 25 Jan 1786 d. 1830
+
II Joseph Morton
b. 9 Jan 1789 d. 16 Aug 1828
6
Richard Nathaniel Venable
[1.2.1.5.6.4]
b. 16 Jan 1763 d. 1837
Mary Morton
b. 1780 d. 1839
7
William Henry Venable
[1.2.1.5.6.4.1]
Margaret M. Reid
8
Andrew "Black Andrew" Reid Venable
[1.2.1.5.6.4.1.1]
b. 4 Apr 1830 d. 12 Sep 1913
Louisa Cabell Carrington
b. 30 Apr 1837 d. 16 Jan 1902
9
Adeline Carrington Venable
[1.2.1.5.6.4.1.1.1]
b. 12 Sep 1861
9
Susan Watkins Venable
[1.2.1.5.6.4.1.1.2]
b. 6 Jul 1863
9
Emma Cabell Venable
[1.2.1.5.6.4.1.1.3]
b. 2 Sep 1867
9
William Henry Venable
[1.2.1.5.6.4.1.1.4]
b. 2 Sep 1870
9
Edgar Wirt Venable
[1.2.1.5.6.4.1.1.5]
b. 17 Oct 1872
9
Richard Venable
[1.2.1.5.6.4.1.1.6]
b. 1876 d. 1876
7
Frances Anderson Venable
[1.2.1.5.6.4.2]
b. 1799 d. 1861
J. H. C. Leach
b. 1791 d. 1866
8
Mary Elizabeth Leach
[1.2.1.5.6.4.2.1]
b. 1822 d. 1876
James T. Spencer
b. 1821 d. 1886
9
Fannie Venable Spencer
[1.2.1.5.6.4.2.1.1]
+
A. G. McIlwaine
9
Ann Thomas Spencer
[1.2.1.5.6.4.2.1.2]
+
F. H. Armistead
8
Frances Venable Leach
[1.2.1.5.6.4.2.2]
b. 1826 d. 1903
John A. Lancaster
b. 1819 d. 1865
9
Nathaniel Lancaster
[1.2.1.5.6.4.2.2.1]
b. 1856
Annie F. Leitch
b. 1856
10
Annie Lancaster
[1.2.1.5.6.4.2.2.1.1]
+
Decatur H. Rodgers
6
Martha Venable
[1.2.1.5.6.5]
b. 18 May 1765 d. 1858
+
Nathaniel Venable
b. Abt 1755
6
Ann Venable
[1.2.1.5.6.6]
b. 6 Nov 1767 d. 1768
6
Ann Venable
[1.2.1.5.6.7]
b. 9 Dec 1768
+
James Daniel
6
Agnes Venable
[1.2.1.5.6.8]
b. 15 Apr 1771 d. 17 May 1802
6
Mary Venable
[1.2.1.5.6.9]
b. 16 Jan 1773 d. 1807
6
Nathaniel E. Venable
[1.2.1.5.6.10]
b. 13 Feb 1776 d. 23 Aug 1801
6
Frances Venable
[1.2.1.5.6.11]
b. 18 Apr 1778 d. 1799
6
William Lewis Venable
[1.2.1.5.6.12]
b. 30 May 1780 d. Bef 17 Aug 1824
Frances Watkins Nantz
b. 1791 d. 1859
7
Frances Matthews Venable
[1.2.1.5.6.12.1]
b. Abt 1810 d. 16 Aug 1863
Thomas Flournoy
b. 25 Jul 1804 d. 27 Dec 1892
8
Mary Agnes Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.1]
b. 23 Aug 1828
William H. Marshall
9
Pattie Venable Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.1]
+
Wood Dunham
9
Amanda F. Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.2]
9
James Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.3]
Carey Knox
10
James Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.3.1]
10
Ruth Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.3.2]
9
Louise Cabell Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.4]
Matthews Fink
10
Marshall Scott Fink
[1.2.1.5.6.12.1.1.4.1]
10
Paul Fink
[1.2.1.5.6.12.1.1.4.2]
10
Miriam Fink
[1.2.1.5.6.12.1.1.4.3]
9
Sallie Anne Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.5]
Judson Lloyd
10
Mary Lloyd
[1.2.1.5.6.12.1.1.5.1]
Wade
11
James S. Wade
[1.2.1.5.6.12.1.1.5.1.1]
10
John Lloyd
[1.2.1.5.6.12.1.1.5.2]
10
Kathleen Lloyd
[1.2.1.5.6.12.1.1.5.3]
Arthur Field
11
Mary Agnes Field
[1.2.1.5.6.12.1.1.5.3.1]
11
Sarah Field
[1.2.1.5.6.12.1.1.5.3.2]
10
Robert Lloyd
[1.2.1.5.6.12.1.1.5.4]
9
Fannie T. Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.6]
William H. Marshall
10
Pattie Venable Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.6.1]
10
James Marshall
[1.2.1.5.6.12.1.1.6.2]
8
II David Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.2]
b. 20 May 1829 d. 20 Nov 1895
Martha Daniel Bouldin
b. 11 Jan 1852
9
Martha Daniel Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.2.1]
b. 15 Mar 1871
9
Fannie Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.2.2]
b. 3 Jul 1872
9
Thomas Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.2.3]
b. 12 Oct 1877 d. 19 Sep 1947
+
Mary Harvey Hamlin
b. 22 Jun 1873 d. 25 Jul 1967
8
Frances Watkins Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.3]
b. 24 Sep 1831 d. 1900
Thomas Tyler Bouldin, Jr
b. 24 Mar 1813 d. 13 Nov 1891
9
Fannie Lewis Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.1]
b. 7 Dec 1852 d. 24 Oct 1946
+
Preston Buford
b. 4 Mar 1856 d. 20 May 1930
9
Mary Willie Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.2]
b. 24 Jul 1854
9
David Flournoy Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.3]
b. 16 Apr 1856 d. 31 Oct 1856
9
Henry Wood Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.4]
b. 3 Nov 1857 d. Aug 1935
Lela Edward Coles
b. 1858 d. 1908
10
Fannie Lewis Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.4.1]
b. 1882 d. 1957
+
Thomas Spratly
10
Lela Coles Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.4.2]
b. 15 Jul 1885 d. 29 Sep 1955
+
Oska Shoemake
10
Thomas Tyler Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.4.3]
b. 1 Oct 1890 d. 27 Apr 1966
+
Louise Coles
+
Evelyn Louise Coles
9
Ellen Barksdale Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.5]
b. 10 Feb 1860 d. 22 Nov 1936
9
Rachel Contesse Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.6]
b. 28 Nov 1861 d. 19 Feb 1872
9
Martha Cabell Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.7]
b. 19 Apr 1864 d. 31 Aug 1911
+
Gentry
9
Flournoy Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.8]
b. 22 Nov 1865 d. May 1957
Annie White
10
Elizabeth Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.8.1]
b. Abt 1895
9
Claiborne Barksdale Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.9]
b. 5 Oct 1867 d. 1 Jun 1959
Mary Crump
10
Alice Good Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.9.1]
10
Thomas Tyler Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.9.2]
10
Mary Crump Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.9.3]
10
Jr. Clairborne Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.9.4]
9
John Lewis Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.10]
b. 24 Nov 1871 d. 18 Feb 1958
+
Hetty Jones
9
Annie Venable Bouldin
[1.2.1.5.6.12.1.3.11]
b. 1 Aug 1876 d. 24 Apr 1974
+
Thomas W. Daniel
8
Amanda Nantz Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.4]
b. 8 May 1835
8
William Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.5]
b. 29 Nov 1835 d. 30 Mar 1836
8
Martha Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.6]
b. 28 Jul 1837
+
William Henry Venable
8
Nathaniel Abraham Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.7]
b. 20 Jan 1839
Laura Lewis
9
John Herbert Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.7.1]
Florence Wilson
10
John Wilson Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.7.1.1]
9
Fannie Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.7.2]
+
Charles Kimbro Taylor
9
Norborne Lewis Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.7.3]
9
Thomas Lewis Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.7.4]
+
Lois Latimer
8
Elizabeth Anne Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.8]
b. 26 Nov 1840
Reubin Booth Hicks
9
Thomas Hicks
[1.2.1.5.6.12.1.8.1]
Jennie Bowber
10
Elizabeth Baten Hicks
[1.2.1.5.6.12.1.8.1.1]
10
Francis Venable Hicks
[1.2.1.5.6.12.1.8.1.2]
10
Thomas Flournoy Hicks
[1.2.1.5.6.12.1.8.1.3]
10
Reubin Booth Hicks
[1.2.1.5.6.12.1.8.1.4]
8
Louisa Cabell Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.9]
b. 2 Nov 1841
Richard Field
9
Louise Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.1]
+
Albert McCracken
9
Meade Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.2]
9
George Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.3]
9
Martha Venable Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.4]
9
Anna Morton Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.5]
+
William Moran
9
Nona Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.6]
+
Sandridge
9
Kate Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.7]
+
Horace Hayden
9
Fanny Venable Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.8]
+
Oscar Collins
9
Sally Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.9]
9
David Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.10]
9
Eva Field
[1.2.1.5.6.12.1.9.11]
+
Robert E. Lee Morton
8
Jacob Morton Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.10]
b. 7 Oct 1843
Mildred Coles Carrington
b. Abt 1845
9
Thomas Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.10.1]
9
Anna Lightfoot Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.10.2]
9
Elizabeth Morton Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.10.3]
9
Walter Carrington Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.10.4]
b. Abt 1875 d. 1896
8
William Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.1.11]
b. 24 Oct 1846
7
Thomas Frederick Venable
[1.2.1.5.6.12.2]
b. 24 Feb 1812 d. 25 Dec 1881
Mary Priscilla Venable
b. 8 Oct 1815 d. 14 Oct 1881
8
William Venable
[1.2.1.5.6.12.2.1]
b. Abt 1835
8
Nathaniel Venable
[1.2.1.5.6.12.2.2]
b. Abt 1837
8
Abraham Venable
[1.2.1.5.6.12.2.3]
b. Abt 1839
8
Clement Venable
[1.2.1.5.6.12.2.4]
b. Abt 1840
8
Harriet Ann Venable
[1.2.1.5.6.12.2.5]
b. 19 Aug 1841 d. 12 Aug 1923
Henry Watkins Edmunds
b. 10 Oct 1837 d. 14 Aug 1926
9
Edwin Edmunds
[1.2.1.5.6.12.2.5.1]
+
Kate Irwin
9
Thomas Venable Edmunds
[1.2.1.5.6.12.2.5.2]
b. 23 Sep 1867 d. 4 Mar 1935
Florence Brown
b. 2 Oct 1875 d. 2 Jun 1957
10
Pauline Gray Edmunds
[1.2.1.5.6.12.2.5.2.1]
Hugh Ames Sexton
11
Amy Hill Sexton
[1.2.1.5.6.12.2.5.2.1.1]
+
E. Michael Rowell
9
Mary Embra Edmunds
[1.2.1.5.6.12.2.5.3]
b. 7 Sep 1872 d. Nov 1945
Minos Ebenezer Miller
b. 24 Oct 1856 d. 21 Jun 1936
10
Harriet Venable Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.1]
b. 16 May 1897 d. 16 Feb 1975
10
Mary Pauline Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.2]
b. 19 Jul 1900 d. 6 Nov 1906
10
Andrew Pickens Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.3]
Gertrude Groff
11
Charles Groff Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.3.1]
Sandra Lake Newton
12
Jarrod Sebastian Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.3.1.1]
[
=>
]
12
Jason Reade Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.3.1.2]
Diane Aylor
12
Mary Catherine Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.3.1.3]
11
Jr. Andrew Pickens Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.3.2]
Betty Jean Myers
12
James Ross Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.3.2.1]
12
Andrew Peter Miller
[1.2.1.5.6.12.2.5.3.3.2.2]
8
Catherine Venable
[1.2.1.5.6.12.2.6]
b. Abt 1844
8
M. Walter Venable
[1.2.1.5.6.12.2.7]
b. Abt 1846
8
Gertrude Venable
[1.2.1.5.6.12.2.8]
b. Abt 1848
+
William A. Hocker
8
Robert Venable
[1.2.1.5.6.12.2.9]
b. Abt 1850
8
Cantey Venable
[1.2.1.5.6.12.2.10]
b. Abt 1852
8
Frederick Venable
[1.2.1.5.6.12.2.11]
b. Abt 1855
8
Charles Venable
[1.2.1.5.6.12.2.12]
b. Abt 1857
7
Nathaniel Abraham Venable
[1.2.1.5.6.12.3]
b. 1814
+
Agnes Catherine Venable
b. 9 Nov 1817 d. 14 Oct 1881
7
Martha Watkins Venable
[1.2.1.5.6.12.4]
b. 5 Jun 1816 d. 1905
William Cabell Flournoy
b. 31 Dec 1809 d. 31 Mar 1861
8
Ann Cabell Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.1]
b. Abt 1835 d. Abt 1837
8
II John James Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.2]
b. 13 Apr 1837 d. 7 Jan 1875
8
William Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.3]
b. Abt 1839 d. Abt 1842
8
Benjamin Stanhope Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.4]
b. Abt 1841 d. Abt 1842
8
Frances Florida Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.5]
b. 6 Jul 1843
+
John P. Fitzgerald
8
Sarah Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.6]
b. 12 Aug 1845
+
J. C. Painter
8
George Mallory Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.7]
b. Abt 1848 d. Abt 1853
8
Landon Cabell Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8]
b. 4 Mar 1850
Martha G. Givens
b. 1858 d. 9 May 1884
9
Bessie Venable Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.1]
b. 29 Jan 1878
+
Brown
9
Florida Fitzgerald Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.2]
b. 31 Aug 1879
9
Sarah Wright Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.3]
b. 9 Apr 1881
+
Butts
9
Martha Watkins Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.4]
b. 24 Dec 1882
Susan Cabell Cobbs
b. 5 Nov 1864
9
Mary Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.5]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
9
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.6]
b. 20 Sep 1890
9
Mildred Cobbs Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.7]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
9
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.8]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
9
Thomas Stanhope Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.8.9]
b. 24 Oct 1896
8
Alice Eliza Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.9]
b. 4 Nov 1852
+
Littleton Fitzgerald
8
Charles Bruce Flournoy
[1.2.1.5.6.12.4.10]
b. 11 Nov 1854
+
Virginia Dalby
7
William Goodridge Venable
[1.2.1.5.6.12.5]
b. 2 May 1819 d. 29 Feb 1908
+
Mildred Lightfoot Carrington
d. 14 Apr 1843
Sally Tucker Venable
b. 12 Sep 1825 d. 12 Dec 1897
8
David Venable
[1.2.1.5.6.12.5.1]
b. 1846 d. INFANT
8
Frederick Nantz Venable
[1.2.1.5.6.12.5.2]
b. 26 Mar 1848 d. Abt 1862
8
Mildred Lightfoot Venable
[1.2.1.5.6.12.5.3]
b. 24 Mar 1850 d. 1935
William Francis M. Lyte
b. 16 Mar 1847 d. 27 Jan 1877
9
William Venable Lyte
[1.2.1.5.6.12.5.3.1]
b. 4 Apr 1875
9
Emily Moore Lyte
[1.2.1.5.6.12.5.3.2]
b. 2 Oct 1876 d. 26 Sep 1970
8
Paul Carrington Venable
[1.2.1.5.6.12.5.4]
b. 3 Aug 1852 d. Sep 1908
Georgianna Carpenter
b. 30 Oct 1856 d. 1957
9
Emory Moore Venable
[1.2.1.5.6.12.5.4.1]
9
Margaret Ellie Venable
[1.2.1.5.6.12.5.4.2]
b. Jul 1885 d. Aug 1904
9
Alice Venable
[1.2.1.5.6.12.5.4.3]
b. 1887 d. 1908
8
Sally Emily Venable
[1.2.1.5.6.12.5.5]
b. 10 Feb 1855 d. 3 Jan 1897
8
Frances Proctor Venable
[1.2.1.5.6.12.5.6]
b. 1857 d. Abt 1859
8
Jr. William Goodridge Venable
[1.2.1.5.6.12.5.7]
b. 1 Dec 1859
Sadie Heiskell Anderson
b. 23 Dec 1836 d. 20 Mar 1907
9
William Anderson Venable
[1.2.1.5.6.12.5.7.1]
b. 26 Oct 1886
9
James Heiskell Venable
[1.2.1.5.6.12.5.7.2]
b. Bef 1889 d. INFANT
9
Sidney Carrington Venable
[1.2.1.5.6.12.5.7.3]
b. 22 Aug 1890
9
Douglas Randolph Venable
[1.2.1.5.6.12.5.7.4]
b. 1 Aug 1892
9
Frederick Nantz Venable
[1.2.1.5.6.12.5.7.5]
b. 23 Aug 1898 d. Abt 1898
8
Albert Sidney Venable
[1.2.1.5.6.12.5.8]
b. 3 Sep 1862 d. 1936
Sallie Elizabeth Garden
b. 27 Feb 1868 d. 1951
9
Venable
[1.2.1.5.6.12.5.8.1]
d. INFANT
9
Sidney Johnson Venable
[1.2.1.5.6.12.5.8.2]
b. 13 Nov 1894
8
George Custis Moore Venable
[1.2.1.5.6.12.5.9]
b. 11 Oct 1867 d. Oct 1875
6
Thomas Venable
[1.2.1.5.6.13]
b. 17 Nov 1782 d. 1809
6
Elizabeth Venable
[1.2.1.5.6.14]
b. 21 Nov 1784 d. Abt 1845
+
Goodridge Wilson
5
James Venable
[1.2.1.5.7]
b. 1734 d. 23 Jul 1833
Judith Morton
b. 27 Dec 1739 d. 1826
6
Joseph Morton Venable
[1.2.1.5.7.1]
b. 28 Jun 1761 d. 1833
Elizabeth Watkins
b. 6 Dec 1769 d. Apr 1832
7
Joseph Morton Venable
[1.2.1.5.7.1.1]
b. 23 Dec 1791 d. 1838
Mary Fleming Cowan
b. 1797 d. 1880
8
Mary Craig Venable
[1.2.1.5.7.1.1.1]
b. 20 Mar 1820 d. 6 Feb 1870
James Eben Blythe
b. 8 Nov 1819 d. 4 Jul 1864
9
Edward William Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.1]
b. 7 Dec 1841
Sarah Katherine Keyser
b. 29 Aug 1847 d. 18 Mar 1918
10
Keyser Ranger Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.1.1]
b. 1 Mar 1869
Sarah Amanda Cox
b. 16 Jan 1878
11
Sarah Katherine Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.1.1.1]
b. 15 Jun 1896
Morris Nelson
b. 6 Oct 1894
12
Mary Katherine Nelson
[1.2.1.5.7.1.1.1.1.1.1.1]
11
Frank Eben Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.1.1.2]
b. 4 Jun 1899
11
Rachael Elizabeth Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.1.1.3]
b. 9 Aug 1904
11
Edward William Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.1.1.4]
b. 12 Jul 1909
10
Mary Venable Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.1.2]
b. 3 Feb 1871
9
Joseph Morton Venable Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.2]
b. 28 Jun 1843 d. 9 Mar 1906
Emma F. Coleman
b. 19 Jan 1848
10
Mary Venable Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.2.1]
b. 30 Sep 1872 d. 9 Dec 1878
10
Morton Coleman Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.2.2]
b. 15 Mar 1875
+
Fredonia Ward
b. 7 Dec 1886
10
James Eben Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.2.3]
b. 8 Apr 1878
+
Janie Goler
b. 4 Jul 1891
10
Harriet May Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.2.4]
b. 9 Dec 1879 d. 28 Aug 1880
9
James Henry Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.3]
b. 22 Aug 1845
Laura Elmore
b. Jan 1860
10
Jr. James Henry Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.3.1]
b. 12 Mar 1883
10
Richard Elmore Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.3.2]
b. 27 Jul 1885
+
Mary S.
b. Cal 1891
+
Evelyn Durkin
b. 18 Aug 1891 d. 12 Aug 1913
Pearl Lewis
b. 6 May 1890
11
Nettie E. Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.3.2.1]
b. Cal 1910
10
Hazel Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.3.3]
b. 8 Nov 1891
9
George Cowan Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.4]
b. 12 Dec 1847 d. 23 Mar 1914
Lucy A. Witcher
b. 13 Jun 1850
10
Ben Barnes Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.4.1]
b. 20 Sep 1873
+
Kitty Joslin
b. 10 May 1872
10
George McElroy Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.4.2]
b. 23 Nov 1880
+
Van Vivian Hammett
b. 27 Jun 1884
9
Richard Butler Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.5]
b. 25 Jan 1850
+
Jennie Eleanore Voorhees
b. 6 Jan 1866
9
Margaret McElroy Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.6]
b. 6 Oct 1852 d. 19 Apr 1942
John Byron Ellis
b. 29 Nov 1842 d. 22 Oct 1916
10
Byron Ellis
[1.2.1.5.7.1.1.1.6.1]
b. 1 Oct 1874 d. 12 Oct 1875
10
Mabel Hanna Ellis
[1.2.1.5.7.1.1.1.6.2]
b. 20 Jun 1876
+
Isaiah Jackson Roberts
b. 3 Mar 1865 d. 3 May 1915
10
Estelle Blythe Ellis
[1.2.1.5.7.1.1.1.6.3]
b. 20 Jun 1876 d. 28 Oct 1877
10
James Frank Ellis
[1.2.1.5.7.1.1.1.6.4]
b. 24 Mar 1878 d. 18 Jul 1878
10
Margaret Blythe Ellis
[1.2.1.5.7.1.1.1.6.5]
b. 4 Dec 1879
Roy MeGregor Boone Scott
b. 29 Nov 1879
11
Margaret Venable Scott
[1.2.1.5.7.1.1.1.6.5.1]
b. 21 Sep 1909
11
Roy McGregor Boone Scott
[1.2.1.5.7.1.1.1.6.5.2]
b. 25 Apr 1912
9
Mary Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.7]
b. 26 May 1855 d. 13 Nov 1857
9
Frank Venable Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.8]
b. 11 May 1860 d. 24 Jul 1942
+
Mayme Herrington
b. 28 Jun 1876 d. 15 Jun 1904
+
Susan Loveday Smith
b. 3 May 1867 d. 18 May 1946
9
Jr. James Eben Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.9]
b. 3 Sep 1862
Margaret Lee Magrill
b. 4 Nov 1876
10
Mary Margaret Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.9.1]
b. 3 Aug 1894
Thomas Henry Andrews
b. 2 Dec 1890
11
Emma Lee Andrews
[1.2.1.5.7.1.1.1.9.1.1]
10
III James Eben Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.9.2]
b. 10 Nov 1900 d. 24 May 1971
Annie L.
b. Cal 1904
11
IV James Eben Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.9.2.1]
11
Dorothy Ann Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.9.2.2]
11
Marisue Blythe
[1.2.1.5.7.1.1.1.9.2.3]
Jr. Douglas Hamilton Mebane
12
Laura Lee Mebane
[1.2.1.5.7.1.1.1.9.2.3.1]
12
III Douglas Hamilton Mebane
[1.2.1.5.7.1.1.1.9.2.3.2]
8
Judith Joyce Venable
[1.2.1.5.7.1.1.2]
b. 1836
Thomas King Hanna
b. 1829 d. 1906
9
Annie Hanna
[1.2.1.5.7.1.1.2.1]
+
Robert Aull Wilson
7
Elizabeth McRoberts Venable
[1.2.1.5.7.1.2]
b. 1795 d. 1869
William Quin Morton
b. 1797 d. 1850
8
Quin Morton
[1.2.1.5.7.1.2.1]
Elizabeth A. Logan
9
Jennie Morton
[1.2.1.5.7.1.2.1.1]
+
John C. Cunningham
9
Mary Logan Morton
[1.2.1.5.7.1.2.1.2]
+
Jesse B. Kincheloe
9
Verlinda Morton
[1.2.1.5.7.1.2.1.3]
8
William Joseph Morton
[1.2.1.5.7.1.2.2]
b. 1817 d. 1896
Eleanor Waters
b. 1818 d. 1862
9
Mary E. Morton
[1.2.1.5.7.1.2.2.1]
b. 1848 d. 1920
William Semple Ryland
b. 1836 d. 1906
10
Mary Eleanor Ryland
[1.2.1.5.7.1.2.2.1.1]
+
A. S. Boles
8
Agnes Mary Morton
[1.2.1.5.7.1.2.3]
b. 1818 d. 1873
William C. Hanna
b. 1808
9
Elizabeth Morton Hanna
[1.2.1.5.7.1.2.3.1]
b. 1838
Charles Holt Dobbs
b. 1835
10
Agnes H. Dobbs
[1.2.1.5.7.1.2.3.1.1]
10
Elizabeth Morton Dobbs
[1.2.1.5.7.1.2.3.1.2]
8
Salina Morton
[1.2.1.5.7.1.2.4]
b. 1830 d. 1874
I. W. Canfield
b. 1823 d. 1899
9
Salina Canfield
[1.2.1.5.7.1.2.4.1]
b. 1858
James Venable
b. 1856 d. 1894
10
Lina Venable
[1.2.1.5.7.1.2.4.1.1]
+
John Charles Dent
8
Henry Thomas Morton
[1.2.1.5.7.1.2.5]
b. 1832 d. 1906
Mary Aurilla Proctor
b. 1844
9
Ella Anderson Micheaux Morton
[1.2.1.5.7.1.2.5.1]
+
Jesse Child
9
Emma Morton
[1.2.1.5.7.1.2.5.2]
b. 1865 d. 1953
Solomon L. Ginsburg
b. 6 Aug 1867 d. 31 Mar 1927
10
Arvilla Henrietta Ginsburg
[1.2.1.5.7.1.2.5.2.1]
b. 1894
10
Brazilla Ginsburg
[1.2.1.5.7.1.2.5.2.2]
b. 1896
+
R. H. Parker
9
Jennie Curtis Morton
[1.2.1.5.7.1.2.5.3]
b. 1869 d. 1909
+
C. W. Thornton
George A. Gage
b. 1867
10
Aurilla Micheaux Gage
[1.2.1.5.7.1.2.5.3.1]
+
J. W. Quackenbush
7
Francis W. Venable
[1.2.1.5.7.1.3]
b. 1799 d. 1852
Nancy Carter Nelson
b. 1814 d. 1873
8
Lucy Hopkins Venable
[1.2.1.5.7.1.3.1]
b. 1846
Robert Philips Burford
b. 1844
9
Hermina Burford
[1.2.1.5.7.1.3.1.1]
+
I. A. Stone
9
Annabel Burford
[1.2.1.5.7.1.3.1.2]
7
Samuel Lyle Venable
[1.2.1.5.7.1.4]
b. 8 Jan 1803 d. 23 Aug 1850
+
Virginia Woodson Bransford
b. 16 Oct 1813 d. 21 Sep 1895
6
Abraham Venable
[1.2.1.5.7.2]
b. 1762
Mary Morton
b. Abt 1763
7
Hampden Sidney Venable
[1.2.1.5.7.2.1]
b. 1792 d. 1846
Amelia Goggin
b. 1796 d. 1895
8
Sophia S. Venable
[1.2.1.5.7.2.1.1]
James H. Waugh
9
Mary E. Waugh
[1.2.1.5.7.2.1.1.1]
+
Charles B. Sanders
8
Amanda Judith Venable
[1.2.1.5.7.2.1.2]
b. 1826 d. 1877
James F. Paxton
b. 1814 d. 1890
9
Amelia D. Paxton
[1.2.1.5.7.2.1.2.1]
+
Benjamin F. Naylor
6
James Henry Venable
[1.2.1.5.7.3]
b. 4 Aug 1778 d. 5 May 1851
Elizabeth Cowan
b. 17 Jan 1784
7
Jr. James Henry Venable
[1.2.1.5.7.3.1]
b. 23 Jan 1816
Mary McDonald
b. Abt 1816
8
James Venable
[1.2.1.5.7.3.1.1]
b. 1856 d. 1894
Salina Canfield
b. 1858
9
Lina Venable
[1.2.1.5.7.3.1.1.1]
+
John Charles Dent
6
Agnes Venable
[1.2.1.5.7.4]
b. 12 Mar 1785
William Mahon
b. 1785
7
Mary Mahon
[1.2.1.5.7.4.1]
b. 1801 d. 1869
James Gray Read
b. 1 May 1793 d. 1869
8
Sarah A. Read
[1.2.1.5.7.4.1.1]
+
Ransom
8
John Franklin Read
[1.2.1.5.7.4.1.2]
b. 14 Oct 1822 d. 19 Feb 1901
Eliza Ann Pratt
b. 13 Jun 1830 d. 29 Oct 1915
9
Ophelia Read
[1.2.1.5.7.4.1.2.1]
+
Charles Edgar Poindexter
6
Frances Venable
[1.2.1.5.7.5]
b. Jun 1804 d. 1824
Leonard Robinson
b. 1759 d. 1835
7
Ann Lymann Robinson
[1.2.1.5.7.5.1]
b. 1806 d. 1867
Archibald Robert Scott
b. 1809 d. 1891
8
Archibald Marshall Scott
[1.2.1.5.7.5.1.1]
b. 1849 d. 1912
Ida Scott
b. 1855
9
Frances Scott
[1.2.1.5.7.5.1.1.1]
+
Charles Chandler Chaffin
5
Mary Venable
[1.2.1.5.8]
b. 1734
+
Robert Strange
+
Charles Moorman
b. 1737 d. 1798
5
Elizabeth Venable
[1.2.1.5.9]
b. 22 May 1739 d. 1778
Josiah Morton
b. 14 Nov 1737 d. 28 Nov 1785
6
Agnes Woodson Morton
[1.2.1.5.9.1]
b. 1772
Theodoreck Bland McRobert
7
Anna Bland McRobert
[1.2.1.5.9.1.1]
b. 1800 d. 1881
Beverly Crawford
d. 1846
8
Rowena Bland Crawford
[1.2.1.5.9.1.1.1]
b. 1828 d. 1879
James A. Baker
b. 1821 d. 1896
9
Mary Baker
[1.2.1.5.9.1.1.1.1]
+
John M. Parish
9
Anna Bland Baker
[1.2.1.5.9.1.1.1.2]
+
George Thompson
5
John Venable
[1.2.1.5.10]
b. 1740 d. 1811
+
Agnes Moorman
b. 26 Feb 1743