News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Anne LeGrand
1556 - 1636 (80 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Anne LeGrand
[1]
b. 12 May 1556 d. 24 May 1636
Simon Mussard
b. 1554 d. 22 Nov 1616
2
Emile François Marie Mussard
[1.1]
b. 3 Jul 1579 d. 3 Nov 1618
Jean Flournoy
b. 21 May 1574 d. 3 Jun 1657
3
Mie Flournoy
[1.1.1]
b. 11 Feb 1605/06 d. 13 Jul 1629
+
Laurent Legare
3
Judith Flournoy
[1.1.2]
b. 3 Jan 1616/17
+
Simon Honnie
3
Francoise Flournoy
[1.1.3]
b. 23 Nov 1614 d. 20 Feb 1616/17
3
Andre Flournoy
[1.1.4]
b. 17 Nov 1613 d. 9 Jan 1613/14
3
Marguerite Flournoy
[1.1.5]
b. 8 Sep 1611 d. 20 May 1695
+
Frederic Canadelle
3
Esther Flournoy
[1.1.6]
b. 22 Dec 1600 d. 17 Oct 1601
3
Jeanne Flournoy
[1.1.7]
b. 23 Feb 1603/04 d. 14 Apr 1681
+
Etienne Gando
3
Marie Flournoy
[1.1.8]
b. 13 Aug 1602 d. 31 Dec 1668
+
Jean Henri Esther
3
Gabriel Flournoy
[1.1.9]
b. 10 Oct 1618 d. 18 Oct 1618
3
Jean Flournoy
[1.1.10]
b. 30 Oct 1599
+
Judith Payari
d. 16 Apr 1673
3
Jacques Flournoy
[1.1.11]
b. 19 Jul 1608 d. 19 Mar 1675
Judith Puerari
b. 8 Apr 1624 d. 14 Nov 1675
4
Sara Flournoy
[1.1.11.1]
b. 3 Jun 1647 d. 14 Jan 1647/48
4
Jeanne Flournoy
[1.1.11.2]
b. 27 Nov 1645 d. 14 Nov 1688
+
Pierre Archimbaud
4
Jeanne-Marie Flournoy
[1.1.11.3]
b. 3 May 1651 d. 29 Aug 1724
+
Jaques Cartier
4
Delie Flournoy
[1.1.11.4]
b. 31 Oct 1648
Goy
5
Jacqueline Goy
[1.1.11.4.1]
d. 1701
4
Anne-Gabrielle Flournoy
[1.1.11.5]
b. 3 Dec 1655 d. 17 Dec 1687
+
Jean Thomegay
4
Elisabeth Flournoy
[1.1.11.6]
b. 26 Aug 1653
+
Michel Barrilliet
4
Esaie Flournoy
[1.1.11.7]
b. 13 Jan 1659/60 d. 23 Jul 1714
+
Christina Eggens
4
Henry Flournoy
[1.1.11.8]
b. 19 Aug 1666
4
Jacob Flournoy
[1.1.11.9]
b. 5 Jan 1663 d. Nov 1731
+
Magdeleine Prodhom
b. 24 Jun 1658
Marthe Morel
b. 1667 d. Abt 1695
5
Francois Flournoy
[1.1.11.9.1]
b. 31 Jan 1686/87 d. Bef 5 Mar 1773
Mary Gibson
b. 1691
6
Gibson Flournoy
[1.1.11.9.1.1]
b. 1 May 1735 d. Bef 6 Jan 1812
Mary Frances Farmer
b. Abt 1736 d. Abt 1817
7
Jr. Gibson Flournoy
[1.1.11.9.1.1.1]
b. Abt 1768 d. Abt 1806
Martha Ashurst
b. Abt 1772 d. 1801
8
William Henry Flournoy
[1.1.11.9.1.1.1.1]
b. Abt 1795 d. 15 Sep 1822
8
Martha Flournoy
[1.1.11.9.1.1.1.2]
b. Abt 1797
8
Jane Frances Flournoy
[1.1.11.9.1.1.1.3]
b. 17 Jul 1793 d. 14 Feb 1833
Irby Hudson
b. 26 May 1786 d. 12 Apr 1844
9
Caroline Frances Hudson
[1.1.11.9.1.1.1.3.1]
b. 5 May 1821 d. 10 Feb 1884
+
Robert Carter Jenkins
b. 15 Nov 1817 d. 2 May 1888
9
Martha Hudson
[1.1.11.9.1.1.1.3.2]
b. 23 Nov 1813
9
Elizabeth Hudson
[1.1.11.9.1.1.1.3.3]
b. 18 Nov 1815
9
Jane Ann Hudson
[1.1.11.9.1.1.1.3.4]
b. 5 Jun 1819 d. 11 Aug 1877
9
Sarah Hudson
[1.1.11.9.1.1.1.3.5]
b. 13 Dec 1822
7
Peter Farmer Flournoy
[1.1.11.9.1.1.2]
b. Abt 1770
Frances Shipp
8
Permelia Flournoy
[1.1.11.9.1.1.2.1]
b. 17 Dec 1797 d. 24 Oct 1870
+
Enoch George Brown
8
Samantha Flournoy
[1.1.11.9.1.1.2.2]
8
Whitfield Flournoy
[1.1.11.9.1.1.2.3]
8
Maddison Flournoy
[1.1.11.9.1.1.2.4]
7
Lawrence M Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3]
b. 1783 d. 1818
Mary Bradford
b. 1785 d. 17 Jan 1816
8
Laura Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.1]
b. 1814 d. 10 Nov 1881
+
Estes
8
Thomas Gibson Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2]
b. 14 Aug 1809 d. 1896
Rosannah Stephens
b. 4 Jan 1810 d. 1893
9
Mordicai Gibson Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.1]
b. 20 Aug 1836 d. 29 Jun 1920
+
Martha J. Murchison
9
Frances Narcissa Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.2]
b. 23 Jul 1843 d. 8 Jul 1868
9
Isaac Laurence Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.3]
b. 1 Jun 1838 d. 10 May 1862
9
Gideon Davis Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.4]
b. 25 Nov 1839 d. 24 Oct 1915
9
Nancy J. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.5]
b. 23 Jul 1843
9
James Bradford Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.6]
b. 1 Sep 1836 d. 24 Aug 1922
+
Celia Ann Rutland
b. 3 May 1837 d. 30 Jan 1918
9
Jacob "Jake" Ashland Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7]
b. 17 Sep 1841 d. 7 Oct 1919
Eulah M Varner
b. 1 Dec 1846 d. 24 Nov 1915
10
John Walter Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1]
b. 27 Mar 1869 d. 9 Feb 1963
Lenora Abie Calloway
b. 12 Mar 1878 d. 12 Oct 1956
11
Luther Woodrow Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.1]
11
Ralph Burnet Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.2]
11
Frank Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.3]
b. Abt 1911
11
Lenora Bell Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.4]
11
Walter Grady Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.5]
b. 12 Oct 1902 d. 2 Mar 1966
Helen Lovina Mason
12
Fern Lee Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.5.1]
[
=>
]
12
Forest Wayne Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.5.2]
11
Roy G Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.6]
11
Eulia M Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.7]
11
Homer Monroe Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.8]
11
Archer Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.9]
11
Frank Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.1.10]
10
Edward Burnett Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.2]
b. 22 Aug 1880 d. 15 Jun 1969
10
James Monroe Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.3]
b. Jan 1886 d. 2 Feb 1971
10
William W Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.4]
b. Oct 1888 d. 12 Mar 1970
10
Mattie Bell Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.5]
b. 13 Aug 1876 d. 23 Jun 1916
10
Jacob Gidden Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.6]
b. 21 Oct 1883 d. 3 Oct 1956
+
Vertie B
b. 30 Jan 1893 d. 23 Apr 1957
10
George Gibson Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.7]
b. 16 Apr 1875 d. 23 Dec 1950
Lily E Ashburn
b. 26 Apr 1885 d. 13 Jun 1962
11
George G Flournoy, Jr
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.7.1]
b. Abt 1908
11
L Flourney
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.7.2]
b. 1906
11
Floyd Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.7.3]
b. 1908
11
Sarah E Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.7.7.4]
9
Martha R. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.2.8]
b. Bef 1847
8
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.3]
b. 26 Jun 1812 d. 14 Nov 1888
+
Mariah Louisa Steed
b. 15 Nov 1817 d. 24 Aug 1908
8
Caroline Elizabeth Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.4]
b. 10 Aug 1817 d. 22 Feb 1900
8
Louisa Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.5]
b. 13 Mar 1816 d. 10 Nov 1881
8
Mary Flournoy
[1.1.11.9.1.1.3.6]
7
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.11.9.1.1.4]
b. Abt 1780
7
Phoebe Flournoy
[1.1.11.9.1.1.5]
b. 28 Feb 1764 d. 2 Mar 1819
+
William Hill
b. Abt 1760 d. Abt 1850
7
Mary Frances Flournoy
[1.1.11.9.1.1.6]
b. 18 Jan 1766 d. Aft 1803
William Pleasant
b. 30 Jun 1767
8
Pleasant
[1.1.11.9.1.1.6.1]
b. 15 Jun 1803
8
Thomas Pleasant
[1.1.11.9.1.1.6.2]
+
Mary Durham
7
John Francis Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7]
b. 1757 d. 7 May 1842
Mary Ashurst
b. Abt 1770 d. Aft Nov 1834
8
Robert F. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.1]
b. 10 Dec 1797 d. 27 Oct 1834
+
Martha Lawton
8
Martha E. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.2]
b. Aft 1793 d. Abt 1859
+
Lewis W. King
d. 1 May 1815
+
Jabez Pleiades Marshall
+
II Irby Hudson
8
Josiah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3]
b. 17 Mar 1789 d. 25 Jan 1842
Martha Dixon "Patsy" Manley
b. 14 Oct 1789 d. 27 Apr 1877
9
Martha Elizabeth Ann Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.1]
b. 1827
Walter Richardson Branham
b. 18 Nov 1813 d. 2 Sep 1894
10
Edward Vance Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.1]
b. 18 Nov 1843 d. 10 Aug 1902
Julia Billups
b. 1858 d. 1907
11
Hal Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.1.1]
b. 1888
11
Emmee Connelly Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.1.2]
+
Benjamin Tyler Carter
b. 17 Nov 1885 d. 18 May 1962
10
Junius Wingfield Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2]
b. 1841
Laura Sasnett
b. Abt 1845
11
William Sasnett Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.1]
b. 26 Oct 1866 d. 8 Dec 1930
Marie Johnson
12
Annie Laurie Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.1.1]
12
Walter Johnson Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.1.2]
11
III Walter Richardson Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.2]
b. 1870
Lily Fluker
b. Abt 1875
12
Walter Richardson Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.2.1]
b. Abt 1895
12
Robert Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.2.2]
b. Abt 1895
11
Flournoy Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.3]
b. 1874
+
Margaret Brewster
+
Sena Hope
11
Bolling Sasnett Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.2.4]
b. 16 Jul 1880
+
Elizabeth MacElreath
10
Elizabeth Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.3]
b. Mar 1848
Henry Emory
11
Walter Emory
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.3.1]
Addie Singleton
12
Joseph Emory
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.3.1.1]
12
Rebecca Emory
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.3.1.2]
11
Annie Emory
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.3.2]
11
Julia Emory
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.3.3]
10
Jr. Walter Richardson Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.4]
b. Feb 1850
10
Martha Manley Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.5]
b. 3 Jun 1857
10
Henry Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.6]
b. 11 May 1860
+
Sadie Harwell
10
Virlinda Branham
[1.1.11.9.1.1.7.3.1.7]
9
Josiah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.2]
b. 14 Oct 1817 d. 27 Jul 1840
Evelina Powels
10
Georgianne Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.2.1]
10
Samuel Josiah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.2.2]
+
Mary E. Toney
E. J. Toney
11
Roper Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.2.2.1]
b. Abt 1870
Martha W. Rossier
b. 1820 d. 14 Feb 1852
10
Georgianna Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.2.3]
+
Van A. Leonard
10
Samuel Josiah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.2.4]
9
Robert A. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3]
b. 6 May 1825 d. 27 Oct 1896
Eugenia Moffett
b. 8 Feb 1836 d. 4 Jul 1902
10
Dora Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3.1]
b. 14 Sep 1856
+
Jr. Henry H. Epping
b. Cal 1856
10
Thomas Moffett Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3.2]
b. 12 Aug 1859 d. 28 Nov 1913
Araminta Lee Long
11
Robert Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.1]
b. 16 Aug 1900
+
Elizabeth Molder
11
Mary Nisbet Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.2]
b. 1 Jan 1903
+
Harbin King Park
11
Rebecca Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.3]
b. 23 Oct 1905
+
Charles Dexter Jordan
11
Jr. Thomas Moffett Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.4]
+
Nell Gray Kimbrough
11
Eugenia Moffett Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.5]
b. 1 Dec 1893
+
Holcombe Boscomb Harper
11
Arminta Long Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.3.2.6]
b. 5 Nov 1895
+
Gifford Banks Tarver
9
Martha D. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.4]
b. 1829
9
Frances 'Fannie' Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.5]
b. 23 Aug 1821 d. 20 Mar 1899
Joel Early Hurt
b. Abt 1821 d. 1865
10
Julia Flournoy Hurt
[1.1.11.9.1.1.7.3.5.1]
d. 31 Dec 1891
+
Peyton Colquitt
+
Lee Jordan
9
Thomas F. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6]
b. 1 Dec 1809 d. 29 Jan 1859
Caroline Elizabeth Rogers
b. Abt 1814 d. 23 May 1854
10
Mary Lou Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1]
b. 1 Dec 1832 d. 12 Nov 1893
Robert Rutherford Howard
b. 14 Feb 1824 d. 20 Nov 1897
11
John Robert Howard
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.1]
b. 19 Dec 1873 d. 9 May 1948
11
Sallie Howard
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.2]
b. 31 Aug 1851 d. 23 Aug 1902
11
Jennie Howard
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.3]
b. 16 Jun 1859 d. 20 Oct 1920
11
Caroline E. Howard
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.4]
b. Abt 1863
11
Alice V. Howard
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.5]
b. Abt 1865 d. 4 Jul 1944
11
Alice Vivian Howard
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.6]
b. 23 Apr 1865 d. 4 Jul 1944
11
Virginia Moore Howard
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.7]
b. 16 Jun 1860 d. 20 Oct 1920
11
Elizabeth Howard
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.1.8]
10
Robert Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.2]
b. 25 Nov 1834 d. 24 Jul 1867
Susan B. McKenzie
b. 21 Apr 1838 d. 6 Nov 1889
11
Walter Burch Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.2.1]
b. 15 Oct 1858
11
Ava Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.2.2]
b. 25 Oct 1864
11
Robert Ernest Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.2.3]
b. 6 Dec 1866
11
Charles M. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.2.4]
b. Apr 1860 d. Nov 1864
10
Martha Virginia Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.3]
b. 14 Jul 1838 d. 8 Mar 1907
+
John Castle Moore
10
Caroline Elizabeth Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.4]
b. 16 Aug 1840 d. 12 Sep 1927
+
Bethume Beaton McKenzie
b. 11 Oct 1837
10
Frances Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.5]
b. 9 Jul 1842 d. 29 Feb 1924
+
Frank W. Edison
10
Osborne Rogers Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.6]
b. 1835
+
Fletcher Hardin
b. Abt 1844
+
Mattie Flournoy
10
Thomas Josiah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.6.7]
b. 1 Aug 1846 d. 1885
9
Elizabeth J. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7]
b. Feb 1827 d. 1904
Robert S. Flournoy
b. 1825 d. 1870
10
George Henry Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.1]
b. 14 May 1850 d. 12 Feb 1941
10
Sarah E. "Sallie" Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.2]
b. Dec 1848 d. 26 Sep 1927
10
Martha L. O. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.3]
b. Dec 1856 d. 20 Jul 1922
10
Margaritte L. F. "Maggie" Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.4]
b. Oct 1858 d. 23 Nov 1931
10
Wilson P. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.5]
b. 2 Mar 1855 d. 9 Sep 1939
Emma N.
b. Apr 1871
11
Robert Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.5.1]
b. Oct 1895
11
George F. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.5.2]
b. May 1899
11
Tillman Russell Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.5.3]
b. 3 Nov 1898 d. Aug 1971
10
James Pierce Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.6]
b. 1845 d. 20 Nov 1898
10
J. R. F. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.7]
b. Abt 1848
10
M. C. F. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.7.8]
b. Cal 1856
9
Mary Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.8]
b. 12 Jul 1811 d. 27 Nov 1835
+
Lawrence C. Toombs
d. 3 Sep 1829
+
Gabrial Toombs
9
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.9]
b. 26 Jun 1812 d. 14 Nov 1888
9
John Manly Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10]
b. 14 Jan 1814 d. 14 Sep 1859
Mary Ann Gordon
b. 10 Mar 1823 d. 28 Jul 1886
10
Mary Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.1]
b. 7 May 1852 d. 20 Feb 1875
+
Francis Maury Fontaine
b. 4 Sep 1871 d. 24 Apr 1894
10
Virginia Abercrombie Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.2]
b. 7 Oct 1855 d. 20 Aug 1857
10
Charles Gordon Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.3]
b. 24 Dec 1844 d. 5 Apr 1902
+
Addie Gallespie
b. 10 Oct 1859 d. 9 Jan 1920
10
John Francis Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4]
b. 13 Mar 1847 d. 15 Jul 1936
Rebecca Epping
11
Rebecca Epping Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.1]
b. 16 May 1873 d. 27 Jan 1963
George Swift Hamburger
b. Mar 1870 d. 20 Mar 1935
12
Frank Flournoy Hamburger
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.1.1]
b. 14 Oct 1896 d. 7 Aug 1971 [
=>
]
12
Frances Isabel Hamburger
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.1.2]
b. 14 Jul 1903 d. 4 Jan 1956
11
Jr. John Francis Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.2]
b. 19 Sep 1871 d. 17 Sep 1937
Leila Morey Priestley
b. 10 Oct 1879 d. Feb 1956
12
Charles Priestley Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.2.1]
b. 17 Jan 1904 d. 7 Oct 1972 [
=>
]
Mary Welch Reynolds
b. 1 May 1852 d. 11 Mar 1926
11
Mallory Reynolds Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.3]
b. 15 Oct 1882
Mattie Hatcher
b. Cal 1882 d. 6 May 1956
12
Samuel H. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.3.1]
b. Cal 1905
12
Mary R. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.3.2]
b. Cal 1908
11
Maud Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.4]
b. Apr 1884
11
Josiah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.5]
b. Mar 1886 d. 13 Jan 1954
Jeannette Stephens Martin
b. Cal 1884
12
Jr. Josiah M. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.5.1]
12
Helen Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.5.2]
11
Gordon Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.6]
b. Dec 1887 d. 4 Feb 1930
Susette Joerg
b. 9 May 1891 d. 5 Jan 1972
12
Susette R. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.6.1]
11
Mary Hannah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.7]
b. Apr 1890
11
John Manly Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.8]
b. Dec 1891
11
Walker Reynolds Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.9]
b. Dec 1892 d. 25 Mar 1962
Mary Wheat
12
Margaret Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.10.4.9.1]
9
Louisa Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.11]
b. 13 Mar 1816 d. 10 Nov 1881
9
John Manly Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.12]
b. 14 Oct 1817 d. 27 Jul 1840
9
Catherine Caroline Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.13]
b. 5 Oct 1812 d. 28 Sep 1900
+
Willilam Hurt
Nathan Bass
b. 19 Oct 1808 d. 22 Sep 1890
10
Julia Bass
[1.1.11.9.1.1.7.3.13.1]
+
Zachary Taylor Leavell
b. Abt 1847
9
Amanda Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.14]
b. 9 Aug 1815 d. 4 Oct 1816
9
Thomas Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.15]
b. 1826
9
Robert Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.3.16]
b. 6 May 1826 d. 27 Oct 1896
8
Elizabeth A. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.4]
+
Obediah Echols
8
Mary Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.5]
d. Bef 1834
+
John H. Posey
8
Emily Flournoy
[1.1.11.9.1.1.7.6]
d. Bef 1834
7
William F. J. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.8]
b. Abt 1775 d. 6 Jun 1831
Nancy Hubart
b. Abt 1776 d. 17 Jun 1829
8
Matthew H. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.8.1]
b. Abt 1801 d. 11 Feb 1828
Elizabeth P. Wright
d. Aft 1829
9
Mary Ann Flournoy
[1.1.11.9.1.1.8.1.1]
b. 1827
8
John P. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.8.2]
Agnes Grant
9
Agnes Flournoy
[1.1.11.9.1.1.8.2.1]
d. 31 Jul 1840
9
John P. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.8.2.2]
d. 16 Jun 1835
8
William B. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.8.3]
8
Everlina Flournoy
[1.1.11.9.1.1.8.4]
+
Mark A. Cooper
7
Daniel Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9]
b. Abt 1777 d. Abt 1830
Sarah P. Wooldridge
8
Augustus Wooldridge Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.1]
b. Abt 1811
+
Anna Eliza Holland
8
John Gibson Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.2]
b. 24 Jan 1812 d. Nov 1892
Martha Ann S. Bass
9
Homer Edwin Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.2.1]
10
Bertie Rosa Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.2.1.1]
8
Alvinah Sarah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.3]
+
Peter Williams
8
Virginia Ann Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.4]
+
Robert W. Menefee
8
William Spencer Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.5]
+
Cornelia Bell
b. Abt 1823
8
Hannah Catherine Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.6]
+
Richard Elam Snelling
8
Caroline Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.7]
8
George Morion Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.8]
8
Richard Lafayette Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.9]
8
Ann Spencer Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.10]
8
Elizabeth F. Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.11]
+
Ball
Judith Flournoy
8
Phoebe Marshall Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.12]
b. Abt 1800 d. Abt 1865
Moab Elam
9
Adolphas Gustovus Elam
[1.1.11.9.1.1.9.12.1]
b. 31 Aug 1820
Rebecca Flournoy
10
William Sam Elam
[1.1.11.9.1.1.9.12.1.1]
b. Abt 1846
Ezra Seldon Howard
9
Lucy Jane Howard
[1.1.11.9.1.1.9.12.2]
9
Susan Emma Howard
[1.1.11.9.1.1.9.12.3]
9
Virginia Flournoy Howard
[1.1.11.9.1.1.9.12.4]
9
Irby H. Howard
[1.1.11.9.1.1.9.12.5]
8
Creed Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.13]
8
Daniel Henry Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.14]
8
Judith Watson Flournoy
[1.1.11.9.1.1.9.15]
7
Mary Ann Flournoy
[1.1.11.9.1.1.10]
b. Abt 1766 d. 1 Jan 1846
+
Peter Mahone
b. 20 Apr 1763 d. Bef 1807
7
Virginia Flournoy
[1.1.11.9.1.1.11]
b. Abt 1762
+
Mordecai Jacobs
7
Jane Flournoy
[1.1.11.9.1.1.12]
b. Abt 1783
7
David Flournoy
[1.1.11.9.1.1.13]
7
Josiah Flournoy
[1.1.11.9.1.1.14]
6
James Flournoy
[1.1.11.9.1.2]
b. Abt 1736
6
Josiah Flournoy
[1.1.11.9.1.3]
b. Abt 1738
6
Martha Flournoy
[1.1.11.9.1.4]
b. Abt 1740 d. Dec 1805
III Andrew Laprade
b. 1733 d. Aft 29 Apr 1797
7
Nancy Laprade
[1.1.11.9.1.4.1]
b. 4 Jun 1765 d. 27 May 1827
William P. Owen
b. 7 Jul 1761 d. 9 Nov 1823
8
Nancy Owen
[1.1.11.9.1.4.1.1]
b. 11 Sep 1798 d. 5 Jan 1853
John W. Walker
b. 22 Mar 1792 d. 6 Jan 1871
9
Davis Andrew Walker
[1.1.11.9.1.4.1.1.1]
b. 13 Jul 1828 d. 20 Jun 1891
Sarah Adaline Herrin
b. 13 Jul 1828 d. Jan 1859
10
Montgomery Hamilton Walker
[1.1.11.9.1.4.1.1.1.1]
b. 24 Mar 1852
Annie America Blythe
d. 30 Oct 1870
11
Alton Edgar Walker
[1.1.11.9.1.4.1.1.1.1.1]
b. 3 Oct 1877 d. 28 Oct 1939
Mary Eula Watson
b. 23 Feb 1885 d. 7 May 1969
12
Annie Florence Walker
[1.1.11.9.1.4.1.1.1.1.1.1]
[
=>
]
6
Sarah Flournoy
[1.1.11.9.1.5]
b. 1735 d. May 1806
William Wooldridge
b. 1709 d. 1798
7
Sarah Flournoy Wooldridge
[1.1.11.9.1.5.1]
b. Abt 1765 d. 1849
+
David Hudspeth
7
Gibson Wooldridge
[1.1.11.9.1.5.2]
b. 1750/1755 d. Oct 1816
+
Lucy Elizabeth Hudspeth
+
Mrs. Leah Pool
7
Thomas Flournoy Wooldridge
[1.1.11.9.1.5.3]
b. 1756 d. 1836
+
Cheriah Davis
+
Martha Easter
7
Edward Wooldridge
[1.1.11.9.1.5.4]
b. 1760/1770 d. 1828
+
Sarah Vining
7
Martha Wooldridge
[1.1.11.9.1.5.5]
b. Abt 1770
Joseph T. Davis
b. 1758
8
Thomas W. Davis
[1.1.11.9.1.5.5.1]
b. 1791
8
Absalom Davis
[1.1.11.9.1.5.5.2]
b. 1793
8
William Davis
[1.1.11.9.1.5.5.3]
b. 1796
8
Sarah F. Davis
[1.1.11.9.1.5.5.4]
b. 1798
Mary Baugh
b. Abt 1687
6
Jacob Flournoy
[1.1.11.9.1.6]
b. Abt 1717
6
Francis Flournoy
[1.1.11.9.1.7]
b. Abt 1719
6
William Flournoy
[1.1.11.9.1.8]
b. Abt 1726 d. Aft 1773
Edith Friend
b. 31 May 1754 d. 8 Feb 1805
7
Simon Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1]
b. 1779 d. 6 Aug 1856
Catherine Lucinda Langham
b. 1794 d. Aft 1880
8
Joseph B Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1]
b. Dec 1825 d. 3 Jun 1909
Louisa Denham
b. Oct 1823 d. Aft 1910
9
Joanna Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.1]
b. 1858
9
James Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.2]
b. Mar 1864
Sarah
b. Sep 1872
10
Lizzie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.2.1]
b. May 1886
10
Liza Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.2.2]
b. Jul 1890
10
Jack Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.2.3]
b. Sep 1892
10
Sarah J. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.2.4]
b. Jun 1898
9
William Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.3]
b. 1861
9
Davis Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.4]
b. 1850
9
Joseph Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.5]
b. 1858
+
Victoria Quick
b. 1861
9
Louis Andrew Jackson Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6]
b. 23 Feb 1859 d. 19 Jan 1960
Joanna J. Flournoy
b. Aug 1878 d. 6 Mar 1936
10
Mollie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.1]
b. 1887
10
Terrell Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.2]
b. 1892
10
Florence Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.3]
b. 1896
10
Carrie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.4]
b. 1897
10
Eugene Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.5]
b. 1900
10
Sallie B. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.6]
b. 1902
10
Andrew Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.7]
b. 11 Jun 1895 d. 9 Sep 1968
Nancy Hill Pinson
11
Raymond Rockmore Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.7.1]
10
Walker Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.8]
b. 1893
Annie
b. 1900
11
Julius Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.8.1]
11
J.T. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.6.8.2]
9
John F. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7]
b. 11 Sep 1840 d. 20 Jan 1937
Aldine Pike
b. 1839
10
Joseph Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1]
b. Feb 1862 d. 19 Oct 1946
Dolly (Sallie) Daniel
b. 1871
11
Warner Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.1]
b. 29 Aug 1899 d. 15 Jan 1969
Martha Ann White
b. 16 Nov 1900 d. 8 Feb 1960
12
Arthur Herman Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.1.1]
[
=>
]
12
Calvin Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.1.2]
12
Leon Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.1.3]
12
Grizzie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.1.4]
11
Eva M. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.2]
b. Aug 1895
Tom Flournoy
b. 1891
12
Lillian Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.2.1]
12
Edna Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.2.2]
12
John Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.2.3]
12
Roberta Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.2.4]
12
William Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.2.5]
12
Alice Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.2.6]
11
Virgil M. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.3]
Eunice Brown
b. 1897
12
Hattie Lee Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.3.1]
12
Luther A. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.3.2]
12
Howard Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.3.3]
12
Joseph Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.3.4]
b. 18 Apr 1927 d. Jun 1971
Willie Kerns
b. 1890
11
Olin Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.4]
11
Obediah Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.1.5]
b. 1910
10
John J. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.2]
b. 6 Mar 1877 d. 25 Dec 1956
Mattie Bowen
b. 1881
11
Bessie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.1]
b. 1906
11
Clarence Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.2]
b. 1906
+
Opal?
b. 1912
11
John Henry Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.3]
b. 1909
11
Ripley (Walter) Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.4]
b. 1910
+
Dora
11
Mattie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.5]
11
Thomas J. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.2.6]
10
William F. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.3]
b. Jul 1875 d. 13 Feb 1950
Ineza
b. Mar 1881 d. 29 Mar 1955
11
Eley E. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.3.1]
Nimmie
b. Abt 1898
12
Barney Fred Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.3.1.1]
[
=>
]
12
William Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.3.1.2]
12
Gilmor Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.3.1.3]
11
Stenson Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.7.3.2]
b. 1911
9
Mary Lou Ellen Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.8]
b. 26 Sep 1856 d. 6 Apr 1945
John Whitley
b. Cal 1850
10
James Whitley
[1.1.11.9.1.8.1.1.8.1]
b. Cal 1872
10
Joseph Whitley
[1.1.11.9.1.8.1.1.8.2]
b. Cal 1875
10
Mary Whitley
[1.1.11.9.1.8.1.1.8.3]
b. Cal 1876
10
Madison Whitley
[1.1.11.9.1.8.1.1.8.4]
b. Jun 1879
Thomas
10
Mary Lou Ellen Thomas
[1.1.11.9.1.8.1.1.8.5]
+
Stillwell
+
Wade
9
Simon Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.9]
b. 1849 d. 29 Dec 1935
Eliza Ann Pike
b. 1847
10
James Franklin Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.9.1]
b. 15 Jan 1874 d. 13 Jan 1964
Mary Ann Pitts
b. Sep 1879
11
Jr. James Franklin Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.9.1.1]
b. 8 Jul 1899
10
Mattie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.9.2]
b. Cal 1877
10
Simon Matthew Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.1.9.3]
+
Effie Harbuck
+
Sallie Moore
8
William Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.2]
b. Abt 1810 d. Aft 1880
8
Joannah Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.3]
b. 1820 d. Aft 1880
8
Sarah Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.4]
b. 1821
8
Jr. Simon Flournoy, Jr
[1.1.11.9.1.8.1.5]
b. Jan 1812 d. 6 Aug 1856
Martha Ann Teal
b. 1827 d. 1904
9
Sarah E Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.1]
b. 1844
9
Simon F. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.2]
b. Mar 1852 d. 13 Mar 1919
Sallie
b. 1852
10
Sallie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.2.1]
b. 1880
9
Joseph B J Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.3]
b. 17 Mar 1868 d. 27 Jun 1923
+
Mattie
b. May 1866
9
Peter F Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.4]
b. 2 Apr 1868 d. 25 Nov 1942
Lucy A Pitts
b. Dec 1860
10
Frankie May Flonrnoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.4.1]
b. Jul 1883
10
Lucius Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.4.2]
b. Abt 1895
10
John Flonrnoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.4.3]
b. Apr 1884
9
Jo Anna Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.5]
b. 1864
9
John Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.6]
b. 1861
9
James Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.7]
b. 13 Nov 1860 d. 1 Jun 1931
9
Mary Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.8]
b. 1857
9
Tillman F. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9]
b. Jul 1849 d. 20 Jan 1935
Mary Jane Chatman
b. Oct 1851 d. 1932
10
Joanna J. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1]
b. Aug 1878 d. 6 Mar 1936
Louis Andrew Jackson Flournoy
b. 23 Feb 1859 d. 19 Jan 1960
11
Mollie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.1]
b. 1887
11
Terrell Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.2]
b. 1892
11
Florence Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.3]
b. 1896
11
Carrie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.4]
b. 1897
11
Eugene Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.5]
b. 1900
11
Sallie B. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.6]
b. 1902
11
Andrew Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.7]
b. 11 Jun 1895 d. 9 Sep 1968
Nancy Hill Pinson
12
Raymond Rockmore Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.7.1]
11
Walker Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.8]
b. 1893
Annie
b. 1900
12
Julius Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.8.1]
12
J.T. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.1.8.2]
10
William S. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.2]
b. Sep 1881
10
Catherine "Kittie" Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.3]
b. 7 Sep 1884 d. 25 Jun 1960
+
George McCoy
10
Isaac Tillman Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.4]
b. 24 Jul 1886 d. 30 Jul 1935
10
Lucy Ann Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.5]
+
Jr. James Thomas Mealor
b. 27 Jan 1879 d. 15 Sep 1967
10
Mary Mehatibel Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.6]
b. 12 Jul 1892 d. 3 Jun 1964
John Warren Brown
b. 12 Nov 1889 d. 23 Feb 1948
11
Margaret Brown
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.6.1]
11
Lizzie Brown
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.6.2]
b. Abt 1911
11
Blanche Brown
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.6.3]
11
John Warren Brown, Jr
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.6.4]
10
Walker Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.7]
b. Jul 1893 d. 25 Mar 1962
10
Martha Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.8]
b. 5 Aug 1895 d. 9 Jan 1898
+
John W. McGouirk
10
Henry Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.9]
b. Aug 1897
10
James Franklin "Frank" Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.10]
b. 15 Oct 1877 d. 13 Jan 1964
Mary Ann Pitts
b. Sep 1879
11
May Bell Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.10.1]
b. Cal 1904
11
James F Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.10.2]
b. Jul 1899
11
Emmett C Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.10.3]
b. Abt 1901
11
George W Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.9.10.4]
b. Abt 1903
9
Joel L. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10]
b. 9 Sep 1846 d. 14 Dec 1932
Nancy Elizabeth Calhoun
b. 17 Aug 1856 d. 17 Mar 1942
10
Clarence Dewey Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.1]
10
Susie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.2]
10
Egrilma Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.3]
b. Jul 1895
10
Ilga Mattie Flourney
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.4]
b. Oct 1898 d. 17 Apr 1959
10
Mollie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.5]
b. Abt 1896
10
Minnie Lee Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.6]
b. 31 Oct 1891 d. 8 Sep 1967
10
Mattebell Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.7]
b. Feb 1885 d. 17 Apr 1959
10
Isaac Chaney Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.8]
b. 24 Sep 1880 d. 28 Oct 1918
10
Hattie Ethel Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.9]
b. Abt 1902 d. 2 Dec 1961
10
Luella Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.10]
b. Aug 1883 d. 11 Jan 1958
10
Willie Duke Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.11]
b. 1 Apr 1889 d. 18 May 1970
10
Brock Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.12]
10
Callie Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.13]
Mary Jane "Bertie" Moody
b. 2 Feb 1843
10
Marion Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.14]
b. Feb 1872 d. 31 Jan 1937
10
George Hamilton "Hamp" Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15]
b. Abt 1863 d. 24 Apr 1953
Ada Elizabeth Milam
b. Abt 1880 d. 1943
11
George W. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.1]
b. Cal 1902
11
Claude Hamilton Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.2]
b. Abt 1895
11
Maud Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.3]
b. Abt 1898
11
Royce G. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.4]
11
Robert Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.5]
11
Eddie B Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.6]
b. Abt 1907
11
Earnest Grady Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.7]
b. Abt 1909
11
Eunice V Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.8]
11
Bertha B Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.15.9]
10
John Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.5.10.16]
8
Catherine Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.6]
b. 1812
8
Ameraca Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.7]
8
Ellen Flournoy
[1.1.11.9.1.8.1.8]
7
Francis Flournoy
[1.1.11.9.1.8.2]
b. Abt 1776
7
Jane F. Flournoy
[1.1.11.9.1.8.3]
b. Abt 1783
7
Greene Flournoy
[1.1.11.9.1.8.4]
b. Abt 1786
7
Edith Flournoy
[1.1.11.9.1.8.5]
b. 1788
7
Margaret Flournoy
[1.1.11.9.1.8.6]
b. 1794
7
Ann Flournoy
[1.1.11.9.1.8.7]
7
John Flournoy
[1.1.11.9.1.8.8]
7
Martha Flournoy
[1.1.11.9.1.8.9]
7
Mary Flournoy
[1.1.11.9.1.8.10]
7
Sarah Flournoy
[1.1.11.9.1.8.11]
7
Thomas Flournoy
[1.1.11.9.1.8.12]
7
Jr. William Flournoy
[1.1.11.9.1.8.13]
+
Phoebe Farrar
b. Abt 1769
6
Jane Flournoy
[1.1.11.9.1.9]
b. 1726 d. 1806
+
Simon Hancock
6
Mary Flournoy
[1.1.11.9.1.10]
b. Abt 1713
+
Edward Wooldridge
b. 1711 d. 10 Oct 1808
6
Jean Flournoy
[1.1.11.9.1.11]
b. Abt 1715
5
Jacques Flournoy
[1.1.11.9.2]
b. 14 Dec 1688 d. 1740
5
Marie Flournoy
[1.1.11.9.3]
b. 3 Jun 1690 d. Abt May 1700
5
Jeanne-Marie Flournoy
[1.1.11.9.4]
b. 19 Jan 1692/93 d. 23 Jan 1692/93
5
Jeanne Francoise Flournoy
[1.1.11.9.5]
b. 28 Mar 1695 d. Abt 1717
Robert Ashurst
6
Jacob Ashurst
[1.1.11.9.5.1]
5
Magdalaine Flournoy
[1.1.11.9.6]
b. Abt 1685 d. Aft 1731
4
Jacques Jean Flournoy
[1.1.11.10]
b. 15 Sep 1657 d. 22 Feb 1725
Julia Eyrand
b. 16 Aug 1664 d. 16 Aug 1756
5
Julie Flournoy
[1.1.11.10.1]
b. 29 Nov 1699 d. 30 Nov 1699
5
Gedeon Flournoy
[1.1.11.10.2]
b. 2 Dec 1691
+
Jeanne Francoise Comparet
b. 4 Feb 1689/90
5
David Flournoy
[1.1.11.10.3]
b. 8 Nov 1698 d. 2 Jul 1745
5
Flournoy
[1.1.11.10.4]
b. 5 Aug 1693 d. 5 Aug 1693
5
Rachel Flournoy
[1.1.11.10.5]
b. 7 Apr 1685
5
Jean Jacques Flournoy
[1.1.11.10.6]
b. 17 Nov 1686 d. 23 Mar 1740
Mary Williams
b. 25 Dec 1695 d. 25 Mar 1740
6
Rachel Flournoy
[1.1.11.10.6.1]
b. 25 Sep 1730 d. 28 Aug 1741
6
David Flournoy
[1.1.11.10.6.2]
b. 3 Sep 1728 d. 18 Oct 1757
6
Mathews Flournoy
[1.1.11.10.6.3]
b. 21 Jun 1732 d. 1785
Elizabeth Ann Pryor
b. 1739 d. Jun 1798
7
Robert Watkins Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1]
b. 13 May 1763 d. 5 Jul 1825
Mary Willis Cobbs
b. 15 Apr 1777 d. 8 Feb 1829
8
Howell Cobb Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.1]
b. 21 Mar 1813 d. 1872
8
Robert Watkins Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.2]
b. 5 Mar 1811 d. 24 Aug 1894
Amanda Cullens
b. 1816 d. Bef 1858
9
Elizabeth M. Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.2.1]
b. 24 Jul 1844
A. E. Andrews
10
Robert Watkins Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.1.1]
b. 1867 d. Bef 1900
Anna Roberta Flournoy
b. Dec 1868 d. Aft 1900
11
Albert R. Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.1.1.1]
b. 1869
11
Elizabeth F. Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.1.1.2]
b. 1882
11
Gasaway Knight Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.1.1.3]
b. 1887
11
Haynes Cullens Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.1.1.4]
9
Jr. Robert Watkins Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.2.2]
b. 13 Dec 1841 d. 8 Jun 1869
Ophelia C. Tucker
b. 6 Oct 1844 d. Aft 1900
10
Robert Willis Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.2.2.1]
b. 22 Sep 1867
+
Martha Redd Fontaine
b. Sep 1873
10
Anna Roberta Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.2.2.2]
b. Dec 1868 d. Aft 1900
Robert Watkins Andrews
b. 1867 d. Bef 1900
11
Albert R. Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.2.2.1]
b. 1869
11
Elizabeth F. Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.2.2.2]
b. 1882
11
Gasaway Knight Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.2.2.3]
b. 1887
11
Haynes Cullens Andrews
[1.1.11.10.6.3.1.2.2.2.4]
Louisa St. Clair Cullens
b. 9 Feb 1838 d. 9 Oct 1916
9
Mary Louise Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.2.3]
b. 24 Sep 1858 d. 14 May 1929
James Wilson Bell
b. 6 May 1853 d. 27 Oct 1925
10
Rosa Wilson Bell
[1.1.11.10.6.3.1.2.3.1]
+
Robert Lee Campbell
b. 25 Nov 1882 d. 11 Aug 1952
10
Mary Cobb Bell
[1.1.11.10.6.3.1.2.3.2]
b. 17 Jan 1885 d. 8 Mar 1965
+
Erskine Miller Carr
b. 22 Jan 1883 d. 17 Oct 1932
10
Watkins Flournoy Bell
[1.1.11.10.6.3.1.2.3.3]
b. Jan 1895 d. Bef 1950
+
Whitfield King
d. Bef 1950
10
Lillian Tennille Bell
[1.1.11.10.6.3.1.2.3.4]
+
Henry Pittman Hurt
b. 26 Feb 1872 d. 20 Nov 1944
10
Robert Flournoy Bell
[1.1.11.10.6.3.1.2.3.5]
b. 27 Apr 1879 d. 30 Jun 1896
10
James Bell
[1.1.11.10.6.3.1.2.3.6]
b. 6 May 1891 d. 27 Jan 1893
10
Mary Louise Bell
[1.1.11.10.6.3.1.2.3.7]
b. 3 Jun 1877 d. 6 Nov 1878
8
Marcus Aurelius Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.3]
b. 9 Oct 1795
8
Thomas Howell Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.4]
b. 19 Mar 1797 d. 1797
8
Elizabeth America Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.5]
b. 18 May 1800 d. INFANT
8
Robert Willis Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.6]
b. 11 Dec 1802 d. Jan 1845
8
Mary Mildred Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.7]
b. 8 Jan 1805 d. 1874
+
Nathaniel Alexander Adams
d. 28 Aug 1849
8
John James Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.8]
b. 15 Aug 1808
8
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.11.10.6.3.1.9]
b. 25 May 1815 d. 14 Apr 1844
Charles G. McKinley
9
William M. McKinley
[1.1.11.10.6.3.1.9.1]
b. 1 May 1835
9
Mary Elizabeth McKinley
[1.1.11.10.6.3.1.9.2]
b. 16 Sep 1840 d. 25 Apr 1845
9
Elizabeth Julia McKinley
[1.1.11.10.6.3.1.9.3]
d. 25 Apr 1845
7
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.11.10.6.3.2]
b. 1768 d. 1813
William Gustavus Henry
b. 1761 d. 1824
8
William Henry
[1.1.11.10.6.3.2.1]
b. 1793 d. 1847
Cornelia VaVasour Gano
b. 20 Apr 1801 d. 2 Mar 1887
9
Robert William Henry
[1.1.11.10.6.3.2.1.1]
b. 1823 d. 1862
Martha Douglas Cocke
b. 17 Dec 1822 d. 28 Mar 1850
10
Martha Douglas Henry
[1.1.11.10.6.3.2.1.1.1]
b. 24 Feb 1850 d. 29 Jan 1924
Leonidas Armstead Sypert
b. 1832 d. 1893
11
Susan Jouett Sypert
[1.1.11.10.6.3.2.1.1.1.1]
b. 1881 d. 1 Sep 1954
Charles Washington Johnston
b. 1871 d. 1 Dec 1958
12
Abraham Russel Johnston
[1.1.11.10.6.3.2.1.1.1.1.1]
b. 31 Aug 1914 d. 14 Dec 1943 [
=>
]
8
Matthews Winston Henry
[1.1.11.10.6.3.2.2]
b. 11 Jan 1790
7
Martha Caroline Flournoy
[1.1.11.10.6.3.3]
b. 1764 d. 1803/1806
John Thomas Wells
b. 1760 d. 1802
8
Francis Flournoy Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1]
b. Abt 1800 d. Nov 1866
Martha McNutt
9
Robert Williamsom Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1.1]
b. 3 Aug 1849
9
Lucky Francis Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1.2]
b. 18 May 1846 d. 1915
Francis M. Sutherland
10
Flora S. Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1.2.1]
b. Feb 1881
10
Thomas J. Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1.2.2]
b. Oct 1878
10
Robert W. Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1.2.3]
b. Sep 1875
9
Flora Adelia Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1.3]
b. 31 Dec 1833 d. 25 Dec 1914
George F. Simons
b. 14 Feb 1834
10
George F. Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.1]
b. Jul 1872
Mary Lula Rose
b. 31 May 1874
11
Mattie L. Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.1]
+
Andrew J. Garner
b. Abt 1883
11
Volney Rose Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.2]
Elizabeth Cooper
12
Nancy Lois Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.2.1]
11
Steele White Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.3]
Elizabeth Winston
12
Dennis Steele Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Suzanne Elizabeth Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.3.2]
11
George Wells Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.1.4]
b. 1912
10
F. Wells Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.2]
b. Aug 1868
Susan Ann Rose
b. Apr 1871
11
George F. Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.2.1]
b. Apr 1898
11
Flora L. Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.2.2]
b. Jul 1894
10
William U. Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.3]
b. 1866
10
Courtney Stuart Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.4]
b. 1865
11
Jr. Courtney Stuart Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.4.1]
11
Kerr Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.4.2]
b. Yes, date unknown
10
Martha W. Simons
[1.1.11.10.6.3.3.1.3.5]
b. 1861
9
Elizabeth Casandra Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1.4]
b. 1828
9
Laura Martha McNutt Wells
[1.1.11.10.6.3.3.1.5]
b. 13 Jul 1827
Clark Lewis Owen
b. 6 Jun 1807 d. 6 Apr 1862
10
Owen
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.1]
b. 1852
10
Laura Minta Owen
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2]
b. 1850 d. Mar 1885
John Owen Rowlett
b. 6 Aug 1847 d. 21 Oct 1918
11
Henry J. Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.1]
b. 1879
11
A. Owen Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.2]
b. 1880 d. 1942
11
Mary Laura Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.3]
b. 1873
11
John O. II Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.4]
b. 1875
11
Ruth I. Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.5]
b. 1876 d. Sep 1957
11
George Simons Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.6]
b. 4 Sep 1884 d. 1956
Mattie Virginia Richey
12
Myrtle Flora Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.6.1]
[
=>
]
12
Grover Owen Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.6.2]
[
=>
]
11
Flora Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.7]
11
Pansy Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.8]
11
Laura Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.9]
11
Daniel Rowlett
[1.1.11.10.6.3.3.1.5.2.10]
8
Lewis Wells
[1.1.11.10.6.3.3.2]
8
Martha Wells
[1.1.11.10.6.3.3.3]
8
Cassandra Wells
[1.1.11.10.6.3.3.4]
8
Frank Wells
[1.1.11.10.6.3.3.5]
8
John J. Wells
[1.1.11.10.6.3.3.6]
8
Thomas Flournoy Wells
[1.1.11.10.6.3.3.7]
6
John Flournoy
[1.1.11.10.6.4]
b. 9 Dec 1726 d. 19 Jan 1825
+
Camilla Ballexserd
b. 1722 d. 1743
6
Thomas Flournoy
[1.1.11.10.6.5]
b. 20 Nov 1738 d. 25 Feb 1801
Anne Martin
d. 1814
7
Lucy Faris Flournoy
[1.1.11.10.6.5.1]
b. 1786 d. 1836
William Booker Morton
b. 3 Sep 1775 d. 10 Aug 1816
8
Elvira Henry Morton
[1.1.11.10.6.5.1.1]
b. 1806 d. 1840
William Peter Barksdale
b. 1799 d. 1854
9
Louisa Frances Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.1.1]
b. 1830 d. 1907
John Bullock Crews
b. 1814 d. 1882
10
Louise Barksdale Crews
[1.1.11.10.6.5.1.1.1.1]
10
Frances Sydnor Crews
[1.1.11.10.6.5.1.1.1.2]
10
Rosa Crews
[1.1.11.10.6.5.1.1.1.3]
+
Nicholas Hairston
8
Anne Martin Morton
[1.1.11.10.6.5.1.2]
b. 1804
William Henry Dennis
b. 1801 d. 1866
9
Jacob Dennis
[1.1.11.10.6.5.1.2.1]
8
Mary Elizabeth Morton
[1.1.11.10.6.5.1.3]
b. 24 Apr 1808 d. 13 Dec 1889
William Sydnor Barksdale
b. 7 May 1806 d. 10 Sep 1874
9
Lucy Ann Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.1]
b. 4 Oct 1828 d. 11 Jan 1906
James Woodford Arendall
b. 20 Jan 1820 d. 17 Mar 1871
10
Lucy Flournoy Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.1]
b. 5 Jun 1862 d. 11 Dec 1888
10
Judith Williams Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.2]
b. 16 Sep 1865 d. 31 Aug 1896
Robert V. Farmer
11
Maude M. Farmer
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.2.1]
b. 10 Mar 1885
10
Elizabeth Frances Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.3]
b. 23 May 1867 d. 12 Jun 1895
W. G. Slayton
11
Hattie S. Slayton
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.3.1]
b. 15 Jan 1885 d. 12 Sep 1886
10
Virginia Alice Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.4]
b. 26 Dec 1869
Charles King Petty
11
Henry T. Petty
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.4.1]
b. 3 Oct 1896
10
William Barksdale Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5]
b. 25 Apr 1849 d. 11 Nov 1911
Phebe Pennich Dixon
d. 11 Jul 1898
11
Agis Lycurgus Lafayette Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.1]
b. 16 Dec 1871
11
Thomas Frank Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.2]
b. 30 May 1874
+
E. Lillian Walker
11
Morton Armistead Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.3]
b. 2 Aug 1877 d. 2 Aug 1879
11
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.4]
b. 8 Jan 1880
+
William H. Douglas
11
Alice M. Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.5]
b. 10 Jun 1884
11
Lou Boyd Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.6]
b. 27 Jul 1888 d. 11 Sep 1889
11
Rosa Crews Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.7]
b. 18 Mar 1891 d. Jan 1970
Christopher Columbus Tankersley
b. 10 Sep 1884 d. 1921
12
Earl Willard Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.7.1]
12
Lorine Edith Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.7.2]
12
Irvin W. Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.7.3]
12
Annie Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.5.7.4]
10
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.6]
b. 23 Apr 1851 d. 28 Sep 1853
10
Ann Catherine Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.7]
b. 7 Mar 1853 d. 15 Jul 1882
Alexander D. Thompson
11
Sandy S. Thompson
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.1]
b. 5 Jul 1878
11
Adel May Thompson
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.2]
b. 30 Apr 1881 d. 18 Mar 1882
11
Maud Iola Thompson
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.3]
b. 16 Feb 1879
11
John Armistead Thompson
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.4]
b. 9 Oct 1876 d. 20 Jun 1878
11
Charles Woodford Thompson
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.5]
b. 10 Oct 1873
11
William M.B. Thompson
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.7.6]
b. 25 Jun 1875
10
John Armstead Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8]
b. 12 Jan 1855 d. 1 Jul 1935
Alice Madison Cole
b. 3 Feb 1854 d. 29 Jan 1940
11
John William Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.1]
b. 19 Nov 1885 d. 31 Mar 1936
Marguerite A. Krebs
d. 27 Jun 1919
12
John Madison Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.1.1]
12
Alice Marguerite Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.1.2]
12
Annette Elaine Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.1.3]
11
James Newton Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.2]
b. 11 Jul 1877
11
Luella T. Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.3]
b. 6 Oct 1879 d. 10 Sep 1964
Luther A. Irby
b. 11 May 1871 d. 29 Jul 1953
12
John Ferman Irby
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.3.1]
12
Jr. Luther A. Irby
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.3.2]
12
Samuel Irby
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.3.3]
12
Floyd Irby
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.3.4]
11
Patsy Cole Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.4]
b. 6 Oct 1888
11
Kathleen Kent Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.5]
b. 23 Apr 1896
11
Allie Lovelace Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.8.6]
b. 24 Jul 1894
10
Thomas Syndor Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.9]
b. 11 May 1857 d. 1940
Virginia Lee Shields
b. Abt 1862
11
Jake Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.9.1]
b. Abt 1885
Ruth Conway
b. Abt 1894
12
James Conway Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.9.1.1]
12
Julian Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.9.1.2]
b. Abt 1917 d. Abt 1918
+
Sarah Hunter Beaman
b. Abt 1900
10
James Morton Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10]
b. 29 Feb 1860 d. 14 Dec 1938
Jennie Sarah Farmer
b. 29 Sep 1865 d. 12 Apr 1948
11
Sue Brown Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.1]
+
Willie Claude Shelton
11
John Carson Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.2]
+
Pattye Myrtle Lewis
+
Edna Wilson Moore
11
Minnie Gunn Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.3]
+
Walter Henry Spencer
b. 14 Aug 1904 d. 1940
11
James Herbert Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4]
b. 25 Dec 1883 d. 16 Feb 1961
Mamie Lettica Atkinson
b. 6 Apr 1883 d. 22 Feb 1955
12
Raleigh Thomas Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4.1]
b. 11 May 1916 d. 23 Jul 1966
12
Oliver Twister Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4.2]
b. 18 Apr 1918 d. 12 Apr 1972
12
James Washington Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4.3]
b. 28 Aug 1905 d. Aug 1971
12
Henry Clyde Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4.4]
12
Albert Thorton Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4.5]
b. 23 Mar 1909 d. 13 Apr 1949
12
Mabel Pearl Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4.6]
b. 18 Nov 1910 d. 26 Jan 1965
12
Lettie Ann Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4.7]
12
Lem Carter Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.4.8]
11
Molly B. Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.5]
b. 25 Nov 1888 d. 28 Dec 1972
Doctor Cooper Smith
b. 23 Apr 1882 d. 6 May 1968
12
Mary Virginia Smith
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.5.1]
12
Mae Louise Smith
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.5.2]
12
Belva Dunn Smith
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.5.3]
12
Manuel Cooper Smith
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.5.4]
11
Emma Carter Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6]
Osa Perrow Roark
b. 17 Jun 1888 d. 18 Sep 1968
12
Bertha Mae Roark
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6.1]
12
Mildred Gunn Roark
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6.2]
12
Ida Evelyn Roark
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6.3]
12
Tapley Clinton Roark
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6.4]
b. 13 May 1918 d. 22 Mar 1948
12
Ralph Wiggington Roark
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6.5]
12
Wilmer Ryland Roark
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6.6]
12
John Morton Roark
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6.7]
12
Verona Pearl Roark
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.6.8]
b. 25 Dec 1922 d. 14 Feb 1923
11
Tap McDowell Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.7]
b. 4 Jul 1896 d. 14 Oct 1962
+
Hattie Owen McDowell
b. 24 Jul 1885 d. 10 May 1968
11
Bettie Arendall
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.8]
Leslie A. Anderson
12
Ruby Anderson
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.8.1]
b. 13 Aug 1911
12
Artie H. Anderson
[1.1.11.10.6.5.1.3.1.10.8.2]
9
John Thomas Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.2]
b. 9 Mar 1844
9
Mary Susan Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.3]
b. 22 Jun 1846
9
Alice Sydnor Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.4]
b. 31 Oct 1848
9
Flournoy X. Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.5]
b. 23 Jun 1852
9
Judith Williams Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.6]
b. 16 Mar 1831
9
Elizabeth Armistead Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.7]
b. 3 Aug 1833
9
William Morton Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.8]
b. 2 Jan 1837
9
Elvira Frances Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.9]
b. 28 Jul 1839
9
Anthony Sydnor Barksdale
[1.1.11.10.6.5.1.3.10]
b. 29 Nov 1841
8
William Booker Morton
[1.1.11.10.6.5.1.4]
b. 1811
+
Faris
7
David Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2]
b. Abt 1780
Mary Morton
b. Abt 1782
8
Thomas Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1]
b. 25 Jul 1804 d. 27 Dec 1892
Frances Matthews Venable
b. Abt 1810 d. 16 Aug 1863
9
Martha Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.1]
b. 28 Jul 1837
+
William Henry Venable
9
Nathaniel Abraham Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.2]
b. 20 Jan 1839
Laura Lewis
10
John Herbert Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.2.1]
Florence Wilson
11
John Wilson Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.2.1.1]
10
Fannie Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.2.2]
+
Charles Kimbro Taylor
10
Norborne Lewis Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.2.3]
10
Thomas Lewis Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.2.4]
+
Lois Latimer
9
II David Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.3]
b. 20 May 1829 d. 20 Nov 1895
Martha Daniel Bouldin
b. 11 Jan 1852
10
Fannie Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.3.1]
b. 3 Jul 1872
10
Thomas Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.3.2]
b. 12 Oct 1877 d. 19 Sep 1947
+
Mary Harvey Hamlin
b. 22 Jun 1873 d. 25 Jul 1967
10
Martha Daniel Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.3.3]
b. 15 Mar 1871
9
Frances Watkins Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.4]
b. 24 Sep 1830 d. 1900
Jr. Thomas Tyler Bouldin
b. 24 Mar 1813 d. 1891
10
Ellen Barksdale Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.1]
b. 10 Feb 1860
10
Fanny Louis Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.2]
+
Preston Buford
10
Mary Willie Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.3]
10
Henry Wood Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.4]
Lilla Coles
11
Fanny Lewis Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.4.1]
+
Thomas Spratly
11
Lilla Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.4.2]
+
Oska Shoemake
11
Thomas Tyler Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.4.3]
+
Louise Coles
10
Martha Cabell Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.5]
+
Gentry
10
Flournoy Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.6]
Annie White
11
Elizabeth Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.6.1]
b. Abt 1895
10
Clairborne Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.7]
Mary Crump
11
Alice Good Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.7.1]
11
Thomas Tyler Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.7.2]
11
Mary Crump Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.7.3]
11
Jr. Clairborne Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.7.4]
10
John Lewis Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.8]
+
Hetty Jones
10
Annie Venable Bouldin
[1.1.11.10.6.5.2.1.4.9]
+
Thomas W. Daniel
9
Amanda Nantz Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.5]
b. 8 May 1835
9
William Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.6]
b. 29 Nov 1835 d. 30 Mar 1836
9
Mary Agnes Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.7]
b. 23 Aug 1828
William H. Marshall
10
Pattie Venable Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.1]
+
Wood Dunham
10
Amanda F. Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.2]
10
James Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.3]
Carey Knox
11
James Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.3.1]
11
Ruth Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.3.2]
10
Louise Cabell Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.4]
Matthews Fink
11
Marshall Scott Fink
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.4.1]
11
Paul Fink
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.4.2]
11
Miriam Fink
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.4.3]
10
Sallie Anne Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.5]
Judson Lloyd
11
Mary Lloyd
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.1]
Wade
12
James S. Wade
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.1.1]
11
John Lloyd
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.2]
11
Kathleen Lloyd
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.3]
Arthur Field
12
Mary Agnes Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.3.1]
12
Sarah Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.3.2]
11
Robert Lloyd
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.5.4]
10
Fannie T. Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.6]
William H. Marshall
11
Pattie Venable Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.6.1]
11
James Marshall
[1.1.11.10.6.5.2.1.7.6.2]
9
Jacob Morton Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.8]
b. 7 Oct 1843
Mildred Coles Carrington
b. Abt 1845
10
Walter Carrington Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.8.1]
b. Abt 1875 d. 1896
10
Thomas Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.8.2]
10
Anna Lightfoot Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.8.3]
10
Elizabeth Morton Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.8.4]
9
William Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.9]
b. 24 Oct 1846
9
Louisa Cabell Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.10]
b. 2 Nov 1841
Richard Field
10
Louise Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.1]
+
Albert McCracken
10
Meade Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.2]
10
George Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.3]
10
Martha Venable Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.4]
10
Anna Morton Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.5]
+
William Moran
10
Nona Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.6]
+
Sandridge
10
Kate Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.7]
+
Horace Hayden
10
Fanny Venable Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.8]
+
Oscar Collins
10
Sally Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.9]
10
David Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.10]
10
Eva Field
[1.1.11.10.6.5.2.1.10.11]
+
Robert E. Lee Morton
9
Elizabeth Anne Flournoy
[1.1.11.10.6.5.2.1.11]
b. 26 Nov 1840
Reubin Booth Hicks
10
Thomas Hicks
[1.1.11.10.6.5.2.1.11.1]
Jennie Bowber
11
Elizabeth Baten Hicks
[1.1.11.10.6.5.2.1.11.1.1]
11
Francis Venable Hicks
[1.1.11.10.6.5.2.1.11.1.2]
11
Thomas Flournoy Hicks
[1.1.11.10.6.5.2.1.11.1.3]
11
Reubin Booth Hicks
[1.1.11.10.6.5.2.1.11.1.4]
+
Sally Edmunds Hicks
b. Abt 1827
+
Agnes Woodson Watkins
b. 28 Feb 1774
7
Anne Farish Flournoy
[1.1.11.10.6.5.3]
b. Abt 1772
Archer Womack
b. 1777 d. 1816
8
Julia Ann Womack
[1.1.11.10.6.5.3.1]
b. 22 Sep 1815 d. 1 Jan 1887
Joseph Richard Bailey
b. 1815 d. 28 Aug 1857
9
David Flournoy Bailey
[1.1.11.10.6.5.3.1.1]
b. 1845
Sarah Eleanor Preston
b. 1843
10
Julia Bailey
[1.1.11.10.6.5.3.1.1.1]
+
William T. Tillar
9
Louise Bailey
[1.1.11.10.6.5.3.1.2]
b. Cal 1844
9
Anna A. Bailey
[1.1.11.10.6.5.3.1.3]
b. Cal 1850
7
Julia Elizabeth Flournoy
[1.1.11.10.6.5.4]
b. 7 Sep 1767 d. 5 Nov 1836
George Wells Foster
8
Ann Martin Foster
[1.1.11.10.6.5.4.1]
b. Abt 1788
+
Lovick Pierce
7
John James Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5]
b. 15 Oct 1782 d. 1862
Ann Carrington Cabell
b. 20 Sep 1787 d. 7 Jul 1854
8
Ann Eliza Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.1]
b. 1808
+
Henry Wood
8
William Cabell Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2]
b. 31 Dec 1809 d. 31 Mar 1861
Martha Watkins Venable
b. 5 Jun 1816 d. 1905
9
William Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.1]
b. Abt 1839 d. Abt 1842
9
Landon Cabell Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2]
b. 4 Mar 1850
Susan Cabell Cobbs
b. 5 Nov 1864
10
Mildred Cobbs Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.1]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
10
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.2]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
10
Mary Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.3]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
10
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.4]
b. 20 Sep 1890
10
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.5]
b. 24 Oct 1896
Martha G. Givens
b. 1858 d. 9 May 1884
10
Martha Watkins Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.6]
b. 24 Dec 1882
10
Sarah Wright Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.7]
b. 9 Apr 1881
+
Butts
10
Florida Fitzgerald Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.8]
b. 31 Aug 1879
10
Bessie Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.2.9]
b. 29 Jan 1878
+
Brown
9
George Mallory Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1853
9
Charles Bruce Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.4]
b. 11 Nov 1854
+
Virginia Dalby
9
Alice Eliza Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.5]
b. 4 Nov 1852
+
Littleton Fitzgerald
9
Sarah Venable Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.6]
b. 12 Aug 1845
+
J. C. Painter
9
Benjamin Stanhope Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.7]
b. Abt 1841 d. Abt 1842
9
II John James Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.8]
b. 13 Apr 1837 d. 7 Jan 1875
9
Ann Cabell Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.9]
b. Abt 1835 d. Abt 1837
9
Frances Florida Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.2.10]
b. 6 Jul 1843
+
John P. Fitzgerald
8
Patrick Henry Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.3]
b. 4 Mar 1813 d. 3 Mar 1887
Susan Edmunds
9
Nicholas Edmunds Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.3.1]
b. 23 Mar 1841
+
Catharine Patrick Wood
9
William Stanhope Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.3.2]
b. 23 Dec 1845
+
Bettie A. Wilson
9
Ann Cabell Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.3.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1848
8
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4]
b. 15 Dec 1811 d. 12 Mar 1883
Susan Ann Love
d. 21 Apr 1848
9
Mary P. Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.1]
b. 11 Sep 1838 d. 1874
John F. Cobbs
10
Susan Cabell Cobbs
[1.1.11.10.6.5.5.4.1.1]
b. 5 Nov 1864
Landon Cabell Flournoy
b. 4 Mar 1850
11
Mildred Cobbs Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.1]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
11
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.2]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
11
Mary Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.3]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
11
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.4]
b. 20 Sep 1890
11
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.1.1.5]
b. 24 Oct 1896
9
Cabell Edward Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.2]
b. 30 Jun 1840 d. 1864
9
John James Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.3]
b. 11 Apr 1842
9
Louisa Cabell Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.4]
b. 3 May 1844
+
William W. Cobbs
9
Henry Wood Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.5]
b. 6 Jun 1846
+
Rose Buena Wood
9
Allen Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.6]
d. Abt 1849
Mildred H. Coles
d. 1901
9
Helen Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.7]
b. 9 May 1856
+
John R. Patton
9
Ann Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.8]
b. Abt 1858 d. Abt 1862
9
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.9]
b. 8 May 1860
9
Cole Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.10]
b. 1 Oct 1862
9
Lettice Carrington Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.11]
b. 21 Aug 1865
9
Charles Carrington Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.12]
b. 17 Feb 1871
9
Walter Cole Flournoy
[1.1.11.10.6.5.5.4.13]
7
Mary Flournoy
[1.1.11.10.6.5.6]
7
Marcia Martin Flournoy
[1.1.11.10.6.5.7]
6
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.11.10.6.6]
b. 5 Dec 1721 d. Jul 1793
Thomas Spencer
b. 5 Dec 1721 d. 2 Dec 1793
7
Jr. Thomas Spencer
[1.1.11.10.6.6.1]
b. 1751 d. 1806
Lucy A. Watkins
b. 1759 d. 1847
8
Thomas J. Spencer
[1.1.11.10.6.6.1.1]
b. 1795 d. 1822
Ann Eliza Eastham
b. 1803 d. 1881
9
James T. Spencer
[1.1.11.10.6.6.1.1.1]
b. 1821 d. 1886
Mary Elizabeth Leach
b. 1822 d. 1876
10
Fannie Venable Spencer
[1.1.11.10.6.6.1.1.1.1]
+
A. G. McIlwaine
10
Ann Thomas Spencer
[1.1.11.10.6.6.1.1.1.2]
+
F. H. Armistead
7
John Spencer
[1.1.11.10.6.6.2]
b. 16 Dec 1745 d. 26 May 1826
7
Samuel Flournoy Spencer
[1.1.11.10.6.6.3]
b. 5 Dec 1755 d. 9 Dec 1838
Agnes Woodson Daniel
b. 1754 d. 1799
8
Mary Phena "Polly" Spencer
[1.1.11.10.6.6.3.1]
b. 1796
8
Alexander R Spencer
[1.1.11.10.6.6.3.2]
b. 1816 d. 1908
7
Mary Spencer
[1.1.11.10.6.6.4]
b. 20 Oct 1742 d. 5 Mar 1829
7
Sion Spencer
[1.1.11.10.6.6.5]
b. 12 Apr 1744 d. 4 Dec 1775
7
Elizabeth Julia Spencer
[1.1.11.10.6.6.6]
b. 18 Jun 1747 d. 1832
7
Ann Spencer
[1.1.11.10.6.6.7]
b. 13 Jul 1749 d. 1780
7
Martha Owen Spencer
[1.1.11.10.6.6.8]
b. 7 Sep 1757 d. 5 Jun 1836
7
Gideon Spencer
[1.1.11.10.6.6.9]
b. 21 May 1760 d. 8 May 1822
6
Flournoy
[1.1.11.10.6.7]
b. 25 Nov 1736 d. Jan 1736/37
6
Gédéon Flournoy
[1.1.11.10.6.8]
b. 19 Mar 1722 d. 1754
Jane Frances Sabourin
b. 21 Jul 1730 d. 1797
7
Gédéon Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1]
b. 21 Sep 1753 d. 25 Sep 1821
Jeanne-Françoise Delisle
b. 10 Nov 1755 d. 4 May 1832
8
Gédéon Jean François Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1]
b. 15 Jul 1784 d. 22 Jul 1863
Elizabeth Pernette Covelle
b. 17 Aug 1797 d. 2 Jan 1880
9
Alexandre Antoine Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1]
b. 10 Jan 1818 d. 9 Aug 1890
Caroline Claparède
b. 1831 d. 1875
10
Paul-Eugène-Edmond Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.1]
b. 2 Jan 1863 d. 6 Jul 1936
10
Théodore Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2]
b. 15 Aug 1854 d. 5 Nov 1920
Marie Helene Burnier
b. 15 Aug 1856 d. 22 Aug 1909
11
Berthe-Alice Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.1]
b. 1 Mar 1881 d. 3 Jul 1965
11
Blanche Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.2]
b. 15 Jun 1882 d. 20 Apr 1905
11
Henri Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.3]
b. 28 Mar 1886 d. 6 May 1955
Jeanne Elisabeth Richard
12
Elisabeth-Marie-Julie Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.3.1]
[
=>
]
12
Olivier-Louis-Théodore Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.3.2]
[
=>
]
11
Hélène Olga Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.4]
b. 28 Mar 1891 d. 1 Jan 1972
11
Ariane Dorothée Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.5]
Raymond de Saussure
b. 1884 d. 1970
12
Bertrand de Saussure
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.5.1]
12
Gerard de Saussure
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.5.2]
[
=>
]
11
Marguerite Flournoy
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.6]
b. 31 Oct 1883 d. 10 Jun 1963
Albert Jean Alexandre Mottu
b. 21 Nov 1874 d. 10 Mar 1951
12
Yolande Renée Mottu
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.6.1]
[
=>
]
12
Théodore Auguste Roger Mottu
[1.1.11.10.6.8.1.1.1.2.6.2]
[
=>
]
6
Mary Flournoy
[1.1.11.10.6.9]
b. 23 Feb 1735 d. 8 Sep 1798
William Booker
b. 1720 d. 10 Oct 1783
7
Jane Davis Booker
[1.1.11.10.6.9.1]
b. 1755 d. 1800
Jacob Morton
b. 29 Jan 1751 d. 22 May 1829
8
William Booker Morton
[1.1.11.10.6.9.1.1]
b. 3 Sep 1775 d. 10 Aug 1816
Lucy Faris Flournoy
b. 1786 d. 1836
9
Elvira Henry Morton
[1.1.11.10.6.9.1.1.1]
b. 1806 d. 1840
William Peter Barksdale
b. 1799 d. 1854
10
Louisa Frances Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.1.1]
b. 1830 d. 1907
John Bullock Crews
b. 1814 d. 1882
11
Louise Barksdale Crews
[1.1.11.10.6.9.1.1.1.1.1]
11
Frances Sydnor Crews
[1.1.11.10.6.9.1.1.1.1.2]
11
Rosa Crews
[1.1.11.10.6.9.1.1.1.1.3]
+
Nicholas Hairston
9
Anne Martin Morton
[1.1.11.10.6.9.1.1.2]
b. 1804
William Henry Dennis
b. 1801 d. 1866
10
Jacob Dennis
[1.1.11.10.6.9.1.1.2.1]
9
Mary Elizabeth Morton
[1.1.11.10.6.9.1.1.3]
b. 24 Apr 1808 d. 13 Dec 1889
William Sydnor Barksdale
b. 7 May 1806 d. 10 Sep 1874
10
Lucy Ann Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1]
b. 4 Oct 1828 d. 11 Jan 1906
James Woodford Arendall
b. 20 Jan 1820 d. 17 Mar 1871
11
Lucy Flournoy Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.1]
b. 5 Jun 1862 d. 11 Dec 1888
11
Judith Williams Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.2]
b. 16 Sep 1865 d. 31 Aug 1896
Robert V. Farmer
12
Maude M. Farmer
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.2.1]
b. 10 Mar 1885
11
Elizabeth Frances Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.3]
b. 23 May 1867 d. 12 Jun 1895
W. G. Slayton
12
Hattie S. Slayton
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.3.1]
b. 15 Jan 1885 d. 12 Sep 1886
11
Virginia Alice Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.4]
b. 26 Dec 1869
Charles King Petty
12
Henry T. Petty
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.4.1]
b. 3 Oct 1896
11
William Barksdale Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5]
b. 25 Apr 1849 d. 11 Nov 1911
Phebe Pennich Dixon
d. 11 Jul 1898
12
Agis Lycurgus Lafayette Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5.1]
b. 16 Dec 1871
12
Thomas Frank Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5.2]
b. 30 May 1874
12
Morton Armistead Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5.3]
b. 2 Aug 1877 d. 2 Aug 1879
12
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5.4]
b. 8 Jan 1880
12
Alice M. Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5.5]
b. 10 Jun 1884
12
Lou Boyd Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5.6]
b. 27 Jul 1888 d. 11 Sep 1889
12
Rosa Crews Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.5.7]
b. 18 Mar 1891 d. Jan 1970 [
=>
]
11
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.6]
b. 23 Apr 1851 d. 28 Sep 1853
11
Ann Catherine Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.7]
b. 7 Mar 1853 d. 15 Jul 1882
Alexander D. Thompson
12
Sandy S. Thompson
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.7.1]
b. 5 Jul 1878
12
Adel May Thompson
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.7.2]
b. 30 Apr 1881 d. 18 Mar 1882
12
Maud Iola Thompson
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.7.3]
b. 16 Feb 1879
12
John Armistead Thompson
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.7.4]
b. 9 Oct 1876 d. 20 Jun 1878
12
Charles Woodford Thompson
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.7.5]
b. 10 Oct 1873
12
William M.B. Thompson
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.7.6]
b. 25 Jun 1875
11
John Armstead Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.8]
b. 12 Jan 1855 d. 1 Jul 1935
Alice Madison Cole
b. 3 Feb 1854 d. 29 Jan 1940
12
John William Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.8.1]
b. 19 Nov 1885 d. 31 Mar 1936 [
=>
]
12
James Newton Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.8.2]
b. 11 Jul 1877
12
Luella T. Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.8.3]
b. 6 Oct 1879 d. 10 Sep 1964 [
=>
]
12
Patsy Cole Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.8.4]
b. 6 Oct 1888
12
Kathleen Kent Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.8.5]
b. 23 Apr 1896
12
Allie Lovelace Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.8.6]
b. 24 Jul 1894
11
Thomas Syndor Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.9]
b. 11 May 1857 d. 1940
Virginia Lee Shields
b. Abt 1862
12
Jake Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.9.1]
b. Abt 1885 [
=>
]
11
James Morton Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10]
b. 29 Feb 1860 d. 14 Dec 1938
Jennie Sarah Farmer
b. 29 Sep 1865 d. 12 Apr 1948
12
Sue Brown Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10.1]
12
John Carson Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10.2]
12
Minnie Gunn Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10.3]
12
James Herbert Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10.4]
b. 25 Dec 1883 d. 16 Feb 1961 [
=>
]
12
Molly B. Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10.5]
b. 25 Nov 1888 d. 28 Dec 1972 [
=>
]
12
Emma Carter Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10.6]
[
=>
]
12
Tap McDowell Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10.7]
b. 4 Jul 1896 d. 14 Oct 1962
12
Bettie Arendall
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.1.10.8]
[
=>
]
10
John Thomas Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.2]
b. 9 Mar 1844
10
Mary Susan Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.3]
b. 22 Jun 1846
10
Alice Sydnor Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.4]
b. 31 Oct 1848
10
Flournoy X. Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.5]
b. 23 Jun 1852
10
Judith Williams Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.6]
b. 16 Mar 1831
10
Elizabeth Armistead Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.7]
b. 3 Aug 1833
10
William Morton Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.8]
b. 2 Jan 1837
10
Elvira Frances Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.9]
b. 28 Jul 1839
10
Anthony Sydnor Barksdale
[1.1.11.10.6.9.1.1.3.10]
b. 29 Nov 1841
9
William Booker Morton
[1.1.11.10.6.9.1.1.4]
b. 1811
8
Robert Morton
[1.1.11.10.6.9.1.2]
Marcia M. Flournoy
9
Robert A. Morton
[1.1.11.10.6.9.1.2.1]
Sallie Ann Collins
10
Sallie C. Morton
[1.1.11.10.6.9.1.2.1.1]
+
Frank W. Cunningham
7
William Flournoy Booker
[1.1.11.10.6.9.2]
b. 12 May 1761 d. 21 Nov 1807
+
Elizabeth Moore
b. 15 Oct 1774 d. 1805
7
Rebecca Booker
[1.1.11.10.6.9.3]
b. 7 Apr 1773 d. 21 Apr 1818
+
Jr. Robert Smith
b. 10 Oct 1765 d. 26 Mar 1830
7
Frances Booker
[1.1.11.10.6.9.4]
b. 1771 d. 1793
+
Nathaniel Price
7
Gideon Booker
[1.1.11.10.6.9.5]
b. 1756 d. 28 Jul 1794
7
John D. Booker
[1.1.11.10.6.9.6]
b. 1755 d. 1825
+
Martha Jane Watkins
b. 1771 d. 1852
7
Eliza Julia Booker
[1.1.11.10.6.9.7]
b. 1764 d. 30 May 1828
+
Thomas Embra Green
b. Abt 1760 d. 30 Sep 1827
7
Thomas Booker
[1.1.11.10.6.9.8]
d. 1789
7
Nancy Rochet
[1.1.11.10.6.9.9]
7
Mary Williams Booker
[1.1.11.10.6.9.10]
d. 1789
6
Samuel Flournoy
[1.1.11.10.6.10]
b. 4 Oct 1724 d. 12 Dec 1780
Elizabeth Harris
b. 31 Dec 1729 d. 19 May 1791
7
Silas F. Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1]
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
Martha Cannon
b. 1775 d. Oct 1817
8
Alfred Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
9
William Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.1]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
10
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
10
William Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.1.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
10
Alfred Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.1.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
10
Lucien Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.1.4]
b. 22 Feb 1861
9
Alonzo Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.2]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
10
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.2.1]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
11
Genevieve McRady
[1.1.11.10.6.10.1.1.2.1.1]
10
James Patteson Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.2.2]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
10
Belle Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.2.3]
10
Theodosia Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.2.4]
9
James Silas Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.3]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
9
Eliza Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.4]
b. 29 May 1829 d. INFANT
9
Alfred F. Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.5]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
10
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.5.1]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
10
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.5.2]
b. 21 Feb 1875
10
Mary Patteson Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.5.3]
b. 24 Apr 1866
10
Spencer Alston Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.5.4]
b. Aug 1879
9
Martha Moore Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.6]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
9
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.7]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
10
Alfred F. Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.1]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
10
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.2]
10
Alice Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.3]
+
Charles Davis
10
Ruth Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.4]
+
B. H. Davis
10
Pattie Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.5]
Milton Walker Sims
11
Laura Sims
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.5.1]
b. 1873
+
J. Fred Smith
b. Abt 1870
11
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.5.2]
b. 1872
+
Charles Mills
11
Milton Sims
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.5.3]
b. 1876
11
Bartlett Sims
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.5.4]
b. May 1878
+
Almaide Priscilla Kerr
10
Laura Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.6]
Thomas Bell
11
Mary Bell
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.6.1]
+
Edward Gleason
10
Mary Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.1.7.7]
+
Napoleon Davis
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
9
Charles Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.8]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
9
David Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.9]
b. 1842 d. 1856
9
Maria Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.10]
b. 1837 d. 1841
9
Mary Camp Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
9
Martha Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.12]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
9
Indiana Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.1.13]
b. 1847
8
Eliza Susan Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.2]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
9
Alfred H. Harris
[1.1.11.10.6.10.1.2.1]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
9
Eliza Susan Harris
[1.1.11.10.6.10.1.2.2]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
9
Martha Harris
[1.1.11.10.6.10.1.2.3]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
8
William Cannon Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
9
Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.1]
b. 1833 d. 1833
9
Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.2]
b. 1829 d. 1829
9
Martha Julia Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.3]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
10
Myra Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.3.3.1]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
10
Julian Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.3.3.2]
b. 23 Dec 1868
10
William Cannon Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.3.3.3]
b. 11 Jan 1866
10
Tyree Rodes Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.3.3.4]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
10
John Harper Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.3.3.5]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
10
Flournoy Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.3.3.6]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
11
John Avirett Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.3.3.6.1]
b. 22 Mar 1894
9
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.4]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
10
Ezell Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.4.1]
b. 9 Dec 1878
10
Martha Julia Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.4.2]
b. 13 Sep 1875
10
John Walker Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.4.3]
b. 24 Jan 1874
10
Mary Lou Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.4.4]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
10
III William Cannon Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.4.5]
b. 8 Apr 1872
9
John J. Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.3.5]
b. 1838
8
Mary Amanda Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.4]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
9
Mary Eliza Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.1]
b. 1 Jul 1825
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
10
Myra Flournoy Knapp
[1.1.11.10.6.10.1.4.1.1]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
10
Maud Officer
[1.1.11.10.6.10.1.4.1.2]
b. 9 May 1847
10
Eustis Field Officer
[1.1.11.10.6.10.1.4.1.3]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
10
William P. Officer
[1.1.11.10.6.10.1.4.1.4]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
9
James Alexander Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.2]
b. 30 May 1823
9
Jr. William Hume Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
9
Julian Clarence Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.4]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
9
Silas Flournoy Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
9
Margaret Julia Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.6]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
9
Henrietta Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.7]
b. 1833 d. 1833
9
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.8]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
9
Florence Huntley Field
[1.1.11.10.6.10.1.4.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
8
Julia Ann Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.5]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
9
Hume Rigg Feild
[1.1.11.10.6.10.1.5.1]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
9
Eliza Mildred Feild
[1.1.11.10.6.10.1.5.2]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
10
Julia Batte
[1.1.11.10.6.10.1.5.2.1]
+
W. R. Garrett
10
Mildred Batte
[1.1.11.10.6.10.1.5.2.2]
10
E. F. Batte
[1.1.11.10.6.10.1.5.2.3]
8
Madison Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.6]
b. 1807
8
Martha C. Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.7]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
9
Silas Flournoy Trotter
[1.1.11.10.6.10.1.7.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
8
Silas Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
9
Mary Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.1]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
10
Elizabeth Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.8.1.1]
b. Bef 1865
10
James P. Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.8.1.2]
b. Bef 1863
10
Mary Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.8.1.3]
b. Bef 1867
10
Silas Flournoy Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.8.1.4]
b. Bef 1871
10
William W. Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.8.1.5]
b. Bef 1869
10
Martha Rivers
[1.1.11.10.6.10.1.8.1.6]
b. Bef 1873
9
Camp Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
10
Lucien Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
11
Lillian May Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.1]
b. 1906
11
Mary Wise Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.2]
b. 1911
11
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.3]
11
Laura Louise Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.4]
11
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.1.5]
10
John Wise Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
11
Louise Wise Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.1]
b. 1907
11
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.2]
b. 1912
Minnie Childress Cole
12
Thomas Cole Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.2.1]
11
Camp Rogers Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.3]
11
Betty McAfee Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.2.4]
10
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
11
Eloise Walker
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
+
Raymond Grady Thomas
11
Newton Flournoy Walker
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
+
Rose Mary Bozeman
+
Valta Irene Gholston
11
Lucien John Walker
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972
Janie Lucile Stallcup
b. 1912
12
Lou Anne Walker
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.3.1]
[
=>
]
11
Jane Louise Walker
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.4]
+
Benjamin Elliot Mosher
11
Jacob Camp Walker
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.3.5]
+
Ouida Louise Gill
10
Augusta Mary Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
11
Georgia Louia May
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.1]
b. 1899
11
Julia Flournoy May
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.2]
Robert Henry Mays
12
Judy Mays
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.2.1]
12
Robert Mays
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.2.2]
d. INFANT
11
Elizabeth Wise May
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.3]
b. 1902
11
James Kathryn May
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.4]
b. 1902
11
Norma Lucile May
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.4.5]
b. 1902
10
Julia Rivers Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
11
Lucien Wise Jordan
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.5.1]
11
Andrew Booty Jordan
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.5.2]
Mattie Lou Shaw
12
Jr. Andrew Booty Jordan
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.5.2.1]
[
=>
]
12
Lou Ann Jordan
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.5.2.2]
[
=>
]
12
John Franklin Jordan
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.5.2.3]
[
=>
]
12
Gwen Elizabeth Jordan
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.5.2.4]
10
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
11
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.6.1]
11
Mary Louise Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.6.2]
11
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.2.6.3]
9
Lucien Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.3]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
10
Caroline Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.3.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
9
Elizabeth Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.4]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
10
Duncan
[1.1.11.10.6.10.1.8.4.1]
b. Bef 1870 d. 1876
10
Maude Eustace Duncan
[1.1.11.10.6.10.1.8.4.2]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
9
III Silas Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.5]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
10
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.5.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
10
Silas Camp Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.8.5.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
8
Sarah Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.9]
b. 1816
8
Louisa Ann Flournoy
[1.1.11.10.6.10.1.10]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
9
Laura Ann Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.1]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
10
Leroy M. Black
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.1]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
10
Louisa Catherine Black
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
11
Mary Lou Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.1]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
12
Robert Lester Gilbert
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.1.1]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953 [
=>
]
12
Sadie Louise Gilbert
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.1.2]
[
=>
]
12
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.1.3]
12
Leon Gilbert
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.1.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
11
Ernest M. Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.2]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
11
Leroy Black Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.3]
b. 1864 d. 1934
11
James Carley Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.4]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
12
William Lambeth Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.4.1]
[
=>
]
12
James Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.4.2]
11
Laura Jane Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.5]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
12
Gilbert Buford Dickey
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.5.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown [
=>
]
12
Louise Dickey
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.5.2]
b. Jan 1899 [
=>
]
11
Frank Leon Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.6]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
12
Richard Leon Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.6.1]
[
=>
]
11
Emily Olivia Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.7]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
12
Myra Tatum
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.7.1]
[
=>
]
12
Thomas Leroy Tatum
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.7.2]
11
John A. Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.8]
b. 1873 d. 1874/1963
11
Levair Lester
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.2.9]
b. Abt 1869
10
Laura Ann Black
[1.1.11.10.6.10.1.10.1.3]
9
Flournoy Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.2]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
10
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.1]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
11
Martha Lafavre Bishop
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.1.1]
11
Richard Yancey Bishop
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.1.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
10
Alice Fletcher Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.2]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
11
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.1]
Willie Crook
b. Abt 1901
12
Fergene Dawes Richmond
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.1.1]
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
11
Alice LaFavia Dawes
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.2]
+
Glen Carl Moody
11
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.3]
Mary Ona Kitchens
12
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.3.1]
[
=>
]
12
Frank Leslie Dawes
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.3.2]
11
Thomas Asbury Dawes
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.2.4]
b. 4 Apr 1895
10
Cora Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
10
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.2.4]
b. Jul 1882
9
Thomas Leroy Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.3]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
10
Lucy M. Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
11
Rosa Mai Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.1]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
11
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.2]
b. 1886
11
Thomas Webber Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.3]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
11
George L Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.4]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
11
Wilber Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.5]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
12
Mabel Wilson
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.1.5.1]
10
Webber Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
10
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.11.10.6.10.1.10.3.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
9
Joseph Trotter Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
10
Adella Frances Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.1]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
11
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.1.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
12
Francis Joseph Goodall
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.1.1.1]
12
John Patrick Goodall
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.1.1.2]
[
=>
]
12
Jerome Anthony Goodall
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.1.1.3]
[
=>
]
+
Frank G Curran
10
Mamie J. Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.2]
b. 8 Dec 1875 d. 18 Sep 1968
Maclovio De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
11
Orman Joe De Arnaz
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.2.1]
+
Alma Viola
11
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.2.2]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
10
Robert Lee Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.3]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
10
Anita Josephine Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.4]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
10
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.5]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
10
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
11
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.1]
Eugenia Joyce Barker
12
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.1.1]
[
=>
]
12
Jennifer Alberta Houle
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.1.2]
[
=>
]
12
Winifred Catherine Houle
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.1.3]
[
=>
]
11
Anna Josephine Houle
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.2]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
12
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.2.1]
[
=>
]
11
Dorothy Louise Houle
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.3]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
12
John Dennis Scully
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.3.1]
12
Constance L Scully
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.3.2]
12
Brian C. Scully
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.3.3]
11
Alberta Isabel Houle
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.4]
Jeptha Milton Gibbs, III
12
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.4.1]
[
=>
]
12
Jane Gibbs
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.4.2]
12
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.4.3]
[
=>
]
12
Edward Thurston Gibbs
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.4.4]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
12
William Houle Gibbs
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.6.4.5]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
10
Edna Emma Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
11
Anita Ruth Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.1]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
11
Helen May Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.2]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
11
Howard Joseph Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.3]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
12
Anthony Howard Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.3.1]
12
Stephnie Jeane Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.3.2]
12
Nicholas Joseph Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.3.3]
+
Edna Mae Thompson
11
Edna Dorothy Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.4]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
11
Norman Francis Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.5]
Margaret (Peggy) Louise Clark
12
Michael Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.5.1]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
12
Norma Louise Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.5.2]
[
=>
]
12
Nancy Nell Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.5.3]
[
=>
]
12
Joseph Edward Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.5.4]
[
=>
]
11
Kathryn Alberta Otero
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.6]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
12
Michael Allen McCune
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.6.1]
12
Patricia Lee McCune
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.6.2]
12
Barbara Ruth McCune
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.7.6.3]
[
=>
]
10
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
11
Anita H. Juch
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
12
Edwin Arthur Heacock
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.1.1]
[
=>
]
12
Caroll Jane Heacock
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.1.2]
12
Vivian L. Heacock
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.1.3]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
11
Chester Arthur Juch
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
11
Flournoy Albert Juch
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
11
Stanley St. Clair Juch
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.4]
Eleanor Louise Moore
12
Hollis Eleanor Juch
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.4.1]
[
=>
]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
12
Stanley Robert Juch
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.4.2]
[
=>
]
12
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.4.3]
[
=>
]
11
Louis Dewey Juch
[1.1.11.10.6.10.1.10.4.8.5]
9
Simon Bolivar Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.5]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
9
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.11.10.6.10.1.10.6]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
10
Louisa Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.6.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
11
Rosalie E. McQuade
[1.1.11.10.6.10.1.10.6.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
10
Henry Crowell Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.6.2]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
10
Nellie M Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.6.3]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
10
Edna L. Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.6.4]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
10
William P. Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.6.5]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
10
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.6.6]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
9
Martha Keziah Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.7]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
9
Mary Julia Yancey
[1.1.11.10.6.10.1.10.8]
b. 1834
+
William D. Roberts
7
David Flournoy
[1.1.11.10.6.10.2]
b. 14 Apr 1761 d. 30 Jun 1831
+
Elizabeth Mills Britton
b. 17 Oct 1760 d. 30 Jun 1830
7
Gideon Flournoy
[1.1.11.10.6.10.3]
b. 20 Feb 1751 d. 15 Feb 1821
+
Jane F DeLisle
Grace B. Tarry
b. 1755 d. 20 Dec 1819
8
"Mattie" Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.11.10.6.10.3.1]
b. 1795 d. 10 Oct 1855
Arthur Woodfin
b. 1790 d. 9 Oct 1855
9
William G. Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.1]
b. 1817
9
Richard M. Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.2]
b. 1817
9
Thomas E Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.3]
b. 1818
9
John James Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.4]
b. 19 Mar 1820 d. 23 Sep 1860
9
Charles Newton Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.5]
b. 31 Jul 1824 d. 2 Jul 1912
9
Mary Elizabeth Susan Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.6]
b. 12 Jun 1829 d. 23 Nov 1890
9
Arthur Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.7]
b. 1832
9
Harriet Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.8]
b. 1836
9
Martha Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.1.9]
b. 1838
8
Martha Ann Flournoy
[1.1.11.10.6.10.3.2]
b. Abt 1798 d. 1847
Thomas Woodfin
b. 1795 d. 1853
9
William Thomas Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.2.1]
b. 16 Sep 1822 d. 3 Aug 1894
9
Samuel Flournoy Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.2.2]
b. 4 Aug 1824 d. 14 Feb 1866
9
James Edward Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.2.3]
b. 1826 d. 1889
9
Jane Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.2.4]
b. 1828 d. 1892
9
Frances Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.2.5]
b. 1830
9
George Washington Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.2.6]
b. 15 Mar 1832 d. 3 Aug 1895
9
Martha Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.2.7]
b. 1834
9
Rebecca Woodfin
[1.1.11.10.6.10.3.2.8]
b. 18 Dec 1836 d. 16 Aug 1860
7
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.11.10.6.10.4]
b. 25 Nov 1765
+
Isham Britton
b. Bef 1761
7
Julia Briton Flournoy
[1.1.11.10.6.10.5]
b. Abt 1770
7
John Flournoy
[1.1.11.10.6.10.6]
b. 29 Apr 1754
7
Thomas Flournoy
[1.1.11.10.6.10.7]
b. Bef 1767
7
Ursula Harris Flournoy
[1.1.11.10.6.10.8]
b. 15 May 1749
James Bailey Harris
b. 1749
8
III James Harris
[1.1.11.10.6.10.8.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
9
Alfred Turpin Harris
[1.1.11.10.6.10.8.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
10
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.11.10.6.10.8.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
8
Samuel Harris
[1.1.11.10.6.10.8.2]
b. Abt 1774
8
Elizabeth Harris
[1.1.11.10.6.10.8.3]
b. Abt 1776
8
Mary Harris
[1.1.11.10.6.10.8.4]
b. Abt 1778
7
Hannah Flournoy
[1.1.11.10.6.10.9]
b. Abt 1762
7
Jordan Flournoy
[1.1.11.10.6.10.10]
b. 20 Sep 1763 d. 21 Jun 1833
+
Judith Farrar
b. 21 Apr 1756 d. 1828
7
Samuel Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11]
b. 9 Dec 1758 d. 19 Aug 1818
Nancy Ann Martin
b. 1765
8
Samuel Martin Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.1]
b. 1799 d. 1878
+
Minerva Ann Wadlington
b. 1814 d. 1858
+
Harriett Elvira Fenley
b. 24 Jan 1820
8
Agnes Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.2]
b. 1799
8
Martha Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.3]
b. 15 Aug 1813 d. 1891
Randolph Allen Hankla
b. 1 Feb 1803
9
Minerva Nancy Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.1]
b. 29 Mar 1837 d. 1 Apr 1898
9
Pendleton Flournoy Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.2]
b. 24 Mar 1831
9
James Marion F. Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.3]
b. 8 Feb 1833
9
John Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.4]
b. 21 Feb 1835
9
Mary Francis Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.5]
b. 29 Dec 1839
9
Martha Matilda Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.6]
b. 17 Jul 1844
9
Joseph Randolph Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.7]
b. 5 Nov 1847
9
William Harrison Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.8]
b. 17 Feb 1849
9
Ella Eugenia Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.9]
b. 24 Jul 1853
9
Eliza Hankla
[1.1.11.10.6.10.11.3.10]
b. 2 Dec 1841 d. 7 Aug 1919
8
Matthews Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.4]
b. 1789 d. 1833
8
James Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.5]
b. 1 Jan 1791 d. 3 Mar 1855
+
Martha Halloway
b. 1790 d. 1871
8
Jack Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.6]
b. 1799 d. 1818
8
Nancy Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.7]
b. 1795
8
Rachel Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.8]
b. 1797
8
Amelia Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.9]
b. 1786
8
Emily Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.10]
b. 1801
8
Patsy Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.11]
b. 1793
8
Cassandra Flournoy
[1.1.11.10.6.10.11.12]
b. 1803
7
Martha Flournoy
[1.1.11.10.6.10.12]
b. Feb 1768
7
Mary Flournoy
[1.1.11.10.6.10.13]
b. Bef 1756
5
Jacques Flournoy
[1.1.11.10.7]
b. 2 Feb 1702/03 d. Aft 2 Feb 1702/03
5
Julie Flournoy
[1.1.11.10.8]
b. 9 Jul 1690 d. 14 Feb 1690/91
5
Julie Flournoy
[1.1.11.10.9]
b. 7 Oct 1692 d. 14 Oct 1692
5
Marie Flournoy
[1.1.11.10.10]
b. 1 May 1689 d. 16 Aug 1689
Elisabeth Boussens
b. 1620 d. 24 Jun 1644
4
Elisabeth Flournoy
[1.1.11.11]
b. 7 Mar 1642/43 d. 13 Jul 1714
+
Antoine Marcet
4
Jean Flournoy
[1.1.11.12]
b. 21 Dec 1640 d. 25 Mar 1642
4
Michel Flournoy
[1.1.11.13]
b. 8 Dec 1638 d. 29 Jan 1638/39
3
Jean Flournoy
[1.1.12]
b. 19 Mar 1597/98 d. 16 Aug 1599