News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Register for a User Account
Home
Search
Login
Find
Surnames
What's New
Most Wanted
Reports
Cemeteries
Media
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
•
First Name:
Last Name:
ID:
Mary Branch
1660 - 1697 (37 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Mary Branch
[1]
b. 1660 d. 1697
Thomas Jefferson
b. Abt 1653 d. Bef 7 Dec 1697
2
Mary Jefferson
[1.1]
b. 1679 d. 1 Sep 1745
Thomas Harris
b. 1669 d. Bef 6 Jul 1730
3
Phoebe Harris
[1.1.1]
b. Abt 1689 d. Between 1697 and 1800
3
Jr. Thomas Harris, Jr
[1.1.2]
b. Abt 1690 d. Bef 1 Aug 1741
3
Timothy Harris
[1.1.3]
b. 1691 d. Jun 1743
3
Francis Harris
[1.1.4]
b. Abt 1692 d. Jul 1743
3
Sarah Harris
[1.1.5]
b. Abt 1696 d. Bef 24 Sep 1753
3
William Samuel Harris
[1.1.6]
b. Abt 1696 d. Bef 18 Dec 1794
+
Elizabeth Ward
b. Abt 1696
Martha Osborne
b. Abt 1700
4
Mary Harris
[1.1.6.1]
b. Abt 1720
+
Bernard Markham
b. Abt 1720
4
Elizabeth Harris
[1.1.6.2]
b. Abt 1750
+
Vincent Markham
b. Abt 1750
Martha Ward
b. Abt 1700
4
Thomas Harris
[1.1.6.3]
b. Abt 1756
+
Carolina Matilda Harris
b. 1 Dec 1756 d. 1815
3
Mary Harris
[1.1.7]
b. Abt 1698 d. 17 Dec 1759
+
Francis James
b. Abt 1694
John Goode
b. Abt 1698
4
Bennett Goode
[1.1.7.1]
b. Abt 1710 d. 1771
Martha Jefferson
b. Abt 1712 d. 20 Oct 1796
5
Martha Goode
[1.1.7.1.1]
b. 1760 d. 1810
Charles Povall
b. 1763 d. 1803
6
Martha Povall
[1.1.7.1.1.1]
b. 1 Nov 1784
William Carrington
b. 20 Aug 1774 d. 21 May 1825
7
Martha Ann Carrington
[1.1.7.1.1.1.1]
b. 26 Feb 1806 d. 29 Apr 1865
Codrington Carrington
b. 23 Oct 1801 d. 10 Sep 1859
8
Willie Ann Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.1]
b. 13 Jun 1833
8
Ellen Maria Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.2]
b. 22 Mar 1836 d. 14 Jul 1873
+
Fox
8
Martha Virginia Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.3]
b. 2 Apr 1839
+
E. C. Mayo
8
Robert Codrington Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4]
b. 6 Sep 1842
Hellen C. Walton
b. Cal 1846
9
Martha Elvira Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.1]
b. 10 Sep 1867
9
Nathaniel W. Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.2]
b. Jul 1868
+
Myrtle H.
Anna V. Woodson
b. Oct 1868 d. Bef 1910
10
Robert Miller Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.2.1]
10
Lilly Marie Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.2.2]
+
Walton
10
William Blair Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.2.3]
+
Bessie Patterson
b. 18 Jun 1903 d. Sep 1974
10
Alvin Roy Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.2.4]
b. 3 Nov 1900 d. Feb 1970
+
Carrie S.
10
James N. Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.2.5]
9
Collin Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.3]
b. Cal 1870
9
Minnie M. Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.4]
b. Cal 1872
9
Lillian Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.5]
b. Cal 1874
9
Bernard Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.6]
b. Feb 1879
9
Rose Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.4.7]
b. Abt 1880
8
William A. Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.5]
b. 22 Sep 1843 d. 25 Sep 1843
8
Cornelia Booker Carrington
[1.1.7.1.1.1.1.6]
b. 1 Feb 1845
+
T. B. S. Walton
7
Ellen Theodosia Carrington
[1.1.7.1.1.1.2]
b. 1813 d. 1896
William Royal Bradley
b. 1804 d. 1889
8
Martha Carrington Bradley
[1.1.7.1.1.1.2.1]
b. 1826/1847 d. 1862/1933
Thomas Pride Shields
b. 1808/1837 d. 1862/1922
9
Martha Tomasia Shields
[1.1.7.1.1.1.2.1.1]
b. 21 Aug 1859 d. 15 Aug 1944
Joseph Cosgray Sweeney
b. 23 Dec 1859 d. 2 Apr 1945
10
James Chamberlain Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1]
Helen Armstrong
b. 5 Aug 1897 d. 6 Aug 1970
11
Ruth Beverly Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.1]
William Reese Swift
12
Jr. William Reese Swift
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.1.1]
[
=>
]
12
Susan Gaye Swift
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.1.2]
[
=>
]
12
Kimberly Swift
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.1.3]
11
John Armstrong Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.2]
Inez Elane Potter
12
Brian Wade Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.2.1]
[
=>
]
12
James C. Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.2.2]
11
James Carrington Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.3]
Elizabeth Boehmer
12
Shawn Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.3.1]
[
=>
]
12
Shannon Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.3.2]
[
=>
]
12
Kate Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.3.3]
12
Sam Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.3.4]
[
=>
]
11
Helen Jean Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.4]
b. 30 Jul 1921 d. 1928
11
Robert Stewart Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.5]
b. 4 Nov 1925 d. 30 Sep 1964
Beverly Jean Willis
12
Kathaleen Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.5.1]
12
Michael Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.5.2]
[
=>
]
12
Carolyn Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.5.3]
12
Jr. Robert Stewart Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.1.5.4]
[
=>
]
10
Thomas Shields Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2]
b. 19 Dec 1894 d. 27 Apr 1974
Hildred Ashbaugh
11
Dorathea Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2.1]
Eugene C. Werst
12
Linda Bassler Werst
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2.1.1]
[
=>
]
12
Karen Madsen Werst
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2.1.2]
[
=>
]
12
Robert Werst
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2.1.3]
11
Jr. Thomas Shields Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2.2]
Dorthy Schiderer
12
Larry Shields Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2.2.1]
[
=>
]
12
Patricia Marie Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2.2.2]
12
Barbara Jeanne Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.2.2.3]
[
=>
]
10
Richmond Carrington Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.3]
b. 18 Sep 1896 d. 12 Aug 1966
10
Ruth Virginia Sweeney
[1.1.7.1.1.1.2.1.1.4]
3
Edith Harris
[1.1.8]
b. Abt 1700 d. Abt 1745
+
Henry Trent
b. 1676 d. 5 Sep 1726
+
John Osborne
b. Abt 1684
+
Peter Fitzpatrick
b. Abt 1684
3
James Harris
[1.1.9]
b. Abt 1702 d. Bef 27 Jul 1767
Sarah Bailey
b. Abt 1704
4
John Bailey Harris
[1.1.9.1]
b. Abt 1732
4
Phoebe Bailey Harris
[1.1.9.2]
b. Abt 1734
M.B.C.R. Joseph Royal Farrar
b. Abt 1734 d. 1796
5
Mary Farrar
[1.1.9.2.1]
b. Abt 1766
+
William Wager Harris
b. Abt 1766
4
Mary Harris
[1.1.9.3]
b. Abt 1736
4
Thomas Bailey Harris
[1.1.9.4]
b. Abt 1738 d. Bef 22 Nov 1810
+
Frances Moseley
b. Abt 1732
4
James Bailey Harris
[1.1.9.5]
b. 1749
Ursula Harris Flournoy
b. 15 May 1749
5
III James Harris
[1.1.9.5.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
6
Alfred Turpin Harris
[1.1.9.5.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
7
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.9.5.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
5
Samuel Harris
[1.1.9.5.2]
b. Abt 1774
5
Elizabeth Harris
[1.1.9.5.3]
b. Abt 1776
5
Mary Harris
[1.1.9.5.4]
b. Abt 1778
4
William Bailey Harris
[1.1.9.6]
b. 1757 d. Abt 1816
+
Mary Pollard
b. Abt 1760 d. Abt 1830
4
Francis Bailey Harris
[1.1.9.7]
b. Abt 1758
+
Ann Diugud
b. Abt 1760
3
John Harris
[1.1.10]
b. 28 Mar 1703 d. Aft 28 Mar 1749
Ursula Goode
b. 1707 d. Abt 1734
4
William Harris
[1.1.10.1]
b. Abt 1728
+
Osborne
b. Abt 1727
+
Elizabeth Evans
b. Abt 1745
4
Elizabeth Harris
[1.1.10.2]
b. 31 Dec 1729 d. 19 May 1791
Samuel Flournoy
b. 4 Oct 1724 d. 12 Dec 1780
5
Ursula Harris Flournoy
[1.1.10.2.1]
b. 15 May 1749
James Bailey Harris
b. 1749
6
III James Harris
[1.1.10.2.1.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
7
Alfred Turpin Harris
[1.1.10.2.1.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
8
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.10.2.1.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
6
Samuel Harris
[1.1.10.2.1.2]
b. Abt 1774
6
Elizabeth Harris
[1.1.10.2.1.3]
b. Abt 1776
6
Mary Harris
[1.1.10.2.1.4]
b. Abt 1778
5
Gideon Flournoy
[1.1.10.2.2]
b. 20 Feb 1751 d. 15 Feb 1821
+
Jane F DeLisle
Grace B. Tarry
b. 1755 d. 20 Dec 1819
6
"Mattie" Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.10.2.2.1]
b. 1795 d. 10 Oct 1855
Arthur Woodfin
b. 1790 d. 9 Oct 1855
7
William G. Woodfin
[1.1.10.2.2.1.1]
b. 1817
7
Richard M. Woodfin
[1.1.10.2.2.1.2]
b. 1817
7
Thomas E Woodfin
[1.1.10.2.2.1.3]
b. 1818
7
John James Woodfin
[1.1.10.2.2.1.4]
b. 19 Mar 1820 d. 23 Sep 1860
7
Charles Newton Woodfin
[1.1.10.2.2.1.5]
b. 31 Jul 1824 d. 2 Jul 1912
7
Mary Elizabeth Susan Woodfin
[1.1.10.2.2.1.6]
b. 12 Jun 1829 d. 23 Nov 1890
7
Arthur Woodfin
[1.1.10.2.2.1.7]
b. 1832
7
Harriet Woodfin
[1.1.10.2.2.1.8]
b. 1836
7
Martha Woodfin
[1.1.10.2.2.1.9]
b. 1838
6
Martha Ann Flournoy
[1.1.10.2.2.2]
b. Abt 1798 d. 1847
Thomas Woodfin
b. 1795 d. 1853
7
William Thomas Woodfin
[1.1.10.2.2.2.1]
b. 16 Sep 1822 d. 3 Aug 1894
7
Samuel Flournoy Woodfin
[1.1.10.2.2.2.2]
b. 4 Aug 1824 d. 14 Feb 1866
7
James Edward Woodfin
[1.1.10.2.2.2.3]
b. 1826 d. 1889
7
Jane Woodfin
[1.1.10.2.2.2.4]
b. 1828 d. 1892
7
Frances Woodfin
[1.1.10.2.2.2.5]
b. 1830
7
George Washington Woodfin
[1.1.10.2.2.2.6]
b. 15 Mar 1832 d. 3 Aug 1895
7
Martha Woodfin
[1.1.10.2.2.2.7]
b. 1834
7
Rebecca Woodfin
[1.1.10.2.2.2.8]
b. 18 Dec 1836 d. 16 Aug 1860
5
John Flournoy
[1.1.10.2.3]
b. 29 Apr 1754
5
Mary Flournoy
[1.1.10.2.4]
b. Bef 1756
5
Samuel Flournoy
[1.1.10.2.5]
b. 9 Dec 1758 d. 19 Aug 1818
Nancy Ann Martin
b. 1765
6
Amelia Flournoy
[1.1.10.2.5.1]
b. 1786
6
Matthews Flournoy
[1.1.10.2.5.2]
b. 1789 d. 1833
6
James Flournoy
[1.1.10.2.5.3]
b. 1 Jan 1791 d. 3 Mar 1855
+
Martha Halloway
b. 1790 d. 1871
6
Patsy Flournoy
[1.1.10.2.5.4]
b. 1793
6
Nancy Flournoy
[1.1.10.2.5.5]
b. 1795
6
Rachel Flournoy
[1.1.10.2.5.6]
b. 1797
6
Samuel Martin Flournoy
[1.1.10.2.5.7]
b. 1799 d. 1878
+
Minerva Ann Wadlington
b. 1814 d. 1858
+
Harriett Elvira Fenley
b. 24 Jan 1820
6
Agnes Flournoy
[1.1.10.2.5.8]
b. 1799
6
Jack Flournoy
[1.1.10.2.5.9]
b. 1799 d. 1818
6
Emily Flournoy
[1.1.10.2.5.10]
b. 1801
6
Cassandra Flournoy
[1.1.10.2.5.11]
b. 1803
6
Martha Flournoy
[1.1.10.2.5.12]
b. 15 Aug 1813 d. 1891
Randolph Allen Hankla
b. 1 Feb 1803
7
Pendleton Flournoy Hankla
[1.1.10.2.5.12.1]
b. 24 Mar 1831
7
James Marion F. Hankla
[1.1.10.2.5.12.2]
b. 8 Feb 1833
7
John Hankla
[1.1.10.2.5.12.3]
b. 21 Feb 1835
7
Minerva Nancy Hankla
[1.1.10.2.5.12.4]
b. 29 Mar 1837 d. 1 Apr 1898
7
Mary Francis Hankla
[1.1.10.2.5.12.5]
b. 29 Dec 1839
7
Eliza Hankla
[1.1.10.2.5.12.6]
b. 2 Dec 1841 d. 7 Aug 1919
7
Martha Matilda Hankla
[1.1.10.2.5.12.7]
b. 17 Jul 1844
7
Joseph Randolph Hankla
[1.1.10.2.5.12.8]
b. 5 Nov 1847
7
William Harrison Hankla
[1.1.10.2.5.12.9]
b. 17 Feb 1849
7
Ella Eugenia Hankla
[1.1.10.2.5.12.10]
b. 24 Jul 1853
5
David Flournoy
[1.1.10.2.6]
b. 14 Apr 1761 d. 30 Jun 1831
+
Elizabeth Mills Britton
b. 17 Oct 1760 d. 30 Jun 1830
5
Hannah Flournoy
[1.1.10.2.7]
b. Abt 1762
5
Jordan Flournoy
[1.1.10.2.8]
b. 20 Sep 1763 d. 21 Jun 1833
+
Judith Farrar
b. 21 Apr 1756 d. 1828
5
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.10.2.9]
b. 25 Nov 1765
+
Isham Britton
b. Bef 1761
5
Thomas Flournoy
[1.1.10.2.10]
b. Bef 1767
5
Martha Flournoy
[1.1.10.2.11]
b. Feb 1768
5
Julia Briton Flournoy
[1.1.10.2.12]
b. Abt 1770
5
Silas F. Flournoy
[1.1.10.2.13]
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
Martha Cannon
b. 1775 d. Oct 1817
6
Eliza Susan Flournoy
[1.1.10.2.13.1]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
7
Martha Harris
[1.1.10.2.13.1.1]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
7
Alfred H. Harris
[1.1.10.2.13.1.2]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
7
Eliza Susan Harris
[1.1.10.2.13.1.3]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
6
Alfred Flournoy
[1.1.10.2.13.2]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
7
Alonzo Flournoy
[1.1.10.2.13.2.1]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
8
Belle Flournoy
[1.1.10.2.13.2.1.1]
8
Theodosia Flournoy
[1.1.10.2.13.2.1.2]
8
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.10.2.13.2.1.3]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
9
Genevieve McRady
[1.1.10.2.13.2.1.3.1]
8
James Patteson Flournoy
[1.1.10.2.13.2.1.4]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
7
William Flournoy
[1.1.10.2.13.2.2]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
8
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.10.2.13.2.2.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
8
William Flournoy
[1.1.10.2.13.2.2.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
8
Alfred Flournoy
[1.1.10.2.13.2.2.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
8
Lucien Flournoy
[1.1.10.2.13.2.2.4]
b. 22 Feb 1861
7
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.10.2.13.2.3]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
8
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.10.2.13.2.3.1]
8
Alice Wilson
[1.1.10.2.13.2.3.2]
+
Charles Davis
8
Ruth Wilson
[1.1.10.2.13.2.3.3]
+
B. H. Davis
8
Pattie Wilson
[1.1.10.2.13.2.3.4]
Milton Walker Sims
9
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.10.2.13.2.3.4.1]
b. 1872
+
Charles Mills
9
Laura Sims
[1.1.10.2.13.2.3.4.2]
b. 1873
+
J. Fred Smith
b. Abt 1870
9
Milton Sims
[1.1.10.2.13.2.3.4.3]
b. 1876
9
Bartlett Sims
[1.1.10.2.13.2.3.4.4]
b. May 1878
+
Almaide Priscilla Kerr
8
Laura Wilson
[1.1.10.2.13.2.3.5]
Thomas Bell
9
Mary Bell
[1.1.10.2.13.2.3.5.1]
+
Edward Gleason
8
Mary Wilson
[1.1.10.2.13.2.3.6]
+
Napoleon Davis
8
Alfred F. Wilson
[1.1.10.2.13.2.3.7]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
7
Martha Moore Flournoy
[1.1.10.2.13.2.4]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
7
Eliza Flournoy
[1.1.10.2.13.2.5]
b. 29 May 1829 d. INFANT
7
James Silas Flournoy
[1.1.10.2.13.2.6]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
7
Alfred F. Flournoy
[1.1.10.2.13.2.7]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
8
Mary Patteson Flournoy
[1.1.10.2.13.2.7.1]
b. 24 Apr 1866
8
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.10.2.13.2.7.2]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
8
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.10.2.13.2.7.3]
b. 21 Feb 1875
8
Spencer Alston Flournoy
[1.1.10.2.13.2.7.4]
b. Aug 1879
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
7
Maria Flournoy
[1.1.10.2.13.2.8]
b. 1837 d. 1841
7
David Flournoy
[1.1.10.2.13.2.9]
b. 1842 d. 1856
7
Charles Flournoy
[1.1.10.2.13.2.10]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
7
Mary Camp Flournoy
[1.1.10.2.13.2.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
7
Indiana Flournoy
[1.1.10.2.13.2.12]
b. 1847
7
Martha Flournoy
[1.1.10.2.13.2.13]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
6
William Cannon Flournoy
[1.1.10.2.13.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
7
Flournoy
[1.1.10.2.13.3.1]
b. 1829 d. 1829
7
Flournoy
[1.1.10.2.13.3.2]
b. 1833 d. 1833
7
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.10.2.13.3.3]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
8
Mary Lou Flournoy
[1.1.10.2.13.3.3.1]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
8
III William Cannon Flournoy
[1.1.10.2.13.3.3.2]
b. 8 Apr 1872
8
John Walker Flournoy
[1.1.10.2.13.3.3.3]
b. 24 Jan 1874
8
Martha Julia Flournoy
[1.1.10.2.13.3.3.4]
b. 13 Sep 1875
8
Ezell Flournoy
[1.1.10.2.13.3.3.5]
b. 9 Dec 1878
7
John J. Flournoy
[1.1.10.2.13.3.4]
b. 1838
7
Martha Julia Flournoy
[1.1.10.2.13.3.5]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
8
Flournoy Rivers
[1.1.10.2.13.3.5.1]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
9
John Avirett Rivers
[1.1.10.2.13.3.5.1.1]
b. 22 Mar 1894
8
John Harper Rivers
[1.1.10.2.13.3.5.2]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
8
Tyree Rodes Rivers
[1.1.10.2.13.3.5.3]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
8
William Cannon Rivers
[1.1.10.2.13.3.5.4]
b. 11 Jan 1866
8
Julian Rivers
[1.1.10.2.13.3.5.5]
b. 23 Dec 1868
8
Myra Rivers
[1.1.10.2.13.3.5.6]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
6
Martha C. Flournoy
[1.1.10.2.13.4]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
7
Silas Flournoy Trotter
[1.1.10.2.13.4.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
6
Louisa Ann Flournoy
[1.1.10.2.13.5]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
7
Joseph Trotter Yancey
[1.1.10.2.13.5.1]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
8
Robert Lee Yancey
[1.1.10.2.13.5.1.1]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
8
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.10.2.13.5.1.2]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
9
Anita H. Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
10
Vivian L. Heacock
[1.1.10.2.13.5.1.2.1.1]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
10
Caroll Jane Heacock
[1.1.10.2.13.5.1.2.1.2]
10
Edwin Arthur Heacock
[1.1.10.2.13.5.1.2.1.3]
Dorothy Louise Holborn
11
Julie Heacock
[1.1.10.2.13.5.1.2.1.3.1]
+
Fredrick L White
9
Chester Arthur Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
9
Flournoy Albert Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
9
Stanley St. Clair Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.4]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
10
Stanley Robert Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.1]
Evelyn Elizabeth "Betty" Perkins
11
Robert Erwin William Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.1.1]
+
Barbara Anne Rich
+
Linda Corrine Montgomery
11
Elizabeth Ann Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.1.2]
+
Chesley D. Quaide
10
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.2]
Hugh Washburn Steven
11
Julia Warren Steven
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.2.1]
Donald Laurence Blumenthal
12
David Steven Blumenthal
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.2.1.1]
[
=>
]
11
David Hugh Steven
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.2.2]
Amiee Suzanne Wightman
12
Christopher Wightman "Kit" Steven
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.2.2.1]
12
Brooke Heidi Steven
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.2.2.2]
Eleanor M Juch
10
Hollis Eleanor Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.3]
Wesley Richard Peterson
11
Jordan S. Peterson
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.3.1]
11
Logan Sven Peterson
[1.1.10.2.13.5.1.2.4.3.2]
+
Lawrence Glen Terry
9
Louis Dewey Juch
[1.1.10.2.13.5.1.2.5]
8
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.10.2.13.5.1.3]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
8
Adella Frances Yancey
[1.1.10.2.13.5.1.4]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
9
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.10.2.13.5.1.4.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
10
Jerome Anthony Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.1]
Doris Holyfield
11
Patricia Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.1.1]
11
Michael Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.1.2]
Ann Capello
11
Mary Ann Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.1.3]
b. 25 Jun 1943 d. 25 Jun 1943
11
Jerome Anthony Goodall, Jr.
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.1.4]
+
Catherine Elizabeth Horvay
11
Katherine Elizabeth Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.1.5]
11
Anita C Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.1.6]
+
Reta Adeline Thibedeau
10
John Patrick Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.2]
Paulina D. Lacasella
11
Blake Michael Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.2.1]
+
Sarah M Meade
11
Jonathan Randall Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.2.2]
11
Leigh Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.2.3]
b. 3 Nov 1945 d. 15 Apr 1962
11
Pamela Ann Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.2.4]
+
Gary Eugene Peters
+
Dickey Leete Sims
11
Gregory Patrick Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.2.5]
11
Ursula Louise Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.2.6]
+
Mark Douglas Thacker
10
Francis Joseph Goodall
[1.1.10.2.13.5.1.4.1.3]
+
Frank G Curran
8
Mary Anna "Mayme" Yancey
[1.1.10.2.13.5.1.5]
b. 8 Dec 1874 d. 18 Sep 1968
Maclovio Danislao De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
9
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.10.2.13.5.1.5.1]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
9
Orman Joe De Arnaz
[1.1.10.2.13.5.1.5.2]
+
Alma Viola
8
Anita Josephine Yancey
[1.1.10.2.13.5.1.6]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
8
Edna Emma Yancey
[1.1.10.2.13.5.1.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
9
Helen May Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.1]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
9
Edna Dorothy Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.2]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
9
Anita Ruth Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.3]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
9
Norman Francis Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.4]
Margaret (Peggy) Louise Clark
10
Nancy Nell Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1]
William Richard Mann
11
Gary Allen Francis Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.1]
Cynthia Kay Semmler
12
Christopher Lee Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.1.1]
12
Cheryl Marie Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.1.2]
11
Richard Lee Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.2]
11
Leslie Melinda Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.3]
Patterson
12
Jenna Nichole Patterson
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.3.1]
11
Steven Joseph Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.4]
Annette Elizabeth Risso
12
Steven William Farrell Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.4.1]
12
Richard Christopher Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.4.2]
12
Michelle Elizabeth Mann
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.1.4.3]
10
Joseph Edward Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.2]
Mary Helen Norman
11
Marilyn Marie Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.2.1]
Theodore Louis Beteta
12
Bryan Douglas Beteta
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.2.1.1]
12
Kevin Thomas Beteta
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.2.1.2]
11
Michael Norman Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.2.2]
10
Norma Louise Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.3]
Richard Eugene Polen
11
Lisa Ann Polen
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.3.1]
+
Jr. Joseph Warren Wilson, Jr
11
Michael Eugene Polen
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.3.2]
+
Marguerete Paige Thrasher
11
Holly Louise Polen
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.3.3]
+
Mark Thomas Setterberg
11
Amy Elizabeth Polen
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.3.4]
+
David Lance Parrish
10
Michael Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.4.4]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
9
Kathryn Alberta Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.5]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
10
Patricia Lee McCune
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.1]
10
Barbara Ruth McCune
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2]
Jewell Ray "Bud" DeShon
11
Linda Lee De Shon
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2.1]
Gary Jacobs
12
Lacy Nicole Jacobs
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2.1.1]
+
Steven Peter Ricketts
Lonnie Jay Simmons
12
Justin Jay Simmons
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2.1.2]
[
=>
]
11
Lori Rae De Shon
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2.2]
Eric Miguel Jewett
12
Nicholas Jewett
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2.2.1]
11
Larry Dean De Shon
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2.3]
Lydia Gail Tooker
12
Tyler Alexander De Shon
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2.3.1]
12
Jordan Taylor De Shon
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.2.3.2]
10
Michael Allen McCune
[1.1.10.2.13.5.1.7.5.3]
9
Howard Joseph Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.6]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
10
Anthony Howard Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.6.1]
10
Stephnie Jeane Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.6.2]
+
Joseph Michael Flynn
10
Nicholas Joseph Otero
[1.1.10.2.13.5.1.7.6.3]
+
Johnna M Verardo
+
Edna Mae Thompson
8
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.10.2.13.5.1.8]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
9
Alberta Isabel Houle
[1.1.10.2.13.5.1.8.1]
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
Jeptha Milton Gibbs, III
b. 17 Jan 1901 d. 9 Nov 1973
10
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.1]
Mary Melissa Meyers
11
Jeptha Milton Gibbs, V
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.1.1]
Cathy Helene Cline
12
Mary Taylor Christina Gibbs
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.1.1.1]
11
Mary Melissa Gibbs
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.1.2]
10
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.2]
Jerry Hamilton Guild
11
Nancy J. Guild
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.2.1]
11
Christopher Parsons Guild
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.2.2]
11
Matthew Hamilton Guild
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.2.3]
+
Ivy
11
Peter Christopher Guild
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.2.4]
11
Bonnie C. Guild
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.2.5]
10
Edward Thurston Gibbs
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.3]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
10
William Houle Gibbs
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.4]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
10
Jane Gibbs
[1.1.10.2.13.5.1.8.1.5]
+
Richard Calvin Torrey
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
b. 24 Feb 1900 d. Feb 1973
9
Dorothy Louise Houle
[1.1.10.2.13.5.1.8.2]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
10
Constance L Scully
[1.1.10.2.13.5.1.8.2.1]
+
Newton
10
John Dennis Scully
[1.1.10.2.13.5.1.8.2.2]
10
Brian C. Scully
[1.1.10.2.13.5.1.8.2.3]
9
Anna Josephine Houle
[1.1.10.2.13.5.1.8.3]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
10
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.10.2.13.5.1.8.3.1]
Cathy Ann Glessner
11
Kimberly Darcy Currier
[1.1.10.2.13.5.1.8.3.1.1]
+
Andrew Goldsmith
Darren McAdams
12
Dylan McAdams
[1.1.10.2.13.5.1.8.3.1.1.1]
12
Colin Guy McAdams
[1.1.10.2.13.5.1.8.3.1.1.2]
11
Darcy Catherine Currier
[1.1.10.2.13.5.1.8.3.1.2]
William C. Hunter
12
Hannah Hunter
[1.1.10.2.13.5.1.8.3.1.2.1]
12
Jessica Hunter
[1.1.10.2.13.5.1.8.3.1.2.2]
9
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.10.2.13.5.1.8.4]
Eugenia Joyce Barker
10
Winifred Catherine Houle
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.1]
Robert Eugene Cherry
11
Robert Lewis Scott Cherry
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.1.1]
Erin Stobee
12
Finnean Leopold Cherry
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.1.1.1]
12
Greta Cherry
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.1.1.2]
10
Jennifer Alberta Houle
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.2]
Richard C. Sandoval
11
Emilia Alberta Sandoval
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.2.1]
+
Steven Byrne
11
Terresita Maria Sandoval
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.2.2]
Russell Nordstedt
12
Riley Nordstedt
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.2.2.1]
10
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.3]
Wendell Wade Hennigh
11
Joshua Houle Hennigh
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.3.1]
11
Lukas Wade "Luke" Hennigh
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.3.2]
Nicole Amanda Valenzuela
12
Noah Nash Hennigh
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.3.2.1]
12
Maksim Wade Hennigh
[1.1.10.2.13.5.1.8.4.3.2.2]
7
Simon Bolivar Yancey
[1.1.10.2.13.5.2]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
7
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.10.2.13.5.3]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
8
Louisa Yancey
[1.1.10.2.13.5.3.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
9
Rosalie E. McQuade
[1.1.10.2.13.5.3.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
8
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.10.2.13.5.3.2]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
8
Edna L. Yancey
[1.1.10.2.13.5.3.3]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
8
Henry Crowell Yancey
[1.1.10.2.13.5.3.4]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
8
Nellie M Yancey
[1.1.10.2.13.5.3.5]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
8
William P. Yancey
[1.1.10.2.13.5.3.6]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
7
Laura Ann Yancey
[1.1.10.2.13.5.4]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
8
Laura Ann Black
[1.1.10.2.13.5.4.1]
8
Louisa Catherine Black
[1.1.10.2.13.5.4.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
9
Leroy Black Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.1]
b. 1864 d. 1934
9
Mary Lou Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.2]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
10
Sadie Louise Gilbert
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.1]
Harold Leigh Aymett
b. 11 Feb 1884 d. 6 Jul 1948
11
Marilouise Aymett
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.1.1]
John Bateman McClure
12
Jr. John Bateman McClure
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.1.1.1]
10
Robert Lester Gilbert
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.2]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953
Ila Deane Griffin
11
Robert Parks Gilbert
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.2.1]
Betty Carol Huske
12
II Carey Parks Gilbert
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.2.1.1]
[
=>
]
12
Steven Huske Gilbert
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.2.1.2]
12
Virginia Carol Gilbert
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.2.1.3]
[
=>
]
+
Inez Timmerman
10
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.3]
10
Leon Gilbert
[1.1.10.2.13.5.4.2.2.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
9
Laura Jane Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.3]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
10
Gilbert Buford Dickey
[1.1.10.2.13.5.4.2.3.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown
Dorothy
11
Frances Dickey
[1.1.10.2.13.5.4.2.3.1.1]
11
Jr. Gilbert Buford Dickey
[1.1.10.2.13.5.4.2.3.1.2]
10
Louise Dickey
[1.1.10.2.13.5.4.2.3.2]
b. Jan 1899
Sharp
11
Lester Sharp
[1.1.10.2.13.5.4.2.3.2.1]
11
Gilbert Sharp
[1.1.10.2.13.5.4.2.3.2.2]
9
Emily Olivia Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.4]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
10
Thomas Leroy Tatum
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.1]
10
Myra Tatum
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2]
William Weakly Johnson
b. Abt 1895 d. Abt 1940
11
Mary Emily Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.1]
Luther Manly Taylor
12
Emmye Taylor
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.1.1]
12
Myra Jane Taylor
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.1.2]
12
Michael Taylor
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.1.3]
12
John Taylor
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.1.4]
11
Jr. William Weakly Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.2]
Betty Coles
12
III William Weakly Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.2.1]
12
Steven Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.2.2]
12
Linda Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.2.3]
12
Dianne Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.2.4]
11
John Tatum Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.3]
Peggy
12
Jr. John Tatum Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.3.1]
12
Scott Johnson
[1.1.10.2.13.5.4.2.4.2.3.2]
9
Levair Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.5]
b. Abt 1869
9
John A. Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.6]
b. 1873 d. 1874/1963
9
Ernest M. Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.7]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
9
Frank Leon Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.8]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
10
Richard Leon Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.8.1]
Josephine Elizabeth Martin
11
Frank Martin Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.8.1.1]
+
Margery Wallace
11
Jr. Richard Leon Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.8.1.2]
+
Jane Ferrier
9
James Carley Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.9]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
10
William Lambeth Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.9.1]
Joan Shuler
b. 3 Nov 1920 d. 25 May 1969
11
Laura Ann Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.9.1.1]
+
Thomas Curry Pollock
10
James Lester
[1.1.10.2.13.5.4.2.9.2]
8
Leroy M. Black
[1.1.10.2.13.5.4.3]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
7
Martha Keziah Yancey
[1.1.10.2.13.5.5]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
7
Mary Julia Yancey
[1.1.10.2.13.5.6]
b. 1834
+
William D. Roberts
7
Flournoy Yancey
[1.1.10.2.13.5.7]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
8
Alice Fletcher Yancey
[1.1.10.2.13.5.7.1]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
9
Thomas Asbury Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.1]
b. 4 Apr 1895
9
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.2]
b. 29 Jan 1897 d. 24 Nov 1973
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
Willie Crook
b. Abt 1901
10
Fergene Dawes Richmond
[1.1.10.2.13.5.7.1.2.1]
9
Alice LaFavia Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.3]
+
Glen Carl Moody
9
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4]
b. 20 Mar 1902 d. 19 Apr 1974
Mary Ona Kitchens
10
Frank Leslie Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.1]
+
Linda M Dickey
10
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2]
Erma Pauline Lively
11
Michael Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.1]
Gabbi
12
Allyson Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.1.1]
11
Susan Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.2]
Jon Ricciardi
12
Sydney Ricciardi
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.2.1]
12
Natalie Ricciardi
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.2.2]
11
Matthew Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.3]
Julie
12
Evan Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.3.1]
12
Emily Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.3.2]
12
Kaylie Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.3.3]
11
Julie Marie Dawes
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.4]
Kent Edward Zirker
12
Ethan Zirker
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.4.1]
12
Jenna Zirker
[1.1.10.2.13.5.7.1.4.2.4.2]
8
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.10.2.13.5.7.2]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
9
Martha Lafavre Bishop
[1.1.10.2.13.5.7.2.1]
9
Richard Yancey Bishop
[1.1.10.2.13.5.7.2.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
8
Cora Yancey
[1.1.10.2.13.5.7.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
8
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.10.2.13.5.7.4]
b. Jul 1882
7
Thomas Leroy Yancey
[1.1.10.2.13.5.8]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
8
Lucy M. Yancey
[1.1.10.2.13.5.8.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
9
George L Wilson
[1.1.10.2.13.5.8.1.1]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
9
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.10.2.13.5.8.1.2]
b. 1886
9
Rosa Mai Wilson
[1.1.10.2.13.5.8.1.3]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
9
Wilber Wilson
[1.1.10.2.13.5.8.1.4]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
10
Mabel Wilson
[1.1.10.2.13.5.8.1.4.1]
9
Thomas Webber Wilson
[1.1.10.2.13.5.8.1.5]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
8
Webber Yancey
[1.1.10.2.13.5.8.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
8
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.10.2.13.5.8.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
6
Mary Amanda Flournoy
[1.1.10.2.13.6]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
7
James Alexander Field
[1.1.10.2.13.6.1]
b. 30 May 1823
7
Mary Eliza Field
[1.1.10.2.13.6.2]
b. 1 Jul 1825
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
8
Maud Officer
[1.1.10.2.13.6.2.1]
b. 9 May 1847
8
Eustis Field Officer
[1.1.10.2.13.6.2.2]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
8
William P. Officer
[1.1.10.2.13.6.2.3]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
8
Myra Flournoy Knapp
[1.1.10.2.13.6.2.4]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
7
Jr. William Hume Field
[1.1.10.2.13.6.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
7
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.10.2.13.6.4]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
7
Silas Flournoy Field
[1.1.10.2.13.6.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
7
Henrietta Field
[1.1.10.2.13.6.6]
b. 1833 d. 1833
7
Margaret Julia Field
[1.1.10.2.13.6.7]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
7
Julian Clarence Field
[1.1.10.2.13.6.8]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
7
Florence Huntley Field
[1.1.10.2.13.6.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
6
Madison Flournoy
[1.1.10.2.13.7]
b. 1807
6
Julia Ann Flournoy
[1.1.10.2.13.8]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
7
Eliza Mildred Feild
[1.1.10.2.13.8.1]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
8
Julia Batte
[1.1.10.2.13.8.1.1]
+
W. R. Garrett
8
Mildred Batte
[1.1.10.2.13.8.1.2]
8
E. F. Batte
[1.1.10.2.13.8.1.3]
7
Hume Rigg Feild
[1.1.10.2.13.8.2]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
6
Silas Flournoy
[1.1.10.2.13.9]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
7
III Silas Flournoy
[1.1.10.2.13.9.1]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
8
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.10.2.13.9.1.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
8
Silas Camp Flournoy
[1.1.10.2.13.9.1.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
7
Lucien Flournoy
[1.1.10.2.13.9.2]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
8
Caroline Flournoy
[1.1.10.2.13.9.2.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
7
Mary Flournoy
[1.1.10.2.13.9.3]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
8
James P. Rivers
[1.1.10.2.13.9.3.1]
b. Bef 1863
8
Elizabeth Rivers
[1.1.10.2.13.9.3.2]
b. Bef 1865
8
Mary Rivers
[1.1.10.2.13.9.3.3]
b. Bef 1867
8
William W. Rivers
[1.1.10.2.13.9.3.4]
b. Bef 1869
8
Silas Flournoy Rivers
[1.1.10.2.13.9.3.5]
b. Bef 1871
8
Martha Rivers
[1.1.10.2.13.9.3.6]
b. Bef 1873
7
Camp Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
8
Lucien Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
9
Lillian May Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.1.1]
b. 1906
9
Mary Wise Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.1.2]
b. 1911
9
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.1.3]
b. 1914
9
Laura Louise Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.1.4]
9
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.1.5]
8
John Wise Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
9
Louise Wise Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.2.1]
b. 1907
9
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.2.2]
b. 1912
Minnie Childress Cole
10
Thomas Cole Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.2.2.1]
9
Camp Rogers Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.2.3]
9
Betty McAfee Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.2.4]
8
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
9
Eloise Walker
[1.1.10.2.13.9.4.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
+
Raymond Grady Thomas
9
Newton Flournoy Walker
[1.1.10.2.13.9.4.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
+
Rose Mary Bozeman
+
Valta Irene Gholston
9
Lucien John Walker
[1.1.10.2.13.9.4.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972
Janie Lucile Stallcup
b. 1912
10
Lou Anne Walker
[1.1.10.2.13.9.4.3.3.1]
Duane Tarrant
11
Lucien Clyde Tarrant
[1.1.10.2.13.9.4.3.3.1.1]
+
Dana Hanks
11
Nola Tarrant
[1.1.10.2.13.9.4.3.3.1.2]
+
Wally Newcomb
11
William Rusk Tarrant
[1.1.10.2.13.9.4.3.3.1.3]
+
Andrea Stigdon
+
Frank Casey
9
Jane Louise Walker
[1.1.10.2.13.9.4.3.4]
+
Benjamin Elliot Mosher
9
Jacob Camp Walker
[1.1.10.2.13.9.4.3.5]
+
Ouida Louise Gill
8
Augusta Mary Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
9
Georgia Louia May
[1.1.10.2.13.9.4.4.1]
b. 1899
9
Elizabeth Wise May
[1.1.10.2.13.9.4.4.2]
b. 1902
9
James Kathryn May
[1.1.10.2.13.9.4.4.3]
b. 1902
9
Norma Lucile May
[1.1.10.2.13.9.4.4.4]
b. 1902
9
Julia Flournoy May
[1.1.10.2.13.9.4.4.5]
Robert Henry Mays
10
Judy Mays
[1.1.10.2.13.9.4.4.5.1]
10
Robert Mays
[1.1.10.2.13.9.4.4.5.2]
d. INFANT
8
Julia Rivers Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
9
Andrew Booty Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1]
Mattie Lou Shaw
10
Jr. Andrew Booty Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.1]
Arlene
11
Arthur Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.1.1]
12
Seth Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.1.1.1]
12
Regan Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.1.1.2]
11
Andrew Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.1.2]
11
Jason Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.1.3]
11
Cynthia Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.1.4]
10
Lou Ann Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.2]
Rufus Taylor Higginbotham
11
Rufus Taylor Higginbotham
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.2.1]
11
Andrew Benjamin Higginbotham
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.2.2]
11
Laura Michelle Higginbotham
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.2.3]
10
John Franklin Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.3]
Judy
11
Julia Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.3.1]
11
Jennifer Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.3.2]
10
Gwen Elizabeth Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.1.4]
9
Lucien Wise Jordan
[1.1.10.2.13.9.4.5.2]
b. 1914
8
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
9
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.6.1]
9
Mary Louise Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.6.2]
9
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.10.2.13.9.4.6.3]
7
Elizabeth Flournoy
[1.1.10.2.13.9.5]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
8
Maude Eustace Duncan
[1.1.10.2.13.9.5.1]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
8
Duncan
[1.1.10.2.13.9.5.2]
b. Bef 1870 d. 1876
6
Sarah Flournoy
[1.1.10.2.13.10]
b. 1816
4
Ursula Harris
[1.1.10.3]
b. Abt 1731
4
John Jordan Harris
[1.1.10.4]
b. 1732 d. Bef 19 Nov 1800
Anne Obedience Turpin
b. 17 Sep 1734 d. 8 Aug 1800
5
Lucy Harris
[1.1.10.4.1]
b. 1756 d. 1832
Obadiah Smith
b. Abt 1756
6
Mary Burke Smith
[1.1.10.4.1.1]
b. 9 Jun 1781
5
Carolina Matilda Harris
[1.1.10.4.2]
b. 1 Dec 1756 d. 1815
+
Thomas Harris
b. Abt 1756
5
John Turpin Harris
[1.1.10.4.3]
b. 12 Oct 1758 d. 1815
Rebecca Britton
b. Abt 1770
6
Hiram Harris
[1.1.10.4.3.1]
b. 15 Sep 1796 d. 3 Jun 1867
Margaret Christian Harris
b. Abt 1796 d. Mar 1825
7
Rebecca Ann Harris
[1.1.10.4.3.1.1]
b. 3 Mar 1823
+
Alfred Douglas
b. Abt 1823
+
John Wilson
b. Abt 1823
7
Henry Benskin Christian Harris
[1.1.10.4.3.1.2]
b. 3 Feb 1825
Sarah C. Calvert
b. 9 Mar 1834/1835 d. 18 Mar 1865
8
Rebecca D Harris
[1.1.10.4.3.1.2.1]
b. 20 May 1852
+
Spencer L Barnes
b. Abt 1852
8
Hiram Henry Harris
[1.1.10.4.3.1.2.2]
b. 31 Jul 1855
8
Martha W. Harris
[1.1.10.4.3.1.2.3]
b. 7 Aug 1859
+
Jesse Gordon Roach
b. 1855 d. 1937
8
Catherine B. Harris
[1.1.10.4.3.1.2.4]
b. Aug 1861
+
William T. Barnett
b. Abt 1861
8
James Clay Harris
[1.1.10.4.3.1.2.5]
b. 16 Oct 1868
+
Mary Anderson
b. Abt 1868
+
Sarah A. Farris
Elizabeth Ann Daniels
b. 17 Oct 1842
8
Margaret Christian Harris
[1.1.10.4.3.1.2.6]
b. 10 Jan 1871
+
James A. Gaunt
b. Abt 1870
8
Pauline B. Harris
[1.1.10.4.3.1.2.7]
b. 20 Apr 1873 d. 29 Oct 1974
8
Robert D. Harris
[1.1.10.4.3.1.2.8]
b. 31 Mar 1875 d. 8 Oct 1875
8
Sallie Tilden Harris
[1.1.10.4.3.1.2.9]
b. 9 Sep 1877 d. 1952
+
James Henry Brown
b. 1869 d. 1949
8
William Henry "Hiram" Harris
[1.1.10.4.3.1.2.10]
b. 7 May 1879 d. 1944
Anna E. Ogden
b. 1884 d. 1941
9
Miles Franklin Harris
[1.1.10.4.3.1.2.10.1]
8
Mary Harris
[1.1.10.4.3.1.2.11]
b. 15 Jun 1880
Robert Granville Gaunt
b. Abt 1880
9
Mary Gladys Gaunt
[1.1.10.4.3.1.2.11.1]
b. Abt 1902
8
Jesse B. Harris
[1.1.10.4.3.1.2.12]
b. Mar 1882
Margaret Wilson
b. Abt 1796 d. Abt 1827
7
Mary Eleanor Harris
[1.1.10.4.3.1.3]
b. 28 Sep 1827
Elizabeth George
b. Abt 1796
7
John Wilson Harris
[1.1.10.4.3.1.4]
b. 1837 d. Aft 1867
7
Jr. Hiram Harris
[1.1.10.4.3.1.5]
b. 1840
+
Frances Gordon
b. Abt 1840
7
Mary Eleanor Harris
[1.1.10.4.3.1.6]
b. Abt 1845
+
McRae
b. Abt 1845
7
Margaret Elizabeth Harris
[1.1.10.4.3.1.7]
b. 1847
John E. Benson
b. Abt 1847
8
Eleanor Harris Benson
[1.1.10.4.3.1.7.1]
b. Abt 1870
+
Frances Gordon
b. Abt 1825
5
Judith Harris
[1.1.10.4.4]
b. 1760
+
John Crittenden
b. Abt 1759
5
Jordan Turpin Harris
[1.1.10.4.5]
b. 20 May 1763 d. 1826
Elizabeth Mosby Cannon
b. Abt 1763
6
James Madison Harris
[1.1.10.4.5.1]
b. 1776
Caroline John
b. Abt 1776
7
Md William Jordan Harris
[1.1.10.4.5.1.1]
b. Abt 1800
+
Mary Helen Epes
b. Abt 1800
6
Horatio Turpin Harris
[1.1.10.4.5.2]
b. 1799 d. 1855
+
Keturah
b. Abt 1799
6
John Francis Harris
[1.1.10.4.5.3]
b. 1808 d. 1880
+
Mary Duke Patten
b. Abt 1808
+
Ann Price
b. Abt 1763
5
Mary Elizabeth Josepha Harris
[1.1.10.4.6]
b. 1767
5
Francis Turpin Harris
[1.1.10.4.7]
b. 7 May 1768 d. 5 Dec 1836
+
Sally Gaines
b. Abt 1768
5
Polly Harris
[1.1.10.4.8]
b. 1774
Elizabeth Robards
b. Abt 1700
4
Jesse Harris
[1.1.10.5]
c. 14 Jun 1741
3
Martha Harris
[1.1.11]
b. Abt 1706 d. 1743
+
William Pasture
b. Abt 1702
3
Ann Harris
[1.1.12]
b. 1708
Booth
b. Abt 1700
4
Anne Booth
[1.1.12.1]
b. Abt 1735 d. 1758
Samuel Yeargain
b. Abt 1735 d. Aft 24 Dec 1784
5
Sarah Ann Yeargain
[1.1.12.1.1]
b. 1752 d. 1786
William Alston
b. 1748 d. 1789
6
John Joseph Alston
[1.1.12.1.1.1]
b. Abt 1775 d. 1 Apr 1831
Elizabeth Jones
b. Abt 1775
7
Nancy Alston
[1.1.12.1.1.1.1]
b. Abt 1800
+
John Degraaffenreidt
b. Abt 1800
7
Mary Ann Alston
[1.1.12.1.1.1.2]
b. Abt 1802
+
Thomas Degraaffenreidt
b. Abt 1802
James Taylor
b. Abt 1802
8
Joe Taylor
[1.1.12.1.1.1.2.1]
b. Abt 1838
+
Anna Alston
b. Abt 1838
6
William Chancy Alston
[1.1.12.1.1.2]
b. Abt 1777 d. 1789
6
Samuel Yeargan Alston
[1.1.12.1.1.3]
b. Abt 1779 d. Bef 1789
6
Oroondates Davis Alston
[1.1.12.1.1.4]
b. Abt 1781 d. 15 May 1851
+
Medley Medley
b. Abt 1781
6
Nancy Ann Alston
[1.1.12.1.1.5]
b. Abt 1783 d. 1860
+
Robert Palmer
b. Abt 1783
6
Mary Ann Alston
[1.1.12.1.1.6]
b. 9 Jun 1785 d. 8 Sep 1867
Edwards Rives
b. 19 Mar 1775 d. 2 Feb 1840
7
Sarah G. Rives
[1.1.12.1.1.6.1]
b. 11 Sep 1801 d. Bef 1830
7
William Alston Rives
[1.1.12.1.1.6.2]
b. 1 Nov 1803
7
Martha K. Rives
[1.1.12.1.1.6.3]
b. Oct 1806
+
John Jackson Goldston
b. Abt 1806
7
Oran D. Rives
[1.1.12.1.1.6.4]
b. 24 Sep 1808
7
Anna Rives
[1.1.12.1.1.6.5]
b. 14 Feb 1810
+
William Goldson Harris
b. Abt 1810
7
Robert Edwards Rives
[1.1.12.1.1.6.6]
b. 24 May 1812 d. 1861
+
Mary Antoinette Brown
b. 16 Jun 1833
7
Thomas T. Rives
[1.1.12.1.1.6.7]
b. 28 Jul 1814
7
James Franklin Rives
[1.1.12.1.1.6.8]
b. 13 Jun 1820
7
Mary Edwards Rives
[1.1.12.1.1.6.9]
b. 27 Dec 1827 d. 13 Nov 1873
+
Aaron Gaston Headen
b. 21 Aug 1822 d. 1 Mar 1907
+
Samuel Yeargain
b. 1707 d. 24 Dec 1784
3
Benjamin Harris
[1.1.13]
b. Abt 1710 d. Aft 24 Apr 1776
Frances Platt
b. Abt 1710
4
Mary Harris
[1.1.13.1]
b. Abt 1744
+
Sion Spencer
b. Abt 1744
4
Anne Harris
[1.1.13.2]
b. 1745
+
Joel Estes
b. 1741 d. 1825
Priscilla Wager
b. Abt 1710
4
Henson Wager Harris
[1.1.13.3]
b. 1753
+
Edward Moseley
b. Abt 1753
4
Phoebe Harris
[1.1.13.4]
b. 1755
Nathaniel Carrington
b. 28 Feb 1743/44 d. Nov 1803
5
Frances Ann Carrington
[1.1.13.4.1]
5
Henningham Carrington
[1.1.13.4.2]
4
Edith Harris
[1.1.13.5]
b. 1757 d. Aft 18 Nov 1779
4
William Wager Harris
[1.1.13.6]
b. Abt 1766
+
Mary Farrar
b. Abt 1766
2
Jr. Thomas Jefferson
[1.2]
b. 20 Nov 1679 d. 15 Feb 1730/31
Mary Field
b. 3 Feb 1679/80 d. 13 Aug 1715
3
Judith Jefferson
[1.2.1]
b. 30 Aug 1698 d. 14 Feb 1723
+
George Farrar
b. 30 Aug 1698 d. 1772
3
Thomas Jefferson
[1.2.2]
b. 24 Sep 1700 d. 14 Feb 1722/23
3
Field Jefferson
[1.2.3]
b. 6 Mar 1701/02 d. 16 Feb 1765
+
Mary Frances Robertson
b. Aft 1700 d. Bef 29 May 1762
+
Mary Hunt
d. Aft 1765
3
Alice Jefferson
[1.2.4]
b. 1704/1706
3
Peter Jefferson
[1.2.5]
b. 29 Feb 1707/08 d. 17 Aug 1757
Jane Randolph
b. 5 Feb 1719/20 d. 31 Mar 1776
4
Jane Jefferson
[1.2.5.1]
b. 27 Jun 1740 d. 1 Oct 1765
4
Mary Jefferson
[1.2.5.2]
b. 1 Oct 1741 d. 1817
John William Bolling
b. 24 Jun 1737 d. 1797
5
Thomas Bolling
[1.2.5.2.1]
b. 11 Feb 1764
5
Jane Bolling
[1.2.5.2.2]
b. 17 Sep 1765
5
Ann Bolling
[1.2.5.2.3]
b. 18 Jul 1767
5
Martha Bolling
[1.2.5.2.4]
b. 1769
5
Archibald Bolling
[1.2.5.2.5]
b. Abt 1770 d. 1829
Catherine Payne
b. Abt 1780
6
Edward Bolling
[1.2.5.2.5.1]
b. Abt 1793 d. 1855
+
Anne Cralle
b. 1786/1829 d. 1807/1909
6
Jr. Archibald Bolling
[1.2.5.2.5.2]
b. 1806 d. 1860
Anne E. Wiggington
b. 1795/1818 d. 1840/1906
7
Harriet W. Bolling
[1.2.5.2.5.2.1]
+
Robert H. Waddell
7
Mary Jefferson Bolling
[1.2.5.2.5.2.2]
+
Rudolph Tuesler
7
John Blair Bolling
[1.2.5.2.5.2.3]
d. INFANT
7
William Holcombe Bolling
[1.2.5.2.5.2.4]
b. 29 May 1837 d. 6 Jul 1899
Sallie Spiers White
b. 5 Jan 1843 d. 21 Nov 1925
8
Rolfe Emerson Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.1]
b. 22 Aug 1861 d. 3 Feb 1936
Annie Stuart Litchfield
b. 19 Feb 1869 d. 12 Apr 1944
9
Elizabeth Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.1.1]
Jorge Eduardo Boyd
10
Lola Elizabeth Boyd
[1.2.5.2.5.2.4.1.1.1]
10
Mildred Stuart Boyd
[1.2.5.2.5.2.4.1.1.2]
10
Edith Bolling Boyd
[1.2.5.2.5.2.4.1.1.3]
10
Elena Rolfe Boyd
[1.2.5.2.5.2.4.1.1.4]
8
Gertrude Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.2]
b. 16 May 1863 d. 1893/1957
Alexander Hunter Galt
b. 5 Dec 1860 d. 1893/1951
9
Alexander Bolling Galt
[1.2.5.2.5.2.4.2.1]
8
Anne Lee Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.3]
b. 15 Jun 1865 d. 26 Feb 1917
Matthew Hawes Maury
b. 9 Jun 1860 d. 10 Oct 1930
9
Anne Bolling Maury
[1.2.5.2.5.2.4.3.1]
John A. Goodloe
10
Jr. John A. Goodloe
[1.2.5.2.5.2.4.3.1.1]
10
Ann L. Goodloe
[1.2.5.2.5.2.4.3.1.2]
10
Matthew Maury Goodloe
[1.2.5.2.5.2.4.3.1.3]
10
Elizabeth Goodloe
[1.2.5.2.5.2.4.3.1.4]
9
Lucy Logwood Maury
[1.2.5.2.5.2.4.3.2]
John Edward Moeling
10
Moeling
[1.2.5.2.5.2.4.3.2.1]
10
Sally Green Moeling
[1.2.5.2.5.2.4.3.2.2]
b. 10 Aug 1937 d. 28 May 1965
8
William Archibald Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.4]
b. 11 Oct 1867 d. 1899/1958
Mary Johnson Keller
b. 31 Mar 1870 d. 1899/1964
9
John Esten Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.4.1]
+
Edith Marion Bourne
9
William Holcombe Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.4.2]
+
Virginia Gaither
8
Bertha Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.5]
b. 11 Oct 1869 d. 1870/1963
8
Charles Rodefer Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.6]
b. 11 Jun 1871 d. 11 Jun 1871
8
Edith Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.7]
b. 15 Oct 1872 d. 28 Dec 1961
+
Norman Galt
b. 30 Apr 1866 d. 28 Jan 1908
+
Thomas Woodrow Wilson
b. 28 Dec 1856 d. 3 Feb 1924
8
John Randolph Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.8]
b. 11 Apr 1876 d. 1877/1966
8
Richard Wilmer Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.9]
b. 6 Oct 1879 d. 1913/1970
Elianor Hunter Lutz
9
Clara Lutz Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.9.1]
9
Jr. Richard Wilmer Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.9.2]
9
Sterling Ruffin Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.9.3]
9
Barbara Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.9.4]
8
Julian Brandon Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.10]
b. 7 May 1882 d. 1912/1973
+
Viola Roosevelt Belden
8
Geraldine Bolling
[1.2.5.2.5.2.4.11]
b. 12 Aug 1885 d. 6 Jul 1887
6
Pocahontas R. Bolling
[1.2.5.2.5.3]
b. Abt 1810
+
William G. White
b. Est 1778/1822 d. Est 1803/1900
+
Peter J. Hill
b. 1815/1847 d. 1872/1934
6
Alexander Bolling
[1.2.5.2.5.4]
b. 1785/1824 d. 1878
+
Susan Gray
b. 1786/1830 d. 1807/1909
6
Jefferson Bolling
[1.2.5.2.5.5]
b. 1785/1824 d. 1797/1902
6
Catherine Bolling
[1.2.5.2.5.6]
b. 1785/1824 d. 1796/1905
5
Robert Bolling
[1.2.5.2.6]
b. Abt 1771
+
Jane Spotswood Payne
b. 20 Oct 1780 d. 27 Feb 1807
5
Edward Bolling
[1.2.5.2.7]
b. 17 Sep 1772 d. 1835
Dorothea Dandridge Payne
b. 10 Jul 1777 d. 1800/1871
6
Powhatan Polling Bolling
[1.2.5.2.7.1]
b. Abt 1800 d. Aft 1840
Arminda R. Payne
b. 1790/1816 d. 1840/1904
7
Pocahontas J. Bolling
[1.2.5.2.7.1.1]
b. 1830 d. 1831/1924
7
Elvira G. Bolling
[1.2.5.2.7.1.2]
b. 1837 d. 1838/1931
4
President Thomas Jefferson
[1.2.5.3]
b. 2 Apr 1743 d. 4 Jul 1826
+
Sally Hemings
b. Abt 1769
Martha Wayles
b. 30 Oct 1748 d. 6 Sep 1782
5
Martha Jefferson
[1.2.5.3.1]
b. 27 Sep 1772 d. 10 Oct 1836
Jr. Thomas Mann Randolph
b. 17 May 1768 d. 20 Jun 1828
6
Anne Cary Randolph
[1.2.5.3.1.1]
b. 23 Jan 1791 d. 11 Feb 1826
+
Charles Lewis Bankhead
b. 1788 d. 1835
6
Thomas Jefferson Randolph
[1.2.5.3.1.2]
b. 12 Sep 1792 d. 8 Oct 1875
Jane Hollins Nicholas
b. 1798 d. 1871
7
Margaret Smith Randolph
[1.2.5.3.1.2.1]
b. 7 Mar 1816 d. 20 Dec 1842
William Mann Randolph
d. 1850
8
William Lewis Randolph
[1.2.5.3.1.2.1.1]
+
Margaret Randolph Taylor
+
Agnes Dillon
8
Jane Margaret Randolph
[1.2.5.3.1.2.1.2]
b. 7 May 1840
+
Edward Clifton Anderson
7
Maria Jefferson Carr Randolph
[1.2.5.3.1.2.2]
b. 20 Jul 1817 d. 16 Jul 1857
John Charles Randolph Taylor
b. 30 May 1812 d. 6 Jan 1875
8
Bennett Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.1]
b. 15 Aug 1836 d. 9 Apr 1898
8
Susan Beverley Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.2]
b. 8 Feb 1840 d. 22 Sep 1890
8
Jefferson Randolph Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.3]
b. 27 Dec 1842 d. 15 Apr 1919
8
Margaret Randolph Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.4]
b. 14 Nov 1843 d. 12 Feb 1898
8
Charlotte Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.5]
b. 17 Dec 1845 d. 17 May 1846
8
Stevens Mason Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.6]
b. 16 Jul 1847 d. 10 Jan 1917
8
Cornelia Jefferson Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.7]
b. 29 Mar 1849 d. 3 Mar 1937
8
Moncure Robinson Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.8]
b. 23 Feb 1851 d. 7 Dec 1915
8
Edmund Randolph Taylor
[1.2.5.3.1.2.2.9]
b. 12 Jul 1853 d. 16 Jun 1919
7
Mary Buchanan Randolph
[1.2.5.3.1.2.3]
b. 23 Nov 1818 d. 24 Oct 1821
7
Caryanne Nicholas Randolph
[1.2.5.3.1.2.4]
b. 22 Apr 1820 d. 24 Jul 1857
+
Francis Gildart Ruffin
b. 1816 d. 1892
7
Mary Buchanan Randolph
[1.2.5.3.1.2.5]
b. 17 Dec 1821 d. 23 Jun 1884
7
Eleonora Wayles Randolph
[1.2.5.3.1.2.6]
b. 1 Dec 1823 d. 15 Aug 1896
+
William Byrd Harrison
b. 1800 d. 1870
7
Caroline Ramsay Randolph
[1.2.5.3.1.2.7]
b. 15 Jan 1828 d. 28 Jun 1902
7
Thomas Jefferson Randolph
[1.2.5.3.1.2.8]
b. 29 Aug 1829 d. 8 Aug 1872
Mary Walker Meriwether
b. 29 Apr 1833 d. 4 Oct 1863
8
George Geiger Randolph
[1.2.5.3.1.2.8.1]
8
III Thomas Jefferson Randolph
[1.2.5.3.1.2.8.2]
8
Francis Merriwether Randolph
[1.2.5.3.1.2.8.3]
b. 22 Oct 1854 d. 8 Sep 1922
Charlotte Nelson Macon
b. 10 Dec 1859 d. 24 May 1935
9
Charlotte Nelson Randolph
[1.2.5.3.1.2.8.3.1]
b. 10 Dec 1859 d. 24 May 1935
Gilbert Thomas Rafferty
b. Jan 1876 d. 12 Aug 1929
10
Doris Rafferty
[1.2.5.3.1.2.8.3.1.1]
Jr. Roberts Coles
11
III Roberts Coles
[1.2.5.3.1.2.8.3.1.1.1]
+
Charlotte N. Meriwether
d. 1876
7
Jane Nicholas Randolph
[1.2.5.3.1.2.9]
b. 10 Dec 1831 d. 26 Aug 1868
+
Robert Garlick Hill Kean
b. 7 Oct 1828 d. 1898
7
Wilson Cary Nicholas Randolph
[1.2.5.3.1.2.10]
b. 26 Oct 1834 d. 26 Apr 1907
+
Mary Holliday
7
Meriwether Lewis Randolph
[1.2.5.3.1.2.11]
b. 17 Jul 1837 d. 1 Feb 1871
+
Anna T. Daniel
7
Sarah Nicholas Randolph
[1.2.5.3.1.2.12]
b. 10 Oct 1839 d. 25 Apr 1892
+
Noah H. Haggard
6
Ellen Wayles Randolph
[1.2.5.3.1.3]
b. 30 Aug 1794 d. 26 Jul 1795
6
Ellen Wayles Randolph
[1.2.5.3.1.4]
b. 13 Oct 1796 d. 21 Apr 1876
+
Joseph Coolidge
b. 1798 d. 1879
6
Cornelia Jefferson Randolph
[1.2.5.3.1.5]
b. 26 Jul 1799 d. 24 Feb 1871
6
Virginia Jefferson Randolph
[1.2.5.3.1.6]
b. 22 Aug 1801 d. 26 Apr 1882
+
Nicholas Philip Trist
b. 1800 d. 1874
6
Mary Jefferson Randolph
[1.2.5.3.1.7]
b. 2 Nov 1803 d. 29 Mar 1876
6
James Madison Randolph
[1.2.5.3.1.8]
b. 17 Jan 1806 d. 23 Jan 1834
6
Benjamin Franklin Randolph
[1.2.5.3.1.9]
b. 14 Jul 1808 d. 18 Feb 1871
+
Sarah Champe Carter
b. 1810 d. 1896
6
Meriwether Lewis Randolph
[1.2.5.3.1.10]
b. 31 Jan 1810 d. 24 Sep 1837
Elizabeth A. Martin
7
Lewis Jackson Randolph
[1.2.5.3.1.10.1]
b. Mar 1836 d. 1840
6
Septimia Anne Randolph
[1.2.5.3.1.11]
b. 3 Jan 1814 d. 14 Sep 1887
+
David Scott Meikleham
b. 1804 d. 20 Nov 1849
6
George Wythe Randolph
[1.2.5.3.1.12]
b. 10 Mar 1818 d. 3 Apr 1867
+
Mary Elizabeth Adams
5
Jane Randolph Jefferson
[1.2.5.3.2]
b. 3 Apr 1774
5
Jefferson
[1.2.5.3.3]
b. 28 May 1777
5
Mary Jefferson
[1.2.5.3.4]
b. 1 Aug 1778
5
Jefferson
[1.2.5.3.5]
b. 3 Nov 1780
5
Lucy Elizabeth Jefferson
[1.2.5.3.6]
b. 8 May 1782
4
Elizabeth Jefferson
[1.2.5.4]
b. 4 Nov 1744 d. 24 Feb 1774
4
Martha Jefferson
[1.2.5.5]
b. 29 May 1746 d. 3 Sep 1811
Dabney Carr
b. 26 Oct 1743 d. 16 May 1773
5
Jane Barbara Carr
[1.2.5.5.1]
b. 1766 d. 1840
Jr. Wilson Miles Cary
b. 1760 d. 1793
6
Wilson Jefferson Cary
[1.2.5.5.1.1]
b. 1784 d. 1823
Virginia Randolph
b. 30 Jan 1786 d. 2 May 1852
7
Wilson Jefferson Cary
[1.2.5.5.1.1.1]
b. 1806 d. 1877
Jane Margaret Carr
b. 15 Mar 1809 d. 22 Jan 1903
8
Wilson Miles Cary
[1.2.5.5.1.1.1.1]
b. Abt 1830
8
Sarah Nicholas Cary
[1.2.5.5.1.1.1.2]
b. 1832
James Howard McHenry
9
Juliana H. McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.1]
d. 1901
9
Wilson Cary McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.2]
Edith Dove
10
Howard McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.2.1]
+
Frances Garrison
10
Edith Dove McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.2.2]
9
John McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.3]
Priscilla Pinkney Stewart
10
John McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.3.1]
10
James McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.3.2]
+
Margaret Hambleton Ober
10
Julia Howard McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.3.3]
Jr. Robert Lee Randolph
b. 1895
11
Robert Lee Randolph
[1.2.5.5.1.1.1.2.3.3.1]
11
Priscilla Stewart Randolph
[1.2.5.5.1.1.1.2.3.3.2]
10
Priscilla Pinkney McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.3.4]
Duncan Forbes Thayer
11
Priscilla Stewart Thayer
[1.2.5.5.1.1.1.2.3.4.1]
11
Cornelia Van Rensselaer Thayer
[1.2.5.5.1.1.1.2.3.4.2]
9
Ellen McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.4]
R. Brent Keyser
10
Ellen Keyser
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.1]
James Bruce
11
Ellen Bruce
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.1.1]
11
Louise Este Bruce
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.1.2]
10
Juliana Brent Keyser
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.2]
Gaylord Lee Clark
11
Juliana Gaylord Clark
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.2.1]
11
Letitia Lee Clark
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.2.2]
11
Mathilde Keyser Clark
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.2.3]
11
Gaylord Lee Clark
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.2.4]
11
Sally Cary Clark
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.2.5]
10
W. McHenry Keyser
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.3]
Margaret Hambleton Ober
11
Robert Brent Keyser
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.3.1]
11
W. McHenry Keyser
[1.2.5.5.1.1.1.2.4.3.2]
9
Sophia McHenry
[1.2.5.5.1.1.1.2.5]
Charles Morton Stewart
10
Charles Morton Stewart
[1.2.5.5.1.1.1.2.5.1]
Lillie Emerson Van Leuven
11
Charles Morton Stewart
[1.2.5.5.1.1.1.2.5.1.1]
10
Margaret Stewart
[1.2.5.5.1.1.1.2.5.2]
10
Sophia McHenry Stewart
[1.2.5.5.1.1.1.2.5.3]
George Martin Gillet
11
George Martin Gillet
[1.2.5.5.1.1.1.2.5.3.1]
11
James McHenry Gillet
[1.2.5.5.1.1.1.2.5.3.2]
8
Virginia Cary
[1.2.5.5.1.1.1.3]
b. 1833 d. Abt 1833
8
John Brune Cary
[1.2.5.5.1.1.1.4]
b. 1840 d. 1917
Frances Eugenia Daniel
9
Hetty Cary
[1.2.5.5.1.1.1.4.1]
Fairfax Harrison
b. 13 Mar 1869
10
Sally Cary Fairfax Harrison
[1.2.5.5.1.1.1.4.1.1]
10
Richard Harrison
[1.2.5.5.1.1.1.4.1.2]
10
Constance Cary Harrison
[1.2.5.5.1.1.1.4.1.3]
b. 30 Mar 1895
10
Ursula Harrison
[1.2.5.5.1.1.1.4.1.4]
b. 14 Dec 1898
7
Jane Blair Cary
[1.2.5.5.1.1.2]
b. 1808 d. 1888
Edward Dunlap Smith
8
Archibald Cary Smith
[1.2.5.5.1.1.2.1]
b. 1853 d. 1911
7
Mary Randolph Cary
[1.2.5.5.1.1.3]
b. 1811 d. 1887
Orlando Fairfax
b. 1806 d. 1882
8
Mary Edith Fairfax
[1.2.5.5.1.1.3.1]
+
John Jaquelin Ambler Moncure
8
Virginia Fairfax
[1.2.5.5.1.1.3.2]
d. 1832
8
Edith Fairfax
[1.2.5.5.1.1.3.3]
d. 1839
8
Orlando Cary Fairfax
[1.2.5.5.1.1.3.4]
d. 1836
8
Jane Cary Fairfax
[1.2.5.5.1.1.3.5]
8
Monimia Fairfax
[1.2.5.5.1.1.3.6]
b. 27 Dec 1837
+
George Davis
b. 1 Mar 1820 d. 23 Feb 1896
8
Randolph Fairfax
[1.2.5.5.1.1.3.7]
b. 1842 d. 1862
8
Ethelbert Fairfax
[1.2.5.5.1.1.3.8]
b. 1845 d. 1865
7
Anne Mantia Cary
[1.2.5.5.1.1.4]
b. 1813 d. 1822
7
Archibald Cary
[1.2.5.5.1.1.5]
b. 1815 d. 1854
Mominia Fairfax
b. 1820 d. 1875
8
Constance Fairfax Cary
[1.2.5.5.1.1.5.1]
b. 1843 d. 1920
Burton Norvell Harrison
b. 14 Jul 1838 d. 29 Mar 1904
9
Archibald Cary Harrison
[1.2.5.5.1.1.5.1.1]
9
Francis Burton Harrison
[1.2.5.5.1.1.5.1.2]
9
Fairfax Harrison
[1.2.5.5.1.1.5.1.3]
b. 13 Mar 1869
Hetty Cary
10
Sally Cary Fairfax Harrison
[1.2.5.5.1.1.5.1.3.1]
10
Richard Harrison
[1.2.5.5.1.1.5.1.3.2]
10
Constance Cary Harrison
[1.2.5.5.1.1.5.1.3.3]
b. 30 Mar 1895
10
Ursula Harrison
[1.2.5.5.1.1.5.1.3.4]
b. 14 Dec 1898
7
Ellen Randolph Cary
[1.2.5.5.1.1.6]
b. 1817 d. 1901
7
Martha Jefferson Cary
[1.2.5.5.1.1.7]
b. 1820 d. 1873
Jr. Gouverneur Morris
b. 9 Feb 1813 d. 20 Aug 1888
8
III Gouverneur Morris
[1.2.5.5.1.1.7.1]
b. 27 Dec 1844 d. 16 Feb 1897
Henrietta Baldwin
b. 1850
9
Henrietta Fairfax Morris
[1.2.5.5.1.1.7.1.1]
b. 22 Aug 1874
9
IV Gouverneur Morris
[1.2.5.5.1.1.7.1.2]
b. 7 Feb 1876
9
Powhattan Randolph Morris
[1.2.5.5.1.1.7.1.3]
b. 17 Mar 1878
+
Louisa Addison Hughes
b. Mar 1875
7
Sally Newsum Cary
[1.2.5.5.1.1.8]
b. 1822 d. Abt 1823
7
Louisa Hartwell Cary
[1.2.5.5.1.1.9]
b. 1823 d. Abt 1823
6
Sarah Cary
[1.2.5.5.1.2]
b. 1788
6
Miles Cary
[1.2.5.5.1.3]
b. 1789 d. 1827
Elizabeth Scarsbrooke Wilson Curle
7
Henry Cary
[1.2.5.5.1.3.1]
8
Jr. Henry Cary
[1.2.5.5.1.3.1.1]
7
Lucius Falkland Cary
[1.2.5.5.1.3.2]
b. 1815 d. 1845
Lucy Anne Henley
8
Harriette Cary
[1.2.5.5.1.3.2.1]
b. 22 Mar 1838
+
William Christian
8
Wilson Miles Cary
[1.2.5.5.1.3.2.2]
b. 1843 d. 1919
Anne Eliza Sublett
b. 1846 d. 1875
9
Emily Sampson Cary
[1.2.5.5.1.3.2.2.1]
Jr. Thomas Marshall
10
Fairfax Cary Marshall
[1.2.5.5.1.3.2.2.1.1]
9
Hunsdon Cary
[1.2.5.5.1.3.2.2.2]
b. 4 Apr 1872
+
Mary Miller
Lilias Blair McPhail
9
II Lucius Falkland Cary
[1.2.5.5.1.3.2.2.3]
b. 1879
+
Alma Miller Cecil
9
Lilias Blair Cary
[1.2.5.5.1.3.2.2.4]
b. 11 Sep 1883 d. Nov 1972
Thomas King Currie
10
Jr. Thomas King Currie
[1.2.5.5.1.3.2.2.4.1]
6
Martha Carr Cary
[1.2.5.5.1.4]
b. Abt 1791
5
Lucy Maria Carr
[1.2.5.5.2]
b. 7 Mar 1768 d. 1803
Richard M. Terrell
b. 1765 d. 3 Oct 1802
6
Martha Jefferson Terrell
[1.2.5.5.2.1]
b. 17 Jul 1793
6
Lucy Terrell
[1.2.5.5.2.2]
b. 1795
6
Ann Overton Terrell
[1.2.5.5.2.3]
b. 1797
6
Virginia Terrell
[1.2.5.5.2.4]
b. 1798 d. 1860
Francis Carr
b. 4 Feb 1784 d. Abt 1843
7
Peter Carr
[1.2.5.5.2.4.1]
d. 1859
+
Lydia Laura Lewis
d. 1864
6
Dabney Carr Terrell
[1.2.5.5.2.5]
b. 1801 d. 1827
6
Mary Jane Terrell
[1.2.5.5.2.6]
b. 1803 d. 1879
John Andrew Gardiner Davis
b. 1802 d. 1840
7
John Staige Davis
[1.2.5.5.2.6.1]
b. 1824 d. 1885
+
Lucy Landon Blackford
Caroline Kean Hill
b. 1833 d. 1912
8
John Staige Davis
[1.2.5.5.2.6.1.1]
b. 24 Jun 1866
Volumnia Hundley Staples
b. 1 Apr 1868
9
Adeline Staples Davis
[1.2.5.5.2.6.1.1.1]
b. 25 Oct 1894
Lawrence L. Phillips
10
Harriet B. Phillips
[1.2.5.5.2.6.1.1.1.1]
9
Eugenia Davis
[1.2.5.5.2.6.1.1.2]
b. 17 Aug 1896
Jr. John Woods Harris
10
Eugenia Davis Harris
[1.2.5.5.2.6.1.1.2.1]
9
Jr. John Staige Davis
[1.2.5.5.2.6.1.1.3]
b. 15 Sep 1900
5
Mary Carr
[1.2.5.5.3]
b. 7 Mar 1768
Daniel Sladding
b. 1760/1765 d. 1800/1810
6
Arthur Slaton
[1.2.5.5.3.1]
b. 1797
5
Peter Carr
[1.2.5.5.4]
b. 2 Jan 1770 d. 1815
Hester Stevenson
b. 1767 d. 1834
6
Dabney S. Carr
[1.2.5.5.4.1]
b. 1802 d. 1854
6
Ellen Boucher Carr
[1.2.5.5.4.2]
b. 1806 d. 1876
6
Jane Margaret Carr
[1.2.5.5.4.3]
b. 15 Mar 1809 d. 22 Jan 1903
Wilson Jefferson Cary
b. 1806 d. 1877
7
Wilson Miles Cary
[1.2.5.5.4.3.1]
b. Abt 1830
7
Sarah Nicholas Cary
[1.2.5.5.4.3.2]
b. 1832
James Howard McHenry
8
Juliana H. McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.1]
d. 1901
8
Wilson Cary McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.2]
Edith Dove
9
Howard McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.2.1]
+
Frances Garrison
9
Edith Dove McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.2.2]
8
John McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.3]
Priscilla Pinkney Stewart
9
John McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.3.1]
9
James McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.3.2]
+
Margaret Hambleton Ober
9
Julia Howard McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.3.3]
Jr. Robert Lee Randolph
b. 1895
10
Robert Lee Randolph
[1.2.5.5.4.3.2.3.3.1]
10
Priscilla Stewart Randolph
[1.2.5.5.4.3.2.3.3.2]
9
Priscilla Pinkney McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.3.4]
Duncan Forbes Thayer
10
Priscilla Stewart Thayer
[1.2.5.5.4.3.2.3.4.1]
10
Cornelia Van Rensselaer Thayer
[1.2.5.5.4.3.2.3.4.2]
8
Ellen McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.4]
R. Brent Keyser
9
Ellen Keyser
[1.2.5.5.4.3.2.4.1]
James Bruce
10
Ellen Bruce
[1.2.5.5.4.3.2.4.1.1]
10
Louise Este Bruce
[1.2.5.5.4.3.2.4.1.2]
9
Juliana Brent Keyser
[1.2.5.5.4.3.2.4.2]
Gaylord Lee Clark
10
Juliana Gaylord Clark
[1.2.5.5.4.3.2.4.2.1]
10
Letitia Lee Clark
[1.2.5.5.4.3.2.4.2.2]
10
Mathilde Keyser Clark
[1.2.5.5.4.3.2.4.2.3]
10
Gaylord Lee Clark
[1.2.5.5.4.3.2.4.2.4]
10
Sally Cary Clark
[1.2.5.5.4.3.2.4.2.5]
9
W. McHenry Keyser
[1.2.5.5.4.3.2.4.3]
Margaret Hambleton Ober
10
Robert Brent Keyser
[1.2.5.5.4.3.2.4.3.1]
10
W. McHenry Keyser
[1.2.5.5.4.3.2.4.3.2]
8
Sophia McHenry
[1.2.5.5.4.3.2.5]
Charles Morton Stewart
9
Charles Morton Stewart
[1.2.5.5.4.3.2.5.1]
Lillie Emerson Van Leuven
10
Charles Morton Stewart
[1.2.5.5.4.3.2.5.1.1]
9
Margaret Stewart
[1.2.5.5.4.3.2.5.2]
9
Sophia McHenry Stewart
[1.2.5.5.4.3.2.5.3]
George Martin Gillet
10
George Martin Gillet
[1.2.5.5.4.3.2.5.3.1]
10
James McHenry Gillet
[1.2.5.5.4.3.2.5.3.2]
7
Virginia Cary
[1.2.5.5.4.3.3]
b. 1833 d. Abt 1833
7
John Brune Cary
[1.2.5.5.4.3.4]
b. 1840 d. 1917
Frances Eugenia Daniel
8
Hetty Cary
[1.2.5.5.4.3.4.1]
Fairfax Harrison
b. 13 Mar 1869
9
Sally Cary Fairfax Harrison
[1.2.5.5.4.3.4.1.1]
9
Richard Harrison
[1.2.5.5.4.3.4.1.2]
9
Constance Cary Harrison
[1.2.5.5.4.3.4.1.3]
b. 30 Mar 1895
9
Ursula Harrison
[1.2.5.5.4.3.4.1.4]
b. 14 Dec 1898
+
Elizabeth Overton Carr
b. 27 Apr 1773 d. 1837
5
Samuel Carr
[1.2.5.5.5]
b. 9 Oct 1771 d. 25 Jul 1855
Maria Dabney
b. Abt 1801
6
Lawrence Carr
[1.2.5.5.5.1]
6
George Watson Carr
[1.2.5.5.5.2]
b. 1823
Emma Gilmer Watts
7
William Watts Carr
[1.2.5.5.5.2.1]
7
Betty Carr
[1.2.5.5.5.2.2]
+
Donald McDonald
Pinnie Laws
7
Sally Carr
[1.2.5.5.5.2.3]
6
Maria Jefferson Carr
[1.2.5.5.5.3]
b. 1826
6
Sally Watson Carr
[1.2.5.5.5.4]
b. 12 Sep 1826 d. 1850
Francis Edward Garland Carr
b. Abt 1825 d. 1893
7
George Watson Carr
[1.2.5.5.5.4.1]
b. Abt 1845
6
Sarah Carr
[1.2.5.5.5.5]
b. 1828 d. 1848
Eleanor Barbara Carr
b. Abt 1779 d. 1815
6
John Addison Carr
[1.2.5.5.5.6]
b. 1801 d. 1839
6
Dabney Overton Carr
[1.2.5.5.5.7]
b. 1806 d. 1841
6
Martha Carr
[1.2.5.5.5.8]
b. 1808 d. 1816
6
James Lawrence Carr
[1.2.5.5.5.9]
b. 1811 d. 1875
5
Jr. Dabney Carr
[1.2.5.5.6]
b. 27 Apr 1773 d. 8 Jan 1837
Elizabeth Overton Carr
b. 27 Apr 1773 d. 1837
6
Nancy Addison Carr
[1.2.5.5.6.1]
b. Abt 1801
6
Jane Cary Carr
[1.2.5.5.6.2]
b. 3 Dec 1807 d. 21 Jul 1859
Peyton Randolph Harrison
b. 19 Nov 1800 d. 10 Sep 1887
7
Elizabeth Carr Harrison
[1.2.5.5.6.2.1]
b. 3 Mar 1826 d. 27 Apr 1847
7
Randolph Harrison
[1.2.5.5.6.2.2]
b. 16 Jan 1829 d. 22 Sep 1863
7
Dabney Carr Harrison
[1.2.5.5.6.2.3]
b. 12 Sep 1830 d. 16 Feb 1862
Sallie Pendleton Buchanan
b. 1835 d. 1916
8
Jane Carr Harrison
[1.2.5.5.6.2.3.1]
b. 1856 d. 1864
8
Dabney Carr Harrison, Jr
[1.2.5.5.6.2.3.2]
b. 15 Oct 1858 d. 8 Jul 1931
Ellen Robinson Riley
b. 13 May 1876 d. 26 Dec 1952
9
William Riley Harrison
[1.2.5.5.6.2.3.2.1]
b. 25 Nov 1900 d. 1 May 1924
9
Dabney Carr Harrison, III
[1.2.5.5.6.2.3.2.2]
+
Edith Barrington Harrison
b. 25 Feb 1914 d. 23 Jul 1967
Marion Colston Harrison
b. 17 Mar 1909 d. 23 May 1933
10
Dabney Carr Harrison, IV
[1.2.5.5.6.2.3.2.2.1]
8
Ann Spottiswoode Dandridge Harrison
[1.2.5.5.6.2.3.3]
b. 1860 d. 1898
7
Peyton Randolph Harrison, Jr
[1.2.5.5.6.2.4]
b. 17 Jun 1832 d. 21 Jul 1861
Sarah Forrest Hunter
b. 7 Jul 1833 d. 11 Jan 1926
8
Jane Cary Harrison
[1.2.5.5.6.2.4.1]
b. 1856 d. 1928
8
Edmund Pendleton Hunter Harrison
[1.2.5.5.6.2.4.2]
b. 27 Dec 1857 d. 25 Aug 1941
Carolina Henderson Webster
b. 14 Aug 1860 d. 7 Jul 1933
9
Sarah Hunter Harrison
[1.2.5.5.6.2.4.2.1]
b. 3 Mar 1893 d. 11 Sep 1967
+
Charles Downing Pinkerton
b. 2 Jul 1871 d. 31 Jan 1974
9
Carolyn Webster Harrison
[1.2.5.5.6.2.4.2.2]
b. 19 Apr 1897
9
Edmund Pendleton Hunter Harrison
[1.2.5.5.6.2.4.2.3]
b. 20 Nov 1900 d. 11 Jul 1974
+
Miriam Louise Washabaugh
8
Peyton Randolph Harrison, III
[1.2.5.5.6.2.4.3]
b. 21 Jul 1859 d. 25 Aug 1941
Lilian Irene Gorham
b. Nov 1873 d. 1890
9
Lillian Gorham Harrison
[1.2.5.5.6.2.4.3.1]
b. Aug 1890 d. 20 Nov 1969
Forrest Agustus Brown
b. 28 Jul 1888 d. May 1965
10
Forrest Washington Brown
[1.2.5.5.6.2.4.3.1.1]
10
Sarah F Brown
[1.2.5.5.6.2.4.3.1.2]
b. Abt 1913
10
Peyton Randolph Brown
[1.2.5.5.6.2.4.3.1.3]
b. 16 Sep 1916 d. Feb 1973
+
Barbara C
10
David Hunter Brown
[1.2.5.5.6.2.4.3.1.4]
b. 20 Dec 1923 d. 4 Mar 1958
10
Lillian J Brown
[1.2.5.5.6.2.4.3.1.5]
Nannie Spotswood Boyd
b. 22 Nov 1873 d. 26 May 1937
9
Holmes Boyd Harrison
[1.2.5.5.6.2.4.3.2]
b. 22 Oct 1899 d. 22 May 1911
9
Peyton Randolph Harrison, IV
[1.2.5.5.6.2.4.3.3]
b. 2 Sep 1905 d. 16 Feb 1938
9
Anne "Nana" Spottswood Harrison
[1.2.5.5.6.2.4.3.4]
+
Bennett Taylor
7
Virginia Randolph Harrison
[1.2.5.5.6.2.5]
b. 31 Mar 1834 d. 9 Aug 1895
William James Hoge
b. 14 Aug 1825 d. 5 Jul 1864
8
Mary Swift Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.1]
b. 15 Oct 1855 d. 20 Apr 1934
DeLacey Wardlaw
b. 5 Nov 1856 d. 20 Jan 1934
9
Virginia Randolph Wardlaw
[1.2.5.5.6.2.5.1.1]
b. 1 Aug 1881
James William Adamson
b. Bef 1877
10
Elizabeth Randolph Adamson
[1.2.5.5.6.2.5.1.1.1]
10
Mary Virginia Adamson
[1.2.5.5.6.2.5.1.1.2]
10
Jessie Buxton Adamson
[1.2.5.5.6.2.5.1.1.3]
10
George Delacey Adamson
[1.2.5.5.6.2.5.1.1.4]
b. 16 May 1914 d. 9 Sep 1915
9
Blanche Lewis Wardlaw
[1.2.5.5.6.2.5.1.2]
b. 6 Aug 1883
+
Frank Reeves Webb
9
Mary Louise Wardlaw
[1.2.5.5.6.2.5.1.3]
William McKeen Thompson
10
Randolph Murray Thompson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.1]
10
Addishon Hoge Thompson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.2]
10
Donald Wardlaw Thompson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.3]
10
Jr. William McKeon Thompson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.4]
10
Delacey Alexander Thompson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.5]
William MacKeen Thomson
b. 26 Jun 1882 d. 9 Aug 1970
10
Donald Wardlaw Thomson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.6]
10
DeLacey Alexander Thomson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.7]
10
William Mackeen Thomson, Jr.
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.8]
+
Rosalee M Malphurs
+
Helen M. Richardson
10
Addison Hoge Thomson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.9]
10
Randolph Murray Thomson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.10]
Mary H Turner
11
Laura Bennett Thomson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.10.1]
James Lowell Hemphill
12
Lee Hemphill
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.10.1.1]
10
David Mackeen Thomson
[1.2.5.5.6.2.5.1.3.11]
+
Valaria Jane Anderson
9
Carolyn Cunningham Wardlaw
[1.2.5.5.6.2.5.1.4]
b. 19 Jul 1891
John Jay Naugle
10
John Jay Naugle
[1.2.5.5.6.2.5.1.4.1]
8
Payton Harrison Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2]
b. 6 Jan 1858 d. 12 Oct 1940
Mary Stuart
b. 3 Feb 1862
9
Virginia Randolph Bolling Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.1]
b. 8 Jun 1884 d. 5 May 1937
+
Emidio San Germano
b. 13 Jun 1882 d. 13 Jun 1960
9
William Lacy Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.2]
b. 25 Nov 1885
Emily Tyron Mengel
b. 12 Mar 1892
10
Emily Tryon Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.2.1]
10
Mary Holladay Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.2.2]
10
William Lacy Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.2.3]
9
Mary Stuart Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.3]
b. 21 Feb 1887
+
George Harrison Houston
b. 4 Jan 1883 d. 9 Jul 1949
9
Jr. Payton Harrison Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.4]
b. 26 Jan 1889
Blanche Weissinger Smith
b. 14 Sep 1891
10
Payton Harrison Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.4.1]
10
Nell Hunt Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.4.2]
9
Elizabeth Addison Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.5]
b. 17 Jan 1891
+
Edmund Taylor Meriwether
b. 25 Jun 1881 d. 7 Jul 1961
9
Evelyn Cary Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.2.6]
b. 17 Aug 1897
+
George Jackson Mead
b. 27 Dec 1891
8
Dabney Carr Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.3]
b. 24 Feb 1860 d. 11 Aug 1861
8
William Hoge
[1.2.5.5.6.2.5.4]
b. 1 Mar 1864 d. 13 Aug 1868
7
William Wirt Harrison
[1.2.5.5.6.2.6]
b. 16 Feb 1837 d. 19 Jan 1880
7
Mary Clifton Harrison
[1.2.5.5.6.2.7]
b. 21 Apr 1839 d. 14 Mar 1862
7
Nancy Addison "Nannie" Harrison
[1.2.5.5.6.2.8]
b. 8 Aug 1841 d. 23 Feb 1862
7
Henry Tucker Harrison
[1.2.5.5.6.2.9]
b. 12 Jun 1844 d. 4 Mar 1914
7
Williana Irving Harrison
[1.2.5.5.6.2.10]
b. 27 Feb 1847
6
Nancy Addison Carr
[1.2.5.5.6.3]
b. Abt 1812
6
Dabney Jefferson Carr
[1.2.5.5.6.4]
b. 1817 d. 1826
5
Martha Carr
[1.2.5.5.7]
b. Abt 1775
4
Peter Field Jefferson
[1.2.5.6]
b. 16 Oct 1748 d. 29 Nov 1748
4
Jefferson
[1.2.5.7]
b. 9 Mar 1749/50 d. 9 Mar 1749/50
4
Lucy Jefferson
[1.2.5.8]
b. 10 Oct 1752 d. 1784
+
Charles Lilburn Lewis
b. Abt 1752 d. 1853
4
Randolph Jefferson
[1.2.5.9]
b. 1 Oct 1755 d. 15 Aug 1815
Anna Jefferson Lewis
b. Abt 1754 d. May 1808
5
James Lilburne Jefferson
[1.2.5.9.1]
b. 1784 d. 1874
+
Mitchie Pryor
d. Aft 1814
4
Anna Scott Jefferson
[1.2.5.10]
b. 1 Oct 1755 d. 1805
+
Hastings Marks
d. Aft 1788
3
Mary Jefferson
[1.2.6]
b. 1709 d. 13 Apr 1755
Jr. Thomas Turpin
b. 9 May 1708 d. 20 Jun 1790
4
Anne Obedience Turpin
[1.2.6.1]
b. 17 Sep 1734 d. 8 Aug 1800
John Jordan Harris
b. 1732 d. Bef 19 Nov 1800
5
Lucy Harris
[1.2.6.1.1]
b. 1756 d. 1832
Obadiah Smith
b. Abt 1756
6
Mary Burke Smith
[1.2.6.1.1.1]
b. 9 Jun 1781
5
Carolina Matilda Harris
[1.2.6.1.2]
b. 1 Dec 1756 d. 1815
+
Thomas Harris
b. Abt 1756
5
John Turpin Harris
[1.2.6.1.3]
b. 12 Oct 1758 d. 1815
Rebecca Britton
b. Abt 1770
6
Hiram Harris
[1.2.6.1.3.1]
b. 15 Sep 1796 d. 3 Jun 1867
Margaret Christian Harris
b. Abt 1796 d. Mar 1825
7
Rebecca Ann Harris
[1.2.6.1.3.1.1]
b. 3 Mar 1823
+
Alfred Douglas
b. Abt 1823
+
John Wilson
b. Abt 1823
7
Henry Benskin Christian Harris
[1.2.6.1.3.1.2]
b. 3 Feb 1825
Sarah C. Calvert
b. 9 Mar 1834/1835 d. 18 Mar 1865
8
Rebecca D Harris
[1.2.6.1.3.1.2.1]
b. 20 May 1852
+
Spencer L Barnes
b. Abt 1852
8
Hiram Henry Harris
[1.2.6.1.3.1.2.2]
b. 31 Jul 1855
8
Martha W. Harris
[1.2.6.1.3.1.2.3]
b. 7 Aug 1859
+
Jesse Gordon Roach
b. 1855 d. 1937
8
Catherine B. Harris
[1.2.6.1.3.1.2.4]
b. Aug 1861
+
William T. Barnett
b. Abt 1861
8
James Clay Harris
[1.2.6.1.3.1.2.5]
b. 16 Oct 1868
+
Mary Anderson
b. Abt 1868
+
Sarah A. Farris
Elizabeth Ann Daniels
b. 17 Oct 1842
8
Margaret Christian Harris
[1.2.6.1.3.1.2.6]
b. 10 Jan 1871
+
James A. Gaunt
b. Abt 1870
8
Pauline B. Harris
[1.2.6.1.3.1.2.7]
b. 20 Apr 1873 d. 29 Oct 1974
8
Robert D. Harris
[1.2.6.1.3.1.2.8]
b. 31 Mar 1875 d. 8 Oct 1875
8
Sallie Tilden Harris
[1.2.6.1.3.1.2.9]
b. 9 Sep 1877 d. 1952
+
James Henry Brown
b. 1869 d. 1949
8
William Henry "Hiram" Harris
[1.2.6.1.3.1.2.10]
b. 7 May 1879 d. 1944
Anna E. Ogden
b. 1884 d. 1941
9
Miles Franklin Harris
[1.2.6.1.3.1.2.10.1]
8
Mary Harris
[1.2.6.1.3.1.2.11]
b. 15 Jun 1880
Robert Granville Gaunt
b. Abt 1880
9
Mary Gladys Gaunt
[1.2.6.1.3.1.2.11.1]
b. Abt 1902
8
Jesse B. Harris
[1.2.6.1.3.1.2.12]
b. Mar 1882
Margaret Wilson
b. Abt 1796 d. Abt 1827
7
Mary Eleanor Harris
[1.2.6.1.3.1.3]
b. 28 Sep 1827
Elizabeth George
b. Abt 1796
7
John Wilson Harris
[1.2.6.1.3.1.4]
b. 1837 d. Aft 1867
7
Jr. Hiram Harris
[1.2.6.1.3.1.5]
b. 1840
+
Frances Gordon
b. Abt 1840
7
Mary Eleanor Harris
[1.2.6.1.3.1.6]
b. Abt 1845
+
McRae
b. Abt 1845
7
Margaret Elizabeth Harris
[1.2.6.1.3.1.7]
b. 1847
John E. Benson
b. Abt 1847
8
Eleanor Harris Benson
[1.2.6.1.3.1.7.1]
b. Abt 1870
+
Frances Gordon
b. Abt 1825
5
Judith Harris
[1.2.6.1.4]
b. 1760
+
John Crittenden
b. Abt 1759
5
Jordan Turpin Harris
[1.2.6.1.5]
b. 20 May 1763 d. 1826
Elizabeth Mosby Cannon
b. Abt 1763
6
James Madison Harris
[1.2.6.1.5.1]
b. 1776
Caroline John
b. Abt 1776
7
Md William Jordan Harris
[1.2.6.1.5.1.1]
b. Abt 1800
+
Mary Helen Epes
b. Abt 1800
6
Horatio Turpin Harris
[1.2.6.1.5.2]
b. 1799 d. 1855
+
Keturah
b. Abt 1799
6
John Francis Harris
[1.2.6.1.5.3]
b. 1808 d. 1880
+
Mary Duke Patten
b. Abt 1808
+
Ann Price
b. Abt 1763
5
Mary Elizabeth Josepha Harris
[1.2.6.1.6]
b. 1767
5
Francis Turpin Harris
[1.2.6.1.7]
b. 7 May 1768 d. 5 Dec 1836
+
Sally Gaines
b. Abt 1768
5
Polly Harris
[1.2.6.1.8]
b. 1774
3
Martha Jefferson
[1.2.7]
b. Abt 1712 d. 20 Oct 1796
Bennett Goode
b. Abt 1710 d. 1771
4
Martha Goode
[1.2.7.1]
b. 1760 d. 1810
Charles Povall
b. 1763 d. 1803
5
Martha Povall
[1.2.7.1.1]
b. 1 Nov 1784
William Carrington
b. 20 Aug 1774 d. 21 May 1825
6
Martha Ann Carrington
[1.2.7.1.1.1]
b. 26 Feb 1806 d. 29 Apr 1865
Codrington Carrington
b. 23 Oct 1801 d. 10 Sep 1859
7
Willie Ann Carrington
[1.2.7.1.1.1.1]
b. 13 Jun 1833
7
Ellen Maria Carrington
[1.2.7.1.1.1.2]
b. 22 Mar 1836 d. 14 Jul 1873
+
Fox
7
Martha Virginia Carrington
[1.2.7.1.1.1.3]
b. 2 Apr 1839
+
E. C. Mayo
7
Robert Codrington Carrington
[1.2.7.1.1.1.4]
b. 6 Sep 1842
Hellen C. Walton
b. Cal 1846
8
Martha Elvira Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.1]
b. 10 Sep 1867
8
Nathaniel W. Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.2]
b. Jul 1868
+
Myrtle H.
Anna V. Woodson
b. Oct 1868 d. Bef 1910
9
Robert Miller Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.2.1]
9
Lilly Marie Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.2.2]
+
Walton
9
William Blair Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.2.3]
+
Bessie Patterson
b. 18 Jun 1903 d. Sep 1974
9
Alvin Roy Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.2.4]
b. 3 Nov 1900 d. Feb 1970
+
Carrie S.
9
James N. Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.2.5]
8
Collin Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.3]
b. Cal 1870
8
Minnie M. Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.4]
b. Cal 1872
8
Lillian Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.5]
b. Cal 1874
8
Bernard Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.6]
b. Feb 1879
8
Rose Carrington
[1.2.7.1.1.1.4.7]
b. Abt 1880
7
William A. Carrington
[1.2.7.1.1.1.5]
b. 22 Sep 1843 d. 25 Sep 1843
7
Cornelia Booker Carrington
[1.2.7.1.1.1.6]
b. 1 Feb 1845
+
T. B. S. Walton
6
Ellen Theodosia Carrington
[1.2.7.1.1.2]
b. 1813 d. 1896
William Royal Bradley
b. 1804 d. 1889
7
Martha Carrington Bradley
[1.2.7.1.1.2.1]
b. 1826/1847 d. 1862/1933
Thomas Pride Shields
b. 1808/1837 d. 1862/1922
8
Martha Tomasia Shields
[1.2.7.1.1.2.1.1]
b. 21 Aug 1859 d. 15 Aug 1944
Joseph Cosgray Sweeney
b. 23 Dec 1859 d. 2 Apr 1945
9
James Chamberlain Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1]
Helen Armstrong
b. 5 Aug 1897 d. 6 Aug 1970
10
Ruth Beverly Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1]
William Reese Swift
11
Jr. William Reese Swift
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1.1]
Kathie Fair
12
Kelly Swift
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1.1.1]
12
Michael Neal Swift
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1.1.2]
12
Kenneth William Swift
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1.1.3]
11
Susan Gaye Swift
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1.2]
III John Neill
12
IV John Neill
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1.2.1]
12
Shannon Neill
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1.2.2]
+
John Stoneburner
11
Kimberly Swift
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.1.3]
+
Beverley White
10
John Armstrong Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.2]
Inez Elane Potter
11
Brian Wade Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.2.1]
Cathy Rose McPherson
12
Jr. Brian Wade Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.2.1.1]
12
Jennifer Rose Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.2.1.2]
11
James C. Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.2.2]
10
James Carrington Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3]
Elizabeth Boehmer
11
Shawn Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.1]
Tim Mortenson
12
Vallery Mortensen
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.1.1]
12
Katherin Mortensen
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.1.2]
11
Shannon Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.2]
Edward Popore
12
Spencer Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.2.1]
12
Max Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.2.2]
11
Kate Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.3]
+
Jeff Broihier
11
Sam Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.4]
Yvonne Cosgrave
12
Quinlan Rose Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.3.4.1]
10
Helen Jean Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.4]
b. 30 Jul 1921 d. 1928
10
Robert Stewart Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.5]
b. 4 Nov 1925 d. 30 Sep 1964
Beverly Jean Willis
11
Kathaleen Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.5.1]
+
Doug Mathes
11
Michael Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.5.2]
Mary Ellen Kelley
12
Jack Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.5.2.1]
11
Carolyn Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.5.3]
+
Timothy Carmichael
11
Jr. Robert Stewart Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.5.4]
Joanna
12
Jayson Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.5.4.1]
12
Millisa Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.1.5.4.2]
9
Thomas Shields Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.2]
b. 19 Dec 1894 d. 27 Apr 1974
Hildred Ashbaugh
10
Dorathea Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.1]
Eugene C. Werst
11
Linda Bassler Werst
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.1.1]
12
Leigh Anne
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.1.1.1]
12
Alissa Marie
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.1.1.2]
11
Karen Madsen Werst
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.1.2]
12
Craig Axel
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.1.2.1]
12
Sarah Dorothea
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.1.2.2]
11
Robert Werst
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.1.3]
10
Jr. Thomas Shields Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.2]
Dorthy Schiderer
11
Larry Shields Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.2.1]
Maryann Tarpy
12
James Shields Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.2.1.1]
12
Joseph Carrington Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.2.1.2]
11
Patricia Marie Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.2.2]
+
Kenneth Coakley
11
Barbara Jeanne Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.2.3]
Rodney Lee Combs
12
James "T.J." Combs
[1.2.7.1.1.2.1.1.2.2.3.1]
9
Richmond Carrington Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.3]
b. 18 Sep 1896 d. 12 Aug 1966
9
Ruth Virginia Sweeney
[1.2.7.1.1.2.1.1.4]
+
Alice
b. Abt 1679 d. Bef 1723
2
Martha Jefferson
[1.3]
b. 23 Feb 1681/82 d. Bef 23 Jul 1754
Robert Wynne
b. 1685 d. 12 Jul 1754
3
Angelica Wynne
[1.3.1]
b. Abt 1710
William Raines
4
Robert Wynne Raines
[1.3.1.1]
b. 25 Jun 1739
4
Jefferson Raines
[1.3.1.2]
b. 10 Nov 1744
4
Anna Raines
[1.3.1.3]
b. 22 Jul 1746
4
Nathaniel Raines
[1.3.1.4]
b. 21 Mar 1747/48
4
Theodosia Raines
[1.3.1.5]
b. 10 Dec 1749
3
Lucretia Wynne
[1.3.2]
b. 1712/13
Joseph Tudor Tucker
b. Abt 1710
4
Martha Tucker
[1.3.2.1]
b. Abt 1730
+
Benjamin Bell
b. Abt 1725 d. 1773
4
Robert Tucker
[1.3.2.2]
b. 8 Sep 1739
4
Joel Tucker
[1.3.2.3]
b. Abt 1741
4
Lucretia Tucker
[1.3.2.4]
b. Abt 1743
3
Martha Wynne
[1.3.3]
b. 1715
Matthew Parham
b. Abt 1697
4
Angelica Parham
[1.3.3.1]
b. 7 Jun 1745
4
Robert Parham
[1.3.3.2]
b. Jan 1747/48
4
Elizabeth Parham
[1.3.3.3]
b. Abt 1749
4
Jr. Matthew Parham
[1.3.3.4]
b. 27 Feb 1750/51
3
Carnelia Wynne
[1.3.4]
b. Abt 1717
3
Anne Wynne
[1.3.5]
b. Abt 1719
Thomas Butler
b. Abt 1719
4
Martha Butler
[1.3.5.1]
b. 8 Nov 1741
4
Mary Butler
[1.3.5.2]
b. 21 Mar 1742/43
+
Joseph Mattox
b. Abt 1660