News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Calendar
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Bookmarks
Contact Us
Register for a User Account
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
John Pledge
1642 - Bef 1704 (< 61 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Pledge
[1]
b. 1613/1642 d. Bef 1704
2
Esther Pledge
[1.1]
b. Abt 1644 d. 1703/1759
John Cannon
b. Abt 1642 d. Bef Sep 1696
3
William Cannon
[1.1.1]
b. Abt 1673 d. Bef Aug 1747
Judith Woodson
b. Abt 1673 d. Bef Jun 1733
4
Elizabeth Cannon
[1.1.1.1]
b. Abt 1708 d. Abt 1741
III Abraham Childers
b. Abt 1681 d. Abt 1763
5
William Cannon Childers
[1.1.1.1.1]
b. Abt 1718 d. Aft 1765
5
IV Abraham Childers
[1.1.1.1.2]
b. Abt 1702
5
Sophia Childers
[1.1.1.1.3]
b. Abt 1706
Samuel Taylor
6
Richard Taylor
[1.1.1.1.3.1]
b. 1724/1762 d. 1745/1840
+
Susan
b. 1724/1768 d. 1745/1847
6
Joseph Taylor
[1.1.1.1.3.2]
b. 1724/1762 d. 1745/1840
+
Judith Gilliam
b. 1724/1768 d. 1745/1847
+
Sarah Mosely
b. 1724/1768 d. 1745/1847
6
Thomas Taylor
[1.1.1.1.3.3]
b. 1724/1762 d. 1745/1840
+
Lucy
b. 1724/1768 d. 1745/1847
6
Mary Taylor
[1.1.1.1.3.4]
b. 1724/1762 d. 1742/1843
+
Henry Bagly
b. 1716/1760 d. 1742/1837
6
Frances Taylor
[1.1.1.1.3.5]
b. 1741/1768 d. 1790/1858
+
Thomas Crump
b. 1733/1765 d. 1790/1852
6
Creed Taylor
[1.1.1.1.3.6]
b. Abt 1766 d. 17 Jan 1836
+
Sarah Woodson
b. 1774 d. Abt 1861
6
Jr. Samuel Taylor
[1.1.1.1.3.7]
Elizabeth Hughes
7
Sophia Childress Taylor
[1.1.1.1.3.7.1]
b. 19 Oct 1792 d. 19 Jan 1879
+
Moses Owsley Bledsoe
b. 6 Feb 1788 d. 17 Nov 1851
7
III Samuel Taylor
[1.1.1.1.3.7.2]
b. 15 Sep 1781 d. 23 Feb 1853
Martha Woodson
b. 1785 d. Yes, date unknown
8
Ann Jane Taylor
[1.1.1.1.3.7.2.1]
b. Abt 1805
+
William Yates Gholson
8
IV Samuel Taylor
[1.1.1.1.3.7.2.2]
b. Abt 1808
+
Sydney Brown
+
Frances Brown
8
Creed Taylor
[1.1.1.1.3.7.2.3]
b. Abt 1806
+
Lucy Matilda Woodson
b. 21 Dec 1811 d. Aft 1870
5
Tabitha Childers
[1.1.1.1.4]
b. Abt 1710
+
Dawson
b. 1692/1728 d. 1718/1807
5
Lucretia Childers
[1.1.1.1.5]
b. Abt 1722 d. Bef 1787
Matthew Tucker
b. Abt 1728 d. Jun 1796
6
John Tucker
[1.1.1.1.5.1]
b. Abt 1753
+
Rhoda Powell
b. 1734/1761 d. 1783/1851
6
Whitefield Tucker
[1.1.1.1.5.2]
b. Abt 1766
6
Louisa Tucker
[1.1.1.1.5.3]
b. Abt 1758 d. Bef Mar 1790
+
Christopher Irvine
b. 1726/1758 d. 1783/1845
6
Lucretia Edee Tucker
[1.1.1.1.5.4]
b. Abt 1762
John Fuqua Maxey
b. 1757 d. 1790
7
Catherine P. Maxey
[1.1.1.1.5.4.1]
b. 1780
+
Jr. John Irvine
b. 1778
7
James Maxey
[1.1.1.1.5.4.2]
b. Abt 1782 d. Abt 1820
7
Susanna Maxey
[1.1.1.1.5.4.3]
+
William Woodfin
6
Jesse Tucker
[1.1.1.1.5.5]
b. 1764
+
Nancy Layne
b. 1747/1774 d. 1796/1864
6
Joseph Tucker
[1.1.1.1.5.6]
b. Abt 1751
6
Isaiah Tucker
[1.1.1.1.5.7]
b. Abt 1756
6
Sarah Tucker
[1.1.1.1.5.8]
b. Abt 1752
+
Charles Ellis
b. 1718/1750 d. 1775/1837
6
Mary Ann Tucker
[1.1.1.1.5.9]
b. Abt 1755
+
John Irvin
b. 1720/1752 d. 1777/1839
6
Scena Tucker
[1.1.1.1.5.10]
b. Abt 1768
6
Betsey Ann Tucker
[1.1.1.1.5.11]
b. Abt 1772
+
Garland Hurt
b. 1736/1768 d. 1793/1855
6
Drury Tucker
[1.1.1.1.5.12]
b. Abt 1750
5
Elizabeth Childers
[1.1.1.1.6]
b. Abt 1714
James Thomas
b. 1703/1733 d. 1801
6
Sophia Thomas
[1.1.1.1.6.1]
b. 1731/1758 d. 1780/1848
+
Peter Parrish
b. 1723/1755 d. 1780/1842
6
Lucy Thomas
[1.1.1.1.6.2]
b. 1726/1774 d. 1745/1855
+
Dawson
b. 1720/1772 d. 1745/1850
6
Jesse Thomas
[1.1.1.1.6.3]
b. 1734/1761 d. 1786/1847
+
Jane Bowles
b. Dec 1757 d. 1786/1851
6
Joshua Thomas
[1.1.1.1.6.4]
b. 1726/1774 d. 1741/1853
6
Elizabeth Haskins Thomas
[1.1.1.1.6.5]
b. 1726/1774 d. 1745/1855
+
Turner
b. 1720/1772 d. 1745/1850
6
James Thomas
[1.1.1.1.6.6]
b. 1726/1774 d. 1741/1853
6
Jane Thomas
[1.1.1.1.6.7]
b. 1748/1772 d. 1791/1860
+
Anderson Bowles
b. May 1764 d. 1791/1855
6
Sally Thomas
[1.1.1.1.6.8]
b. 1754/1781 d. 1803/1871
+
James Boatright
b. 1746/1778 d. 1803/1865
6
Abraham Thomas
[1.1.1.1.6.9]
b. 1726/1774 d. 1741/1853
6
Joseph Thomas
[1.1.1.1.6.10]
b. 1726/1774 d. 1741/1853
5
Mary Ann Childers
[1.1.1.1.7]
b. Abt 1716
+
Carter
b. 1692/1728 d. 1718/1807
5
Creed Childers
[1.1.1.1.8]
b. Abt 1724
5
Childers
[1.1.1.1.9]
David Prior
6
Jr. David Prior
[1.1.1.1.9.1]
b. 1724/1762 d. 1733/1840
4
John Cannon
[1.1.1.2]
b. Abt 1709 d. 21 May 1757
Martha Woodson
b. Abt 1716 d. Aft 1783
5
William Cannon
[1.1.1.2.1]
b. 18 Nov 1749 d. 18 Sep 1819
Sarah Mosby
b. 17 Feb 1751 d. Bef 1798
6
Martha Cannon
[1.1.1.2.1.1]
b. 1775 d. Oct 1817
Silas F. Flournoy
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
7
Alfred Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
8
William Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
9
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
9
William Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.1.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
9
Alfred Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.1.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
9
Lucien Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.1.4]
b. 22 Feb 1861
8
Alonzo Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
9
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.2.1]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
10
Genevieve McRady
[1.1.1.2.1.1.1.2.1.1]
9
James Patteson Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.2.2]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
9
Belle Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.2.3]
9
Theodosia Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.2.4]
8
James Silas Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.3]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
8
Eliza Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.4]
b. 29 May 1829 d. INFANT
8
Alfred F. Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.5]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
9
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.5.1]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
9
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.5.2]
b. 21 Feb 1875
9
Mary Patteson Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.5.3]
b. 24 Apr 1866
9
Spencer Alston Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.5.4]
b. Aug 1879
8
Martha Moore Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.6]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
8
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.7]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
9
Alfred F. Wilson
[1.1.1.2.1.1.1.7.1]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
9
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.1.2.1.1.1.7.2]
9
Alice Wilson
[1.1.1.2.1.1.1.7.3]
+
Charles Davis
9
Ruth Wilson
[1.1.1.2.1.1.1.7.4]
+
B. H. Davis
9
Pattie Wilson
[1.1.1.2.1.1.1.7.5]
Milton Walker Sims
10
Laura Sims
[1.1.1.2.1.1.1.7.5.1]
b. 1873
+
J. Fred Smith
b. Abt 1870
10
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.1.2.1.1.1.7.5.2]
b. 1872
+
Charles Mills
10
Milton Sims
[1.1.1.2.1.1.1.7.5.3]
b. 1876
10
Bartlett Sims
[1.1.1.2.1.1.1.7.5.4]
b. May 1878
+
Almaide Priscilla Kerr
9
Laura Wilson
[1.1.1.2.1.1.1.7.6]
Thomas Bell
10
Mary Bell
[1.1.1.2.1.1.1.7.6.1]
+
Edward Gleason
9
Mary Wilson
[1.1.1.2.1.1.1.7.7]
+
Napoleon Davis
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
8
Charles Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.8]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
8
David Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.9]
b. 1842 d. 1856
8
Maria Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.10]
b. 1837 d. 1841
8
Mary Camp Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
8
Martha Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.12]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
8
Indiana Flournoy
[1.1.1.2.1.1.1.13]
b. 1847
7
Eliza Susan Flournoy
[1.1.1.2.1.1.2]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
8
Alfred H. Harris
[1.1.1.2.1.1.2.1]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
8
Eliza Susan Harris
[1.1.1.2.1.1.2.2]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
8
Martha Harris
[1.1.1.2.1.1.2.3]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
7
William Cannon Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
8
Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.1]
b. 1833 d. 1833
8
Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.2]
b. 1829 d. 1829
8
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.3]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
9
Myra Rivers
[1.1.1.2.1.1.3.3.1]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
9
Julian Rivers
[1.1.1.2.1.1.3.3.2]
b. 23 Dec 1868
9
William Cannon Rivers
[1.1.1.2.1.1.3.3.3]
b. 11 Jan 1866
9
Tyree Rodes Rivers
[1.1.1.2.1.1.3.3.4]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
9
John Harper Rivers
[1.1.1.2.1.1.3.3.5]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
9
Flournoy Rivers
[1.1.1.2.1.1.3.3.6]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
10
John Avirett Rivers
[1.1.1.2.1.1.3.3.6.1]
b. 22 Mar 1894
8
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.4]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
9
Ezell Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.4.1]
b. 9 Dec 1878
9
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.4.2]
b. 13 Sep 1875
9
John Walker Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.4.3]
b. 24 Jan 1874
9
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.4.4]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
9
III William Cannon Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.4.5]
b. 8 Apr 1872
8
John J. Flournoy
[1.1.1.2.1.1.3.5]
b. 1838
7
Mary Amanda Flournoy
[1.1.1.2.1.1.4]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
8
Mary Eliza Field
[1.1.1.2.1.1.4.1]
b. 1 Jul 1825
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
9
Myra Flournoy Knapp
[1.1.1.2.1.1.4.1.1]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
9
Maud Officer
[1.1.1.2.1.1.4.1.2]
b. 9 May 1847
9
Eustis Field Officer
[1.1.1.2.1.1.4.1.3]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
9
William P. Officer
[1.1.1.2.1.1.4.1.4]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
8
James Alexander Field
[1.1.1.2.1.1.4.2]
b. 30 May 1823
8
Jr. William Hume Field
[1.1.1.2.1.1.4.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
8
Julian Clarence Field
[1.1.1.2.1.1.4.4]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
8
Silas Flournoy Field
[1.1.1.2.1.1.4.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
8
Margaret Julia Field
[1.1.1.2.1.1.4.6]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
8
Henrietta Field
[1.1.1.2.1.1.4.7]
b. 1833 d. 1833
8
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.1.2.1.1.4.8]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
8
Florence Huntley Field
[1.1.1.2.1.1.4.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
7
Julia Ann Flournoy
[1.1.1.2.1.1.5]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
8
Hume Rigg Feild
[1.1.1.2.1.1.5.1]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
8
Eliza Mildred Feild
[1.1.1.2.1.1.5.2]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
9
Julia Batte
[1.1.1.2.1.1.5.2.1]
+
W. R. Garrett
9
Mildred Batte
[1.1.1.2.1.1.5.2.2]
9
E. F. Batte
[1.1.1.2.1.1.5.2.3]
7
Madison Flournoy
[1.1.1.2.1.1.6]
b. 1807
7
Martha C. Flournoy
[1.1.1.2.1.1.7]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
8
Silas Flournoy Trotter
[1.1.1.2.1.1.7.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
7
Silas Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
8
Mary Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.1]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
9
Elizabeth Rivers
[1.1.1.2.1.1.8.1.1]
b. Bef 1865
9
James P. Rivers
[1.1.1.2.1.1.8.1.2]
b. Bef 1863
9
Mary Rivers
[1.1.1.2.1.1.8.1.3]
b. Bef 1867
9
Silas Flournoy Rivers
[1.1.1.2.1.1.8.1.4]
b. Bef 1871
9
William W. Rivers
[1.1.1.2.1.1.8.1.5]
b. Bef 1869
9
Martha Rivers
[1.1.1.2.1.1.8.1.6]
b. Bef 1873
8
Camp Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
9
Lucien Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
10
Lillian May Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.1.1]
b. 1906
10
Mary Wise Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.1.2]
b. 1911
10
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.1.3]
10
Laura Louise Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.1.4]
10
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.1.5]
9
John Wise Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
10
Louise Wise Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.2.1]
b. 1907
10
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.2.2]
b. 1912
Minnie Childress Cole
11
Thomas Cole Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.2.2.1]
10
Camp Rogers Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.2.3]
10
Betty McAfee Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.2.4]
9
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
10
Eloise Walker
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
+
Raymond Grady Thomas
10
Newton Flournoy Walker
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
+
Rose Mary Bozeman
+
Valta Irene Gholston
10
Lucien John Walker
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972
Janie Lucile Stallcup
b. 1912
11
Lou Anne Walker
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.3.1]
Duane Tarrant
12
Lucien Clyde Tarrant
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.3.1.1]
12
Nola Tarrant
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.3.1.2]
12
William Rusk Tarrant
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.3.1.3]
+
Frank Casey
10
Jane Louise Walker
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.4]
+
Benjamin Elliot Mosher
10
Jacob Camp Walker
[1.1.1.2.1.1.8.2.3.5]
+
Ouida Louise Gill
9
Augusta Mary Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
10
Georgia Louia May
[1.1.1.2.1.1.8.2.4.1]
b. 1899
10
Julia Flournoy May
[1.1.1.2.1.1.8.2.4.2]
Robert Henry Mays
11
Judy Mays
[1.1.1.2.1.1.8.2.4.2.1]
11
Robert Mays
[1.1.1.2.1.1.8.2.4.2.2]
d. INFANT
10
Elizabeth Wise May
[1.1.1.2.1.1.8.2.4.3]
b. 1902
10
James Kathryn May
[1.1.1.2.1.1.8.2.4.4]
b. 1902
10
Norma Lucile May
[1.1.1.2.1.1.8.2.4.5]
b. 1902
9
Julia Rivers Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
10
Lucien Wise Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.1]
10
Andrew Booty Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2]
Mattie Lou Shaw
11
Jr. Andrew Booty Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.1]
Arlene
12
Arthur Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.1.1]
[
=>
]
12
Andrew Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.1.2]
12
Jason Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.1.3]
12
Cynthia Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.1.4]
11
Lou Ann Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.2]
Rufus Taylor Higginbotham
12
Rufus Taylor Higginbotham
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.2.1]
12
Andrew Benjamin Higginbotham
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.2.2]
12
Laura Michelle Higginbotham
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.2.3]
11
John Franklin Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.3]
Judy
12
Julia Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.3.1]
12
Jennifer Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.3.2]
11
Gwen Elizabeth Jordan
[1.1.1.2.1.1.8.2.5.2.4]
9
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
10
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.6.1]
10
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.6.2]
10
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.2.6.3]
8
Lucien Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.3]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
9
Caroline Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.3.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
8
Elizabeth Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.4]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
9
Duncan
[1.1.1.2.1.1.8.4.1]
b. Bef 1870 d. 1876
9
Maude Eustace Duncan
[1.1.1.2.1.1.8.4.2]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
8
III Silas Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.5]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
9
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.5.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
9
Silas Camp Flournoy
[1.1.1.2.1.1.8.5.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
7
Sarah Flournoy
[1.1.1.2.1.1.9]
b. 1816
7
Louisa Ann Flournoy
[1.1.1.2.1.1.10]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
8
Laura Ann Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.1]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
9
Leroy M. Black
[1.1.1.2.1.1.10.1.1]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
9
Louisa Catherine Black
[1.1.1.2.1.1.10.1.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
10
Mary Lou Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.1]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
11
Robert Lester Gilbert
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.1.1]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953
Ila Deane Griffin
12
Robert Parks Gilbert
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.1.1.1]
[
=>
]
+
Inez Timmerman
11
Sadie Louise Gilbert
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.1.2]
Harold Leigh Aymett
b. 11 Feb 1884 d. 6 Jul 1948
12
Marilouise Aymett
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.1.2.1]
[
=>
]
11
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.1.3]
11
Leon Gilbert
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.1.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
10
Ernest M. Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.2]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
10
Leroy Black Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.3]
b. 1864 d. 1934
10
James Carley Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.4]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
11
William Lambeth Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.4.1]
Joan Shuler
b. 3 Nov 1920 d. 25 May 1969
12
Laura Ann Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.4.1.1]
11
James Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.4.2]
10
Laura Jane Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.5]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
11
Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.5.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown
Dorothy
12
Jr. Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.5.1.1]
12
Frances Dickey
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.5.1.2]
11
Louise Dickey
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.5.2]
b. Jan 1899
Sharp
12
Lester Sharp
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.5.2.1]
12
Gilbert Sharp
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.5.2.2]
10
Frank Leon Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.6]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
11
Richard Leon Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.6.1]
Josephine Elizabeth Martin
12
Jr. Richard Leon Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.6.1.1]
12
Frank Martin Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.6.1.2]
10
Emily Olivia Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.7]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
11
Myra Tatum
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.7.1]
William Weakly Johnson
b. Abt 1895 d. Abt 1940
12
Mary Emily Johnson
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.7.1.1]
[
=>
]
12
Jr. William Weakly Johnson
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.7.1.2]
[
=>
]
12
John Tatum Johnson
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.7.1.3]
[
=>
]
11
Thomas Leroy Tatum
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.7.2]
10
John A. Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.8]
b. 1873 d. 1874/1963
10
Levair Lester
[1.1.1.2.1.1.10.1.2.9]
b. Abt 1869
9
Laura Ann Black
[1.1.1.2.1.1.10.1.3]
8
Flournoy Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.2]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
9
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.2.1]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
10
Martha Lafavre Bishop
[1.1.1.2.1.1.10.2.1.1]
10
Richard Yancey Bishop
[1.1.1.2.1.1.10.2.1.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
9
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.2.2]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
10
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.1]
Willie Crook
b. Abt 1901
11
Fergene Dawes Richmond
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.1.1]
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
10
Alice LaFavia Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.2]
+
Glen Carl Moody
10
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.3]
Mary Ona Kitchens
11
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.3.1]
Erma Pauline Lively
12
Michael Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.3.1.1]
[
=>
]
12
Susan Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.3.1.2]
[
=>
]
12
Matthew Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.3.1.3]
[
=>
]
12
Julie Marie Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.3.1.4]
[
=>
]
11
Frank Leslie Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.3.2]
+
Linda M Dickey
10
Thomas Asbury Dawes
[1.1.1.2.1.1.10.2.2.4]
b. 4 Apr 1895
9
Cora Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.2.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
9
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.2.4]
b. Jul 1882
8
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.3]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
9
Lucy M. Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.3.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
10
Rosa Mai Wilson
[1.1.1.2.1.1.10.3.1.1]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
10
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.1.2.1.1.10.3.1.2]
b. 1886
10
Thomas Webber Wilson
[1.1.1.2.1.1.10.3.1.3]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
10
George L Wilson
[1.1.1.2.1.1.10.3.1.4]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
10
Wilber Wilson
[1.1.1.2.1.1.10.3.1.5]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
11
Mabel Wilson
[1.1.1.2.1.1.10.3.1.5.1]
9
Webber Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.3.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
9
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.2.1.1.10.3.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
8
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
9
Adella Frances Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4.1]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
10
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
11
Francis Joseph Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.1]
11
John Patrick Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.2]
Paulina D. Lacasella
12
Pamela Ann Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.2.1]
12
Gregory Patrick Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.2.2]
12
Ursula Louise Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.2.3]
12
Blake Michael Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.2.4]
12
Jonathan Randall Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.2.5]
12
Leigh Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.2.6]
b. 3 Nov 1945 d. 15 Apr 1962
11
Jerome Anthony Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.3]
+
Reta Adeline Thibedeau
Doris Holyfield
12
Michael Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.3.1]
12
Patricia Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.3.2]
Ann Capello
12
Jerome Anthony Goodall, Jr.
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.3.3]
12
Mary Ann Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.3.4]
b. 25 Jun 1943 d. 25 Jun 1943
12
Anita C Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.3.5]
12
Katherine Elizabeth Goodall
[1.1.1.2.1.1.10.4.1.1.3.6]
+
Frank G Curran
9
Mamie J. Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4.2]
b. 8 Dec 1875 d. 18 Sep 1968
Maclovio De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
10
Orman Joe De Arnaz
[1.1.1.2.1.1.10.4.2.1]
+
Alma Viola
10
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.1.2.1.1.10.4.2.2]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
9
Robert Lee Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4.3]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
9
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4.4]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
9
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4.5]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
9
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4.6]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
10
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1]
Eugenia Joyce Barker
11
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1.1]
Wendell Wade Hennigh
12
Joshua Houle Hennigh
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1.1.1]
12
Lukas Wade "Luke" Hennigh
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1.1.2]
[
=>
]
11
Jennifer Alberta Houle
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1.2]
Richard C. Sandoval
12
Terresita Maria Sandoval
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1.2.1]
[
=>
]
12
Emilia Alberta Sandoval
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1.2.2]
11
Winifred Catherine Houle
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1.3]
Robert Eugene Cherry
12
Robert Lewis Scott Cherry
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.1.3.1]
[
=>
]
10
Anna Josephine Houle
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.2]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
11
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.2.1]
Cathy Ann Glessner
12
Darcy Catherine Currier
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.2.1.1]
[
=>
]
12
Kimberly Darcy Currier
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.2.1.2]
[
=>
]
10
Dorothy Louise Houle
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.3]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
11
John Dennis Scully
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.3.1]
11
Constance L Scully
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.3.2]
+
Newton
11
Brian C. Scully
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.3.3]
10
Alberta Isabel Houle
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4]
Jeptha Milton Gibbs, III
11
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.1]
Mary Melissa Meyers
12
Jeptha Milton Gibbs, V
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.1.1]
[
=>
]
12
Mary Melissa Gibbs
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.1.2]
11
Jane Gibbs
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.2]
+
Richard Calvin Torrey
11
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.3]
Jerry Hamilton Guild
12
Matthew Hamilton Guild
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.3.1]
12
Nancy J. Guild
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.3.2]
12
Christopher Parsons Guild
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.3.3]
12
Peter Christopher Guild
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.3.4]
12
Bonnie C. Guild
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.3.5]
11
Edward Thurston Gibbs
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.4]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
11
William Houle Gibbs
[1.1.1.2.1.1.10.4.6.4.5]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
9
Edna Emma Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
10
Anita Ruth Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.1]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
10
Helen May Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.2]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
10
Howard Joseph Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.3]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
11
Anthony Howard Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.3.1]
11
Stephnie Jeane Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.3.2]
+
Joseph Michael Flynn
11
Nicholas Joseph Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.3.3]
+
Johnna M Verardo
+
Edna Mae Thompson
10
Edna Dorothy Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.4]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
10
Norman Francis Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5]
Margaret (Peggy) Louise Clark
11
Michael Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.1]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
11
Norma Louise Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.2]
Richard Eugene Polen
12
Michael Eugene Polen
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.2.1]
12
Lisa Ann Polen
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.2.2]
12
Holly Louise Polen
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.2.3]
12
Amy Elizabeth Polen
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.2.4]
11
Nancy Nell Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.3]
William Richard Mann
12
Steven Joseph Mann
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.3.1]
[
=>
]
12
Gary Allen Francis Mann
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.3.2]
[
=>
]
12
Richard Lee Mann
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.3.3]
12
Leslie Melinda Mann
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.3.4]
[
=>
]
11
Joseph Edward Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.4]
Mary Helen Norman
12
Marilyn Marie Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.4.1]
[
=>
]
12
Michael Norman Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.5.4.2]
10
Kathryn Alberta Otero
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.6]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
11
Michael Allen McCune
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.6.1]
11
Patricia Lee McCune
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.6.2]
11
Barbara Ruth McCune
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.6.3]
Jewell Ray "Bud" DeShon
12
Linda Lee De Shon
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.6.3.1]
[
=>
]
12
Lori Rae De Shon
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.6.3.2]
[
=>
]
12
Larry Dean De Shon
[1.1.1.2.1.1.10.4.7.6.3.3]
[
=>
]
9
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.4.8]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
10
Anita H. Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
11
Edwin Arthur Heacock
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.1.1]
Dorothy Louise
12
Julie Heacock
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.1.1.1]
11
Caroll Jane Heacock
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.1.2]
11
Vivian L. Heacock
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.1.3]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
10
Chester Arthur Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
10
Flournoy Albert Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
10
Stanley St. Clair Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4]
Eleanor Louise Moore
11
Hollis Eleanor Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.1]
+
Lawrence Terry
Wesley Richard Peterson
12
Logan Sven Peterson
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.1.1]
12
Jordan S. Peterson
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.1.2]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
11
Stanley Robert Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.2]
Evelyn Elizabeth Perkins
12
Robert Erwin William Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.2.1]
12
Elizabeth Ann Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.2.2]
11
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.3]
Hugh Washburn Steven
12
Julia Warren Steven
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.3.1]
[
=>
]
12
David Hugh Steven
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.4.3.2]
[
=>
]
10
Louis Dewey Juch
[1.1.1.2.1.1.10.4.8.5]
8
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.5]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
8
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.2.1.1.10.6]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
9
Louisa Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.6.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
10
Rosalie E. McQuade
[1.1.1.2.1.1.10.6.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
9
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.6.2]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
9
Nellie M Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.6.3]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
9
Edna L. Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.6.4]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
9
William P. Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.6.5]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
9
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.6.6]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
8
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.7]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
8
Mary Julia Yancey
[1.1.1.2.1.1.10.8]
b. 1834
+
William D. Roberts
6
Elizabeth Mosby Cannon
[1.1.1.2.1.2]
b. 16 May 1771
6
Mary Cannon
[1.1.1.2.1.3]
b. Abt 1776
Elizabeth Chastain Cocke
b. 22 Jan 1753 d. Bef 1807
6
William Cannon, Jr.
[1.1.1.2.1.4]
b. 1796 d. Feb 1838
6
John James Cannon
[1.1.1.2.1.5]
b. 5 Sep 1794 d. 4 Jan 1850
+
Mary Price
b. Abt 1710 d. Bef 1733
3
Joseph Cannon
[1.1.2]
b. 1676/1696 d. 1681/1779
3
Mary Cannon
[1.1.3]
b. 1676/1696 d. 1680/1782
3
Jr. John Cannon
[1.1.4]
c. 1 Apr 1689 d. Feb 1734/35
Mary Price
b. Bef 2 Feb 1690/91 d. Aft 1745
4
III John Cannon
[1.1.4.1]
b. Abt 1712
4
William Cannon
[1.1.4.2]
b. Abt 1714
4
Elizabeth Cannon
[1.1.4.3]
b. 1716
4
Jane Cannon
[1.1.4.4]
b. Abt 1718
+
Samuel Pineham
b. 1699/1730 d. 1725/1811
4
Mary Price
[1.1.4.5]
b. Abt 1710 d. Bef 1733
+
John Cannon
b. Abt 1709 d. 21 May 1757
4
Judith Cannon
[1.1.4.6]
b. Abt 1720
Abraham Childers
b. Abt 1673 d. Abt 1720
3
Tabitha Childers
[1.1.5]
b. Abt 1698 d. 1699/1792
3
Abraham Childers
[1.1.6]
b. Abt 1700 d. Aft 1756
Mary
b. 1696/1715 d. 1721/1800
4
Abraham Childers
[1.1.6.1]
b. 1721/1749 d. 1746/1828
5
Mary Childers
[1.1.6.1.1]
b. 1746/1788 d. 1755/1867
5
Henry Childers
[1.1.6.1.2]
b. 1746/1788 d. 1755/1864
5
Frederick Childers
[1.1.6.1.3]
b. 1746/1781 d. Abt 1785
+
Ann
b. 1745/1774 d. 1764/1860
3
Elizabeth Childers
[1.1.7]
b. Abt 1697 d. Aft 1755
Stephen Hughes
b. Abt 1682 d. 1752
4
Joseph Hughes
[1.1.7.1]
b. Aft 1715 d. Abt 1756
+
Jane
b. 1711/1730 d. 1732/1814
4
Elizabeth Hughes
[1.1.7.2]
b. Aft 1715 d. Abt 1731
Sanburne Woodson
b. 11 Sep 1707 d. Bef 28 Jun 1756
5
Hughes Woodson
[1.1.7.2.1]
b. 1735 d. Jul 1806
Elizabeth Strange
b. 1760
6
Jr. Hughes Woodson
[1.1.7.2.1.1]
b. 30 May 1790 d. Abt Jan 1847
Sarah Mosby Winfrey
b. 16 Sep 1794
7
James Madison Woodson
[1.1.7.2.1.1.1]
b. 16 Jun 1812
7
Elizabeth Woodson
[1.1.7.2.1.1.2]
b. 12 Feb 1814 d. 11 Oct 1825
7
Martha T. Woodson
[1.1.7.2.1.1.3]
b. 2 Apr 1816 d. Abt 1861
+
Joseph Woodson
b. 8 Jan 1816 d. UNKNOWN
7
Hughes A. Woodson
[1.1.7.2.1.1.4]
b. 13 Mar 1818
7
Gustavas B. Woodson
[1.1.7.2.1.1.5]
b. 25 May 1820
7
Nancy S. Woodson
[1.1.7.2.1.1.6]
b. 12 Mar 1824
7
Malissa Page Woodson
[1.1.7.2.1.1.7]
b. 2 Jan 1826 d. 11 Nov 1902
7
Sarah Ellen Woodson
[1.1.7.2.1.1.8]
b. 26 Aug 1830
+
Thomas Woodson
d. UNKNOWN
7
William Henry Woodson
[1.1.7.2.1.1.9]
b. 18 Dec 1833 d. 15 Jun 1915
Cordelia Ann Noffsinger
b. 6 Dec 1868 d. 2 Jan 1914
8
Ethel Beulah Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.1]
b. Sep 1896
8
Eula May Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.2]
b. Jan 1898
8
Hughes W. Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.3]
b. Jan 1900
8
Pearl Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.4]
b. 1903
8
Clytie D. Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.5]
b. 1905
8
Elizabeth Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.6]
b. 1908
Isabella Ramsey
b. 18 May 1854
8
Velotia Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.7]
b. 31 Oct 1870 d. 13 Apr 1959
+
Alonza Brown
b. Abt 1871
8
George Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.8]
b. Cal 1876 d. 4 Oct 1913
8
Thomas Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.9]
8
John Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.10]
8
Mary Ellen Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.11]
8
James D. Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.12]
8
William Weaver Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.13]
8
Sarah M. Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.14]
8
Joseph Edward Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.15]
8
Virginia Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.16]
8
Lena Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.17]
8
Artie Woodson
[1.1.7.2.1.1.9.18]
7
Virginia Ann Woodson
[1.1.7.2.1.1.10]
b. 13 Jul 1835
6
Joseph Woodson
[1.1.7.2.1.2]
b. 1792
6
Sarah Woodson
[1.1.7.2.1.3]
b. 1782
6
Thomas Woodson
[1.1.7.2.1.4]
b. 1788
6
Samuel Woodson
[1.1.7.2.1.5]
b. 1794
John Woodson
b. 1730 d. 1792
5
Elizabeth Hughes Woodson
[1.1.7.2.2]
b. 12 May 1759 d. 15 Dec 1793
+
John Kennon
b. 1752 d. 12 Oct 1813
4
Judith Hughes
[1.1.7.3]
b. Aft 1715 d. 1729/1809
+
Cox
b. 1698/1718 d. 1732/1804
4
John Hughes
[1.1.7.4]
b. Aft 1735 d. 1774
Judith Michaux
b. 1731/1750 d. Aft 1774
5
John Hughes
[1.1.7.4.1]
b. 1755/1774 d. 1761/1857
2
Jr. John Pledge
[1.2]
b. 1641/1685 d. Abt Mar 1720/21
Dorothy Milner
b. Abt 1677 d. Abt 1733
3
Elizabeth Pledge
[1.2.1]
b. 1669/1718 d. 1688/1798
+
Straing
b. 1662/1716 d. 1688/1793
3
Mary Pledge
[1.2.2]
b. 1669/1718 d. 1688/1798
John Johnson
b. Abt 1700 d. 30 Jul 1750
4
Daniel Johnson
[1.2.2.1]
b. Abt 1734 d. 1754
Hannah Edwards
5
Obediah Johnson
[1.2.2.1.1]
b. Abt 1761 d. 7 Jun 1840
Polly Merryman
6
Louisiana Johnson
[1.2.2.1.1.1]
b. 1810 d. 1866
Isaac Otey Perkins
b. 27 May 1802 d. 16 Apr 1862
7
III Isaac Otey Perkins, Jr.
[1.2.2.1.1.1.1]
b. 20 Dec 1846 d. 18 Jan 1913
Margaret Lelia Hughes
b. 12 Dec 1850 d. 18 Dec 1940
8
Edwin Judson Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.1]
b. Abt 1880
+
Henrietta Tapscott Snead
b. Abt 1880
8
Nathaniel James Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.2]
b. 31 May 1877 d. 20 Apr 1962
Ethel Vernon Beard
b. 25 Sep 1879 d. 19 Jan 1934
9
Ethel Goodwin Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.2.1]
Leroy Eugene White
10
Nathaniel Perkins White
[1.2.2.1.1.1.1.2.1.1]
+
Sonja Lois Bragg
8
Lelia Cary Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.3]
8
Louise Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.4]
8
IV Isaac Otey Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.5]
8
Braxton Lee Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.6]
8
Jeter Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.7]
8
William Beckwith Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.8]
9
Jr. William Beckwith Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.8.1]
10
Betsy Temple Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.8.1.1]
+
Sargisson
+
Washburn
8
Robert Cleveland Perkins
[1.2.2.1.1.1.1.9]
7
Ann Judson Perkins
[1.2.2.1.1.1.2]
b. 24 Nov 1835 d. 2 May 1918
7
William Cary Perkins
[1.2.2.1.1.1.3]
b. 8 Oct 1837 d. 12 Jun 1858
7
Nathaniel James Perkins
[1.2.2.1.1.1.4]
b. 10 Oct 1840 d. 1861
7
Charles Jones Perkins
[1.2.2.1.1.1.5]
b. 16 Jul 1844 d. 16 Oct 1924
7
Edward Perkins
[1.2.2.1.1.1.6]
b. Abt 1847
6
Mary M. Johnson
[1.2.2.1.1.2]
b. Abt 1811
+
John Perkins
b. Abt 1795 d. 1848
3
III John Pledge
[1.2.3]
b. 1669/1718 d. 1684/1795
3
Agnes Pledge
[1.2.4]
b. 1669/1718 d. 1683/1798
3
Martha Pledge
[1.2.5]
b. 1669/1718 d. 1683/1798
3
Judith Pledge
[1.2.6]
b. 1669/1718 d. 1683/1798
3
Ann Pledge
[1.2.7]
b. 1669/1718 d. 1683/1798
3
William Pledge
[1.2.8]
b. 1669/1718 d. 1684/1795