News:
First Name:
Last Name:
Log In
Advanced Search
Surnames
What's New
Most Wanted
Albums
All Media
Cemeteries
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
DNA Tests
Statistics
Change Language
Register for a User Account
Home
Search
Login
Find
Surnames
What's New
Most Wanted
Reports
Cemeteries
Media
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
•
First Name:
Last Name:
ID:
Sara Rivière
1566 - 1596 (30 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Sara Rivière
[1]
b. 1566 d. 28 May 1596
Isaac Marcet
b. 2 May 1562 d. 6 Oct 1618
2
Jeanne (Giovanna) Marcet
[1.1]
b. 23 Mar 1591 d. 8 Apr 1663
Daniel Puerari
b. 14 Dec 1581 d. 14 Aug 1663
3
Judith Puerari
[1.1.1]
b. 8 Apr 1624 d. 14 Nov 1675
Jacques Flournoy
b. 19 Jul 1608 d. 19 Mar 1675
4
Jeanne Flournoy
[1.1.1.1]
b. 27 Nov 1645 d. 14 Nov 1688
+
Pierre Archimbaud
4
Sara Flournoy
[1.1.1.2]
b. 3 Jun 1647 d. 14 Jan 1647/48
4
Delie Flournoy
[1.1.1.3]
b. 31 Oct 1648
Goy
5
Jacqueline Goy
[1.1.1.3.1]
d. 1701
4
Jeanne-Marie Flournoy
[1.1.1.4]
b. 3 May 1651 d. 29 Aug 1724
+
Jaques Cartier
4
Elisabeth Flournoy
[1.1.1.5]
b. 26 Aug 1653
+
Michel Barrilliet
4
Anne-Gabrielle Flournoy
[1.1.1.6]
b. 3 Dec 1655 d. 17 Dec 1687
+
Jean Thomegay
4
Jacques Jean Flournoy
[1.1.1.7]
b. 15 Sep 1657 d. 22 Feb 1725
Julia Eyrand
b. 16 Aug 1664 d. 16 Aug 1756
5
Rachel Flournoy
[1.1.1.7.1]
b. 7 Apr 1685
5
Jean Jacques Flournoy
[1.1.1.7.2]
b. 17 Nov 1686 d. 23 Mar 1740
Mary Williams
b. 25 Dec 1695 d. 25 Mar 1740
6
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.7.2.1]
b. 5 Dec 1721 d. Jul 1793
Thomas Spencer
b. 5 Dec 1721 d. 2 Dec 1793
7
Mary Spencer
[1.1.1.7.2.1.1]
b. 20 Oct 1742 d. 5 Mar 1829
7
Sion Spencer
[1.1.1.7.2.1.2]
b. 12 Apr 1744 d. 4 Dec 1775
7
John Spencer
[1.1.1.7.2.1.3]
b. 16 Dec 1745 d. 26 May 1826
7
Elizabeth Julia Spencer
[1.1.1.7.2.1.4]
b. 18 Jun 1747 d. 1832
7
Ann Spencer
[1.1.1.7.2.1.5]
b. 13 Jul 1749 d. 1780
7
Jr. Thomas Spencer
[1.1.1.7.2.1.6]
b. 1751 d. 1806
Lucy A. Watkins
b. 1759 d. 1847
8
Thomas J. Spencer
[1.1.1.7.2.1.6.1]
b. 1795 d. 1822
Ann Eliza Eastham
b. 1803 d. 1881
9
James T. Spencer
[1.1.1.7.2.1.6.1.1]
b. 1821 d. 1886
Mary Elizabeth Leach
b. 1822 d. 1876
10
Fannie Venable Spencer
[1.1.1.7.2.1.6.1.1.1]
+
A. G. McIlwaine
10
Ann Thomas Spencer
[1.1.1.7.2.1.6.1.1.2]
+
F. H. Armistead
7
Samuel Flournoy Spencer
[1.1.1.7.2.1.7]
b. 5 Dec 1755 d. 9 Dec 1838
Agnes Woodson Daniel
b. 1754 d. 1799
8
Mary Phena "Polly" Spencer
[1.1.1.7.2.1.7.1]
b. 1796
8
Alexander R Spencer
[1.1.1.7.2.1.7.2]
b. 1816 d. 1908
7
Martha Owen Spencer
[1.1.1.7.2.1.8]
b. 7 Sep 1757 d. 5 Jun 1836
7
Gideon Spencer
[1.1.1.7.2.1.9]
b. 21 May 1760 d. 8 May 1822
6
Gédéon Flournoy
[1.1.1.7.2.2]
b. 19 Mar 1722 d. 1754
Jane Frances Sabourin
b. 21 Jul 1730 d. 1797
7
Gédéon Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1]
b. 21 Sep 1753 d. 25 Sep 1821
Jeanne-Françoise Delisle
b. 10 Nov 1755 d. 4 May 1832
8
Gédéon Jean François Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1]
b. 15 Jul 1784 d. 22 Jul 1863
Elizabeth Pernette Covelle
b. 17 Aug 1797 d. 2 Jan 1880
9
Alexandre Antoine Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1]
b. 10 Jan 1818 d. 9 Aug 1890
Caroline Claparède
b. 1831 d. 1875
10
Théodore Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1]
b. 15 Aug 1854 d. 5 Nov 1920
Marie Helene Burnier
b. 15 Aug 1856 d. 22 Aug 1909
11
Berthe-Alice Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.1]
b. 1 Mar 1881 d. 3 Jul 1965
11
Blanche Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.2]
b. 15 Jun 1882 d. 20 Apr 1905
11
Marguerite Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.3]
b. 31 Oct 1883 d. 10 Jun 1963
Albert Jean Alexandre Mottu
b. 21 Nov 1874 d. 10 Mar 1951
12
Théodore Auguste Roger Mottu
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.3.1]
[
=>
]
12
Yolande Renée Mottu
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.3.2]
[
=>
]
11
Henri Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.4]
b. 28 Mar 1886 d. 6 May 1955
Jeanne Elisabeth Richard
12
Elisabeth-Marie-Julie Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.4.1]
[
=>
]
12
Olivier-Louis-Théodore Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.4.2]
[
=>
]
11
Hélène Olga Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.5]
b. 28 Mar 1891 d. 1 Jan 1972
11
Ariane Dorothée Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.6]
Raymond de Saussure
b. 1884 d. 1970
12
Gerard de Saussure
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.6.1]
[
=>
]
12
Bertrand de Saussure
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.1.6.2]
10
Paul-Eugène-Edmond Flournoy
[1.1.1.7.2.2.1.1.1.2]
b. 2 Jan 1863 d. 6 Jul 1936
6
Samuel Flournoy
[1.1.1.7.2.3]
b. 4 Oct 1724 d. 12 Dec 1780
Elizabeth Harris
b. 31 Dec 1729 d. 19 May 1791
7
Ursula Harris Flournoy
[1.1.1.7.2.3.1]
b. 15 May 1749
James Bailey Harris
b. 1749
8
III James Harris
[1.1.1.7.2.3.1.1]
b. 1772 d. 1812
Obedience Jefferson Turpin
b. Abt 1772
9
Alfred Turpin Harris
[1.1.1.7.2.3.1.1.1]
b. Abt 1795
Catherine Brander
b. Abt 1794
10
Jr. Alfred Turpin Harris
[1.1.1.7.2.3.1.1.1.1]
b. Abt 1820
+
Julia Crittenden Hathaway
b. Abt 1820
8
Samuel Harris
[1.1.1.7.2.3.1.2]
b. Abt 1774
8
Elizabeth Harris
[1.1.1.7.2.3.1.3]
b. Abt 1776
8
Mary Harris
[1.1.1.7.2.3.1.4]
b. Abt 1778
7
Gideon Flournoy
[1.1.1.7.2.3.2]
b. 20 Feb 1751 d. 15 Feb 1821
+
Jane F DeLisle
Grace B. Tarry
b. 1755 d. 20 Dec 1819
8
"Mattie" Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.7.2.3.2.1]
b. 1795 d. 10 Oct 1855
Arthur Woodfin
b. 1790 d. 9 Oct 1855
9
William G. Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.1]
b. 1817
9
Richard M. Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.2]
b. 1817
9
Thomas E Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.3]
b. 1818
9
John James Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.4]
b. 19 Mar 1820 d. 23 Sep 1860
9
Charles Newton Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.5]
b. 31 Jul 1824 d. 2 Jul 1912
9
Mary Elizabeth Susan Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.6]
b. 12 Jun 1829 d. 23 Nov 1890
9
Arthur Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.7]
b. 1832
9
Harriet Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.8]
b. 1836
9
Martha Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.1.9]
b. 1838
8
Martha Ann Flournoy
[1.1.1.7.2.3.2.2]
b. Abt 1798 d. 1847
Thomas Woodfin
b. 1795 d. 1853
9
William Thomas Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.2.1]
b. 16 Sep 1822 d. 3 Aug 1894
9
Samuel Flournoy Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.2.2]
b. 4 Aug 1824 d. 14 Feb 1866
9
James Edward Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.2.3]
b. 1826 d. 1889
9
Jane Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.2.4]
b. 1828 d. 1892
9
Frances Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.2.5]
b. 1830
9
George Washington Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.2.6]
b. 15 Mar 1832 d. 3 Aug 1895
9
Martha Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.2.7]
b. 1834
9
Rebecca Woodfin
[1.1.1.7.2.3.2.2.8]
b. 18 Dec 1836 d. 16 Aug 1860
7
John Flournoy
[1.1.1.7.2.3.3]
b. 29 Apr 1754
7
Mary Flournoy
[1.1.1.7.2.3.4]
b. Bef 1756
7
Samuel Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5]
b. 9 Dec 1758 d. 19 Aug 1818
Nancy Ann Martin
b. 1765
8
Amelia Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.1]
b. 1786
8
Matthews Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.2]
b. 1789 d. 1833
8
James Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.3]
b. 1 Jan 1791 d. 3 Mar 1855
+
Martha Halloway
b. 1790 d. 1871
8
Patsy Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.4]
b. 1793
8
Nancy Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.5]
b. 1795
8
Rachel Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.6]
b. 1797
8
Samuel Martin Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.7]
b. 1799 d. 1878
+
Minerva Ann Wadlington
b. 1814 d. 1858
+
Harriett Elvira Fenley
b. 24 Jan 1820
8
Agnes Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.8]
b. 1799
8
Jack Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.9]
b. 1799 d. 1818
8
Emily Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.10]
b. 1801
8
Cassandra Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.11]
b. 1803
8
Martha Flournoy
[1.1.1.7.2.3.5.12]
b. 15 Aug 1813 d. 1891
Randolph Allen Hankla
b. 1 Feb 1803
9
Pendleton Flournoy Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.1]
b. 24 Mar 1831
9
James Marion F. Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.2]
b. 8 Feb 1833
9
John Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.3]
b. 21 Feb 1835
9
Minerva Nancy Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.4]
b. 29 Mar 1837 d. 1 Apr 1898
9
Mary Francis Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.5]
b. 29 Dec 1839
9
Eliza Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.6]
b. 2 Dec 1841 d. 7 Aug 1919
9
Martha Matilda Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.7]
b. 17 Jul 1844
9
Joseph Randolph Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.8]
b. 5 Nov 1847
9
William Harrison Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.9]
b. 17 Feb 1849
9
Ella Eugenia Hankla
[1.1.1.7.2.3.5.12.10]
b. 24 Jul 1853
7
David Flournoy
[1.1.1.7.2.3.6]
b. 14 Apr 1761 d. 30 Jun 1831
+
Elizabeth Mills Britton
b. 17 Oct 1760 d. 30 Jun 1830
7
Hannah Flournoy
[1.1.1.7.2.3.7]
b. Abt 1762
7
Jordan Flournoy
[1.1.1.7.2.3.8]
b. 20 Sep 1763 d. 21 Jun 1833
+
Judith Farrar
b. 21 Apr 1756 d. 1828
7
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.7.2.3.9]
b. 25 Nov 1765
+
Isham Britton
b. Bef 1761
7
Thomas Flournoy
[1.1.1.7.2.3.10]
b. Bef 1767
7
Martha Flournoy
[1.1.1.7.2.3.11]
b. Feb 1768
7
Julia Briton Flournoy
[1.1.1.7.2.3.12]
b. Abt 1770
7
Silas F. Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13]
b. 4 Jun 1774 d. 18 May 1822
Martha Cannon
b. 1775 d. Oct 1817
8
Eliza Susan Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.1]
b. 18 Nov 1794 d. 16 Apr 1829
Alfred Moore Harris
b. Oct 1789 d. 21 Feb 1828
9
Martha Harris
[1.1.1.7.2.3.13.1.1]
b. Bef 1815
+
Jerome Pillow
9
Alfred H. Harris
[1.1.1.7.2.3.13.1.2]
b. Bef 1817
+
Martha Jones
9
Eliza Susan Harris
[1.1.1.7.2.3.13.1.3]
b. Bef 1819 d. 1869
+
Watson
8
Alfred Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2]
b. 3 Dec 1796 d. 29 Oct 1873
Martha Moore
b. 25 Dec 1803 d. 13 Sep 1834
9
Alonzo Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.1]
b. 24 Dec 1820 d. 6 Nov 1886
Mary Anderson Patteson
10
Belle Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.1.1]
10
Theodosia Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.1.2]
10
Sallie Patteson Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.1.3]
b. 11 Oct 1851
James H. McRady
11
Genevieve McRady
[1.1.1.7.2.3.13.2.1.3.1]
10
James Patteson Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.1.4]
b. 25 Aug 1853
+
Georgia Elizabeth Martin
9
William Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.2]
b. 18 Oct 1823 d. 23 Oct 1873
Bettie Morrison Armstrong
d. 23 Aug 1867
10
Margaret Nickol Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.2.1]
b. 15 Aug 1847
+
George L. Kouns
d. 16 May 1881
10
William Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.2.2]
b. 12 May 1853
+
Florence Lambert
10
Alfred Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.2.3]
b. 28 Aug 1854
+
Clara Greenlea
d. 1894
10
Lucien Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.2.4]
b. 22 Feb 1861
9
Rachel Jackson Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.3]
b. 1824 d. 1857
Thomas Decater Wilson
10
Jr. Thomas Decater Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.1]
10
Alice Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.2]
+
Charles Davis
10
Ruth Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.3]
+
B. H. Davis
10
Pattie Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.4]
Milton Walker Sims
11
Rachel Jackson Flournoy Sims
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.4.1]
b. 1872
+
Charles Mills
11
Laura Sims
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.4.2]
b. 1873
+
J. Fred Smith
b. Abt 1870
11
Milton Sims
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.4.3]
b. 1876
11
Bartlett Sims
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.4.4]
b. May 1878
+
Almaide Priscilla Kerr
10
Laura Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.5]
Thomas Bell
11
Mary Bell
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.5.1]
+
Edward Gleason
10
Mary Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.6]
+
Napoleon Davis
10
Alfred F. Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.2.3.7]
b. 1847
+
Sammie Gleaves
+
Ella Branch
9
Martha Moore Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.4]
b. 22 Jul 1826 d. 1846
+
Lawrence P. Crain
b. 1822
9
Eliza Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.5]
b. 29 May 1829 d. INFANT
9
James Silas Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.6]
b. 1 Sep 1830 d. 1 Jan 1887
+
Helena H. Sibley
9
Alfred F. Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.7]
b. 21 Sep 1832 d. Mar 1901
Theodosia Eubanks Jones
10
Mary Patteson Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.7.1]
b. 24 Apr 1866
10
Bette Armstrong Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.7.2]
b. 9 Mar 1868
+
John McCullough
10
Thomas Wilson Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.7.3]
b. 21 Feb 1875
10
Spencer Alston Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.7.4]
b. Aug 1879
Maria Ward Camp
b. 19 Feb 1815 d. 27 Feb 1848
9
Maria Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.8]
b. 1837 d. 1841
9
David Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.9]
b. 1842 d. 1856
9
Charles Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.10]
b. 1844 d. 1906
+
Maggie McMillan
9
Mary Camp Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.11]
b. 1846 d. 1903
+
S. H. Sibley
9
Indiana Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.12]
b. 1847
9
Martha Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.2.13]
b. 1848
+
S. B. Surratt Meigs
8
William Cannon Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3]
b. 5 Apr 1800 d. 23 Sep 1838
Martha Ann Rebecca Ward Camp
b. 2 Nov 1810 d. 13 Apr 1875
9
Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.1]
b. 1829 d. 1829
9
Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.2]
b. 1833 d. 1833
9
Jr. William Cannon Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.3]
b. 9 Sep 1836 d. 28 Jul 1878
Ella Ezell
10
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.3.1]
b. 22 Oct 1870
+
N. A. Crockett
10
III William Cannon Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.3.2]
b. 8 Apr 1872
10
John Walker Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.3.3]
b. 24 Jan 1874
10
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.3.4]
b. 13 Sep 1875
10
Ezell Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.3.5]
b. 9 Dec 1878
9
John J. Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.4]
b. 1838
9
Martha Julia Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.3.5]
b. 18 Feb 1838 d. 22 Jan 1882
William Rhodes Rivers
b. 19 Jun 1831 d. 26 Dec 1891
10
Flournoy Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.3.5.1]
b. 15 Oct 1858 d. 11 Apr 1908
Lidie Avirett
11
John Avirett Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.3.5.1.1]
b. 22 Mar 1894
10
John Harper Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.3.5.2]
b. 9 Jan 1860 d. 17 Jul 1864
10
Tyree Rodes Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.3.5.3]
b. 10 May 1862
+
Katherine Fenlon
10
William Cannon Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.3.5.4]
b. 11 Jan 1866
10
Julian Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.3.5.5]
b. 23 Dec 1868
10
Myra Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.3.5.6]
b. 19 Jun 1871
+
T. N. Horn
8
Martha C. Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.4]
b. 13 Jan 1802 d. 25 May 1822
Joseph Trotter
b. 1 Jan 1798 d. 8 Jun 1862
9
Silas Flournoy Trotter
[1.1.1.7.2.3.13.4.1]
b. 4 Sep 1819 d. 21 Feb 1853
8
Louisa Ann Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.5]
b. Abt 1804 d. 26 Sep 1878
Tryon Milton Yancey
b. 1794 d. Aft 1860
9
Joseph Trotter Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1]
b. Oct 1823 d. 3 Sep 1904
Anna Joaquina Ortiz
b. 16 Nov 1840 d. 23 May 1927
10
Robert Lee Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.1]
b. 14 May 1864 d. 23 Oct 1913
10
Louisa "Lula" Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2]
b. 8 Dec 1866 d. 11 Mar 1966
Arthur Earnest Juch
b. 16 Jan 1858 d. 2 Aug 1930
11
Anita H. Juch
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.1]
b. 30 Oct 1887 d. 5 Jun 1949
Arthur Vivian Heacock
b. 29 May 1887 d. 19 Dec 1959
12
Vivian L. Heacock
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.1.1]
b. 8 Sep 1920 d. 11 Sep 1920
12
Caroll Jane Heacock
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.1.2]
12
Edwin Arthur Heacock
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.1.3]
[
=>
]
11
Chester Arthur Juch
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.2]
b. 31 Jul 1889 d. 2 May 1930
11
Flournoy Albert Juch
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.3]
b. 16 Jan 1892 d. 15 Aug 1966
+
Juddie Lois Turner
11
Stanley St. Clair Juch
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.4]
Janet Elisobeth Smith
b. 26 Dec 1891 d. 26 May 1940
12
Stanley Robert Juch
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.4.1]
[
=>
]
12
Phyllis Gertrude Juch
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.4.2]
[
=>
]
Eleanor M Juch
12
Hollis Eleanor Juch
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.4.3]
[
=>
]
11
Louis Dewey Juch
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.2.5]
10
Francis "Frank" H. Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.3]
b. Nov 1869 d. 30 Oct 1885
10
Adella Frances Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.4]
b. 22 Jun 1872 d. 24 Dec 1957
Wilbur Freemont Blake
b. Jul 1861 d. 14 Oct 1912
11
Harriet "Hattie" E. Blake
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.4.1]
b. 17 Aug 1895 d. 24 Dec 1971
Oswald Patrick Goodall
b. 14 May 1883 d. 3 Jul 1941
12
Jerome Anthony Goodall
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.4.1.1]
[
=>
]
12
John Patrick Goodall
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.4.1.2]
[
=>
]
12
Francis Joseph Goodall
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.4.1.3]
+
Frank G Curran
10
Mary Anna "Mayme" Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.5]
b. 8 Dec 1874 d. 18 Sep 1968
Maclovio Danislao De Arnaz
b. Nov 1863 d. Abt 1920
11
Katheryn Atala De Arnaz
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.5.1]
b. 28 Jun 1899 d. 9 Jan 1966
+
Leslie Ervin Mays
b. 11 Mar 1902 d. 1 Jun 1970
11
Orman Joe De Arnaz
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.5.2]
+
Alma Viola
10
Anita Josephine Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.6]
b. 31 Aug 1877 d. 15 Oct 1968
10
Edna Emma Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7]
b. 17 Mar 1880 d. 15 Jan 1958
Joseph Jesús Francis Otero
b. 5 Feb 1873 d. 8 Mar 1936
11
Helen May Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.1]
b. 20 Oct 1899 d. 15 Oct 1965
+
Earl Herman Linderman
b. 17 Nov 1892 d. 13 Aug 1958
+
Edward Joseph Houle
b. 21 Mar 1895 d. 31 May 1964
11
Edna Dorothy Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.2]
b. Abt 1903 d. 5 Apr 1935
11
Anita Ruth Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.3]
b. 23 May 1904 d. 6 Sep 1968
+
Victor Michael Marega
b. 5 Dec 1902 d. 16 Apr 1954
+
Carl Jacob Bernhardt Kober
b. 18 Apr 1885 d. 19 Apr 1936
11
Norman Francis Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.4]
Margaret (Peggy) Louise Clark
12
Nancy Nell Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.4.1]
[
=>
]
12
Joseph Edward Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.4.2]
[
=>
]
12
Norma Louise Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.4.3]
[
=>
]
12
Michael Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.4.4]
b. 17 Dec 1943 d. 20 Dec 1961
11
Kathryn Alberta Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.5]
Maxwell Busch McCune
b. 26 Feb 1907 d. 18 Jan 1961
12
Patricia Lee McCune
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.5.1]
12
Barbara Ruth McCune
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.5.2]
[
=>
]
12
Michael Allen McCune
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.5.3]
11
Howard Joseph Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.6]
b. 8 Nov 1918 d. 10 Jun 1961
Dorothy Lawrence Tapp
12
Anthony Howard Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.6.1]
12
Stephnie Jeane Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.6.2]
12
Nicholas Joseph Otero
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.7.6.3]
+
Edna Mae Thompson
10
Catherine Isabelle Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8]
b. 2 Sep 1883 d. 20 Nov 1970
Joseph Arthur Donat Houle
b. 28 Dec 1877 d. 10 Dec 1946
11
Alberta Isabel Houle
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.1]
+
Stanley William Rathburn
b. 2 Apr 1901 d. 22 Feb 1969
Jeptha Milton Gibbs, III
b. 17 Jan 1901 d. 9 Nov 1973
12
Jeptha Milton Gibbs, IV
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.1.1]
[
=>
]
12
Mary Ann Elizabeth Gibbs
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.1.2]
[
=>
]
12
Edward Thurston Gibbs
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.1.3]
b. 7 Apr 1930 d. INFANT
12
William Houle Gibbs
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.1.4]
b. 14 Sep 1931 d. INFANT
12
Jane Gibbs
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.1.5]
+
Chandler Parsons Anderson, Jr.
b. 24 Feb 1900 d. Feb 1973
11
Dorothy Louise Houle
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.2]
John Chase Scully, Jr.
b. 17 Oct 1907 d. 21 Jun 1969
12
Constance L Scully
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.2.1]
12
John Dennis Scully
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.2.2]
12
Brian C. Scully
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.2.3]
11
Anna Josephine Houle
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.3]
Guy Currier, Jr.
b. 1 Apr 1907 d. 29 Aug 1958
12
Guy Wilbur Currier, III
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.3.1]
[
=>
]
11
Joseph Arthur Houle, Jr
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.4]
Eugenia Joyce Barker
12
Winifred Catherine Houle
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.4.1]
[
=>
]
12
Jennifer Alberta Houle
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.4.2]
[
=>
]
12
Eugenia Joyce "Nina" Houle
[1.1.1.7.2.3.13.5.1.8.4.3]
[
=>
]
9
Simon Bolivar Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.2]
b. 1826 d. 17 Nov 1853
9
Tryon Milton Yancey, Jr
[1.1.1.7.2.3.13.5.3]
b. 23 Sep 1827 d. 12 Jan 1898
Rosa Bailey Crowell
b. 13 May 1845 d. 4 Mar 1909
10
Louisa Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.3.1]
b. 15 Apr 1863 d. 2 Jan 1942
Jr. George McQuade, Jr
b. 1848 d. 18 Dec 1889
11
Rosalie E. McQuade
[1.1.1.7.2.3.13.5.3.1.1]
b. 15 Dec 1882 d. 6 Jun 1956
+
Phillip Lewis
+
William Morgan Pereira
b. 4 Mar 1861 d. 17 Jun 1940
10
Mabel "Belle" Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.3.2]
b. 1867
+
James Henry Garrett
b. Jul 1865
10
Edna L. Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.3.3]
b. Jan 1868 d. 1918
+
William Gaston Jones
b. 2 Jun 1854
10
Henry Crowell Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.3.4]
b. 27 May 1873 d. 11 Feb 1943
+
Annie R. Day
10
Nellie M Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.3.5]
b. Bef 24 May 1879 d. 1936
+
Julius Bernstein Springer
b. 9 Oct 1883 d. Jan 1972
10
William P. Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.3.6]
b. 1881 d. 25 Jul 1932
9
Laura Ann Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.4]
b. 1828 d. Yes, date unknown
Leroy Paul Black
b. 15 Feb 1812 d. 27 Apr 1845
10
Laura Ann Black
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.1]
10
Louisa Catherine Black
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2]
b. 4 Feb 1841 d. 11 Sep 1895
Franklin Buford Lester
b. Abt 1827 d. 11 Mar 1886
11
Leroy Black Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.1]
b. 1864 d. 1934
11
Mary Lou Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.2]
b. 28 Dec 1866 d. 6 Sep 1927
Robert Andrew Gilbert
b. 8 Jan 1862 d. 19 May 1944
12
Sadie Louise Gilbert
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.2.1]
[
=>
]
12
Robert Lester Gilbert
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.2.2]
b. 27 Feb 1890 d. 26 Jul 1953 [
=>
]
12
Mattie Olivia Gilbert
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.2.3]
12
Leon Gilbert
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.2.4]
b. Abt 1894 d. Abt 1896
11
Laura Jane Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.3]
b. 12 Jun 1868 d. 1 Oct 1900
Charles William Gilbert Dickey
b. Oct 1861 d. Yes, date unknown
12
Gilbert Buford Dickey
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.3.1]
b. 1 Dec 1893 d. Yes, date unknown [
=>
]
12
Louise Dickey
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.3.2]
b. Jan 1899 [
=>
]
11
Emily Olivia Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.4]
b. 1869 d. 1887/1963
Arthur R. Tatum
b. 1852/1872 d. 1887/1958
12
Thomas Leroy Tatum
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.4.1]
12
Myra Tatum
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.4.2]
[
=>
]
11
Levair Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.5]
b. Abt 1869
11
John A. Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.6]
b. 1873 d. 1874/1963
11
Ernest M. Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.7]
b. 1874 d. 10 Sep 1875
11
Frank Leon Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.8]
b. 17 Oct 1874 d. 2 Nov 1943
Eunice Ragsdale
b. 27 Oct 1875 d. 7 Mar 1942
12
Richard Leon Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.8.1]
[
=>
]
11
James Carley Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.9]
b. 27 Aug 1878 d. 2 Feb 1956
Marie Louise Beasley
12
William Lambeth Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.9.1]
[
=>
]
12
James Lester
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.2.9.2]
10
Leroy M. Black
[1.1.1.7.2.3.13.5.4.3]
b. 18 Jul 1845 d. Jul 1845
+
Polly Simpson
9
Martha Keziah Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.5]
b. 1829 d. 4 Mar 1844
9
Mary Julia Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.6]
b. 1834
+
William D. Roberts
9
Flournoy Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.7]
b. 1835
Martha La Favre Asbury
b. 29 Mar 1847 d. 21 Oct 1918
10
Alice Fletcher Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.1]
b. 6 Dec 1870 d. 5 May 1905
Frank Lee Dawes
b. 6 Jan 1872 d. 31 Jan 1919
11
Thomas Asbury Dawes
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.1.1]
b. 4 Apr 1895
11
Ralph Carlyle Dawes
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.1.2]
b. 29 Jan 1897 d. 24 Nov 1973
+
Dorothy Boyle
b. Abt 1905
Willie Crook
b. Abt 1901
12
Fergene Dawes Richmond
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.1.2.1]
11
Alice LaFavia Dawes
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.1.3]
+
Glen Carl Moody
11
Frank Lee Duget Dawes
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.1.4]
b. 20 Mar 1902 d. 19 Apr 1974
Mary Ona Kitchens
12
Frank Leslie Dawes
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.1.4.1]
12
Lawrence Melvin Dawes
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.1.4.2]
[
=>
]
10
Louise "Lulu" Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.2]
b. Sep 1872 d. Dec 1942
Alfred George Bishop
b. Jun 1871 d. Aug 1944
11
Martha Lafavre Bishop
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.2.1]
11
Richard Yancey Bishop
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.2.2]
b. 23 Sep 1904 d. 1932
10
Cora Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.3]
b. 1874 d. 16 Jul 1897
+
Thomas Franklin Hill
b. 1 Jun 1867 d. 18 Jan 1945
10
Fletcher Flournoy Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.7.4]
b. Jul 1882
9
Thomas Leroy Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.8]
b. 1837 d. Bef 1880
Rosena M. Culley
b. 30 Apr 1842 d. 5 Sep 1908
10
Lucy M. Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.1]
b. 26 Aug 1861 d. 14 Apr 1941
Joseph J. Wilson
b. 1 Sep 1849 d. 6 Sep 1911
11
George L Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.1.1]
b. Aug 1884 d. 30 Jul 1933
11
Joseph J Wilson, Jr
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.1.2]
b. 1886
11
Rosa Mai Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.1.3]
b. May 1888 d. Nov 1967
+
William Gaston Durley
b. 30 Jan 1885 d. 1971
11
Wilber Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.1.4]
b. Jan 1893
Rosa Wilson
b. Abt 1897
12
Mabel Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.1.4.1]
11
Thomas Webber Wilson
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.1.5]
b. 24 Jan 1893 d. 1948
+
Lucy E Farrar
b. 23 Apr 1896
10
Webber Yancey
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.2]
b. 6 Jan 1866 d. Feb 1888
10
Elizabeth F "Lizzie" Yancy
[1.1.1.7.2.3.13.5.8.3]
b. 27 Jul 1872 d. 14 Jul 1932
8
Mary Amanda Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.6]
b. 23 Apr 1806 d. 23 Apr 1860
William Hume Field
b. 10 Jul 1796 d. 10 May 1861
9
James Alexander Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.1]
b. 30 May 1823
9
Mary Eliza Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.2]
b. 1 Jul 1825
William P. Officer
b. 10 Oct 1810 d. 21 Jun 1851
10
Maud Officer
[1.1.1.7.2.3.13.6.2.1]
b. 9 May 1847
10
Eustis Field Officer
[1.1.1.7.2.3.13.6.2.2]
b. 6 Apr 1849 d. 29 May 1900
10
William P. Officer
[1.1.1.7.2.3.13.6.2.3]
b. 28 Jun 1851 d. 21 Apr 1852
Gilbert Knapp
b. 3 Oct 1827
10
Myra Flournoy Knapp
[1.1.1.7.2.3.13.6.2.4]
b. 30 Jan 1858 d. 24 Aug 1860
9
Jr. William Hume Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.3]
b. 16 Jul 1827 d. 1 Jun 1908
9
Louisa Dan Dudley Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.4]
b. 10 Jul 1829 d. 5 Feb 1897
+
Charles A. Caldwell
9
Silas Flournoy Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.5]
b. 23 Sep 1831 d. Sep 1897
+
Jane Marshall Talbot
9
Henrietta Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.6]
b. 1833 d. 1833
9
Margaret Julia Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.7]
b. 6 Nov 1836 d. 22 Sep 1864
+
Samuel H. Lenox
9
Julian Clarence Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.8]
b. 15 Jul 1841 d. 6 Jan 1906
+
Bettie McLain
9
Florence Huntley Field
[1.1.1.7.2.3.13.6.9]
b. 13 Oct 1843 d. 2 Jan 1870
+
Samuel H. Lenox
8
Madison Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.7]
b. 1807
8
Julia Ann Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.8]
b. 10 Jan 1811 d. 5 Aug 1873
Edward Rex Feild
b. 18 Jun 1804 d. 3 Oct 1858
9
Eliza Mildred Feild
[1.1.1.7.2.3.13.8.1]
b. 25 Jan 1829 d. Bef 1870
William Batte
10
Julia Batte
[1.1.1.7.2.3.13.8.1.1]
+
W. R. Garrett
10
Mildred Batte
[1.1.1.7.2.3.13.8.1.2]
10
E. F. Batte
[1.1.1.7.2.3.13.8.1.3]
9
Hume Rigg Feild
[1.1.1.7.2.3.13.8.2]
b. 11 Sep 1834 d. 17 Jun 1921
+
Valeria Rose
8
Silas Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9]
b. 1815 d. 31 Oct 1844
Elizabeth Wall Camp
b. 7 Apr 1817 d. Mar 1853
9
III Silas Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.1]
b. 24 Mar 1835 d. 5 Jul 1862
Catherine Matilda Wilson
b. 10 Feb 1835 d. 27 Feb 1906
10
Mary Elizabeth Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.1.1]
b. 26 Apr 1858 d. 7 Jul 1930
+
John Morgan Woody
b. Bef 1854 d. 17 Dec 1893
10
Silas Camp Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.1.2]
b. 24 May 1861 d. 5 Nov 1927
9
Lucien Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.2]
b. 1837 d. 11 Nov 1870
Elizabeth C. Tebault
b. Bef 1841 d. 28 Oct 1870
10
Caroline Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.2.1]
b. Bef 1863
+
Goodman
9
Mary Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.3]
b. Abt 1841 d. 30 Mar 1914
James W. Rivers
b. 3 Apr 1833
10
James P. Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.9.3.1]
b. Bef 1863
10
Elizabeth Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.9.3.2]
b. Bef 1865
10
Mary Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.9.3.3]
b. Bef 1867
10
William W. Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.9.3.4]
b. Bef 1869
10
Silas Flournoy Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.9.3.5]
b. Bef 1871
10
Martha Rivers
[1.1.1.7.2.3.13.9.3.6]
b. Bef 1873
9
Camp Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4]
b. 9 Mar 1841 d. 22 Jun 1894
Louise Stewart Wise
b. 7 Oct 1846 d. 28 May 1904
10
Lucien Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.1]
b. 23 Feb 1872 d. 13 Dec 1918
Lillie Ethel May
b. 27 Apr 1879 d. 11 Mar 1965
11
Lillian May Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.1.1]
b. 1906
11
Mary Wise Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.1.2]
b. 1911
11
Alma Elizabeth Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.1.3]
b. 1914
11
Laura Louise Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.1.4]
11
Jr. Lucien Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.1.5]
10
John Wise Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.2]
b. 3 Oct 1874 d. 7 Nov 1905
Lucille Christina McAfee
b. 1 May 1886 d. 13 Oct 1972
11
Louise Wise Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.2.1]
b. 1907
11
Jr. John Wise Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.2.2]
b. 1912
Minnie Childress Cole
12
Thomas Cole Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.2.2.1]
11
Camp Rogers Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.2.3]
11
Betty McAfee Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.2.4]
10
Elizabeth Louise Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.3]
b. 3 Oct 1877 d. 2 Dec 1950
Newton Lafayette Walker
b. 7 Aug 1870 d. 20 Oct 1961
11
Eloise Walker
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.3.1]
b. 10 Feb 1897 d. 19 Dec 1959
+
Raymond Grady Thomas
11
Newton Flournoy Walker
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.3.2]
b. 21 Aug 1899 d. 6 May 1968
+
Rose Mary Bozeman
+
Valta Irene Gholston
11
Lucien John Walker
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.3.3]
b. 10 Mar 1902 d. 24 Nov 1972
Janie Lucile Stallcup
b. 1912
12
Lou Anne Walker
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.3.3.1]
[
=>
]
11
Jane Louise Walker
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.3.4]
+
Benjamin Elliot Mosher
11
Jacob Camp Walker
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.3.5]
+
Ouida Louise Gill
10
Augusta Mary Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.4]
b. 12 Aug 1880 d. 14 Aug 1934
James Madison May
b. 27 Feb 1873 d. 20 Sep 1933
11
Georgia Louia May
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.4.1]
b. 1899
11
Elizabeth Wise May
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.4.2]
b. 1902
11
James Kathryn May
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.4.3]
b. 1902
11
Norma Lucile May
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.4.4]
b. 1902
11
Julia Flournoy May
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.4.5]
Robert Henry Mays
12
Judy Mays
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.4.5.1]
12
Robert Mays
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.4.5.2]
d. INFANT
10
Julia Rivers Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.5]
b. 6 Sep 1885 d. 30 Oct 1969
Andrew Augustus Jordan
b. 4 Sep 1859 d. 3 Dec 1940
11
Andrew Booty Jordan
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.5.1]
Mattie Lou Shaw
12
Jr. Andrew Booty Jordan
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.5.1.1]
[
=>
]
12
Lou Ann Jordan
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.5.1.2]
[
=>
]
12
John Franklin Jordan
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.5.1.3]
[
=>
]
12
Gwen Elizabeth Jordan
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.5.1.4]
11
Lucien Wise Jordan
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.5.2]
b. 1914
10
Jacob Calhoon Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.6]
b. 23 Jan 1887
Nell Martin
b. Bef 1891
11
Jacob Calhoun Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.6.1]
11
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.6.2]
11
Nellie Pearl Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.4.6.3]
9
Elizabeth Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.9.5]
b. 1843 d. 12 Jun 1877
James Wallace Duncan
b. Bef 1839
10
Maude Eustace Duncan
[1.1.1.7.2.3.13.9.5.1]
b. 1 Jul 1868 d. 13 May 1944
+
George Smith
10
Duncan
[1.1.1.7.2.3.13.9.5.2]
b. Bef 1870 d. 1876
8
Sarah Flournoy
[1.1.1.7.2.3.13.10]
b. 1816
6
John Flournoy
[1.1.1.7.2.4]
b. 9 Dec 1726 d. 19 Jan 1825
+
Camilla Ballexserd
b. 1722 d. 1743
6
David Flournoy
[1.1.1.7.2.5]
b. 3 Sep 1728 d. 18 Oct 1757
6
Rachel Flournoy
[1.1.1.7.2.6]
b. 25 Sep 1730 d. 28 Aug 1741
6
Mathews Flournoy
[1.1.1.7.2.7]
b. 21 Jun 1732 d. 1785
Elizabeth Ann Pryor
b. 1739 d. Jun 1798
7
Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1]
b. 13 May 1763 d. 5 Jul 1825
Mary Willis Cobbs
b. 15 Apr 1777 d. 8 Feb 1829
8
Marcus Aurelius Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.1]
b. 9 Oct 1795
8
Thomas Howell Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.2]
b. 19 Mar 1797 d. 1797
8
Elizabeth America Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.3]
b. 18 May 1800 d. INFANT
8
Robert Willis Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.4]
b. 11 Dec 1802 d. Jan 1845
8
Mary Mildred Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.5]
b. 8 Jan 1805 d. 1874
+
Nathaniel Alexander Adams
d. 28 Aug 1849
8
John James Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.6]
b. 15 Aug 1808
8
Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.7]
b. 5 Mar 1811 d. 24 Aug 1894
Amanda Cullens
b. 1816 d. Bef 1858
9
Jr. Robert Watkins Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.7.1]
b. 13 Dec 1841 d. 8 Jun 1869
Ophelia C. Tucker
b. 6 Oct 1844 d. Aft 1900
10
Robert Willis Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.7.1.1]
b. 22 Sep 1867
+
Martha Redd Fontaine
b. Sep 1873
10
Anna Roberta Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.7.1.2]
b. Dec 1868 d. Aft 1900
Robert Watkins Andrews
b. 1867 d. Bef 1900
11
Haynes Cullens Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.1.2.1]
11
Albert R. Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.1.2.2]
b. 1869
11
Elizabeth F. Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.1.2.3]
b. 1882
11
Gasaway Knight Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.1.2.4]
b. 1887
9
Elizabeth M. Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.7.2]
b. 24 Jul 1844
A. E. Andrews
10
Robert Watkins Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.2.1]
b. 1867 d. Bef 1900
Anna Roberta Flournoy
b. Dec 1868 d. Aft 1900
11
Haynes Cullens Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.2.1.1]
11
Albert R. Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.2.1.2]
b. 1869
11
Elizabeth F. Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.2.1.3]
b. 1882
11
Gasaway Knight Andrews
[1.1.1.7.2.7.1.7.2.1.4]
b. 1887
Louisa St. Clair Cullens
b. 9 Feb 1838 d. 9 Oct 1916
9
Mary Louise Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.7.3]
b. 24 Sep 1858 d. 14 May 1929
James Wilson Bell
b. 6 May 1853 d. 27 Oct 1925
10
Mary Louise Bell
[1.1.1.7.2.7.1.7.3.1]
b. 3 Jun 1877 d. 6 Nov 1878
10
Robert Flournoy Bell
[1.1.1.7.2.7.1.7.3.2]
b. 27 Apr 1879 d. 30 Jun 1896
10
Lillian Tennille Bell
[1.1.1.7.2.7.1.7.3.3]
+
Henry Pittman Hurt
b. 26 Feb 1872 d. 20 Nov 1944
10
Mary Cobb Bell
[1.1.1.7.2.7.1.7.3.4]
b. 17 Jan 1885 d. 8 Mar 1965
+
Erskine Miller Carr
b. 22 Jan 1883 d. 17 Oct 1932
10
Rosa Wilson Bell
[1.1.1.7.2.7.1.7.3.5]
+
Robert Lee Campbell
b. 25 Nov 1882 d. 11 Aug 1952
10
James Bell
[1.1.1.7.2.7.1.7.3.6]
b. 6 May 1891 d. 27 Jan 1893
10
Watkins Flournoy Bell
[1.1.1.7.2.7.1.7.3.7]
b. Jan 1895 d. Bef 1950
+
Whitfield King
d. Bef 1950
8
Howell Cobb Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.8]
b. 21 Mar 1813 d. 1872
8
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.7.2.7.1.9]
b. 25 May 1815 d. 14 Apr 1844
Charles G. McKinley
9
Elizabeth Julia McKinley
[1.1.1.7.2.7.1.9.1]
d. 25 Apr 1845
9
William M. McKinley
[1.1.1.7.2.7.1.9.2]
b. 1 May 1835
9
Mary Elizabeth McKinley
[1.1.1.7.2.7.1.9.3]
b. 16 Sep 1840 d. 25 Apr 1845
7
Martha Caroline Flournoy
[1.1.1.7.2.7.2]
b. 1764 d. 1803/1806
John Thomas Wells
b. 1760 d. 1802
8
Lewis Wells
[1.1.1.7.2.7.2.1]
8
Martha Wells
[1.1.1.7.2.7.2.2]
8
Cassandra Wells
[1.1.1.7.2.7.2.3]
8
Frank Wells
[1.1.1.7.2.7.2.4]
8
John J. Wells
[1.1.1.7.2.7.2.5]
8
Thomas Flournoy Wells
[1.1.1.7.2.7.2.6]
8
Francis Flournoy Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7]
b. Abt 1800 d. Nov 1866
Martha McNutt
9
Laura Martha McNutt Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7.1]
b. 13 Jul 1827
Clark Lewis Owen
b. 6 Jun 1807 d. 6 Apr 1862
10
Laura Minta Owen
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1]
b. 1850 d. Mar 1885
John Owen Rowlett
b. 6 Aug 1847 d. 21 Oct 1918
11
Flora Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.1]
11
Pansy Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.2]
11
Laura Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.3]
11
Daniel Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.4]
11
Mary Laura Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.5]
b. 1873
11
John O. II Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.6]
b. 1875
11
Ruth I. Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.7]
b. 1876 d. Sep 1957
11
Henry J. Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.8]
b. 1879
11
A. Owen Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.9]
b. 1880 d. 1942
11
George Simons Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.10]
b. 4 Sep 1884 d. 1956
Mattie Virginia Richey
12
Myrtle Flora Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.10.1]
[
=>
]
12
Grover Owen Rowlett
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.1.10.2]
[
=>
]
10
Owen
[1.1.1.7.2.7.2.7.1.2]
b. 1852
9
Elizabeth Casandra Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7.2]
b. 1828
9
Flora Adelia Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7.3]
b. 31 Dec 1833 d. 25 Dec 1914
George F. Simons
b. 14 Feb 1834
10
Martha W. Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.1]
b. 1861
10
Courtney Stuart Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.2]
b. 1865
11
Kerr Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.2.1]
b. Yes, date unknown
11
Jr. Courtney Stuart Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.2.2]
10
William U. Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.3]
b. 1866
10
F. Wells Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.4]
b. Aug 1868
Susan Ann Rose
b. Apr 1871
11
Flora L. Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.4.1]
b. Jul 1894
11
George F. Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.4.2]
b. Apr 1898
10
George F. Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.5]
b. Jul 1872
Mary Lula Rose
b. 31 May 1874
11
Mattie L. Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.5.1]
+
Andrew J. Garner
b. Abt 1883
11
Volney Rose Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.5.2]
Elizabeth Cooper
12
Nancy Lois Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.5.2.1]
11
Steele White Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.5.3]
Elizabeth Winston
12
Suzanne Elizabeth Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.5.3.1]
12
Dennis Steele Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.5.3.2]
[
=>
]
11
George Wells Simons
[1.1.1.7.2.7.2.7.3.5.4]
b. 1912
9
Lucky Francis Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7.4]
b. 18 May 1846 d. 1915
Francis M. Sutherland
10
Robert W. Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7.4.1]
b. Sep 1875
10
Thomas J. Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7.4.2]
b. Oct 1878
10
Flora S. Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7.4.3]
b. Feb 1881
9
Robert Williamsom Wells
[1.1.1.7.2.7.2.7.5]
b. 3 Aug 1849
7
Elizabeth Julia Flournoy
[1.1.1.7.2.7.3]
b. 1768 d. 1813
William Gustavus Henry
b. 1761 d. 1824
8
Matthews Winston Henry
[1.1.1.7.2.7.3.1]
b. 11 Jan 1790
8
William Henry
[1.1.1.7.2.7.3.2]
b. 1793 d. 1847
Cornelia VaVasour Gano
b. 20 Apr 1801 d. 2 Mar 1887
9
Robert William Henry
[1.1.1.7.2.7.3.2.1]
b. 1823 d. 1862
Martha Douglas Cocke
b. 17 Dec 1822 d. 28 Mar 1850
10
Martha Douglas Henry
[1.1.1.7.2.7.3.2.1.1]
b. 24 Feb 1850 d. 29 Jan 1924
Leonidas Armstead Sypert
b. 1832 d. 1893
11
Susan Jouett Sypert
[1.1.1.7.2.7.3.2.1.1.1]
b. 1881 d. 1 Sep 1954
Charles Washington Johnston
b. 1871 d. 1 Dec 1958
12
Abraham Russel Johnston
[1.1.1.7.2.7.3.2.1.1.1.1]
b. 31 Aug 1914 d. 14 Dec 1943 [
=>
]
6
Mary Flournoy
[1.1.1.7.2.8]
b. 23 Feb 1735 d. 8 Sep 1798
William Booker
b. 1720 d. 10 Oct 1783
7
Thomas Booker
[1.1.1.7.2.8.1]
d. 1789
7
Nancy Rochet
[1.1.1.7.2.8.2]
7
Mary Williams Booker
[1.1.1.7.2.8.3]
d. 1789
7
Jane Davis Booker
[1.1.1.7.2.8.4]
b. 1755 d. 1800
Jacob Morton
b. 29 Jan 1751 d. 22 May 1829
8
Robert Morton
[1.1.1.7.2.8.4.1]
Marcia M. Flournoy
9
Robert A. Morton
[1.1.1.7.2.8.4.1.1]
Sallie Ann Collins
10
Sallie C. Morton
[1.1.1.7.2.8.4.1.1.1]
+
Frank W. Cunningham
8
William Booker Morton
[1.1.1.7.2.8.4.2]
b. 3 Sep 1775 d. 10 Aug 1816
Lucy Faris Flournoy
b. 1786 d. 1836
9
Anne Martin Morton
[1.1.1.7.2.8.4.2.1]
b. 1804
William Henry Dennis
b. 1801 d. 1866
10
Jacob Dennis
[1.1.1.7.2.8.4.2.1.1]
9
Elvira Henry Morton
[1.1.1.7.2.8.4.2.2]
b. 1806 d. 1840
William Peter Barksdale
b. 1799 d. 1854
10
Louisa Frances Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.2.1]
b. 1830 d. 1907
John Bullock Crews
b. 1814 d. 1882
11
Louise Barksdale Crews
[1.1.1.7.2.8.4.2.2.1.1]
11
Frances Sydnor Crews
[1.1.1.7.2.8.4.2.2.1.2]
11
Rosa Crews
[1.1.1.7.2.8.4.2.2.1.3]
+
Nicholas Hairston
9
Mary Elizabeth Morton
[1.1.1.7.2.8.4.2.3]
b. 24 Apr 1808 d. 13 Dec 1889
William Sydnor Barksdale
b. 7 May 1806 d. 10 Sep 1874
10
Lucy Ann Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1]
b. 4 Oct 1828 d. 11 Jan 1906
James Woodford Arendall
b. 20 Jan 1820 d. 17 Mar 1871
11
William Barksdale Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.1]
b. 25 Apr 1849 d. 11 Nov 1911
Phebe Pennich Dixon
d. 11 Jul 1898
12
Agis Lycurgus Lafayette Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.1.1]
b. 16 Dec 1871
12
Thomas Frank Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.1.2]
b. 30 May 1874
12
Morton Armistead Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.1.3]
b. 2 Aug 1877 d. 2 Aug 1879
12
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.1.4]
b. 8 Jan 1880
12
Alice M. Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.1.5]
b. 10 Jun 1884
12
Lou Boyd Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.1.6]
b. 27 Jul 1888 d. 11 Sep 1889
12
Rosa Crews Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.1.7]
b. 18 Mar 1891 d. Jan 1970 [
=>
]
11
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.2]
b. 23 Apr 1851 d. 28 Sep 1853
11
Ann Catherine Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.3]
b. 7 Mar 1853 d. 15 Jul 1882
Alexander D. Thompson
12
Charles Woodford Thompson
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.3.1]
b. 10 Oct 1873
12
William M.B. Thompson
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.3.2]
b. 25 Jun 1875
12
John Armistead Thompson
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.3.3]
b. 9 Oct 1876 d. 20 Jun 1878
12
Sandy S. Thompson
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.3.4]
b. 5 Jul 1878
12
Maud Iola Thompson
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.3.5]
b. 16 Feb 1879
12
Adel May Thompson
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.3.6]
b. 30 Apr 1881 d. 18 Mar 1882
11
John Armstead Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.4]
b. 12 Jan 1855 d. 1 Jul 1935
Alice Madison Cole
b. 3 Feb 1854 d. 29 Jan 1940
12
James Newton Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.4.1]
b. 11 Jul 1877
12
Luella T. Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.4.2]
b. 6 Oct 1879 d. 10 Sep 1964 [
=>
]
12
John William Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.4.3]
b. 19 Nov 1885 d. 31 Mar 1936 [
=>
]
12
Patsy Cole Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.4.4]
b. 6 Oct 1888
12
Allie Lovelace Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.4.5]
b. 24 Jul 1894
12
Kathleen Kent Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.4.6]
b. 23 Apr 1896
11
Thomas Syndor Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.5]
b. 11 May 1857 d. 1940
Virginia Lee Shields
b. Abt 1862
12
Jake Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.5.1]
b. Abt 1885 [
=>
]
11
James Morton Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6]
b. 29 Feb 1860 d. 14 Dec 1938
Jennie Sarah Farmer
b. 29 Sep 1865 d. 12 Apr 1948
12
Bettie Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6.1]
[
=>
]
12
James Herbert Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6.2]
b. 25 Dec 1883 d. 16 Feb 1961 [
=>
]
12
Molly B. Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6.3]
b. 25 Nov 1888 d. 28 Dec 1972 [
=>
]
12
Emma Carter Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6.4]
[
=>
]
12
Tap McDowell Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6.5]
b. 4 Jul 1896 d. 14 Oct 1962
12
Sue Brown Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6.6]
12
John Carson Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6.7]
12
Minnie Gunn Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.6.8]
11
Lucy Flournoy Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.7]
b. 5 Jun 1862 d. 11 Dec 1888
11
Judith Williams Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.8]
b. 16 Sep 1865 d. 31 Aug 1896
Robert V. Farmer
12
Maude M. Farmer
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.8.1]
b. 10 Mar 1885
11
Elizabeth Frances Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.9]
b. 23 May 1867 d. 12 Jun 1895
W. G. Slayton
12
Hattie S. Slayton
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.9.1]
b. 15 Jan 1885 d. 12 Sep 1886
11
Virginia Alice Arendall
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.10]
b. 26 Dec 1869
Charles King Petty
12
Henry T. Petty
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.1.10.1]
b. 3 Oct 1896
10
Judith Williams Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.2]
b. 16 Mar 1831
10
Elizabeth Armistead Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.3]
b. 3 Aug 1833
10
William Morton Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.4]
b. 2 Jan 1837
10
Elvira Frances Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.5]
b. 28 Jul 1839
10
Anthony Sydnor Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.6]
b. 29 Nov 1841
10
John Thomas Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.7]
b. 9 Mar 1844
10
Mary Susan Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.8]
b. 22 Jun 1846
10
Alice Sydnor Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.9]
b. 31 Oct 1848
10
Flournoy X. Barksdale
[1.1.1.7.2.8.4.2.3.10]
b. 23 Jun 1852
9
William Booker Morton
[1.1.1.7.2.8.4.2.4]
b. 1811
7
John D. Booker
[1.1.1.7.2.8.5]
b. 1755 d. 1825
+
Martha Jane Watkins
b. 1771 d. 1852
7
Gideon Booker
[1.1.1.7.2.8.6]
b. 1756 d. 28 Jul 1794
7
William Flournoy Booker
[1.1.1.7.2.8.7]
b. 12 May 1761 d. 21 Nov 1807
+
Elizabeth Moore
b. 15 Oct 1774 d. 1805
7
Eliza Julia Booker
[1.1.1.7.2.8.8]
b. 1764 d. 30 May 1828
+
Thomas Embra Green
b. Abt 1760 d. 30 Sep 1827
7
Frances Booker
[1.1.1.7.2.8.9]
b. 1771 d. 1793
+
Nathaniel Price
7
Rebecca Booker
[1.1.1.7.2.8.10]
b. 7 Apr 1773 d. 21 Apr 1818
+
Jr. Robert Smith
b. 10 Oct 1765 d. 26 Mar 1830
6
Flournoy
[1.1.1.7.2.9]
b. 25 Nov 1736 d. Jan 1736/37
6
Thomas Flournoy
[1.1.1.7.2.10]
b. 20 Nov 1738 d. 25 Feb 1801
Anne Martin
d. 1814
7
Mary Flournoy
[1.1.1.7.2.10.1]
7
Marcia Martin Flournoy
[1.1.1.7.2.10.2]
7
Julia Elizabeth Flournoy
[1.1.1.7.2.10.3]
b. 7 Sep 1767 d. 5 Nov 1836
George Wells Foster
8
Ann Martin Foster
[1.1.1.7.2.10.3.1]
b. Abt 1788
+
Lovick Pierce
7
Anne Farish Flournoy
[1.1.1.7.2.10.4]
b. Abt 1772
Archer Womack
b. 1777 d. 1816
8
Julia Ann Womack
[1.1.1.7.2.10.4.1]
b. 22 Sep 1815 d. 1 Jan 1887
Joseph Richard Bailey
b. 1815 d. 28 Aug 1857
9
Louise Bailey
[1.1.1.7.2.10.4.1.1]
b. Cal 1844
9
David Flournoy Bailey
[1.1.1.7.2.10.4.1.2]
b. 1845
Sarah Eleanor Preston
b. 1843
10
Julia Bailey
[1.1.1.7.2.10.4.1.2.1]
+
William T. Tillar
9
Anna A. Bailey
[1.1.1.7.2.10.4.1.3]
b. Cal 1850
7
David Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5]
b. Abt 1780
Mary Morton
b. Abt 1782
8
Thomas Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1]
b. 25 Jul 1804 d. 27 Dec 1892
Frances Matthews Venable
b. Abt 1810 d. 16 Aug 1863
9
Mary Agnes Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.1]
b. 23 Aug 1828
William H. Marshall
10
Pattie Venable Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.1]
+
Wood Dunham
10
Amanda F. Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.2]
10
James Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.3]
Carey Knox
11
James Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.3.1]
11
Ruth Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.3.2]
10
Louise Cabell Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.4]
Matthews Fink
11
Marshall Scott Fink
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.4.1]
11
Paul Fink
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.4.2]
11
Miriam Fink
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.4.3]
10
Sallie Anne Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.5]
Judson Lloyd
11
Mary Lloyd
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.5.1]
Wade
12
James S. Wade
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.5.1.1]
11
John Lloyd
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.5.2]
11
Kathleen Lloyd
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.5.3]
Arthur Field
12
Mary Agnes Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.5.3.1]
12
Sarah Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.5.3.2]
11
Robert Lloyd
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.5.4]
10
Fannie T. Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.6]
William H. Marshall
11
Pattie Venable Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.6.1]
11
James Marshall
[1.1.1.7.2.10.5.1.1.6.2]
9
II David Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.2]
b. 20 May 1829 d. 20 Nov 1895
Martha Daniel Bouldin
b. 11 Jan 1852
10
Martha Daniel Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.2.1]
b. 15 Mar 1871
10
Fannie Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.2.2]
b. 3 Jul 1872
10
Thomas Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.2.3]
b. 12 Oct 1877 d. 19 Sep 1947
+
Mary Harvey Hamlin
b. 22 Jun 1873 d. 25 Jul 1967
9
Frances Watkins Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.3]
b. 24 Sep 1831 d. 1900
Thomas Tyler Bouldin, Jr
b. 24 Mar 1813 d. 13 Nov 1891
10
Fannie Lewis Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.1]
b. 7 Dec 1852 d. 24 Oct 1946
+
Preston Buford
b. 4 Mar 1856 d. 20 May 1930
10
Mary Willie Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.2]
b. 24 Jul 1854
10
David Flournoy Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.3]
b. 16 Apr 1856 d. 31 Oct 1856
10
Henry Wood Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.4]
b. 3 Nov 1857 d. Aug 1935
Lela Edward Coles
b. 1858 d. 1908
11
Fannie Lewis Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.4.1]
b. 1882 d. 1957
+
Thomas Spratly
11
Lela Coles Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.4.2]
b. 15 Jul 1885 d. 29 Sep 1955
+
Oska Shoemake
11
Thomas Tyler Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.4.3]
b. 1 Oct 1890 d. 27 Apr 1966
+
Louise Coles
+
Evelyn Louise Coles
10
Ellen Barksdale Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.5]
b. 10 Feb 1860 d. 22 Nov 1936
10
Rachel Contesse Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.6]
b. 28 Nov 1861 d. 19 Feb 1872
10
Martha Cabell Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.7]
b. 19 Apr 1864 d. 31 Aug 1911
+
Gentry
10
Flournoy Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.8]
b. 22 Nov 1865 d. May 1957
Annie White
11
Elizabeth Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.8.1]
b. Abt 1895
10
Claiborne Barksdale Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.9]
b. 5 Oct 1867 d. 1 Jun 1959
Mary Crump
11
Alice Good Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.9.1]
11
Thomas Tyler Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.9.2]
11
Mary Crump Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.9.3]
11
Jr. Clairborne Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.9.4]
10
John Lewis Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.10]
b. 24 Nov 1871 d. 18 Feb 1958
+
Hetty Jones
10
Annie Venable Bouldin
[1.1.1.7.2.10.5.1.3.11]
b. 1 Aug 1876 d. 24 Apr 1974
+
Thomas W. Daniel
9
Amanda Nantz Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.4]
b. 8 May 1835
9
William Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.5]
b. 29 Nov 1835 d. 30 Mar 1836
9
Martha Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.6]
b. 28 Jul 1837
+
William Henry Venable
9
Nathaniel Abraham Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.7]
b. 20 Jan 1839
Laura Lewis
10
John Herbert Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.7.1]
Florence Wilson
11
John Wilson Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.7.1.1]
10
Fannie Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.7.2]
+
Charles Kimbro Taylor
10
Norborne Lewis Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.7.3]
10
Thomas Lewis Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.7.4]
+
Lois Latimer
9
Elizabeth Anne Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.8]
b. 26 Nov 1840
Reubin Booth Hicks
10
Thomas Hicks
[1.1.1.7.2.10.5.1.8.1]
Jennie Bowber
11
Elizabeth Baten Hicks
[1.1.1.7.2.10.5.1.8.1.1]
11
Francis Venable Hicks
[1.1.1.7.2.10.5.1.8.1.2]
11
Thomas Flournoy Hicks
[1.1.1.7.2.10.5.1.8.1.3]
11
Reubin Booth Hicks
[1.1.1.7.2.10.5.1.8.1.4]
9
Louisa Cabell Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.9]
b. 2 Nov 1841
Richard Field
10
Louise Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.1]
+
Albert McCracken
10
Meade Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.2]
10
George Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.3]
10
Martha Venable Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.4]
10
Anna Morton Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.5]
+
William Moran
10
Nona Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.6]
+
Sandridge
10
Kate Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.7]
+
Horace Hayden
10
Fanny Venable Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.8]
+
Oscar Collins
10
Sally Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.9]
10
David Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.10]
10
Eva Field
[1.1.1.7.2.10.5.1.9.11]
+
Robert E. Lee Morton
9
Jacob Morton Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.10]
b. 7 Oct 1843
Mildred Coles Carrington
b. Abt 1845
10
Thomas Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.10.1]
10
Anna Lightfoot Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.10.2]
10
Elizabeth Morton Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.10.3]
10
Walter Carrington Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.10.4]
b. Abt 1875 d. 1896
9
William Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.5.1.11]
b. 24 Oct 1846
+
Sally Edmunds Hicks
b. Abt 1827
+
Agnes Woodson Watkins
b. 28 Feb 1774
7
John James Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6]
b. 15 Oct 1782 d. 1862
Ann Carrington Cabell
b. 20 Sep 1787 d. 7 Jul 1854
8
Ann Eliza Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.1]
b. 1808
+
Henry Wood
8
William Cabell Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2]
b. 31 Dec 1809 d. 31 Mar 1861
Martha Watkins Venable
b. 5 Jun 1816 d. 1905
9
Ann Cabell Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.1]
b. Abt 1835 d. Abt 1837
9
II John James Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.2]
b. 13 Apr 1837 d. 7 Jan 1875
9
William Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.3]
b. Abt 1839 d. Abt 1842
9
Benjamin Stanhope Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.4]
b. Abt 1841 d. Abt 1842
9
Frances Florida Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.5]
b. 6 Jul 1843
+
John P. Fitzgerald
9
Sarah Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.6]
b. 12 Aug 1845
+
J. C. Painter
9
George Mallory Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.7]
b. Abt 1848 d. Abt 1853
9
Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8]
b. 4 Mar 1850
Martha G. Givens
b. 1858 d. 9 May 1884
10
Bessie Venable Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.1]
b. 29 Jan 1878
+
Brown
10
Florida Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.2]
b. 31 Aug 1879
10
Sarah Wright Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.3]
b. 9 Apr 1881
+
Butts
10
Martha Watkins Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.4]
b. 24 Dec 1882
Susan Cabell Cobbs
b. 5 Nov 1864
10
Mary Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.5]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
10
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.6]
b. 20 Sep 1890
10
Mildred Cobbs Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.7]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
10
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.8]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
10
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.8.9]
b. 24 Oct 1896
9
Alice Eliza Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.9]
b. 4 Nov 1852
+
Littleton Fitzgerald
9
Charles Bruce Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.2.10]
b. 11 Nov 1854
+
Virginia Dalby
8
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3]
b. 15 Dec 1811 d. 12 Mar 1883
Susan Ann Love
d. 21 Apr 1848
9
Allen Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.1]
d. Abt 1849
9
Mary P. Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.2]
b. 11 Sep 1838 d. 1874
John F. Cobbs
10
Susan Cabell Cobbs
[1.1.1.7.2.10.6.3.2.1]
b. 5 Nov 1864
Landon Cabell Flournoy
b. 4 Mar 1850
11
Mary Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.2.1.1]
b. 9 Mar 1889
+
Ward
11
Patterson Fitzgerald Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.2.1.2]
b. 20 Sep 1890
11
Mildred Cobbs Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.2.1.3]
b. 6 Sep 1892
+
W. T. Woodson
11
Jr. Landon Cabell Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.2.1.4]
b. 28 Oct 1894 d. 17 Mar 1950
+
Mariana Dyer
b. 13 Feb 1899 d. 1972
11
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.2.1.5]
b. 24 Oct 1896
9
Cabell Edward Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.3]
b. 30 Jun 1840 d. 1864
9
John James Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.4]
b. 11 Apr 1842
9
Louisa Cabell Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.5]
b. 3 May 1844
+
William W. Cobbs
9
Henry Wood Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.6]
b. 6 Jun 1846
+
Rose Buena Wood
Mildred H. Coles
d. 1901
9
Walter Cole Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.7]
9
Helen Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.8]
b. 9 May 1856
+
John R. Patton
9
Ann Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.9]
b. Abt 1858 d. Abt 1862
9
Thomas Stanhope Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.10]
b. 8 May 1860
9
Cole Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.11]
b. 1 Oct 1862
9
Lettice Carrington Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.12]
b. 21 Aug 1865
9
Charles Carrington Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.3.13]
b. 17 Feb 1871
8
Patrick Henry Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.4]
b. 4 Mar 1813 d. 3 Mar 1887
Susan Edmunds
9
Nicholas Edmunds Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.4.1]
b. 23 Mar 1841
+
Catharine Patrick Wood
9
William Stanhope Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.4.2]
b. 23 Dec 1845
+
Bettie A. Wilson
9
Ann Cabell Flournoy
[1.1.1.7.2.10.6.4.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1848
7
Lucy Faris Flournoy
[1.1.1.7.2.10.7]
b. 1786 d. 1836
+
Faris
William Booker Morton
b. 3 Sep 1775 d. 10 Aug 1816
8
Anne Martin Morton
[1.1.1.7.2.10.7.1]
b. 1804
William Henry Dennis
b. 1801 d. 1866
9
Jacob Dennis
[1.1.1.7.2.10.7.1.1]
8
Elvira Henry Morton
[1.1.1.7.2.10.7.2]
b. 1806 d. 1840
William Peter Barksdale
b. 1799 d. 1854
9
Louisa Frances Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.2.1]
b. 1830 d. 1907
John Bullock Crews
b. 1814 d. 1882
10
Louise Barksdale Crews
[1.1.1.7.2.10.7.2.1.1]
10
Frances Sydnor Crews
[1.1.1.7.2.10.7.2.1.2]
10
Rosa Crews
[1.1.1.7.2.10.7.2.1.3]
+
Nicholas Hairston
8
Mary Elizabeth Morton
[1.1.1.7.2.10.7.3]
b. 24 Apr 1808 d. 13 Dec 1889
William Sydnor Barksdale
b. 7 May 1806 d. 10 Sep 1874
9
Lucy Ann Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.1]
b. 4 Oct 1828 d. 11 Jan 1906
James Woodford Arendall
b. 20 Jan 1820 d. 17 Mar 1871
10
William Barksdale Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1]
b. 25 Apr 1849 d. 11 Nov 1911
Phebe Pennich Dixon
d. 11 Jul 1898
11
Agis Lycurgus Lafayette Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.1]
b. 16 Dec 1871
11
Thomas Frank Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.2]
b. 30 May 1874
+
E. Lillian Walker
11
Morton Armistead Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.3]
b. 2 Aug 1877 d. 2 Aug 1879
11
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.4]
b. 8 Jan 1880
+
William H. Douglas
11
Alice M. Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.5]
b. 10 Jun 1884
11
Lou Boyd Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.6]
b. 27 Jul 1888 d. 11 Sep 1889
11
Rosa Crews Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.7]
b. 18 Mar 1891 d. Jan 1970
Christopher Columbus Tankersley
b. 10 Sep 1884 d. 1921
12
Annie Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.7.1]
12
Lorine Edith Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.7.2]
12
Irvin W. Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.7.3]
12
Earl Willard Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.1.7.4]
b. 8 Apr 1916 d. 21 Jul 1973
10
Mary Elizabeth Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.2]
b. 23 Apr 1851 d. 28 Sep 1853
10
Ann Catherine Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.3]
b. 7 Mar 1853 d. 15 Jul 1882
Alexander D. Thompson
11
Charles Woodford Thompson
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.3.1]
b. 10 Oct 1873
11
William M.B. Thompson
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.3.2]
b. 25 Jun 1875
11
John Armistead Thompson
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.3.3]
b. 9 Oct 1876 d. 20 Jun 1878
11
Sandy S. Thompson
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.3.4]
b. 5 Jul 1878
11
Maud Iola Thompson
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.3.5]
b. 16 Feb 1879
11
Adel May Thompson
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.3.6]
b. 30 Apr 1881 d. 18 Mar 1882
10
John Armstead Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4]
b. 12 Jan 1855 d. 1 Jul 1935
Alice Madison Cole
b. 3 Feb 1854 d. 29 Jan 1940
11
James Newton Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.1]
b. 11 Jul 1877
11
Luella T. Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.2]
b. 6 Oct 1879 d. 10 Sep 1964
Luther A. Irby
b. 11 May 1871 d. 29 Jul 1953
12
Jr. Luther A. Irby
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.2.1]
12
Samuel Irby
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.2.2]
12
Floyd Irby
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.2.3]
12
John Ferman Irby
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.2.4]
11
John William Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.3]
b. 19 Nov 1885 d. 31 Mar 1936
Marguerite A. Krebs
d. 27 Jun 1919
12
Alice Marguerite Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.3.1]
b. 28 Jun 1913
12
Annette Elaine Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.3.2]
b. Jul 1915
12
John Madison Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.3.3]
11
Patsy Cole Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.4]
b. 6 Oct 1888
11
Allie Lovelace Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.5]
b. 24 Jul 1894
11
Kathleen Kent Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.4.6]
b. 23 Apr 1896
10
Thomas Syndor Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.5]
b. 11 May 1857 d. 1940
Virginia Lee Shields
b. Abt 1862
11
Jake Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.5.1]
b. Abt 1885
Ruth Conway
b. Abt 1894
12
James Conway Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.5.1.1]
12
Julian Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.5.1.2]
b. Abt 1917 d. Abt 1918
+
Sarah Hunter Beaman
b. Abt 1900
10
James Morton Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6]
b. 29 Feb 1860 d. 14 Dec 1938
Jennie Sarah Farmer
b. 29 Sep 1865 d. 12 Apr 1948
11
Bettie Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.1]
Leslie A. Anderson
12
Artie H. Anderson
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.1.1]
12
Ruby Anderson
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.1.2]
b. 13 Aug 1911
11
James Herbert Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2]
b. 25 Dec 1883 d. 16 Feb 1961
Mamie Lettica Atkinson
b. 6 Apr 1883 d. 22 Feb 1955
12
James Washington Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2.1]
b. 28 Aug 1905 d. Aug 1971
12
Henry Clyde Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2.2]
12
Albert Thorton Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2.3]
b. 23 Mar 1909 d. 13 Apr 1949
12
Mabel Pearl Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2.4]
b. 18 Nov 1910 d. 26 Jan 1965
12
Lettie Ann Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2.5]
12
Lem Carter Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2.6]
b. 11 Oct 1914 d. 13 Feb 1974
12
Raleigh Thomas Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2.7]
b. 11 May 1916 d. 23 Jul 1966
12
Oliver Twister Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.2.8]
b. 18 Apr 1918 d. 12 Apr 1972
11
Molly B. Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.3]
b. 25 Nov 1888 d. 28 Dec 1972
Doctor Cooper Smith
b. 23 Apr 1882 d. 6 May 1968
12
Manuel Cooper Smith
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.3.1]
12
Mary Virginia Smith
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.3.2]
12
Mae Louise Smith
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.3.3]
12
Belva Dunn Smith
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.3.4]
11
Emma Carter Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4]
Osa Perrow Roark
b. 17 Jun 1888 d. 18 Sep 1968
12
Bertha Mae Roark
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4.1]
12
Mildred Gunn Roark
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4.2]
12
Ida Evelyn Roark
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4.3]
12
Tapley Clinton Roark
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4.4]
b. 13 May 1918 d. 22 Mar 1948
12
Ralph Wiggington Roark
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4.5]
12
Verona Pearl Roark
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4.6]
b. 25 Dec 1922 d. 14 Feb 1923
12
Wilmer Ryland Roark
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4.7]
12
John Morton Roark
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.4.8]
11
Tap McDowell Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.5]
b. 4 Jul 1896 d. 14 Oct 1962
+
Hattie Owen McDowell
b. 24 Jul 1885 d. 10 May 1968
11
Sue Brown Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.6]
+
Willie Claude Shelton
11
John Carson Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.7]
+
Pattye Myrtle Lewis
+
Edna Wilson Moore
11
Minnie Gunn Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.6.8]
+
Walter Henry Spencer
b. 14 Aug 1904 d. 1940
10
Lucy Flournoy Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.7]
b. 5 Jun 1862 d. 11 Dec 1888
10
Judith Williams Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.8]
b. 16 Sep 1865 d. 31 Aug 1896
Robert V. Farmer
11
Maude M. Farmer
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.8.1]
b. 10 Mar 1885
10
Elizabeth Frances Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.9]
b. 23 May 1867 d. 12 Jun 1895
W. G. Slayton
11
Hattie S. Slayton
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.9.1]
b. 15 Jan 1885 d. 12 Sep 1886
10
Virginia Alice Arendall
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.10]
b. 26 Dec 1869
Charles King Petty
11
Henry T. Petty
[1.1.1.7.2.10.7.3.1.10.1]
b. 3 Oct 1896
9
Judith Williams Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.2]
b. 16 Mar 1831
9
Elizabeth Armistead Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.3]
b. 3 Aug 1833
9
William Morton Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.4]
b. 2 Jan 1837
9
Elvira Frances Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.5]
b. 28 Jul 1839
9
Anthony Sydnor Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.6]
b. 29 Nov 1841
9
John Thomas Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.7]
b. 9 Mar 1844
9
Mary Susan Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.8]
b. 22 Jun 1846
9
Alice Sydnor Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.9]
b. 31 Oct 1848
9
Flournoy X. Barksdale
[1.1.1.7.2.10.7.3.10]
b. 23 Jun 1852
8
William Booker Morton
[1.1.1.7.2.10.7.4]
b. 1811
5
Marie Flournoy
[1.1.1.7.3]
b. 1 May 1689 d. 16 Aug 1689
5
Julie Flournoy
[1.1.1.7.4]
b. 9 Jul 1690 d. 14 Feb 1690/91
5
Gedeon Flournoy
[1.1.1.7.5]
b. 2 Dec 1691
+
Jeanne Francoise Comparet
b. 4 Feb 1689/90
5
Julie Flournoy
[1.1.1.7.6]
b. 7 Oct 1692 d. 14 Oct 1692
5
Flournoy
[1.1.1.7.7]
b. 5 Aug 1693 d. 5 Aug 1693
5
David Flournoy
[1.1.1.7.8]
b. 8 Nov 1698 d. 2 Jul 1745
5
Julie Flournoy
[1.1.1.7.9]
b. 29 Nov 1699 d. 30 Nov 1699
5
Jacques Flournoy
[1.1.1.7.10]
b. 2 Feb 1702/03 d. Aft 2 Feb 1702/03
4
Esaie Flournoy
[1.1.1.8]
b. 13 Jan 1659/60 d. 23 Jul 1714
+
Christina Eggens
4
Jacob Flournoy
[1.1.1.9]
b. 5 Jan 1663 d. Nov 1731
Marthe Morel
b. 1667 d. Abt 1695
5
Magdalaine Flournoy
[1.1.1.9.1]
b. Abt 1685 d. Aft 1731
5
Francois Flournoy
[1.1.1.9.2]
b. 31 Jan 1686/87 d. Bef 5 Mar 1773
Mary Baugh
b. Abt 1687
6
Mary Flournoy
[1.1.1.9.2.1]
b. Abt 1713
+
Edward Wooldridge
b. 1711 d. 10 Oct 1808
6
Jean Flournoy
[1.1.1.9.2.2]
b. Abt 1715
6
Jacob Flournoy
[1.1.1.9.2.3]
b. Abt 1717
6
Francis Flournoy
[1.1.1.9.2.4]
b. Abt 1719
6
William Flournoy
[1.1.1.9.2.5]
b. Abt 1726 d. Aft 1773
Edith Friend
b. 31 May 1754 d. 8 Feb 1805
7
Ann Flournoy
[1.1.1.9.2.5.1]
7
John Flournoy
[1.1.1.9.2.5.2]
7
Martha Flournoy
[1.1.1.9.2.5.3]
7
Mary Flournoy
[1.1.1.9.2.5.4]
7
Sarah Flournoy
[1.1.1.9.2.5.5]
7
Thomas Flournoy
[1.1.1.9.2.5.6]
7
Jr. William Flournoy
[1.1.1.9.2.5.7]
7
Francis Flournoy
[1.1.1.9.2.5.8]
b. Abt 1776
7
Simon Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9]
b. 1779 d. 6 Aug 1856
Catherine Lucinda Langham
b. 1794 d. Aft 1880
8
Ameraca Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.1]
8
Ellen Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.2]
8
William Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.3]
b. Abt 1810 d. Aft 1880
8
Catherine Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.4]
b. 1812
8
Jr. Simon Flournoy, Jr
[1.1.1.9.2.5.9.5]
b. Jan 1812 d. 6 Aug 1856
Martha Ann Teal
b. 1827 d. 1904
9
Sarah E Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.1]
b. 1844
9
Joel L. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2]
b. 9 Sep 1846 d. 14 Dec 1932
Mary Jane "Bertie" Moody
b. 2 Feb 1843
10
John Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.1]
10
George Hamilton "Hamp" Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2]
b. Abt 1863 d. 24 Apr 1953
Ada Elizabeth Milam
b. Abt 1880 d. 1943
11
Claude Hamilton Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.1]
b. Abt 1895
11
Maud Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.2]
b. Abt 1898
11
George W. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.3]
b. Cal 1902
11
Robert Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.4]
11
Eddie B Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.5]
b. Abt 1907
11
Earnest Grady Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.6]
b. Abt 1909
11
Eunice V Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.7]
b. Abt 1913
11
Royce G. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.8]
b. 15 Jul 1917 d. 28 Feb 1974
11
Bertha B Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.2.9]
10
Marion Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.3]
b. Feb 1872 d. 31 Jan 1937
Nancy Elizabeth Calhoun
b. 17 Aug 1856 d. 17 Mar 1942
10
Brock Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.4]
10
Callie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.5]
10
Isaac Chaney Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.6]
b. 24 Sep 1880 d. 28 Oct 1918
10
Luella Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.7]
b. Aug 1883 d. 11 Jan 1958
10
Mattebell Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.8]
b. Feb 1885 d. 17 Apr 1959
10
Willie Duke Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.9]
b. 1 Apr 1889 d. 18 May 1970
10
Minnie Lee Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.10]
b. 31 Oct 1891 d. 8 Sep 1967
10
Egrilma Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.11]
b. Jul 1895
10
Mollie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.12]
b. Abt 1896
10
Susie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.13]
10
Ilga Mattie Flourney
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.14]
b. Oct 1898 d. 17 Apr 1959
10
Clarence Dewey Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.15]
10
Hattie Ethel Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.2.16]
b. Abt 1902 d. 2 Dec 1961
9
Tillman F. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3]
b. Jul 1849 d. 20 Jan 1935
Mary Jane Chatman
b. Oct 1851 d. 1932
10
James Franklin "Frank" Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.1]
b. 15 Oct 1877 d. 13 Jan 1964
Mary Ann Pitts
b. Sep 1879
11
James F Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.1.1]
b. Jul 1899
11
Emmett C Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.1.2]
b. Abt 1901
11
George W Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.1.3]
b. Abt 1903
11
May Bell Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.1.4]
b. Cal 1904
10
Joanna J. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2]
b. Aug 1878 d. 6 Mar 1936
Louis Andrew Jackson Flournoy
b. 23 Feb 1859 d. 19 Jan 1960
11
Mollie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.1]
b. 1887
11
Terrell Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.2]
b. 1892
11
Walker Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.3]
b. 1893
Annie
b. 1900
12
Julius Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.3.1]
b. 2 Aug 1910 d. Aug 1974
12
J.T. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.3.2]
11
Andrew Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.4]
b. 11 Jun 1895 d. 9 Sep 1968
Nancy Hill Pinson
12
Raymond Rockmore Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.4.1]
11
Florence Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.5]
b. 1896
11
Carrie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.6]
b. 1897
11
Eugene Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.7]
b. 1900
11
Sallie B. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.2.8]
b. 1902
10
William S. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.3]
b. Sep 1881
10
Catherine "Kittie" Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.4]
b. 7 Sep 1884 d. 25 Jun 1960
+
George McCoy
10
Isaac Tillman Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.5]
b. 24 Jul 1886 d. 30 Jul 1935
10
Lucy Ann Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.6]
+
Jr. James Thomas Mealor
b. 27 Jan 1879 d. 15 Sep 1967
10
Mary Mehatibel Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.7]
b. 12 Jul 1892 d. 3 Jun 1964
John Warren Brown
b. 12 Nov 1889 d. 23 Feb 1948
11
Lizzie Brown
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.7.1]
b. Abt 1911
11
Blanche Brown
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.7.2]
b. Abt 1915
11
John Warren Brown, Jr
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.7.3]
11
Margaret Brown
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.7.4]
10
Walker Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.8]
b. Jul 1893 d. 25 Mar 1962
10
Martha Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.9]
b. 5 Aug 1895 d. 9 Jan 1898
+
John W. McGouirk
10
Henry Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.3.10]
b. Aug 1897
9
Simon F. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.4]
b. Mar 1852 d. 13 Mar 1919
Sallie
b. 1852
10
Sallie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.4.1]
b. 1880
9
Mary Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.5]
b. 1857
9
James Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.6]
b. 13 Nov 1860 d. 1 Jun 1931
9
John Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.7]
b. 1861
9
Jo Anna Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.8]
b. 1864
9
Joseph B J Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.9]
b. 17 Mar 1868 d. 27 Jun 1923
+
Mattie
b. May 1866
9
Peter F Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.10]
b. 2 Apr 1868 d. 25 Nov 1942
Lucy A Pitts
b. Dec 1860
10
Frankie May Flonrnoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.10.1]
b. Jul 1883
10
John Flonrnoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.10.2]
b. Apr 1884
10
Lucius Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.5.10.3]
b. Abt 1895
8
Joannah Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.6]
b. 1820 d. Aft 1880
8
Sarah Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.7]
b. 1821
8
Joseph B Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8]
b. Dec 1825 d. 3 Jun 1909
Louisa Denham
b. Oct 1823 d. Aft 1910
9
John F. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1]
b. 11 Sep 1840 d. 20 Jan 1937
Aldine Pike
b. 1839
10
Joseph Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1]
b. Feb 1862 d. 19 Oct 1946
Dolly (Sallie) Daniel
b. 1871
11
Eva M. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.1]
b. Aug 1895
Tom Flournoy
b. 1891
12
Lillian Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.1.1]
b. 1913
12
Edna Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.1.2]
b. 1915
12
John Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.1.3]
12
Roberta Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.1.4]
12
William Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.1.5]
12
Alice Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.1.6]
11
Virgil M. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.2]
Eunice Brown
b. 1897
12
Hattie Lee Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.2.1]
12
Luther A. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.2.2]
12
Howard Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.2.3]
12
Joseph Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.2.4]
b. 18 Apr 1927 d. Jun 1971
11
Warner Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.3]
b. 29 Aug 1899 d. 15 Jan 1969
Martha Ann White
b. 16 Nov 1900 d. 8 Feb 1960
12
Grizzie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.3.1]
12
Leon Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.3.2]
12
Calvin Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.3.3]
12
Arthur Herman Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.3.4]
[
=>
]
Willie Kerns
b. 1890
11
Olin Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.4]
11
Obediah Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.1.5]
b. 1910
10
William F. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.2]
b. Jul 1875 d. 13 Feb 1950
Ineza
b. Mar 1881 d. 29 Mar 1955
11
Eley E. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.2.1]
Nimmie
b. Abt 1898
12
Barney Fred Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.2.1.1]
[
=>
]
12
William Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.2.1.2]
12
Gilmor Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.2.1.3]
11
Stenson Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.2.2]
b. 1911
10
John J. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.3]
b. 6 Mar 1877 d. 25 Dec 1956
Mattie Bowen
b. 1881
11
Bessie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.3.1]
b. 1906
11
Clarence Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.3.2]
b. 1906
+
Opal?
b. 1912
11
John Henry Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.3.3]
b. 1909
11
Ripley (Walter) Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.3.4]
b. 1910
+
Dora
b. 1913
11
Mattie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.3.5]
11
Thomas J. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.1.3.6]
9
Simon Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.2]
b. 1849 d. 29 Dec 1935
+
Sallie Moore
Eliza Ann Pike
b. 1847
10
Simon Matthew Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.2.1]
+
Effie Harbuck
10
James Franklin Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.2.2]
b. 15 Jan 1874 d. 13 Jan 1964
Mary Ann Pitts
b. Sep 1879
11
Jr. James Franklin Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.2.2.1]
b. 8 Jul 1899
10
Mattie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.2.3]
b. Cal 1877
9
Davis Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.3]
b. 1850
9
Mary Lou Ellen Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.4]
b. 26 Sep 1856 d. 6 Apr 1945
Thomas
10
Mary Lou Ellen Thomas
[1.1.1.9.2.5.9.8.4.1]
+
Stillwell
+
Wade
John Whitley
b. Cal 1850
10
James Whitley
[1.1.1.9.2.5.9.8.4.2]
b. Cal 1872
10
Joseph Whitley
[1.1.1.9.2.5.9.8.4.3]
b. Cal 1875
10
Mary Whitley
[1.1.1.9.2.5.9.8.4.4]
b. Cal 1876
10
Madison Whitley
[1.1.1.9.2.5.9.8.4.5]
b. Jun 1879
9
Joanna Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.5]
b. 1858
9
Joseph Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.6]
b. 1858
+
Victoria Quick
b. 1861
9
Louis Andrew Jackson Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7]
b. 23 Feb 1859 d. 19 Jan 1960
Joanna J. Flournoy
b. Aug 1878 d. 6 Mar 1936
10
Mollie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.1]
b. 1887
10
Terrell Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.2]
b. 1892
10
Walker Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.3]
b. 1893
Annie
b. 1900
11
Julius Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.3.1]
b. 2 Aug 1910 d. Aug 1974
11
J.T. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.3.2]
10
Andrew Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.4]
b. 11 Jun 1895 d. 9 Sep 1968
Nancy Hill Pinson
11
Raymond Rockmore Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.4.1]
10
Florence Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.5]
b. 1896
10
Carrie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.6]
b. 1897
10
Eugene Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.7]
b. 1900
10
Sallie B. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.7.8]
b. 1902
9
William Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.8]
b. 1861
9
James Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.9]
b. Mar 1864
Sarah
b. Sep 1872
10
Lizzie Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.9.1]
b. May 1886
10
Liza Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.9.2]
b. Jul 1890
10
Jack Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.9.3]
b. Sep 1892
10
Sarah J. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.9.8.9.4]
b. Jun 1898
7
Jane F. Flournoy
[1.1.1.9.2.5.10]
b. Abt 1783
7
Greene Flournoy
[1.1.1.9.2.5.11]
b. Abt 1786
7
Edith Flournoy
[1.1.1.9.2.5.12]
b. 1788
7
Margaret Flournoy
[1.1.1.9.2.5.13]
b. 1794
+
Phoebe Farrar
b. Abt 1769
6
Jane Flournoy
[1.1.1.9.2.6]
b. 1726 d. 1806
+
Simon Hancock
Mary Gibson
b. 1691
6
Sarah Flournoy
[1.1.1.9.2.7]
b. 1735 d. May 1806
William Wooldridge
b. 1709 d. 1798
7
Gibson Wooldridge
[1.1.1.9.2.7.1]
b. 1750/1755 d. Oct 1816
+
Lucy Elizabeth Hudspeth
+
Mrs. Leah Pool
7
Thomas Flournoy Wooldridge
[1.1.1.9.2.7.2]
b. 1756 d. 1836
+
Cheriah Davis
+
Martha Easter
7
Sarah Flournoy Wooldridge
[1.1.1.9.2.7.3]
b. Abt 1765 d. 1849
+
David Hudspeth
7
Edward Wooldridge
[1.1.1.9.2.7.4]
b. 1760/1770 d. 1828
+
Sarah Vining
7
Martha Wooldridge
[1.1.1.9.2.7.5]
b. Abt 1770
Joseph T. Davis
b. 1758
8
Thomas W. Davis
[1.1.1.9.2.7.5.1]
b. 1791
8
Absalom Davis
[1.1.1.9.2.7.5.2]
b. 1793
8
William Davis
[1.1.1.9.2.7.5.3]
b. 1796
8
Sarah F. Davis
[1.1.1.9.2.7.5.4]
b. 1798
6
Gibson Flournoy
[1.1.1.9.2.8]
b. 1 May 1735 d. Bef 6 Jan 1812
Mary Frances Farmer
b. Abt 1736 d. Abt 1817
7
David Flournoy
[1.1.1.9.2.8.1]
7
Josiah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.2]
7
John Francis Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3]
b. 1757 d. 7 May 1842
Mary Ashurst
b. Abt 1770 d. Aft Nov 1834
8
Elizabeth A. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.1]
+
Obediah Echols
8
Mary Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.2]
d. Bef 1834
+
John H. Posey
8
Emily Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.3]
d. Bef 1834
8
Josiah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4]
b. 17 Mar 1789 d. 25 Jan 1842
Martha Dixon "Patsy" Manley
b. 14 Oct 1789 d. 27 Apr 1877
9
Thomas F. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1]
b. 1 Dec 1809 d. 29 Jan 1859
Caroline Elizabeth Rogers
b. Abt 1814 d. 23 May 1854
10
Mary Lou Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1]
b. 1 Dec 1832 d. 12 Nov 1893
Robert Rutherford Howard
b. 14 Feb 1824 d. 20 Nov 1897
11
Elizabeth Howard
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1.1]
11
Sallie Howard
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1.2]
b. 31 Aug 1851 d. 23 Aug 1902
11
Jennie Howard
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1.3]
b. 16 Jun 1859 d. 20 Oct 1920
11
Virginia Moore Howard
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1.4]
b. 16 Jun 1860 d. 20 Oct 1920
11
Caroline E. Howard
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1.5]
b. Abt 1863
11
Alice V. Howard
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1.6]
b. Abt 1865 d. 4 Jul 1944
11
Alice Vivian Howard
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1.7]
b. 23 Apr 1865 d. 4 Jul 1944
11
John Robert Howard
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.1.8]
b. 19 Dec 1873 d. 9 May 1948
10
Robert Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.2]
b. 25 Nov 1834 d. 24 Jul 1867
Susan B. McKenzie
b. 21 Apr 1838 d. 6 Nov 1889
11
Walter Burch Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.2.1]
b. 15 Oct 1858
11
Charles M. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.2.2]
b. Apr 1860 d. Nov 1864
11
Ava Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.2.3]
b. 25 Oct 1864
11
Robert Ernest Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.2.4]
b. 6 Dec 1866
10
Osborne Rogers Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.3]
b. 1835
+
Mattie Flournoy
+
Fletcher Hardin
b. Abt 1844
10
Martha Virginia Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.4]
b. 14 Jul 1838 d. 8 Mar 1907
+
John Castle Moore
10
Caroline Elizabeth Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.5]
b. 16 Aug 1840 d. 12 Sep 1927
+
Bethume Beaton McKenzie
b. 11 Oct 1837
10
Frances Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.6]
b. 9 Jul 1842 d. 29 Feb 1924
+
Frank W. Edison
10
Thomas Josiah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.1.7]
b. 1 Aug 1846 d. 1885
9
Mary Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.2]
b. 12 Jul 1811 d. 27 Nov 1835
+
Gabrial Toombs
+
Lawrence C. Toombs
d. 3 Sep 1829
9
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.3]
b. 26 Jun 1812 d. 14 Nov 1888
9
Catherine Caroline Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.4]
b. 5 Oct 1812 d. 28 Sep 1900
+
Willilam Hurt
Nathan Bass
b. 19 Oct 1808 d. 22 Sep 1890
10
Julia Bass
[1.1.1.9.2.8.3.4.4.1]
+
Zachary Taylor Leavell
b. Abt 1847
9
John Manly Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5]
b. 14 Jan 1814 d. 14 Sep 1859
Mary Ann Gordon
b. 10 Mar 1823 d. 28 Jul 1886
10
Charles Gordon Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.1]
b. 24 Dec 1844 d. 5 Apr 1902
+
Addie Gallespie
b. 10 Oct 1859 d. 9 Jan 1920
10
John Francis Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2]
b. 13 Mar 1847 d. 15 Jul 1936
Rebecca Epping
11
Jr. John Francis Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.1]
b. 19 Sep 1871 d. 17 Sep 1937
Leila Morey Priestley
b. 10 Oct 1879 d. Feb 1956
12
Charles Priestley Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.1.1]
b. 17 Jan 1904 d. 7 Oct 1972 [
=>
]
11
Rebecca Epping Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.2]
b. 16 May 1873 d. 27 Jan 1963
George Swift Hamburger
b. Mar 1870 d. 20 Mar 1935
12
Frank Flournoy Hamburger
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.2.1]
b. 14 Oct 1896 d. 7 Aug 1971 [
=>
]
12
Frances Isabel Hamburger
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.2.2]
b. 14 Jul 1903 d. 4 Jan 1956
Mary Welch Reynolds
b. 1 May 1852 d. 11 Mar 1926
11
Mallory Reynolds Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.3]
b. 15 Oct 1882
Mattie Hatcher
b. Cal 1882 d. 6 May 1956
12
Samuel H. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.3.1]
b. Cal 1905
12
Mary R. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.3.2]
b. Cal 1908
11
Maud Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.4]
b. Apr 1884
11
Josiah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.5]
b. Mar 1886 d. 13 Jan 1954
Jeannette Stephens Martin
b. Cal 1884
12
Helen Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.5.1]
12
Jr. Josiah M. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.5.2]
11
Gordon Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.6]
b. Dec 1887 d. 4 Feb 1930
Susette Joerg
b. 9 May 1891 d. 5 Jan 1972
12
Susette R. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.6.1]
11
Mary Hannah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.7]
b. Apr 1890
11
John Manly Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.8]
b. Dec 1891
11
Walker Reynolds Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.9]
b. Dec 1892 d. 25 Mar 1962
Mary Wheat
12
Margaret Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.2.9.1]
10
Mary Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.3]
b. 7 May 1852 d. 20 Feb 1875
+
Francis Maury Fontaine
b. 4 Sep 1871 d. 24 Apr 1894
10
Virginia Abercrombie Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.5.4]
b. 7 Oct 1855 d. 20 Aug 1857
9
Amanda Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.6]
b. 9 Aug 1815 d. 4 Oct 1816
9
Louisa Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.7]
b. 13 Mar 1816 d. 10 Nov 1881
9
Josiah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.8]
b. 14 Oct 1817 d. 27 Jul 1840
Evelina Powels
10
Georgianne Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.8.1]
10
Samuel Josiah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.8.2]
+
Mary E. Toney
E. J. Toney
11
Roper Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.8.2.1]
b. Abt 1870
Martha W. Rossier
b. 1820 d. 14 Feb 1852
10
Georgianna Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.8.3]
+
Van A. Leonard
10
Samuel Josiah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.8.4]
9
John Manly Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.9]
b. 14 Oct 1817 d. 27 Jul 1840
9
Frances 'Fannie' Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.10]
b. 23 Aug 1821 d. 20 Mar 1899
Joel Early Hurt
b. Abt 1821 d. 1865
10
Julia Flournoy Hurt
[1.1.1.9.2.8.3.4.10.1]
d. 31 Dec 1891
+
Peyton Colquitt
+
Lee Jordan
9
Robert A. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11]
b. 6 May 1825 d. 27 Oct 1896
Eugenia Moffett
b. 8 Feb 1836 d. 4 Jul 1902
10
Dora Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11.1]
b. 14 Sep 1856
+
Jr. Henry H. Epping
b. Cal 1856
10
Thomas Moffett Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11.2]
b. 12 Aug 1859 d. 28 Nov 1913
Araminta Lee Long
11
Eugenia Moffett Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11.2.1]
b. 1 Dec 1893
+
Holcombe Boscomb Harper
11
Arminta Long Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11.2.2]
b. 5 Nov 1895
+
Gifford Banks Tarver
11
Robert Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11.2.3]
b. 16 Aug 1900
+
Elizabeth Molder
11
Mary Nisbet Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11.2.4]
b. 1 Jan 1903
+
Harbin King Park
11
Rebecca Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11.2.5]
b. 23 Oct 1905
+
Charles Dexter Jordan
11
Jr. Thomas Moffett Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.11.2.6]
+
Nell Gray Kimbrough
9
Thomas Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.12]
b. 1826
9
Robert Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.13]
b. 6 May 1826 d. 27 Oct 1896
9
Martha Elizabeth Ann Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.14]
b. 1827
Walter Richardson Branham
b. 18 Nov 1813 d. 2 Sep 1894
10
Virlinda Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.1]
10
Junius Wingfield Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2]
b. 1841
Laura Sasnett
b. Abt 1845
11
William Sasnett Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2.1]
b. 26 Oct 1866 d. 8 Dec 1930
Marie Johnson
12
Annie Laurie Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2.1.1]
12
Walter Johnson Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2.1.2]
11
III Walter Richardson Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2.2]
b. 1870
Lily Fluker
b. Abt 1875
12
Walter Richardson Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2.2.1]
b. Abt 1895
12
Robert Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2.2.2]
b. Abt 1895
11
Flournoy Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2.3]
b. 1874
+
Margaret Brewster
+
Sena Hope
11
Bolling Sasnett Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.2.4]
b. 16 Jul 1880
+
Elizabeth MacElreath
10
Edward Vance Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.3]
b. 18 Nov 1843 d. 10 Aug 1902
Julia Billups
b. 1858 d. 1907
11
Hal Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.3.1]
b. 1888
11
Emmee Connelly Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.3.2]
+
Benjamin Tyler Carter
b. 17 Nov 1885 d. 18 May 1962
10
Elizabeth Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.4]
b. Mar 1848
Henry Emory
11
Walter Emory
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.4.1]
Addie Singleton
12
Joseph Emory
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.4.1.1]
12
Rebecca Emory
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.4.1.2]
11
Annie Emory
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.4.2]
11
Julia Emory
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.4.3]
10
Jr. Walter Richardson Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.5]
b. Feb 1850
10
Martha Manley Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.6]
b. 3 Jun 1857
10
Henry Branham
[1.1.1.9.2.8.3.4.14.7]
b. 11 May 1860
+
Sadie Harwell
9
Elizabeth J. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15]
b. Feb 1827 d. 1904
Robert S. Flournoy
b. 1825 d. 1870
10
James Pierce Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.1]
b. 1845 d. 20 Nov 1898
10
J. R. F. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.2]
b. Abt 1848
10
Sarah E. "Sallie" Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.3]
b. Dec 1848 d. 26 Sep 1927
10
George Henry Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.4]
b. 14 May 1850 d. 12 Feb 1941
10
Wilson P. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.5]
b. 2 Mar 1855 d. 9 Sep 1939
Emma N.
b. Apr 1871
11
Robert Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.5.1]
b. Oct 1895
11
Tillman Russell Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.5.2]
b. 3 Nov 1898 d. Aug 1971
11
George F. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.5.3]
b. May 1899
10
M. C. F. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.6]
b. Cal 1856
10
Martha L. O. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.7]
b. Dec 1856 d. 20 Jul 1922
10
Margaritte L. F. "Maggie" Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.15.8]
b. Oct 1858 d. 23 Nov 1931
9
Martha D. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.4.16]
b. 1829
8
Martha E. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.5]
b. Aft 1793 d. Abt 1859
+
Jabez Pleiades Marshall
+
Lewis W. King
d. 1 May 1815
+
II Irby Hudson
8
Robert F. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.3.6]
b. 10 Dec 1797 d. 27 Oct 1834
+
Martha Lawton
7
Virginia Flournoy
[1.1.1.9.2.8.4]
b. Abt 1762
+
Mordecai Jacobs
7
Phoebe Flournoy
[1.1.1.9.2.8.5]
b. 28 Feb 1764 d. 2 Mar 1819
+
William Hill
b. Abt 1760 d. Abt 1850
7
Mary Ann Flournoy
[1.1.1.9.2.8.6]
b. Abt 1766 d. 1 Jan 1846
+
Peter Mahone
b. 20 Apr 1763 d. Bef 1807
7
Mary Frances Flournoy
[1.1.1.9.2.8.7]
b. 18 Jan 1766 d. Aft 1803
William Pleasant
b. 30 Jun 1767
8
Thomas Pleasant
[1.1.1.9.2.8.7.1]
+
Mary Durham
8
Pleasant
[1.1.1.9.2.8.7.2]
b. 15 Jun 1803
7
Jr. Gibson Flournoy
[1.1.1.9.2.8.8]
b. Abt 1768 d. Abt 1806
Martha Ashurst
b. Abt 1772 d. 1801
8
Jane Frances Flournoy
[1.1.1.9.2.8.8.1]
b. 17 Jul 1793 d. 14 Feb 1833
Irby Hudson
b. 26 May 1786 d. 12 Apr 1844
9
Martha Hudson
[1.1.1.9.2.8.8.1.1]
b. 23 Nov 1813
9
Elizabeth Hudson
[1.1.1.9.2.8.8.1.2]
b. 18 Nov 1815
9
Jane Ann Hudson
[1.1.1.9.2.8.8.1.3]
b. 5 Jun 1819 d. 11 Aug 1877
9
Caroline Frances Hudson
[1.1.1.9.2.8.8.1.4]
b. 5 May 1821 d. 10 Feb 1884
+
Robert Carter Jenkins
b. 15 Nov 1817 d. 2 May 1888
9
Sarah Hudson
[1.1.1.9.2.8.8.1.5]
b. 13 Dec 1822
8
William Henry Flournoy
[1.1.1.9.2.8.8.2]
b. Abt 1795 d. 15 Sep 1822
8
Martha Flournoy
[1.1.1.9.2.8.8.3]
b. Abt 1797
7
Peter Farmer Flournoy
[1.1.1.9.2.8.9]
b. Abt 1770
Frances Shipp
8
Samantha Flournoy
[1.1.1.9.2.8.9.1]
8
Whitfield Flournoy
[1.1.1.9.2.8.9.2]
8
Maddison Flournoy
[1.1.1.9.2.8.9.3]
8
Permelia Flournoy
[1.1.1.9.2.8.9.4]
b. 17 Dec 1797 d. 24 Oct 1870
+
Enoch George Brown
7
William F. J. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.10]
b. Abt 1775 d. 6 Jun 1831
Nancy Hubart
b. Abt 1776 d. 17 Jun 1829
8
John P. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.10.1]
Agnes Grant
9
Agnes Flournoy
[1.1.1.9.2.8.10.1.1]
d. 31 Jul 1840
9
John P. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.10.1.2]
d. 16 Jun 1835
8
William B. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.10.2]
8
Everlina Flournoy
[1.1.1.9.2.8.10.3]
+
Mark A. Cooper
8
Matthew H. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.10.4]
b. Abt 1801 d. 11 Feb 1828
Elizabeth P. Wright
d. Aft 1829
9
Mary Ann Flournoy
[1.1.1.9.2.8.10.4.1]
b. 1827
7
Daniel Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11]
b. Abt 1777 d. Abt 1830
Sarah P. Wooldridge
8
Alvinah Sarah Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.1]
+
Peter Williams
8
Virginia Ann Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.2]
+
Robert W. Menefee
8
William Spencer Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.3]
+
Cornelia Bell
b. Abt 1823
8
Hannah Catherine Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.4]
+
Richard Elam Snelling
8
Caroline Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.5]
8
George Morion Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.6]
8
Richard Lafayette Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.7]
8
Ann Spencer Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.8]
8
Elizabeth F. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.9]
+
Ball
8
Augustus Wooldridge Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.10]
b. Abt 1811
+
Anna Eliza Holland
8
John Gibson Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.11]
b. 24 Jan 1812 d. Nov 1892
Martha Ann S. Bass
9
Homer Edwin Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.11.1]
10
Bertie Rosa Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.11.1.1]
Judith Flournoy
8
Creed Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.12]
8
Daniel Henry Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.13]
8
Judith Watson Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.14]
8
Phoebe Marshall Flournoy
[1.1.1.9.2.8.11.15]
b. Abt 1800 d. Abt 1865
Moab Elam
9
Adolphas Gustovus Elam
[1.1.1.9.2.8.11.15.1]
b. 31 Aug 1820
Rebecca Flournoy
10
William Sam Elam
[1.1.1.9.2.8.11.15.1.1]
b. Abt 1846
Ezra Seldon Howard
9
Lucy Jane Howard
[1.1.1.9.2.8.11.15.2]
9
Susan Emma Howard
[1.1.1.9.2.8.11.15.3]
9
Virginia Flournoy Howard
[1.1.1.9.2.8.11.15.4]
9
Irby H. Howard
[1.1.1.9.2.8.11.15.5]
7
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.1.9.2.8.12]
b. Abt 1780
7
Lawrence M Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13]
b. 1783 d. 1818
Mary Bradford
b. 1785 d. 17 Jan 1816
8
Mary Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.1]
8
Thomas Gibson Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2]
b. 14 Aug 1809 d. 1896
Rosannah Stephens
b. 4 Jan 1810 d. 1893
9
Mordicai Gibson Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.1]
b. 20 Aug 1836 d. 29 Jun 1920
+
Martha J. Murchison
9
James Bradford Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.2]
b. 1 Sep 1836 d. 24 Aug 1922
+
Celia Ann Rutland
b. 3 May 1837 d. 30 Jan 1918
9
Isaac Laurence Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.3]
b. 1 Jun 1838 d. 10 May 1862
9
Gideon Davis Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.4]
b. 25 Nov 1839 d. 24 Oct 1915
9
Jacob "Jake" Ashland Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5]
b. 17 Sep 1841 d. 7 Oct 1919
Eulah M Varner
b. 1 Dec 1846 d. 24 Nov 1915
10
John Walter Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1]
b. 27 Mar 1869 d. 9 Feb 1963
Lenora Abie Calloway
b. 12 Mar 1878 d. 12 Oct 1956
11
Walter Grady Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.1]
b. 12 Oct 1902 d. 2 Mar 1966
Helen Lovina Mason
12
Forest Wayne Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.1.1]
12
Fern Lee Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.1.2]
[
=>
]
11
Eulia M Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.2]
11
Roy G Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.3]
11
Lenora Bell Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.4]
11
Frank Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.5]
b. Abt 1911
11
Homer Monroe Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.6]
11
Luther Woodrow Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.7]
11
Archer Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.8]
b. Abt 1915
11
Ralph Burnet Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.9]
11
Frank Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.1.10]
10
George Gibson Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.2]
b. 16 Apr 1875 d. 23 Dec 1950
Lily E Ashburn
b. 26 Apr 1885 d. 13 Jun 1962
11
Sarah E Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.2.1]
11
L Flourney
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.2.2]
b. 1906
11
George G Flournoy, Jr
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.2.3]
b. Abt 1908
11
Floyd Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.2.4]
b. 1908
10
Mattie Bell Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.3]
b. 13 Aug 1876 d. 23 Jun 1916
10
Edward Burnett Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.4]
b. 22 Aug 1880 d. 15 Jun 1969
10
Jacob Gidden Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.5]
b. 21 Oct 1883 d. 3 Oct 1956
+
Vertie B
b. 30 Jan 1893 d. 23 Apr 1957
10
James Monroe Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.6]
b. Jan 1886 d. 2 Feb 1971
10
William W Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.5.7]
b. Oct 1888 d. 12 Mar 1970
9
Frances Narcissa Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.6]
b. 23 Jul 1843 d. 8 Jul 1868
9
Nancy J. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.7]
b. 23 Jul 1843
9
Martha R. Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.2.8]
b. Bef 1847
8
Jacob Ashurst Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.3]
b. 26 Jun 1812 d. 14 Nov 1888
+
Mariah Louisa Steed
b. 15 Nov 1817 d. 24 Aug 1908
8
Laura Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.4]
b. 1814 d. 10 Nov 1881
+
Estes
8
Louisa Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.5]
b. 13 Mar 1816 d. 10 Nov 1881
8
Caroline Elizabeth Flournoy
[1.1.1.9.2.8.13.6]
b. 10 Aug 1817 d. 22 Feb 1900
7
Jane Flournoy
[1.1.1.9.2.8.14]
b. Abt 1783
6
James Flournoy
[1.1.1.9.2.9]
b. Abt 1736
6
Josiah Flournoy
[1.1.1.9.2.10]
b. Abt 1738
6
Martha Flournoy
[1.1.1.9.2.11]
b. Abt 1740 d. Dec 1805
III Andrew Laprade
b. 1733 d. Aft 29 Apr 1797
7
Nancy Laprade
[1.1.1.9.2.11.1]
b. 4 Jun 1765 d. 27 May 1827
William P. Owen
b. 7 Jul 1761 d. 9 Nov 1823
8
Nancy Owen
[1.1.1.9.2.11.1.1]
b. 11 Sep 1798 d. 5 Jan 1853
John W. Walker
b. 22 Mar 1792 d. 6 Jan 1871
9
Davis Andrew Walker
[1.1.1.9.2.11.1.1.1]
b. 13 Jul 1828 d. 20 Jun 1891
Sarah Adaline Herrin
b. 13 Jul 1828 d. Jan 1859
10
Montgomery Hamilton Walker
[1.1.1.9.2.11.1.1.1.1]
b. 24 Mar 1852
Annie America Blythe
d. 30 Oct 1870
11
Alton Edgar Walker
[1.1.1.9.2.11.1.1.1.1.1]
b. 3 Oct 1877 d. 28 Oct 1939
Mary Eula Watson
b. 23 Feb 1885 d. 7 May 1969
12
Annie Florence Walker
[1.1.1.9.2.11.1.1.1.1.1.1]
[
=>
]
5
Jacques Flournoy
[1.1.1.9.3]
b. 14 Dec 1688 d. 1740
5
Marie Flournoy
[1.1.1.9.4]
b. 3 Jun 1690 d. Abt May 1700
5
Jeanne-Marie Flournoy
[1.1.1.9.5]
b. 19 Jan 1692/93 d. 23 Jan 1692/93
5
Jeanne Francoise Flournoy
[1.1.1.9.6]
b. 28 Mar 1695 d. Abt 1717
Robert Ashurst
6
Jacob Ashurst
[1.1.1.9.6.1]
+
Magdeleine Prodhom
b. 24 Jun 1658
4
Henry Flournoy
[1.1.1.10]
b. 19 Aug 1666